This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1079
12 avril 2016
SOMMAIRE
ADF GLF LUX A2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
51782
A.L.S. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51751
AMPLEXOR Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
51791
Bonativo Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51754
CiArt Productions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51791
Ciupinski Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51780
Eaglestone Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51792
Ecommerce Business 11 S.à r.l . . . . . . . . . . . . .
51752
Elvea Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51752
Energy Power S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51753
Fideres Capital I Funding, S.à.r.l. . . . . . . . . . .
51789
Fondation Hôpitaux Robert Schuman . . . . . .
51751
Fortan European Investments S.A. . . . . . . . . .
51753
Fratrix S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51751
GBL Verwaltung S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51751
Global Bond Series V, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
51792
Haarslev Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51750
Hasten Property Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
51774
Holmes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51749
Iberinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51750
ICG European Fund 2006 S.à r.l. . . . . . . . . . .
51747
IHS Global Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
51748
Immobilière Etoile 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
51749
International Institute of Diamond Grading &
Research Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51749
Kerima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51748
KFA Holdings Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
51747
L.F.L. Société civile immobilière . . . . . . . . . . .
51746
Luxconnect S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51747
Millem Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51747
NORD S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51749
OMNIUM AFRICAIN D'INVESTISSE-
MENTS (O.A.I.), Société de Gestion de Patri-
moine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51752
Prévention.Sécurité.Santé . . . . . . . . . . . . . . . . .
51752
ProjektPlus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51748
SAF-Holland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51774
Samir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51746
Signal Credit Opportunities (Lux) Investco I
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51764
Sonae Sierra Brazil B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51750
Sonae Sierra Brazil B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51748
Stable II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51750
Stentex Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51769
TAD Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
51753
Tinsel Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51746
Tomasa Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
51746
Tricadia Credit Investments S.à r.l. . . . . . . . .
51753
Triton Masterluxco 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
51746
Twinhope Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51787
XYLLYX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51785
51745
L
U X E M B O U R G
Tinsel Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 121.180.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016075045/12.
(160039391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
L.F.L. Société civile immobilière, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3321 Berchem, 29, rue de la Montée.
R.C.S. Luxembourg E 2.486.
Statuts coordonnes déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Référence de publication: 2016059776/10.
(160020645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Tomasa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 132.428.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
TOMASA INVESTMENTS S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016075046/12.
(160039401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Triton Masterluxco 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 177.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Triton Masterluxco 4 S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016075048/11.
(160039534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Samir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 52.890.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074993/9.
(160039254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
51746
L
U X E M B O U R G
KFA Holdings Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 180.730.
<i>Extrait des résolutions des Associés de la Société prises en date du 25 janvier 2016i>
Il résulte des décisions écrites des Associés de la Société les décisions suivantes (traduction libre):
- d'accepter la démission des personnes suivantes avec effet immédiat:
* Anita Lyse, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016059768/15.
(160020326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Millem Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 124.478.
Il résulte des résolutions prises par le gérant unique de la société en date du 4 janvier 2016 que le siège social de la
société a été transféré du 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg avec
effet au 4 janvier 2016.
Trustmoore Luxembourg S.A., gérant de la Société, est désormais domicilié au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg avec
effet au 4 janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Référence de publication: 2016059836/15.
(160020131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
ICG European Fund 2006 S.à r.l., Société Anonyme de Titrisation.
Capital social: EUR 16.667,09.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 121.235.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Référence de publication: 2016059714/10.
(160020436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Luxconnect S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 4, rue Alexander Graham Bell.
R.C.S. Luxembourg B 120.379.
La démission de Monsieur Tom KETTELS de son mandat d'administrateur avec effet au 2 décembre 2015 est acceptée.
En date du 2 février 2016, Madame Carole NUSS, demeurant à 3A, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg, a été cooptée
pour le mandat d'administrateur, et son mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2016.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2016062398/14.
(160023354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
51747
L
U X E M B O U R G
IHS Global Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.002,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 190.659.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 5 février 2016i>
L'associé unique de la Société a décidé:
- d'acter la démission de Monsieur Simon Dunlop, né à Wellington (Nouvelle Zélande), le 2 mars 1973, résidant au 9,
Wentworth Dene, GB-KT13 9AJ Weybridge (Royaume-Uni), en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet
date du 5 février 2016;
- de nommer Monsieur Pascal Petit, né à Montmorillon (France), le 3 août 1961, résidant professionnellement au 16-18,
rue du Quatre Septembre, 75002 Paris (France), en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société pour une durée
indéterminée, avec effet en date du 5 février 2016;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2016062292/19.
(160023850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Kerima S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 38.996.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement du 04/02/2016, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré
dissoute et ordonné la liquidation de la société KERIMA S.A., avec siège social à L-1314 Luxembourg, 3, place Dargent,
de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Radia DOUKHI, Avocat à la Cour, de-
meurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Me Radia DOUKHI.
Référence de publication: 2016062343/16.
(160022989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Sonae Sierra Brazil B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.400,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.462.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016074971/10.
(160039314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
ProjektPlus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6730 Grevenmacher, 6, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 135.616.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074909/9.
(160038881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
51748
L
U X E M B O U R G
Holmes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 47.221.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement n° 147/16 du 04 février 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant
en matière commerciale, a, sur base de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel qu'il
a été modifié par la loi du 31 mai 1999 et l'article 536 du Code de commerce, déclaré closes par liquidation les opérations
de liquidation de la société anonyme HOLMES SA.
Pour extrait conforme
Florence SCHWARTZ
<i>Le liquidateur judiciairei>
Référence de publication: 2016062266/15.
(160024024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Immobilière Etoile 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 182.538.
EXTRAIT
En date du 29 janvier 2016, l'associé de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- La démission de Cédric Muenze en tant que gérant de classe B de la Société est acceptée avec effet au 7 août 2015;
- M. Salvatore Rosato, avec adresse professionnelle au 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé
nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 7 août 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 4 février 2016.
Référence de publication: 2016062280/15.
(160023193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
International Institute of Diamond Grading & Research Holdings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 181.060.
Il est porté à la connaissance de tous que Monsieur Bruce Cleaver avec adresse professionnelle au 17 Charterhouse
Street, Londres, EC1N 6RA, Royaume-Uni, a démissionné de ses fonctions de gérant dans la société International Institute
of Diamond Grading & Research Holdings avec effet au 3 février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2016.
Référence de publication: 2016062287/13.
(160023824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
NORD S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4469 Soleuvre, 3, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 82.581.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016074876/11.
(160039078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
51749
L
U X E M B O U R G
Haarslev Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DKK 647.381.120,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 166.797.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société Haarslev Holding S.à r.l. (la «Société») du 21 janvier 2016i>
1. Acceptation de la résignation de Monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-Uni,
résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de
catégorie A de la Société avec effet le 12 janvier 2016.
2. Acceptation de la nomination de Monsieur Alan Fraser Ross, née le 25 octobre 1972 à Stirling, Royaume-Uni, résidant
professionnellement au 11-15, rue Seaton Place, St Helier, Jersey, JE4 0QH, en tant que gérant de catégorie A de la Société
avec effet le 12 janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062249/19.
(160023272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Iberinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 138.780.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voies circulairesi>
Le Conseil d'Administration décide de pourvoir au remplacement de l'administrateur vacant, ERDEBE SA, du fait du
décès de son représentant permanent, Monsieur Herbert Thomas ZELINGER DE BALKANY. Le Conseil décide de pro-
céder par cooptation à la nomination, avec effet à la date du 19 septembre 2015, de Monsieur Jean-Marc JORAND, domicilié
professionnellement Rue de la Rôtisserie 4, CH-1204 Genève, Suisse. Ce mandat d'administrateur prendra fin lors de
l'Assemblée Générale de 2019.
La présente décision sera confirmée lors de la prochaine Assemblée Générale.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016062290/15.
(160023433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Sonae Sierra Brazil B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.400,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.462.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016074973/10.
(160039316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Stable II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 137.134.
Les comptes annuels au 30.09.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 3 mars 2016.
Référence de publication: 2016074980/10.
(160039125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
51750
L
U X E M B O U R G
Fondation Hôpitaux Robert Schuman, Fondation.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg G 86.
Monsieur Erny GILLEN, demeurant à L-2132 Luxembourg, Centre Convict, 5, avenue Marie-Thérèse a démissionné
de sa fonction d'administrateur avec effet au 21 janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062208/12.
(160023252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Fratrix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.508.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2016i>
- Acceptation de la démission, avec effet au 31 décembre 2015, de Monsieur Jean Lambert, gérant de la société.
- Acceptation de la nomination avec effet immédiat de la société Regere Mgt. Services S.A., dont le siège social est
situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 125133, gérant de la société pour une durée indéterminée.
Extrait sincère et conforme
FRATRIX S.à. r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062212/16.
(160023397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
GBL Verwaltung S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.244.162.180,00.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 93.453.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 12 octobre 2015i>
Le Conseil prend acte des démissions de Olivier Pirotte et Arnaud Laviolette de leurs mandats d'Administrateurs à
compter du 1
er
juillet 2015.
Luxembourg.
<i>Pour GBL Verwaltung S.A.
i>Laurence MATHIEU
<i>Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2016062231/15.
(160023508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
A.L.S. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 11, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 135.726.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2016075091/11.
(160039784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
51751
L
U X E M B O U R G
Ecommerce Business 11 S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1736 Senningeberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 197.643.
Monsieur Philipp LEDERER a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 28
décembre 2015.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:
- Monsieur Ralf WENZEL, gérant de catégorie A
- Monsieur Christian SENITZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2016.
ECommerce Business 11 S.à r.l
Référence de publication: 2016062162/18.
(160023762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Elvea Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 146.932.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2016i>
- Acceptation de la démission, avec effet au 31 décembre 2015, de Monsieur Jean Lambert, gérant de la société.
- Acceptation de la nomination avec effet immédiat de la société Regere Mgt. Services S.A., dont le siège social est
situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 125133, gérant de la société pour une durée indéterminée.
Extrait sincère et conforme
ELVEA CAPITAL S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062168/16.
(160023372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
OMNIUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société
Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 20.721.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074885/10.
(160039494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
P.S.S., Prévention.Sécurité.Santé, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 169.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016074908/10.
(160039015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
51752
L
U X E M B O U R G
Energy Power S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 80.811.
EXTRAIT
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision du Conseil d'Administration en date du 5 décembre 2014, ROOSEVELT SERVICES S.A., société anonyme,
15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B-42.411, a été nommée dépositaire
des actions au porteur de la société ENERGY POWER S.A..
Luxembourg, le 5 février 2016.
<i>Pour la société ENERGY POWER S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2016062172/15.
(160023774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Fortan European Investments S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 122.360.
Suite à la dénonciation du contrat de domiciliation, Experta Corporate and Trust Services S.A., agissant en sa qualité
d'agent domiciliataire, déclare que le siège social de la société FORTAN EUROPEAN INVESTMENTS S.A., immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B122.360, n'est plus situé au 42, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
<i>Pour: FORTAN EUROPEAN INVESTMENTS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016062194/16.
(160022998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
TAD Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 160.533.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2016075038/13.
(160039460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Tricadia Credit Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 146.067.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Référence de publication: 2016075035/10.
(160039522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
51753
L
U X E M B O U R G
Bonativo Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.606.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet SE, a European company (Societas Europaea), incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Antsgericht Charlottenburg),
Germany, under number HRB 165662 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (he-
reinafter “Rocket”),
being the holder of twelve thousand five hundred (12,500) common shares and six hundred twenty five (625) series A1
shares and becoming the holder of one (1) series A4 shares and twelve thousand nine hundred seventeen (12,917) series
A6 shares.
here represented by Mrs. Aïcha Tazi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
2. TEC Global Invest XII GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), incorporated and
existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Duisburg
(Amtsgericht Duisburg), Germany, under number HRB 24728, having its registered address at Wissollstraße 5-43, 45478
Mülheim an der Ruhr, Germany (hereinafter “TEC XII”),
being the holder of two thousand eighty three (2,083) series A1 shares,
here represented by Mrs. Aïcha Tazi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a Luxembourg common limited partnership (société en commandite simple),
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies register (Registre de Commerce et des Sociétés du Luxmebourg) under number B 191426, having its registered
address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Holtzbrinck Fund VI”),
being the holder of two thousand eighty three (2,083) series A2 shares and becoming the holder of one thousand one
hundred seventy two (1,172) series A4 shares,
here represented by Mrs. Aïcha Tazi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
4. Kaltroco Limited, a registered private company, incorporated in Jersey with registered number 60595, having its
registered address at Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3AS (hereinafter “Kaltroco”),
being the holder of eight hundred thirty four (834) series A3 shares,
here represented by Mrs. Aïcha Tazi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
5. TEC Global Invest XI GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), incorporated and
existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Duisburg
(Amtsgericht Duisburg), Germany, under number HRB 23773, having its registered address at Wissollstraße 5-43, 45478
Mülheim an der Ruhr, Germany, as a new shareholder of the Company (hereinafter referred to as “TEC XI”),
becoming the holder of four thousand six hundred and ninety (4,690) series A4 shares,
here represented by Mrs. Aïcha Tazi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
6. Rocket Club I, S.C.S., a Luxembourg common limited partnership (société en commandite simple) under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 198814, having its business address at 32-36 boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as “Eiffel”),
becoming the holder of four hundred sixty nine (469) series A4 shares and eight hundred thirty four (834) series A5
shares,
here represented by Mrs. Aïcha Tazi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
7. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company, incorporated and existing under the laws
of Bermuda, having its registered address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11, as a new
shareholder of the Company (hereinafter referred to as “TJT”),
becoming the holder of two hundred and thirty five (235) series A4 shares and four hundred and seventeen (417) series
A5 shares,
51754
L
U X E M B O U R G
here represented by Mrs. Aïcha Tazi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
8. Mr. David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57
th
Street - 33
rd
Floor, New York, New York
10019, United States of America, as a new shareholder of the Company (hereinafter referred to as “DZ”),
becoming the holder of two hundred and thirty five (235) series A4 shares and four hundred and seventeen (417) series
A5 shares,,
here represented by Mrs. Aïcha Tazi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
9. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) incorporated
and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of
Munich (Amtsgericht München), Germany, under number HRA 98863, having its registered address at Kaiserstraße 14b,
80801 Munich, Germany, as a new shareholder of the Company (hereinafter referred to as “Holtzbrinck Fund V”,
becoming the holder of two thousand eighty four (2,084) series A5 shares,
here represented by Mrs. Aïcha Tazi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Parties sub 1. to 4. are the current shareholders (the “Existing Shareholders”) of Bonativo Global S.à r.l., a limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, having its registered address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg) under number
B 188606 and incorporated pursuant to a notarial deed on 1 July 2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2575 dated 23 September 2014 and lastly amended pursuant to a notarial deed dated 28 May 2015,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2041 dated 11 August 2015 (the “Company”).
The Existing Shareholders, represented as stated above, representing the entire share capital and having waived any
notice requirement, the general meeting of the shareholders of the Company is regularly constituted and may validly
deliberate on the following agenda whereby the appearing parties sub 5. to 9. participate and vote for the purpose of agenda
point 9 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Change of the name of the Company from “Bonativo Global S.à r.l.” to “Convenience Food Group S.à r.l.”;
2. Decision to create three (3) additional classes of shares in the share capital of the Company:
- series A4 shares;
- series A5 shares; and
- series A6 shares.
3. Admission of TEC Global Invest XI GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local
court of Duisburg (Amtsgericht Duisburg), Germany, under number HRB 23773, having its registered address at
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany, as a new shareholder of the Company (hereinafter referred to
as “TEC XI”);
4. Admission of Rocket Club I, S.C.S., a Luxembourg common limited partnership (société en commandite simple)
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register (Registre
de Commerce et des Sociétés) under number B 198814, having its business address at 32-36 boulevard d’Avranches, L-1160
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as “Eiffel”);
5. Admission of TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company, incorporated and existing
under the laws of Bermuda, having its registered address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11,
as a new shareholder of the Company (hereinafter referred to as “TJT”);
6. Admission of Mr. David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57
th
Street - 33
rd
Floor, New York,
New York 10019, United States of America, as a new shareholder of the Company (hereinafter referred to as “DZ”);
7. Admission of HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft)
incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local
court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under number HRA 98863, having its registered address at Kaiserstraße
14b, 80801 Munich, Germany, as a new shareholder of the Company (hereinafter referred to as “Holtzbrinck Fund V” and
collectively with TEC XI, Eiffel, TJT and DZ as the “New Shareholders);
8. Increase of the Company’s share capital by an amount of twenty three thousand four hundred seventy one euro (EUR
23,471) so as to raise it from its current amount of eighteen thousand one hundred twenty five euro (EUR 18,125) up to
forty-one thousand five hundred ninety six euro (EUR 41,596) by issuing:
- six thousand eight hundred and two (6,802) Series A4 shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.00);
51755
L
U X E M B O U R G
- three thousand seven hundred fifty-two (3,752) Series A5 shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.00);
and
- twelve thousand nine hundred seventeen (12,917) series A6 shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.00).
9. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth
read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at forty one thousand five hundred ninety-six euros (EUR 41,596.00), represented
by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 two thousand seven hundred and eight (2,708) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 two thousand and eighty-three (2,083) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 eight hundred thirty-four (834) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series A3 Shares”),
5.1.5 six thousand eight hundred and two (6,802) series A4 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”),
5.1.6 three thousand seven hundred fifty-two (3,752) series A5 shares, each with a nominal value of one euro (EUR
1.00) each (hereinafter “Series A5 Shares”) and
5.1.7 twelve thousand nine hundred seventeen (12,917) series A6 shares, each with a nominal value of one euro (EUR
1.00) each (hereinafter “Series A6 Shares”; the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares, the Series
A4 Shares, the Series A5 Shares and the Series A6 Shares jointly also the “Series A Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2. The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amend-ment of these articles of association.”
10. Subsequent amendment of article seven point four sub-point 1 (7.4.1) of the articles of association of the Company,
so that it shall henceforth read as follows:
“ 7.4. Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions
of any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1. in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet AG
("Rocket"), the shareholder TEC Global Invest XI GmbH ("TEC"), the shareholder TEC Global Invest XII GmbH (“TEC
XII”), the shareholder HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”), the shareholder HV Holtzbrinck Ventures
Fund V GmbH & Co. KG (“Holtzbrinck V”), the shareholder Rocket Club I, S.C.S. (“Eiffel”), the shareholder TJT (B)
(Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”), the shareholder David W. Zalaznick (“DZ”) and the shareholder Kaltroco
Limited (“Kaltroco”, jointly with Rocket, TEC, TEC XII, Holtzbrinck, Holtzbrinck V, Eiffel, TJT and DZ the "Investors"
and each also an "Investor") to a company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German
Stock Corporation Act (AktG);”
11. Amendment of article twenty four (24) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read
as follows:
“ Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board (“Advisory Board”). It shall consist of four (5) voting members. The
shareholders may by way of unanimous shareholders’ consent increase or decrease the number of voting members of the
Advisory Board.
24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders’ consent.
24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s respective
appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
24.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, each having four (4) votes, shall be nominated by Rocket in its
sole discretion;
24.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by TEC XII in its sole
discretion; and
51756
L
U X E M B O U R G
24.3.3 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Holtzbrinck in its sole
discretion; and
24.3.4 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Holtzbrinck V in its
sole discretion.
24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other
representative of the respective party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Rocket, TEC XII, Holtzbrinck and Holtzbrinck V are entitled to appoint one substitute member
for each Advisory Board member.
24.5 The Advisory Board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
24.6 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall
be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide for further
provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with
the simple majority of votes cast. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar
quarter.
24.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.”
12. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the undersigned notary to enact, the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Existing Shareholders decide to change the name of the Company from “Bonativo Global S.à r.l”. to “Convenience
Food Group S.à r.l.”
<i>Second Resolutioni>
The Existing Shareholders decide to create three (3) additional classes of shares in the share capital of the Company:
- series A4 shares;
- series A5 shares; and
- series A6 shares.
<i>Third Resolutioni>
The Existing Shareholders agree to the admission of TEC XI as new shareholder of the Company.
<i>Fourth Resolutioni>
The Existing Shareholders agree to the admission of Eiffel as new shareholder of the Company.
<i>Fifth Resolutioni>
The Existing Shareholders agree to the admission of TJT as new shareholder of the Company.
<i>Sixth Resolutioni>
The Existing Shareholders agree to the admission of DZ as new shareholder of the Company.
<i>Seventh Resolutioni>
The Existing Shareholders agree to the admission of Holtzbrinck Fund V as new shareholder of the Company.
<i>Eight Resolutioni>
The Existing Shareholders decide to increase the Company’s share capital by an amount of twenty three thousand four
hundred seventy one euro (EUR 23,471) so as to raise it from its current amount of eighteen thousand one hundred twenty
five euro (EUR 18,125) up to forty-one thousand five hundred ninety six euro (EUR 41,596) by issuing:
- six thousand eight hundred and two (6,802) series A4 shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.00) (“Series
A4 Shares”);
- three thousand seven hundred fifty-two (3,752) series A5 shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.00)
(“Series A5 Shares”); and
- twelve thousand nine hundred seventeen (12,917) series A6 shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.00)
(“Series A5 Shares”).
<i>Subscriptioni>
The twenty three thousand four hundred seventy one (23,471) issued shares (the “New Shares”) have been duly sub-
scribed for an aggregate amount of twenty three thousand four hundred seventy one euro (EUR 23,471) as follows:
- Rocket, here represented as aforementioned, subscribed for one (1) Series A4 Share and twelve thousand nine hundred
seventeen (12.917) Series A6 Shares;
51757
L
U X E M B O U R G
- TEC XI, here represented as aforementioned, subscribed for four thousand six hundred ninety (4,690) Series A4 Shares;
- Holtzbrinck Fund VI, here represented as aforementioned, subscribed for one thousand one hundred seventy two
(1,172) Series A4 Shares;
- Eiffel, here represented as aforementioned, subscribed for four hundred sixty nine (469) Series A4 Shares and eight
hundred thirty four (834) Series A5 Shares;
- TJT, here represented as aforementioned, subscribed for to hundred thirty five (235) Series A4 Shares and four hundred
seventeen (417) Series A5 Shares;
- DZ, here represented as aforementioned, subscribed for to hundred thirty five (235) Series A4 Shares and four hundred
seventeen (417) Series A5 Shares; and
- Holtzbrinck Fund V, here represented as aforementioned, subscribed for two thousand eighty four (2,084) Series A5
Shares.
<i>Paymenti>
The subscribed aforementioned New Shares have been entirely paid up through:
(i) a contribution in cash in the aggregate amount of twenty three thousand four hundred seventy one euro (EUR 23,471);
and
(ii) a contribution in kind having an aggregate value of at least thirty nine thousand two hundred forty one euro (EUR
39,241) consisting of (a) twenty two thousand five hundred seventy two (22,572) shares which represent the entire share
capital of ShopWings Global S.à.r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg) under number B 188604, having its registered address at 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (“ShopWings”) and which is held as follows:
- Rocket holding twelve thousand five hundred (12,500) common shares in ShopWings;
- Eiffel holding six hundred ninety five (695) series A1 shares in ShopWings;
- TJT holing three hundred forty eight (348) series A2 shares in ShopWings;
- DZ holding three hundred forty eight (348) series A2 shares in ShopWings;
- TEC XI holding six thousand nine hundred forty five (6,945) series A3 shares in ShopWings; and
- Holtzbrinck Fund VI holding one thousand seven hundred thirty six (1,736) series A4 shares in ShopWings; and
(b) sixteen thousand six hundred sixty nine (16,669) shares which represent the entire share capital of Digital Services
XXX S.à.r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et
des Sociétés du Luxembourg) under number B 188474, having its registered address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg (“Eatfirst”) and which is held as follows:
- Rocket holding twelve thousand five hundred (12,500) common shares and four hundred seventeen (417) series A1
shares in Eatfirst;
- Holtzbrinck Fund V holding two thousand eighty four (2,084) series A1 shares in Eatfirst;
- Eiffel holing eight hundred thirty four (834) series A2 shares in Eatfirst;
- TJT holding four hundred seventeen (417) series A3 shares in Eatfirst; and
- DZ holding four hundred seventeen (417) series A3 shares in Eatfirst.
The proofs of the existence and of the value of the above contributions have been produced to the undersigned notary.
The total contribution in the aggregate amount of sixty two thousand seven hundred twelve euro (EUR 62,712) consists
of:
(i) twenty three thousand four hundred seventy one euro (EUR 23,471) allocated to the share capital of the Company,
and
(ii) thirty nine thousand two hundred forty one euro (EUR 39,241) allocated to the share premium account of the
Company.
<i>Ninth Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders of the Company decides to amend
article five (5) of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as stated in the agenda.
<i>Tenth Resolutioni>
The general meeting of shareholders of the Company decides to amend article seven point four sub-point 1 (7.4.1) of
the articles of association of the Company, which shall henceforth read as stated in the agenda.
<i>Eleventh Resolutioni>
The general meeting of shareholders of the Company decides to amend article twenty four (24) of the articles of asso-
ciation of the Company, so that it shall henceforth read as stated in the agenda.
51758
L
U X E M B O U R G
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 2,400.-
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
proxyholder and in case of discrepancy between the English and the German texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizigsten Dezember.
Vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet SE, eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) gegründet und bestehend nach deutsch-
em Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662
B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland (im Folgenden „Rocket“),
Inhaberin von zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen und sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteilen der
Serie A1 und zukünftige Inhaberin von einem (1) Anteil der Serie A4 und zwölftausendneunhundertsiebzehn (12.917)
Anteilen der Serie A6,
hier vertreten durch Frau Aïcha Tazi, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
2. TEC Global Invest XII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24728, mit Sitz
in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland (im Folgenden „TEC XII“),
Inhaberin von zweitausenddreiundachtzig (2.083) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Frau Aïcha Tazi, Privatbeamtin,geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 191426, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg (im Folgenden „Holtzbrinck Fund VI“),
Inhaberin von zweitausenddreiundachtzig (2.083) Anteilen der Serie A2 und zukünftige Inhaberin von eintausendein-
hundertzweiundsiebzig (1.172) Anteilen der Serie A4,
hier vertreten durch Frau Aïcha Tazi, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
4. Kaltroco Limited, eine Gesellschaft (registered private company) gegründet in Jersey, mit Eintragungsnummer 60595,
mit Sitz in Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3AS (im Folgenden „Kaltroco“),
Inhaberin von achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Frau Aïcha Tazi, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
5. TEC Global Invest XI GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 23773, mit Sitz
in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft (im Folgenden
„TEC XI“),
zukünftige Inhaberin von viertausendsechshundertneunzig (4.690) Anteilen der Serie A4.
hier vertreten durch Frau Aïcha Tazi, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
6. Rocket Club I, S.C.S., eine luxemburgische Kommanditgesellschaft gegründet und bestehend nach den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels register, Luxembourg, unter der Nummer B 198814, mit Sitz in
32-36 Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft
(im Folgenden „Eiffel“),
zukünftige Inhaberin von vierhunderneunundsechzig (469) Anteilen der Serie A4 und achthundertvierunddreißig (834)
Anteilen der Serie A5.
hier vertreten durch Frau Aïcha Tazi, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
51759
L
U X E M B O U R G
7. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft (limited liability company) gegründet und bestehend
nach dem Recht der Bermudas, mit Sitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11, als neue Ge-
sellschafterin der Gesellschaft (im Folgenden „TJT“),
zukünftige Inhaberin von zweihundertfünfunddreißig (235) Anteilen der Serie A4 und vierhundertsiebzehn (417) An-
teilen der Serie A5.
hier vertreten durch Frau Aïcha Tazi, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
8. Herr David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, ansässig in 9, West 57
th
Street - 33
rd
Floor, New York, New
York 10019, Vereinigte Staaten von Amerika, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft (im Folgenden „DZ“)
zukünftiger Inhaber von zweihundertfünfunddreißig (235) Anteilen der Serie A4 und vierhundertsiebzehn (417) An-
teilen der Serie A5.
hier vertreten durch Frau Aïcha Tazi, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
9. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft gegründet und bestehend nach
deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRA
98863, mit Sitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft (im Fol-
genden „Holtzbrinck Fund V“;
zukünftige Inhaberin von zweitausendvierundachzig (2.084) Anteilen der Serie A5.
hier vertreten durch Frau Aïcha Tazi, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht
Besagte Vollmachten, welche von der/dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur
paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die aufgeführten Parteien von 1. bis 4. sind die derzeitigen Gesellschafter (die „Bestehenden Gesellschafter“) der Bo-
nativo Global S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der
Nummer B 188606, gegründet am 1. Juli 2014 gemäß einer notariellen Urkunde, welche am 23. September 2014 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2575, veröffentlicht und zuletzt am 28. Mai 2015 gemäß einer
notariellen Urkunde geändert wurde, welche am 11. August 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 2041, veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft”).
Die Bestehenden Gesellschafter, wie oben dargelegt vertreten, vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben
auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet, sodass die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ordnungsgemäß zu-
sammengekommen ist und wirksam über die folgende Tagesordnung verhandeln kann, wobei die erschienen Parteien von
5. bis 9. bezüglich des Punktes 9 auf der Tagesordnung und ausschließlich ff. teilnehmen und wählen:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Bonativo Global S.à r.l.“ in „Convenience Food Group S.à r.l.“;
2. Beschluss bezüglich der Schaffung von drei (3) weiteren Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft:
- Anteile der Serie A4;
- Anteile der Serie A5; und
- Anteile der Serie A6.
3. Aufnahme der TEC Global Invest XI GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend
nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB
23773, mit Sitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft
(im Folgenden „TEC XI“);
4. Aufnahme der Rocket Club I, S.C.S., eine luxemburgische Kommanditgesellschaft gegründet und bestehend nach
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels register, Luxembourg, unter der Nummer B
198814, mit Sitz in 32-36 Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als neue Gesell-
schafterin der Gesellschaft (im Folgenden „Eiffel“);
5. Aufnahme der TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., einer Gesellschaft (limited liability company) gegründet
und bestehend nach dem Recht der Bermudas, mit Sitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11,
als neue Gesellschafterin der Gesellschaft (im Folgenden „TJT“);
6. Aufnahme von Herrn David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, ansässig in 9, West 57
th
Street - 33
rd
Floor,
New York, New York 10019, Vereinigte Staaten von Amerika, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft (im Folgenden
„DZ“);
7. Aufnahme der HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, einer Kommanditgesellschaft gegründet und
bestehend nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der
51760
L
U X E M B O U R G
Nummer HRA 98863, mit Sitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, als neue Gesellschafterin der Gesell-
schaft (im Folgenden „Holtzbrinck Fund V“ und zusammen mit TEC XI, Eiffel, TJT und DZ die „Neuen Gesellschafter“);
8. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtzehntausendeinhundert-
fünfundzwanzig Euro (EUR 18.125) um einen Betrag von dreiundzwanzigtausendvierhunderteinundsiebzig Euro (EUR
23.471) auf einen Betrag von einundvierzigtausendfünfhundertsechsundneunzig Euro (EUR 41.596) durch die Ausgabe
von:
- sechstausendachthundertzwei (6.802) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00);
- dreitausendsiebenhundertzweiundfünfzig (3.752) Anteilen der Serie A5 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00); und
- zwölftausendneunhundertsiebzehn (12.917) Anteilen der Serie A6 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00).
9. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einundvierzigtausendfünfhundertsechsundneunzig Euro (EUR
41.596,00), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 zweitausendsiebenhundertacht (2.708) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (im Folgenden die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 zweitausenddreiundachtzig (2.083) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(im Folgenden die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(im Folgenden die „Anteile der Serie A3“),
5.1.5 sechstausendachthundertzwei (6.802) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (im Folgenden die „Anteile der Serie A4“),
5.1.6 dreitausendsiebenhundertzweiundfünfzig (3.752) Anteilen der Serie A5 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (im Folgenden die „Anteile der Serie A5“), und
5.1.7 zwölftausendneunhundertsiebzehn (12.917) Anteilen der Serie A6 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (im Folgenden die „Anteile der Serie A6“; die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2, die Anteile der
Serie A3, die Anteile der Serie A4, die Anteile der Serie A5 und die Anteile der Serie A6 gemeinsam auch die „Anteile
der Serie A“).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
10. Anschließende Änderung des Artikels sieben Punkt vier Punkt eins (7.4.1) der Satzung der Gesellschaft, welcher
nunmehr wie folgt lautet:
„ 7.4. Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten oder -pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von
Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter
Rocket Internet SE („Rocket“), den Gesellschafter TEC Global Invest XI GmbH („TEC“), den Gesellschafter TEC Global
Invest XII GmbH („TEC XII“), den Gesellschafter HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“), den Gesell-
schafter HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG („Holtzbrinck V“), den Gesellschafter Rocket Club I, S.C.S.
(„Eiffel“), den Gesellschafter TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT“), den Gesellschafter David W. Zalaz-
nick („DZ“) und den Gesellschafter Kaltroco Limited („Kaltroco“, zusammen mit Rocket, TEC, TEC XII, Holtzbrinck,
Holtzbrinck V, Eiffel, TJT und DZ die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor
verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);“
11. Änderung des Artikels vierundzwanzig (24) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat („Beirat“). Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-
sellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.
24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-
schafter festlegen und/oder verändern.
51761
L
U X E M B O U R G
24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
24.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit je vier (4) Stimmen werden von Rocket nach eigenem
Ermessen ernannt;
24.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von TEC XII nach eigenem Ermessen
ernannt; und 24.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Holtzbrinck nach eigenem
Ermessen ernannt; und 24.3.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Holtzbrinck
V nach eigenem Ermessen ernannt.
24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von einem anderen Mitglied des Beirats oder einem Vertreter der jeweiligen Partei
vertreten werden. In diesem Fall muss bei der jeweiligen Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden.
Zu diesem Zweck sind Rocket, TEC XII, Holtzbrinck und Holtzbrinck V berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes Beirats-
mitglied zu ernennen.
24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimmbe-
rechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann gegebenenfalls weitere
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalen-
derquartal.
24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.“
12. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter beschließen, den Namen der Gesellschaft von „Bonativo Global S.à r.l.“ in „Conveni-
ence Food Group S.à r.l.“ zu ändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter beschließen, drei (3) weitere Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft
zu schaffen:
- Anteile der Serie A4;
- Anteile der Serie A5; und
- Anteile der Serie A6.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter genehmigen die Aufnahme von TEC XI als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter genehmigen die Aufnahme von Eiffel als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter genehmigen die Aufnahme von TJT als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter genehmigen die Aufnahme von DZ als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter genehmigen die Aufnahme von Holtzbrinck Fund V als neue Gesellschafterin der
Gesellschaft.
<i>Achter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter beschließen, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von achtzehntausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 18.125) um einen Betrag von dreiundzwanzigtausendvier-
hunderteinundsiebzig Euro (EUR 23.471) auf einen Betrag von einundvierzigtausend fünfhundertsechsundneunzig Euro
(EUR 41.596) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:
- sechstausendachthundertzwei (6.802) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(die „Anteile der Serie A4“);
- dreitausendsiebenhundertzweiundfünfzig (3.752) Anteilen der Serie A5 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A5“); und
51762
L
U X E M B O U R G
- zwölftausendneunhundertsiebzehn (12.917) Anteilen der Serie A6 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A6“).
<i>Zeichnungi>
Die dreiundzwanzigtausendvierhunderteinundsiebzig (23.471) ausgegebenen Anteile (die „Neuen Anteile“) wurden
ordnungsgemäß zu einem Gesamtbetrag von dreiundzwanzigtausendvierhunderteinundsiebzig Euro (EUR 23.471) wie
folgt gezeichnet:
- Rocket, hier wie oben dargelegt vertreten, hat einen (1) Anteil der Serie A4 und zwölftausendneunhundertsiebzehn
(12.917) Anteile der Serie A6 gezeichnet;
- TEC XI, hier wie oben dargelegt vertreten, hat viertausendsechshundertneunzig (4.690) Anteile der Serie A4 gezeich-
net;
- Holtzbrinck Fund VI, hier wie oben dargelegt vertreten, hat eintausendeinhundertzweiundsiebzig (1.172) Anteile der
Serie A4 gezeichnet;
- Eiffel, hier wie oben dargelegt vertreten, hat vierhundertneunundsechzig (469) Anteile der Serie A4 und achthundert-
vierunddreißig (834) Anteile der Serie A5 gezeichnet;
- TJT, hier wie oben dargelegt vertreten, hat zweihundertfünfunddreißig (235) Anteile der Serie A4 und vierhundert-
siebzehn (417) Anteile der Serie A5 gezeichnet;
- DZ, hier wie oben dargelegt vertreten, hat zweihundertfünfunddreißig (235) Anteile der Serie A4 und vierhundert-
siebzehn (417) Anteile der Serie A5 gezeichnet; und
- Holtzbrinck Fund V, hier wie oben dargelegt vertreten, hat zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteile der Serie A5
gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die vorbenannten gezeichneten Neuen Anteile wurden vollständig eingezahlt durch:
(i) eine Bareinlage in Höhe eines Gesamtbetrags von dreiundzwanzigtausendvierhunderteinundsiebzig Euro (EUR
23.471); und
(ii) eine Sacheinlage im Gesamtwert von mindestens neununddreißigtausendzweihunderteinundvierzig Euro (EUR
39.241) bestehend aus
(a) zweiundzwanzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig (22.572) Anteilen, die das gesamte Gesellschaftskapital der
ShopWings Global S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxem-
burg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 188604, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg („ShopWings“), vertreten, und welche wie folgt gehalten werden:
- Rocket hält zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile in ShopWings;
- Eiffel hält sechshundertfünfundneunzig (695) Anteile der Serie A1 in ShopWings;
- TJT hält dreihundertachtundvierzig (348) Anteile der Serie A2 in ShopWings;
- DZ hält dreihundertachtundvierzig (348) Anteile der Serie A2 in ShopWings;
- TEC XI hält sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteile der Serie A3 in ShopWings; und
- Holtzbrinck Fund VI hält eintausendsiebenhundertsechsunddreißig (1.736) Anteile der Serie A4 in ShopWings; und
(b) sechszehntausendsechshundertneunundsechzig (16.669) Anteilen, die das gesamte Gesellschaftskapital der Digital
Services XXX S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und be-
stehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
(Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 188474, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg („Eatfirst“), vertreten, und welche wie folgt gehalten werden:
- Rocket hält zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile und vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A1 in
Eatfirst;
- Holtzbrinck Fund V hält zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteile der Serie A1 in Eatfirst;
- Eiffel hält achthundertvierunddreißig (834) Anteile der Serie A2 in Eatfirst;
- TJT hält vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A3 in Eatfirst; und
- DZ hält vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A3 in Eatfirst.
Die Nachweise über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlagen wurden der unterzeichnenden Notarin
erbracht.
Die gesamte Einlage in Höhe von einem Gesamtbetrag von zweiundsechzigtausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR
62.712) besteht aus:
(i) dreiundzwanzigtausendvierhunderteinundsiebzig Euro (EUR 23.471), die dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft
zugeführt werden, und
51763
L
U X E M B O U R G
(ii) neununddreißigtausendzweihunderteinundvierzig Euro (EUR 39.241), die dem Agio der Gesellschaft zugeführt
werden.
<i>Neunter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses beschließt die Generalversammlung der Gesellschofter, Artikel fünf (5) der
Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Gesellschofter beschließt, Artikel sieben Punkt vier Punkt eins (7.4.1) der Satzung der
Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.
<i>Elfter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Gesellschofter beschließt Artikel vierundzwanzig (24) der Satzung der Gesellschaft zu
ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.400,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche der Notarin mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Gezeichnet: A. TAZI, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/334. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25. Januar 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016055690/578.
(160015647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Signal Credit Opportunities (Lux) Investco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 320.033,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F: Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 201.161.
In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
Appeared the following:
Signal Credit Opportunities Fund L.P., a limited partnership under the laws of Jersey, with registered office at 13 Castle
Street, St Helier, Jersey JE4 5UT, Jersey, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services Commission under
number 2051 (the "Sole Shareholder").
hereby represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Pétange (Grand
Duchy of Luxembourg), pursuant to a power of attorney, which, after having been signed ne varietur by its holder and the
undersigned notary, will be appended to the present deed for registration purposes.
The appearing party, represented as indicated above, declares that it currently holds the entire share capital of Signal
Credit Opportunities (Lux) Investco I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed
by the laws of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 23 October 2015, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, with a share capital of twelve thousand five hundred
euros (EUR 12,500.-), with its registered office at 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 201161 (the "Company"). The
Company's articles of association have not been amended since the incorporation of the Company.
51764
L
U X E M B O U R G
The appearing party, represented as indicated above, further declares that the agenda on which resolutions are to be
passed is as follows:
<i>Agendai>
1. Creation of two (2) classes of shares, namely class A and class B shares, in accordance with such terms and conditions
as set forth in the amended articles of association to be adopted pursuant to the resolution under item 6. below.
2. Re-classification of the twelve thousand five hundred (12,500) existing shares in the share capital of the Company as
class A ordinary shares;
3. Increase of the Company's share capital by the amount of three hundred seven thousand five hundred thirty-three
euros (EUR 307,533.-), thereby raising it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)
to three hundred twenty thousand thirty-three euros (EUR 320,033).
4. Issuance of three hundred seven thousand five hundred thirty-three (307,533) new class B shares, with a nominal
value of one euro (EUR 1.-) each.
5. Subscription by the Sole Shareholder to three hundred seven thousand five hundred thirty-three (307,533) new class
B shares of the Company with a par value of one euro (EUR 1.-) each and payment in full of the par value of such new
shares, along with a total share premium in the amount of sixty-six eurocents (EUR 0.66) by the Sole Shareholder by means
of a contribution in kind consisting of a claim of two hundred twenty-two thousand five hundred pound sterling and sixty
pence (GBP 222,500.60) held by the Sole Shareholder against the Company, of which the equivalent in euro is three hundred
seven thousand five hundred thirty-three euros and sixty-six cents (EUR 307,533.66) per the exchange rate published by
the European Central Bank on 10 December 2015, and allocation of (i) an amount equal to the aggregate nominal value of
the new class B shares to the share capital account of the Company, and (ii) the balance to the share premium account
related to the class A shares of the Company.
6. Amendment of article 6 of the Company's articles of association in order to reflect the resolutions to be adopted under
the above items.
7. Amendment of article 11 of the Company's articles of association.
8. Amendment of article 12, third paragraph, of the Company's articles of association.
Thereafter, the appearing party, duly represented as indicated above, passes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to create two (2) classes of shares, namely class A ordinary shares and class B "tracker"
shares, in accordance with such terms and conditions as set forth in the amended articles of association to be adopted
pursuant to the fifth resolution below.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to reclassify the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company
into twelve thousand five hundred (12,500) class A ordinary shares, with a par value of one euro (EUR 1) each.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of three hundred seven thousand
five hundred thirty-three euros (EUR 307,533.-), thereby raising it from its current amount of twelve thousand five hundred
euros (EUR 12,500.-), to three hundred twenty thousand thirty-three euros (EUR 320,033).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to issue three hundred seven thousand five hundred thirty-three (307,533) new class B
shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Shares").
<i>Fifth resolution - Subscription / Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as indicated above, declares that it subscribes to the New Shares and fully
pays up the par value of these New Shares as well as an aggregate share premium of sixty-six eurocents (EUR 0.66) by
means of a contribution in kind consisting of a claim of three hundred seven thousand five hundred thirty-three euros and
sixty-six cents (EUR 307,533.66) held by the Sole Shareholder against the Company (the "Contribution").
The Sole Shareholder, represented as indicated above, declares that it is the sole holder and owner of the Contribution
and that there are no impediments to the transfer thereof to the Company. Proof of the Sole Shareholder's title to the
Contribution has been shown to the Company.
The Sole Shareholder, represented as indicated above, further declares that the value of the Contribution has been
certified at two hundred twenty-two thousand five hundred pound sterling and sixty pence (GBP 222,500.60), of which the
equivalent in euro is three hundred seven thousand five hundred thirty-three euros and sixty-six cents (EUR 307,533.66)
per the exchange rate published by the European Central Bank on 10 December 2015, in a declaration of contribution
signed by the representative of the Sole Shareholder. The value of the Contribution has been further confirmed in a decla-
ration of recipient signed by the Company (the "Declaration").
51765
L
U X E M B O U R G
A copy of the Declaration shall remain attached hereto for the purposes of registration.
The Sole Shareholder resolved to allocate the Contribution as to the aggregate nominal value of the New Shares to the
issued share capital, and the balance to the share premium account related to the class A shares of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Company's articles of association, which shall forthwith read
as follows:
" Art. 6. The Company's capital is set at three hundred twenty thousand thirty-three euro (EUR 320,033) represented by
(i) twelve thousand five hundred (12,500) class A ordinary shares, each with a par value of one euro (EUR 1) and (ii) three
hundred seven thousand five hundred thirty-three (307,533) class B "tracker" shares each with a par value of one euro
(EUR 1), all fully subscribed and entirely paid up.
Subject to the fifth paragraph of Article 11 of these articles of incorporation, the Class B Shares will track the Company's
investment (whether in the form of shares or otherwise), from time to time, in Signal Credit Opportunities (Lux) Investco
II S.à r.l. ("Luxco 2") as well as any asset(s) acquired through substitution thereof (including for the avoidance of doubt
but without limitation any replacement and/or novation) (the "Substitution Asset").
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the member(s) adopted in the manner required
for amendment of these articles of incorporation.
The Company will recognise only one holder in respect of a share. In case of joint ownership, the Company may suspend
the exercise of any right related thereto until one person has been designated to represent the joint owners towards the
Company.
In addition to the share capital, a premium account and/or a capital contribution account (compte 115 "Apport en capitaux
propres non rémunéré par des titres") may be set up. A share premium paid upon issuance of tracker shares of a specific
class of shares or, as the case may be, a contribution made to the capital contribution account (compte 115 "Apport en
capitaux propres non rémunéré par des titres") shall be allocated to respectively a share premium special reserve account
corresponding to the class of shares of the newly issued tracker shares or a capital contribution account (compte 115 "Apport
en capitaux propres non rémunéré par des titres") relating to the class of tracker shares as designated upon contribution, to
be denominated in each case by the corresponding letter.
The Company shall have power to redeem its own shares."
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 11 of the Company's articles of association, which shall forthwith read
as follows:
" Art. 11. At the end of each financial year, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,
as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until
such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the
legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one
tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one in accordance
with these articles of incorporation. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide,
at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward
or transferred to an extraordinary reserve.
Where any amounts are to be distributed by the Company (subject always to the requirement to maintain a statutory
reserve prior to the Company's liquidation):
a) the holders of the Class A Shares shall, pro rata to the capital invested by each of them in respect of the Class A Shares
(par value and, as the case may be, share premium) be entitled to amounts derived from the Company's investments in the
share capital of Luxco 2 to the extent they represent an amount equal to the percentage of the cumulative outstanding
amount of any convertible preferred equity certificates issued by the Company ("CPECs") which is determined by the
Board to represent the Fixed Margin (as defined in the terms and conditions of the CPEC);
b) the holders of the Class B Shares shall, pro rata the capital invested by each of them in respect of the Class B Shares
(par value, and, as the case may be, share premium and any amounts held in the capital contribution account (compte 115
"Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres")), be entitled to a dividend equal to any amounts available for
such distribution derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale
proceeds and any other proceeds and income) from Luxco 2 or the Substitution Asset not distributed under a) above, having
satisfied any costs or expenses or other liabilities directly related to the Luxco 2 or the Substitution Asset, to be determined
by the Board; and
c) the remaining profits shall be distributed to the holders of Class A Shares."
51766
L
U X E M B O U R G
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the third paragraph of article 12 of the Company's articles of association, which
shall forthwith read as follows:
" Art. 12. The assets after deduction of the liabilities shall be distributed to the members in accordance with article 11
of these articles of incorporation."
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party hereto,
the present deed has been drawn up in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party
in the event of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg), on the date indicated at the
beginning of this document.
This deed having been read to the appearing party's proxyholder, whose full name, civil status and residence are known
to the notary, the said person signed together with the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le quinzième jour de décembre,
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Signal Credit Opportunities Fund L.P., une société en commandite constituée selon les lois du Jersey, ayant son siège
social à 13 Castle Street, St Helier, Jersey JE4 5UT, Jersey, Les îles Anglo-Normandes et enregistrée auprès de la com-
mission des services financiers de Jersey sous le numéro 2051 (l'"Associé Unique"),
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration qui, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire
instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, déclare détenir la totalité des parts sociales de Signal Credit
Opportunities (Lux) Investco I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée le 23 octobre
2015 par un acte notarié du notaire instrumentant et en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, ayant un capital social de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), ayant son siège social à 51, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201161 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis
la constitution de la Société.
La partie comparante, représenté comme mentionné ci-dessus, déclare avoir été informé des résolutions à prendre sur
base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Création de deux (2) nouvelles classes de parts sociales, notamment les parts sociales "traçantes" de classe A et les
parts sociales "traçantes" de classe B, conformément aux modalités et conditions énoncées dans les statuts modifiés à
adopter en fonction des résolutions sous le point 6 ci-dessous.
2. Reclassement des douze mille cinq cent (12.500) parts sociales existantes dans le capital social de la Société en parts
sociales "traçantes" de classe A.
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent sept mille cinq cent trente-trois euros (307.533
EUR), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) à trois cent vingt mille trente-
trois euros (320.033 EUR).
4. L'émission d'un nombre de trois cent sept mille cinq cent trente-trois (307.533) nouvelles parts sociales "traçantes"
de classe B avec une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.
5. Souscription par l'Associé Unique à trois cent sept mille cinq cent trente-trois (307.533) nouvelles parts sociales
"traçantes" de classe B de la Société avec une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune et libération de la totalité de
la valeur nominale de ces nouvelles parts sociales, en relation avec une prime d'émission d'un montant de soixante-six
centimes d'euros (0,66 EUR) par l'Associé Unique par voie d'un apport en nature consistant en une créance de deux cent
vingt-deux mille cinq cents livres sterling et soixante pence (222.500,60 GBP) détenue par l'Associé Unique contre la
Société, dont l'équivalent en euros est de trois cent sept mille cinq cent trente-trois euros et soixante-six centimes
(307.533,66 EUR) suivant le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 10 décembre 2015, et l'allocation
(i) d'un montant égal à la valeur nominale totale des nouvelles parts sociales de classe B au capital de la Société, et (ii) du
restant au compte primes d'émission relatif aux parts sociales de classe A de la Société.
6. Modification de l'article 6 des statuts de la Société, afin de refléter les décisions adoptées ci-dessous.
7. Modification de l'article 11 des statuts de la Société.
8. Modification du paragraphe 3 de l'article 12 des statuts de la Société.
Par la suite, la partie comparante, dûment représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a pris les résolutions suivantes:
51767
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de créer deux (2) nouvelles classes de parts sociales, notamment une classe A de parts sociales
ordinaires et une classe B de parts sociales "traçantes", conformément aux modalités et conditions énoncées dans les statuts
modifiés à adopter en fonction de la résolution cinq ci-dessous.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de reclasser les douze mille cinq cent (12.500) parts sociales existantes de la Société en douze
mille cinq cent (12.500) parts sociales ordinaires de classe A, avec une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent sept mille cinq cent trente-
trois euros (307.533 EUR), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) à trois
cent vingt mille trente-trois euros (320.033 EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'émettre un nombre de trois cent sept mille cinq cent trente-trois (307.533) nouvelles parts
sociales de classe B avec une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales").
<i>Cinquième résolution - Souscription et paiementi>
Sur ce, l'Associé Unique, représenté tel qu'indiqué ci-dessus, déclare qu'il souscrit aux Nouvelles Parts Sociales et qu'il
libère la valeur nominale de ces Nouvelles Parts Sociales ainsi qu'une prime d'émission totale qui s'élève à soixante-six
centimes d'euros par voie d'un apport en nature consistant en une créance de trois cent sept mille cinq cent trente-trois euros
et soixante-six centimes (307.533,66 EUR) détenue par l'Associé Unique contre la Société (l'"Apport").
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il est le seul détenteur et propriétaire de l'Apport et
qu'il n'existe aucun obstacle au transfert de celui-ci à la Société. La preuve du titre à l'Apport de l'Associé Unique a été
apportée à la Société.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare ensuite que la valeur de l'Apport a été certifiée à deux
cent vingt-deux mille cinq cents livres sterling et soixante pence (222.500,60 GBP), dont l'équivalent en euros est de trois
cent sept mille cinq cent trente-trois euros et soixante-six centimes (307.533,66 EUR) selon le taux de change publié par
la Banque Centrale Européenne le 10 décembre 2015 dans une déclaration d'apport signée par le représentant de l'Associé
Unique. La valeur de l'Apport a été ensuite confirmée dans une déclaration du bénéficiaire signée par la Société (la "Dé-
claration").
Une copie de la Déclaration sera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.
L'Associé Unique a décidé d'allouer l'Apport concernant la valeur nominale totale des Nouvelles Parts Sociales au capital
de la Société, et le restant au compte primes d'émission relatif aux parts sociales de classe A de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent vingt mille trente-trois euros (320.033 EUR) représenté par (i) douze mille
cinq cent (12.500) parts sociales ordinaires de classe A, avec une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune et (ii) trois
cent sept mille cinq cent trente-trois (307.533) de parts sociales "traçantes" de classe B, avec une valeur nominale d'un euro
(1.- EUR) chacune, toutes complètement souscrites et entièrement libérées.
Selon le paragraphe cinq de l'article 11 de ces Statuts, les Parts Sociales de Classe B Classe tracent l'investissement de
la Société (ou bien en la forme de parts sociales ou autres), le cas échéant, dans le capital social de Signal Credit Oppor-
tunities (Lux) Investco II S.à r.l. ("Luxco 2") ainsi que tous les avoirs acquis par substitution (y compris, pour éviter tout
doute, mais pas exclusivement, tout remplacement et/ou novation) (les "Avoirs de Substitution").
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des Associés adoptée
selon la manière requise pour modifier ces Statuts.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si la propriété de la part sociale est indivise, la Société
pourra suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée pour
représenter les indivisaires à l'égard de la Société.
En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission et/ou un compte de contribution de capital
(compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres"). Une prime d'émission payée pour l'émission de
parts sociales traçantes d'une classe de parts sociales particulière ou, selon le cas, un apport effectué sur le compte de
contribution de capital (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") sera alloué à respectivement
un compte de primes d'émission correspondant à la classe de parts sociales des parts sociales traçantes nouvellement émises
ou un compte de contribution de capital (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") relatif à la
classe de parts sociales traçantes telle que désignée lors de l'apport, à dénommer par la lettre correspondante.
La Société a le pouvoir de racheter ses propres parts sociales."
51768
L
U X E M B O U R G
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 11. A la fin de chaque année sociale, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan
et un compte de profits et de pertes.
L'excédent favorable du compte de profits et de pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pourcent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à
ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la
réserve légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pourcent reprendrait jusqu'à
ce que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés conformément aux
présents statuts. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois affé-
rentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds
de réserve extraordinaire.
Lorsque des sommes sont distribués par la Société (pourvu toujours que les exigences pour maintenir une réserve
statutaire avant la liquidation de la Société):
a) les détenteurs de Parts Sociales de Classe A, au prorata de l'investissement par chacun d'eux à l'égard des Parts Sociales
de Classe A (valeur nominale et, le cas échéant, prime d'émission) ont droit aux sommes issues des investissements de la
Société dans le capital social de Luxco 2, dans la mesure où elles sont équivalentes au pourcentage des sommes cumulées
dues de tout titre de participation préférentiel convertible (convertible preferred equity certificates) émis par la Société
("CPECs"), qui est déterminé par le Conseil de gérance pour représenter la Marge Fixe (telle que définie dans les conditions
générales de la CPEC);
b) les détenteurs de Parts Sociales de Classe B, au prorata de l'investissement par chacun d'eux à l'égard des Parts Sociales
de Classe B (valeur nominale et, le cas échéant, prime d'émission et tout montant détenu au sein du compte de contribution
au capital (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres")) ont droit à un dividende égal à toute
somme disponible pour une telle distribution issu de la Société (y compris, mais pas exclusivement les dividendes, plus-
values, bénéfices de liquidation, produit de la vente et tout autre produit et revenu) de Luxco 2 ou l'Avoir de Substitution
n'ayant pas été distribué sous a) ci-dessus, ont satisfait à tous les coûts et dépenses ou autres engagements directement liés
à Luxco 2 ou l'Avoir de Substitution, déterminé par le Conseil de gérance; et
c) les profits restants seront distribués aux détenteurs de Parts Sociales de Classe A."
<i>Huitième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le paragraphe 3 de l'article 12 des Statuts de la Société, qui aura désormais la
teneur suivante:
" Art. 12. Les avoirs après déduction des engagements seront distribués aux membres conformément à l'article 11 de
ces Statuts."
Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; qu'à la demande du même mandataire, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Pétange (Grand-Duché du Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
La lecture du présent acte a été faite au mandataire de la partie comparante, dont le nom complet, l'état civil et la demeure
sont connus par le notaire, ce mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30726. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016055438/290.
(160014826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Stentex Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 181.970.
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of January.
Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch.
There appeared:
51769
L
U X E M B O U R G
Medtronic Vascular Holdings, a company governed by and existing under the laws of Ireland, having its registered office
at Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland, and registered with the Companies Registration Office in
Ireland under company number 80097 (“Medtronic”),
hereby represented by Mr. Alessandro Morini, avvocato, with professional address at 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and
Renova Innovation Technologies Limited, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the
Commonwealth of the Bahamas, having its registered office at 2
nd
Terrace West, Centreville, P.O. Box N-7755, Nassau,
the Commonwealth of the Bahamas Registrar General of the Commonwealth of The Bahamas under company number
160590 B (“Renova”, and, together with Medtronic, the “Shareholders”),
hereby represented by Mr. Alessandro Morini, named above, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
(i) That the Shareholders are the current shareholders owning all the issued and outstanding shares representing the total
share capital of Stentex Holding, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated, orga-
nized and operating under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at the Atrium Business
Park, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, and registered in the Luxembourg's trade
and companies register under the number B 181.970 (the “Company”). The company has been incorporated by deed of
Maître Francis Kesseler, notary at the time of the incorporation residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
dated 14 November 2013 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 7, of January 2
nd
, 2014 (the “Company”). The articles of association of the Company (the “Articles”) have never been amended thereafter;
(ii) That the agenda of the meeting, of which they have been beforehand informed, is the following (the “Agenda”):
1. Decision to change the number of the members of the board of managers of the Company;
2. Change the denomination of the shareholders in the Articles of Association;
3. Amendment of article 10 of the Articles of Association of the Company accordingly;
4. Acknowledgment of the resignation of certain class B and class C managers;
5. Indemnification of the resigning managers;
6. Appointment of new class B and class C managers; and
7. Miscellaneous.
(iii) That the Shareholders have waived any prior convening notice right and have unanimously adopted the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve with effect as of December 29
th
, 2015, to reduce the number of the managers
of the Company from eleven (11) to seven (7) managers, and this by means of:
- reducing the number of managers appointed upon proposal of Medtronic from five (5) to three (3) members; and
- reducing the number of managers appointed upon proposal of Renova from four (4) to two (2) members.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve, with effect as of December 29
th
, 2015, to replace the denominations of each
of the shareholders of the Company, as currently used in Art. 10 of the Articles, as follows:
- “Medtronic Vascular Holdings” shall be replaced by the denomination “the shareholder(s) belonging to the Medtronic
group of Companies”; and
- “Backston Management Limited” shall be replaced by the denomination “the shareholder(s) belonging to the Renova
group of Companies”.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of resolutions one and two above, the Shareholders unanimously resolve, with effect as of December
29
th
, 2015, to amend and restate the first four paragraphs of article 10 of the Articles of the Company, which shall then
read as follows:
“ Art. 10. The Company shall be managed by a total of seven (7) managers.
- three (3) managers shall be appointed amongst persons to be proposed by the shareholder(s) belonging to the Medtronic
group of Companies;
- two (2) managers shall be appointed amongst persons to be proposed by the shareholder(s) belonging to the Renova
group of Companies; and
- two (2) managers shall be appointed amongst independent persons.
51770
L
U X E M B O U R G
The managers will constitute a board of managers and will be appointed as class A managers (independent managers),
class B managers (managers having been proposed by the shareholder(s) belonging to the Medtronic group of Companies)
and class C managers (managers having been proposed by the shareholder(s) belonging to the Renova group of Companies).
The managers need not to be shareholders of the Company.
The managers shall be appointed, and their remuneration, if any, determined, by a resolution of the general meeting of
shareholders taken unanimously or, in case of a sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of
the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders,
resolving unanimously, or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace
any manager. Each shareholder has the right to suggest to the other shareholder(s) (such decision to be adopted unanimously
at a shareholders' meeting) the removal and/or replacement, acting reasonably, of managers appointed at its suggestion
(and the other shareholder(s) must vote as directed by the suggesting shareholder at such shareholders' meeting). Where a
manager is removed upon suggestion of its nominating shareholder in accordance with this article and Luxembourg laws,
or otherwise vacates office as a manager, that nominating shareholder shall indemnify the Company against any liability
arising from such removal or vacation from office and the other Shareholder(s) shall not withhold its signature(s) on the
required shareholder resolution and shall do all things required in its capacity as shareholder in order to give effect to the
removal of a manager or replacement of a manager.”
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to acknowledge the resignation of the following persons from the position of
manager of the Company, with effect as of December 28
th
, 2015, close of business (the “Resignation”):
- Mr. Jason R. Weidman, born on July 6
th
, 1974 in Tempe, Arizona, United States of America, professionally residing
at 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403, United States of America, resigns from the position of class B manager;
- Ms. Elena Plyasunova, born on April 1
st
, 1966 in Schuchinsk, Republic of Kazakhstan, professionally residing at
Naberezhnaya Tower C, Presnenskaya Naberezhnaya,10, Moscow 123317, Russian Federation, resigns from the position
of class B manager;
- Mr. François Monory, born on April 2
nd
, 1961 in Châtellerault, France, professionally residing at 31, Route du Molliau,
1131 Tolochenaz, Switzerland, resigns from the position of class B manager;
- Ms. Anna Ryzhova, born on July 6
th
, 1979 in Moscow, Russian Federation, professionally residing in Bleicherweg
33, 8002 Zürich, Switzerland, resigns from the position of class C manager;
- Mr. Egor Lukianov, born on June 23
rd
, 1975 in Domodedovo, Russian Federation, professionally residing at Bala-
klavsky avenue 28V building V, 117452, Moscow, Russian Federation, resigns from the position of class C manager; and
- Mr. Mikhail Lifshits, born on May 4
th
, 1963 in Moscow, Russian Federation, professionally residing at 28B Bala-
klavskiy prospect, 117452, Moscow, Russian Federation, resigns from the position of class C manager.
<i>Fifth resolutioni>
Following the Resignation, the Shareholders unanimously resolve to irrevocably undertake to indemnify and keep in-
demnified Mr. Jason R. Weidman, Ms. Elena Plyasunova, Mr. François Monory, Ms. Anna Ryzhova, Mr. Egor Lukianov
and Mr. Mikhail Lifshits against any and all liability arising out of or in any way connected with their mandate as managers
of the Company, except in the case of gross fault or negligence or willful misconduct, including all claims possibly raised
by the Company's creditors against them.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to confirm the appointment and appoint for an unlimited duration, effective as
of December 29
th
, 2015, start of business, Mr. Robert Ten Hoedt as class B manager and Mr. Alexey Moskov as class C
manager.
Therefore, the board of managers of the Company shall be composed, effective as of December 29
th
, 2015, as follows:
- Mr. Philippe Van den Avenne, accountant, born on April 29
th
, 1972 in Beloeil, Belgium, professionally residing at
33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, class A manager;
- Mr. Andrej Grossmann, accountant, born on December 19
th
, 1975 in Berlin (Germany), professionally residing at
33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, class A manager;
- Mr. Sean M. Salmon, Company Director, born on February 12
th
, 1965 in Redondo Beach, in California, United States
of America, professionally residing at 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403, United States of America, class
B manager;
- Mr. Christopher M. Cleary, born on June 15
th
, 1960 in Massachusetts, United States of America, professionally
residing at 710 Medtronic Parkway, MN 55432 Minneapolis, United States of America, class B manager;
- Mr. Robert ten Hoedt, born on September 3
rd
, 1960 in Arnhem, Netherlands, professionally residing in 31, Route du
Molliau, 1131 Tolochenaz, Switzerland, class B manager;
51771
L
U X E M B O U R G
- Mr. Maksim Goldman, Company Director, born on October 31
st
, 1971 in Moscow, Russian Federation, professionally
residing at 28B Balaklavskiy prospect, 117452, Moscow, Russian Federation, class C manager; and
- Mr. Alexey Moskov, born on May 4
th
, 1971 in Moscow, Russian Federation, professionally residing in Malaya
Ordynka Str., 39, building 1, 115184, Moscow, class C manager.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Bertrange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinze janvier.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
Medtronic Vascular Holdings, une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'Irlande, ayant son siège social
au Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande et, immatriculée au Companies Registration Office en Irlande
sous le numéro 80097 («Medtronic»),
ici représentée par Monsieur Alessandro Morini, avvocato, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée; et
Renova Innovation Technologies Limited, une société immatriculée et existant conformément aux lois de Bahamas,
ayant son siège social au 2, Terrace West, Centreville, P.O. Box N-7755, Nassau, Bahamas, inscrite auprès du Registrar
General of the Commonwealth of The Bahamas sous le numéro 160590 B («Renova» et, avec Medtronic, les «Associées»
de la Société),
ici représentée par Monsieur Alessandro Morini, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.
Lesdites procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et par le notaire soussigné demeureront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Qu'elles sont actuellement les associées détenant toutes les parts sociales représentant l'entièreté du capital social de
Stentex Holding, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 33, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 181.970, constituée suivant acte notarié de Maître Francis Kesseler, notaire demeurant à Esch-
sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 14 novembre 2013 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, le 2 janvier 2014, numéro 7 (la «Société») dont les statuts (les «Statuts») n'ont jamais été modifiés depuis;
(ii) Qu'elles ont été informées de l'ordre du jour («l'Ordre du jour») de l'Assemblée qui est le suivant:
1. Décision de modifier le nombre des membres du conseil de gérance de la Société;
2. Changement de da détermination des associées dans les Statuts de la Société;
3. Modification de l'article 10 des Statuts de la Société;
4. Acceptation des démissions de certains gérants de classe B et classe C;
5. Indemnisation des gérants démissionnant;
6. Nomination de nouveaux gérants de classe B et classe C; et
7. Divers.
(iii) Que les Associées ont renoncé à tout droit de convocation préalable et ont partant adopté à l'unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associées décident à l'unanimité de réduire, à compter du 29 décembre 2015, le nombre de gérants de la Société de
onze (11) à sept (7) gérants, et ceci par biais de:
- la réduction du nombre de gérants nommés sur proposition par Medtronic de cinq (5) à trois (3) membres; et
- la réduction du nombre des gérants nommés sur proposition par Renova de quatre (4) à deux (2) membres.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associées décident à l'unanimité, à compter du 29 décembre 2015, de remplacer la dénomination des associées de
la Société, telle qu'elle résulte actuellement des Statuts, comme suit:
- «Medtronic Vascular Holdings» sera remplacé par la dénomination «l'associée (ou les associés) appartenant au groupe
Medtronic»; et
51772
L
U X E M B O U R G
- «Backston Management Limited» sera remplacé par la dénomination «l'associée (ou les associés) appartenant au groupe
Renova».
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des deux résolutions ci-dessus, les Associées décident à l'unanimité de modifier et redresser, à compter
du 29 décembre 2015, les premiers quatre paragraphes de l'article 10 des Statuts, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 10. La Société est gérée par un total de sept (7) gérants.
- trois (3) gérants seront nommés parmi des personnes qui seront proposées par l'associée (ou les associés) appartenant
au groupe Medtronic;
- deux (2) gérants seront nommés parmi des personnes qui seront proposées par l'associée (ou les associés) appartenant
au groupe Renova; et
- deux (2) gérants seront nommés parmi des personnes externes.
Les gérants constitueront un conseil de gérance et seront nommés gérant(s) de classe A (gérants externes), gérant(s) de
classe B (gérants ayant été proposés par l'associée ou les associés appartenant au groupe Medtronic) et gérant(s) de classe
C (gérants ayant été proposés par l'associée ou les associés appartenant au groupe Renova). Les gérants ne sont pas obli-
gatoirement associés.
Les gérants sont nommés et leur rémunération, s'il y en a, est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés
prise à l'unanimité des voix, ou en cas d'associé unique, par décision de cet associé unique. La rémunération des gérants
peut être modifiée par résolution de l'assemblée générale des associés prises dans les mêmes conditions de majorité. Les
gérants peuvent être révoqués et remplacés à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés prise
à l'unanimité des voix ou par une décision de l'associé unique (selon le cas). Chaque associé, agissant de façon raisonnable,
a le droit demander à l'autre associé (ou aux autres associés) (cette décision devant être adoptée à l'unanimité lors d'une
l'assemblée générale) la révocation et/ou le remplacement des gérants nommés suite à sa proposition (l'autre associé (ou
les autres associés) devra alors voter lors de l'assemblée générale conformément aux indications données par l'associé à
l'origine de la proposition). Si un gérant est révoqué à la demande de l'associé à l'origine de sa nomination en conformité
avec ces Statuts et les lois luxembourgeoises, ou qu'il démissionne de son poste de gérant, l'associé à l'origine de sa
nomination devra décharger la Société de toute responsabilité découlant d'une telle révocation ou d'une telle démission
tandis que l'autre associé (ou les autres associés) ne devra pas refuser d'apposer sa signature sur la décision d'associé requise
et devra mettre en oeuvre tout ce qu'il est (ou qu'ils sont) supposé(s) mettre en oeuvre de par sa fonction d'associé(s) afin
de donner plein effet à la démission d'un gérant ou au remplacement d'un gérant».
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associées décident à l'unanimité d'acter la démission des personnes suivantes de la position de gérant de la Société,
à compter du 28 décembre 2015 (fermeture des bureaux) (la «Démission»):
- Monsieur Jason R. Weidman, né le 6 juillet 1974 à Tempe, Arizona, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnel-
lement à 3576 Unocal Place, Santa Rosa, Californie 95403, Etats-Unis d'Amérique, démissionne de la position de gérant
de classe B;
- Madame Elena Plyasunova, née le 1
er
avril 1966 à Schuchinsk, République du Kazakhstan, résidant professionnel-
lement à Naberezhnaya Tower C, Presnenskaya Naberezhnaya,10, Moscou 123317, Fédération de Russie, démissionne de
la position de gérante de classe B;
- Monsieur François Monory, né le 2 avril 1961 à Châtellerault, France, résidant professionnellement à 31, Route du
Molliau, 1131 Tolochenaz, Switzerland, démissionne de la position de gérant de classe B;
- Madame Anna Ryzhova, née le 6 juillet 1979 à Moscou, Fédération de Russie, résidant professionnellement à Blei-
cherweg 33, 8002 Zürich, Suisse, démissionne de la position de gérante de classe C;
- Monsieur Egor Lukianov, né le 23 juin 1975 à Domodedovo, Fédération de Russie, résidant professionnellement à
Balaklavsky avenue 28V building V, 117452, Moscou, Fédération de Russie, démissionne de la position de gérant de classe
C; et
- Monsieur Mikhail Lifshits, né le 4 mai 1963 à Moscou, Fédération de Russie, résidant professionnellement à 28B
Balaklavskiy prospect, 117452, Moscou, Fédération de Russie, démissionne de la position de gérant de classe C.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à la Démission, les Associées décident à l'unanimité d'indemniser, et de tenir indemnisées Monsieur Jason R.
Weidman, Madame Elena Plyasunova, Monsieur François Monory, Madame Anna Ryzhova, Monsieur Egor Lukianov et
Monsieur Mikhail Lifshits à l'égard de toute responsabilité découlant ou se rapportant de toute manière à leur mandat en
tant que gérants de la Société, faite exception en cas de faute lourde, négligence ou mauvaise conduite volontaire, y incluant
toute réclamation ou plainte portée à leur égard, le cas échéant, par les créanciers de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associées décident à l'unanimité de confirmer la nomination et de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur
Robert Ten Hoedt en tant que gérant de classe B, et Monsieur Alexey Moskov en tant que gérant de classe C.
51773
L
U X E M B O U R G
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société se compose, à compter du 29 décembre 2015, comme suit:
- Monsieur Philippe Van den Avenne, comptable, né le 29 April 1972 à Beloeil, Belgique, résidant professionnellement
au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de classe A;
- Monsieur Andrej Grossmann, comptable, né le 19 décembre 1975 à Berlin (Allemagne), résidant professionnellement
au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de classe A;
- Monsieur Sean M. Salmon, Directeur de Société, né le 12 février 1965 à Redondo Beach, Californie, Etats-Unis
d'Amérique, résidant professionnellement à 3576 Unocal Place, Santa Rosa, Californie 95403, Etats-Unis d'Amérique,
gérant de classe B;
- Monsieur Christopher M. Cleary, né le 15 juin 1960 à Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnel-
lement à 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432, Etats-Unis d'Amérique, gérant de classe B;
- Monsieur Robert ten Hoedt, né le 3 septembre 1960 à Arnhem, Pays-Bas, résidant professionnellement au 31, Route
du Molliau, 1131 Tolochenaz, Switzerland gérant de classe B;
- Monsieur Maksim Goldman, Directeur de Société, né le 31 octobre 1971 à Moscou, Fédération de Russie, résidant
professionnellement à 28B Balaklavskiy prospect, 117452, Moscou, Fédération de Russie, gérant de classe C; et
- Monsieur Alexey Moskov, né le 4 mai 1971 à Moscou, Fédération de Russie, résidant professionnellement à Malaya
Ordynka Str., 39, building 1, 115184, Moscou, gérant de classe C.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. MORINI, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/1299. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME
Beringen, le 21 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055447/253.
(160014398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Hasten Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 167.621.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074087/9.
(160038203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
SAF-Holland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 113.090.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of December,
Before Maître Henri Hellinckx notary residing in Luxembourg,
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of SAF-HOLLAND S.A., a Luxembourg public
limited liability company (société anonyme), with its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 113090 (the “Company”). The
Company has been incorporated on 21 December 2005 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing
in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 643 of
29 March 2006. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a
deed of Maître Henri Hellinckx, dated 15 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations -
N° 2637 on 30 September 2014.
The Meeting is opened at 10.30 a.m. by Mr. Marcus PETER, residing in Luxembourg, as representative of the Board
of Directors of the Company.
51774
L
U X E M B O U R G
The Meeting elects Mr. Peter as chairman of the Meeting (the “Chairman”).
The Chairman appoints as secretary Marie-Thérèse WICH, residing in Luxembourg, in accordance with the articles of
association of the Company (“Articles”).
The Meeting elects as scrutineer Markus LAUE, residing in Eschborn, without dissenting vote.
<i>Agendai>
1. Resolution that the remaining amount of the currently existing Authorised Share Capital I of the Company (EUR
164,949.63) is permitted to be used by the Board of Directors as follows.
An amount of up to EUR 45,361.11 representing 4,536,111 newly issued shares and being 10% of the currently issued
share capital of the Company (“Special Amount”) may be issued by the Board of Directors without such issue being subject
to any preferential subscription rights of existing shareholders. In addition, the issue price for the newly issued shares out
of the Special Amount shall not be significantly lower than the stock exchange price of the Company’s shares already
listed.
The remaining amount of the then still available Authorised Share Capital I being EUR 119,588.52 representing
11,958,852 newly issued shares (“Remaining Amount”) may be issued by the Board of Directors only by respecting the
preferential subscription rights of existing shareholders.
Furthermore, it is resolved that the authorisation to use the Special Amount of the above-mentioned Authorised Share
Capital I shall be renewed and be valid for a period of five (5) years starting with the day of publication of this EGM deed
or the deed of any subsequent EGM, as applicable, in the official Luxembourg gazette Mémorial C.
The time period for the authorisation to use the Remaining Amount will not be altered and remains to run until and
including 25 July 2017.
Subsequently, article 5 of the Articles in order to reflect above agenda point.
The board of the Meeting being constituted, the Chairman following due verification declares that:
- all the shareholders present or represented or voting by correspondence and the number of shares held by them are
entered on an attendance list attached to these minutes and duly signed by the shareholders present, the proxyholders of
the shareholders represented and the members of the board of the Meeting;
- the Meeting has been duly convened by publication of the invitation and the agenda in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations and in the Luxembourg Tageblatt in accordance with applicable Luxembourg law on 20 November
2015;
- The convening notice was dispatched by regular mail to (i) registered shareholders that were known by name and
address to the Company and (ii) the members of the Board of Directors of the Company and (iii) the auditor of the Company;
- the Company did not receive a registered letter from one or more shareholders owning at least 5% in the share capital
of the Company requesting in advance of today’s Meeting in accordance with Luxembourg law to add additional items on
the agenda;
- shareholder(s) holding at least 20% of the issued share capital have not requested postponement of today’s Meeting;
- at least 30 calendar days before today’s Meeting all documents relating to today’s agenda, in particular the draft
amended articles of association, and any information as required under Luxembourg law were available for shareholders
at the registered office or respectively on the website of the Company as announced in the invitation to this Meeting.
The Chairman states that it appears from the attendance list that out of the total of issued 45,361,112 shares with nominal
value of EUR 0.01 each, representing the whole share capital of the Company amounting to EUR 453,611.12, a number
of 23,582,645 shares (being 51.98 % of the total issued share capital) are present or validly represented by proxy or
corresponding voting at the present Meeting. In consideration of the agenda and of the provisions of Article 67 and 67-1
of the 1915 Law, the board of the Meeting and the undersigned notary acknowledge that the minimum quorum of fifty
percent (50%) of the issued share capital of the Company is reached.
Thus the present Meeting is validly constituted and can validly deliberate on the agenda set out in the invitation to the
Meeting.
<i>Report of the board of directorsi>
In accordance with Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the
Chairman, acting on behalf of the board of directors of the Company presented to the Meeting a report on the limitation
and suppression of the preferential subscription rights in the context of the use of the existing Authorised Share Capital I
for which in the amount of 10 % of the currently issued share capital, the subscription rights for existing shareholders of
the Company shall be excluded.
The Meeting duly reviewed the report and acknowledged its content. It did not raise any objections pertaining to its
content.
The said report will remain attached to the present deed.
After duly considering the items on the agenda by the Meeting, the Meeting takes the following resolutions:
51775
L
U X E M B O U R G
<i>Resolution 1i>
The resolution was voted as follows:
With 22,360,598 YES votes = 95.03% of votes
With 1,168,047 NO votes = 4.96% of votes
With 54,000 ABSTENTIONS and 0 votes not cast.
The item on the agenda is therefore approved by more than two-thirds (2/3) of the voting rights expressed at today’s
Meeting and is therefore validly taken.
That approval of the resolution results in the amendment and restatement of article 5 of the Articles as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The subscribed share capital of the Company is set at EUR 453,611.12 (four hundred and fifty-three thousand and
six hundred and eleven euros and twelve cents), represented by 45,361,112 (forty-five million three hundred and sixty-one
thousand and one hundred and twelve) shares with a par value of EUR 0.01 (one cent) each.
5.2 Without prejudice to article 5.4.3 below, the subscribed share capital of the Company may be increased or reduced
by a decision of the General Meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
5.3 The Company shall have an authorised share capital of up to EUR 206,187.- (two hundred and six thousand one
hundred and eighty-seven euros) represented by 20,618,700 (twenty million six hundred and eighteen thousand seven
hundred) shares with a nominal value of EUR 0.01.- (one cent) each (the “Authorised Share Capital I”).
5.3.1 The Board of Directors may in the amount and within the limits of the Authorised Share Capital I:
(a) implement a capital increase by issuing from time to time new shares to be paid up in cash or by way of contribution
of assets in kind, by incorporating reserves or profits carried forward or in any other manner, including the exercise of
warrants and the conversion of convertible bonds;
(b) fix the place and the date of the issue or the successive issues of the shares, the issue price, with or without a premium,
the date from which the shares shall bear dividend and the terms and conditions of subscription and payment of the shares;
and
(c) abolish or limit the preferential subscription right of the shareholders when issuing shares to be paid up in cash.
5.3.2 The above mentioned authorisation will be valid for a period of five (5) years starting on the day of publication
of the notarial deed dated 4 June 2012 having recorded the right of the Board of Directors to increase the authorised share
capital up to EUR 206,187.- (two hundred and six thousand one hundred and eighty-seven euros) represented by 20,618,700
(twenty million six hundred eighteen thousand seven hundred) shares. The authorisation may be renewed by a resolution
of the General Meeting.
5.3.3 Until and including 21 December 2015 the Board of Directors has used part of the Authorised Share Capital I so
that the amount that may still be used for capital increases amounts to one hundred sixty-four thousand nine hundred forty-
nine Euro and sixty-three cents (EUR 164,949.63). From such remaining amount, the Board of Directors shall be permitted
to use up to EUR 45,361.11 for issuing 4,536,111 new shares (such amount being 10% of the issued share capital of the
Company on 21 December 2015) without such issue being subject to any preferential subscription rights of existing sha-
reholders (“Special Amount”). In addition, the issue price for the newly issued shares out of the Special Amount shall not
be significantly lower than the stock exchange price of the Company’s shares already listed.
5.3.4 The remaining amount of the then still available Authorised Share Capital I being EUR 119,588.52 representing
11,958,852 newly issued shares (“Remaining Amount”) may be issued by the Board of Directors only by respecting the
preferential subscription rights of existing shareholders.
5.3.5 Furthermore, the authorisation to use the Special Amount in the manner mentioned above shall be renewed and
be valid for a period of five (5) years starting with the day of publication of the notarial deed pertaining to an extraordinary
general meeting of shareholders of the Company signed on 22 December 2015 or the notarial deed of any subsequent
extraordinary general meeting of shareholders, as applicable, in the official Luxembourg gazette Mémorial C.
5.3.6 The time period for the authorisation to use the Remaining Amount will not be altered and remains to run until
and including 25 July 2017.
5.4 The Company shall have another authorised share capital II, which is different and independent from the Authorised
Share Capital I, of up to EUR 90,722.22 (ninety thousand seven hundred and twenty-two euros twenty-two cents) repre-
sented by 9,072,222 (nine million seventy-two thousand two hundred and twenty-two) shares with a nominal value of EUR
0.01.- (one cent) each (the “Authorised Share Capital II”).
5.4.1 The Board of Directors may in the amount and within the limits of the Authorised Share Capital II:
(a) implement a capital increase by the conversion of convertible bonds and/or warrant-linked bonds;
(b) fix the place and the date of the issue or the successive issues of the shares, the issue price, with or without a premium,
the date from which the shares shall bear dividend and the terms and conditions of subscription and payment of the shares;
and
(c) fully abolish or limit any and all preferential subscription right of the shareholders when issuing shares according to
this paragraph.
51776
L
U X E M B O U R G
5.4.2 The above mentioned authorisation regarding the Authorised Share Capital II will be valid for a period of five (5)
years (the “Validity Period”) starting on the day of publication of the notarial deed dated 15 July 2014 having recorded the
creation of the Authorised Share Capital II. For the avoidance of doubt, the Authorised Share Capital II shall also be used
in the case where a convertible bond or warrant-linked bond has been issued within the Validity Period but will be converted
after such Validity Period. The authorisation may be renewed by a resolution of the General Meeting.
5.4.3 Each time the Board of Directors increases the capital within the limits of the Authorised Share Capital I or
Authorised Share Capital II, the present article of the Articles shall be amended so as to reflect the increase of the subscribed
capital.
5.4.4 The Company may acquire and/or redeem its own shares in accordance with the conditions provided in the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and any other applicable law.
There being no further business, the meeting is adjourned by the Chairman and these minutes are signed by the members
of the board of the Meeting and by the undersigned notary at 11 a.m.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by
reason of the present deed are assessed at EUR 2,000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French version and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by name, surname, civil status and
residence, the said persons appearing signed together with the notary, the present deed.
Follows the french version
L’an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de SAF-HOLLAND S.A., une société anonyme
de droit luxembourgeois, avec siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113090 (la “Société”). La Société a été constituée suivant
acte reçu par Me Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 21 Dé-
cembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 643 du 29 mars 2006. Les statuts de la
Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Me Henri Hellinckx en date du 15 juillet
2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2637 du 30 septembre 2014.
L’assemblée s’est ouverte à 10.30 h sous la présidence de M. Marcus PETER, demeurant à Luxembourg, en sa qualité
comme représentant du conseil d’administration.
L’Assemblée a élu M. Peter president de l’Assemblée (le “Président”).
Le Président choisit comme secrétaire Marie-Thérèse WICH, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur sans vote dissident Markus LAUE, demeurant à Eschborn.
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation que le solde restant du Capital Autorisé I (164 949,63 euros) pourra être utilisé par le Conseil d’Admi-
nistration comme suit.
Une somme de maximum 45.361,11 euros représentant 4.536.111 nouvelles actions émises et 10 % de l’actuel capital
social émis par la société («Montant Spécial») pourra être émise par le Conseil d’Administration sans octroi de droit de
souscription préférentiel des actionnaires. De plus, le prix d’émission des nouvelles actions émises en dehors du Montant
Spécial ne devra pas être significativement inférieur au prix d’échange sur les marchés financiers des actions de la société,
déjà cotées.
Le solde restant du Capital Autorisé I, soit 119.588,52 euros représentant 11.958.852 nouvelles actions émises («Solde
Restant») pourra être émis par le Conseil d’Administration qu’en respectant les droits de souscription préférentiels des
actionnaires.
En outre, il est décidé que l’autorisation d’utiliser le Montant Spécial du Capital Autorisé I susmentionné devra être
renouvelée et être valable pour une période de cinq (5) ans à partir du jour de la publication du présent acte notarié de
l’Assemblée Générale Extraordinaire ou, le cas échéant, l’acte notarié de toute Assemblée Générale Extraordinaire sub-
séquente, dans le Mémorial C.
La durée de l’autorisation d’utilisation du Montant Restant ne sera pas altérée et continuera à courir jusqu’au 25 juillet
2017 inclus.
Modification de l’article 5 des Statuts de manière à refléter les points de l’ordre du jour ci-dessus.
51777
L
U X E M B O U R G
Le bureau de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare après vérification que:
- tous les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance ainsi que le nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, leurs
mandataires et les membres du bureau de l’Assemblée restera annexée au présent procès-verbal;
- l’Assemblée a été dûment convoquée par publication de la convocation et de l’ordre du jour dans le Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations et dans le «Tageblatt» luxembourgeois, conformément à la loi luxembourgeoise
applicable le 20 novembre 2015;
- l’avis de convocation a été envoyé par courrier simple (i) aux actionnaires enregistrés, connu de la Société par leur
nom et adresse et (ii) aux membres du Conseil d’Administration de la Société et (iii) au réviseur de la Société;
- la Société n’a pas reçu de lettre recommandée de la part d’un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins 5% dans
le capital social de la Société, requérant en avance de l’Assemblée de ce jour, l’ajout de points supplémentaires à l’ordre
du jour conformément à la loi luxembourgeoise;
- l’actionnaire ou les actionnaires détenant au moins 20% du capital social n’ont pas requis l’ajournement de l’Assemblée
de ce jour;
- au moins 30 jours calendrier avant l’Assemblée de ce jour, tous les documents en relation avec l’ordre du jour de ce
jour, en particulier le projet des statuts modifiés, et toute information requise conformément à la loi luxembourgeoise ont
été rendus accessibles aux actionnaires au siège social ou respectivement sur le site internet de la Société comme annoncé
dans la convocation à cette Assemblée.
Le Président déclare qu’il ressort de la liste de présence que, du total des 45.361.112 actions d’une valeur nominale de
0,01 EUR chacune, représentant l’entièreté du capital social de la Société s’élevant à EUR 453.611,12 un nombre de
23.582.645 actions (donc 51,98% capital social total de la Société) sont présentes ou valablement représentées par procu-
ration ou vote par correspondance à la présente Assemblée. Vue l’ordre du jour et les dispositions des articles 67 et 67-1
de la loi de 1915, le bureau et le notaire soussigné confirment que le quorum minimum offert de cinquante pourcents (50%)
du capital social émis de la Société est atteint.
Ainsi l’assemble est constituée dûment et peut validement délibérer sur l’ordre du jour présenté dans l’invitation à
l’assemblée.
<i>Rapport du conseil d’administrationi>
Conformément à l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le Président,
agissant au nom du conseil d’administration de la Société, a présenté un rapport relatif à la limitation et la suppression des
droits préférentiels de souscription dans le cadre du recours au Capital Autorisé pour lequel 10 % de l’actuel capital social
émis pourra être émis par le Conseil d’Administration sans octroi de droit de souscription préférentiel des actionnaires.
L’Assemblée a examiné le rapport en détail et prend connaissance de son contenu mentionnée ci-dessus et n’a pas
soulevé d’objection quant à son contenu.
Ledit rapport restera annexé aux présentes.
Après avoir dûment examiné le point à l’ordre du jour de l’Assemblée, l’Assemblée prend la résolution suivante:
<i>Résolution 1i>
La résolution est votée comme suit:
Avec 22.360.598 votes POUR = 95,03% des votes
Avec 1.168.047 votes CONTRE = 4,96% des votes
Avec 54.000 ABSTENTIONS et 0 votes non exprimés.
Le point à l’ordre du jour est ainsi approuvé par plus des deux-tiers (2/3) des droits de votes exprimés à la présente
Assemblée, et est ainsi valablement approuvé.
L’approbation de la résolution entraîne la modification de l’article 5 des statuts de la société comme suit:
“ Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 453.611,12 (quatre-cent cinquante-trois mille et six-cent onze
euros et douze centimes), représenté par 45.361.112 (quarante-cinq millions et trois cent soixante-et-un mille cent-douze)
actions d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime) chacune.
5.2 Sans préjudice de l'article 5.4.3. ci-dessous, le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit en
vertu d'une décision de l’Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.
5.3 La Société aura un capital autorisé de EUR 206.187,-(deux cent six mille cent quatre-vingt-sept euros) représenté
par 20.618.700 (vingt millions six cent dix-huit mille sept cents) actions d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime)
chacune (le «Capital Autorisé I»).
5.3.1 Le Conseil d'Administration est autorisé dans le montant et dans les limites du Capital Autorisé I à:
(a) Mettre en oeuvre une augmentation de capital par l’émission d’actions nouvelles à payer en numéraire ou par voie
d’apport en nature, par incorporation des réserves ou bénéfices reports ou de toute autre manière, en ce compris l’exercice
de warrant et la conversion d’obligations convertibles;
51778
L
U X E M B O U R G
(b) Fixer la place et la date d’émission ou des émissions successives d’actions, l’émission du prix, avec ou sans prime
d’émission, la date à partir de laquelle les actions devront produire des dividendes et les termes et conditions de souscription
et paiement des actions; et
(c) Abolir ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires lors de l’émission des actions à payer en
numéraire.
5.3.2 L’autorisation mentionnée ci-avant sera valide pour une période de cinq (5) années à dater du jour de publication
de l’acte notarié daté du 4 juin 2012 ayant enregistré le droit du Conseil d’Administration d’augmenter le Capital Autorisé
I jusqu’à 206.187 EUR (deux cent six mille cent quatre-vingt-sept euros) représenté par 20.618.700 (vingt millions six cent
dix-huit mille sept cents) actions. L’autorisation peut être renouvelée par une résolution de l’Assemblée Générale.
5.3.3 Jusqu’au 21 décembre 2015 inclus, le Conseil d’Administration a déjà utilisé le Capital Autorisé I de sorte que le
montant pouvant encore être utilisé pour les augmentations de capital s’élève à cent soixante-quatre mille neuf cent quarante-
neuf Euro et soixante-trois cents (164.949,63 EUR). De ce solde restant, le Conseil d’Administration est autorisé à utiliser
une somme de maximum 45.361,11 EUR pour émettre 4.536.111 nouvelles actions (cette somme représente 10 % des
actions émises par la société au 21 décembre 2015) sans octroyer de droit de souscription préférentiel aux actionnaires
existants (“Montant Spécial”). En outre, le prix d’émission pour les nouvelles actions émises sur le Montant Spécial ne
doit pas être significativement inférieur au prix d’échange, sur les marchés, des actions déjà cotées de la société.
5.3.4 Le solde restant du Capital Autorisé I étant 119.588,52 EUR représentant 11.958.852 nouvelles actions émises
(“Montant Restant”) pourra être émis par le Conseil d’Administration en respectant les droits de souscription préférentiels
des actionnaires.
5.3.5 En outre, il est décidé que l’autorisation d’utiliser le Montant Spécial susmentionné devra être renouvelée et valable
pour une période de cinq (5) ans à partir du jour de la publication du présent acte notarié relatif à une Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, ou l’acte notarié de toute Assemblée Générale Extraordinaire subséquente, si applicable,
au Mémorial C.
5.3.6 La durée de l’autorisation d’utilisation du Montant Restant ne sera pas altérée et continuera à courir jusqu’au 25
juillet 2017 inclus.
5.4 La Société aura un autre capital autorisé II, lequel est différent et indépendant du Capital Autorisé I, jusqu’à 90.722,22
EUR (quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-deux euros vingt-deux cents) représenté par 9.072.222 (neuf millions soixante-
douze mille deux cent vingt-deux) actions d’une valeur nominale de 0.01 EUR (un centime) chacune (le «Capital Autorisé
II»).
5.4.1 Le Conseil d’Administration peut pour un montant et dans les limites du Capital Social Autorisé II:
(a) mettre en oeuvre une augmentation de capital par la conversion des obligations convertibles et/ou des obligations
liées au warrant;
(b) fixer la date et la place de l’émission ou des émissions successives des Actions, le prix d’émission, avec ou sans
prime d’émission, la date à partir de laquelle les actions devront porter des intérêt et les termes et conditions de souscription
et paiement des actions; et
(c) complètement abolir ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires lors de l’émission des actions
conformément à ce paragraphe.
5.4.2 L’autorisation mentionnée ci-avant relatives au Capital Social Autorisé II sera valide pour une période de cinq (5)
années (la «Période de Validité») commençant le jour de publication de l’acte notarié datée du 15 juillet 2014 ayant
enregistré la création du Capital Social Autorisé II. En prévention de tout doute, le Capital Autorisé II sera aussi utilisé
dans l’hypothèse où une obligation convertible ou une obligation liée au warrant a été émise endéans la Période de Validité
mais sera convertie après cette Période de Validité: L’autorisation peut être renouvelée par une résolution de l’Assemblée
Générale.
5.4.3 Chaque fois que le Conseil d’Administration augmente le capital social dans les limites du Capital Autorisé I ou
du Capital Autorisé II, le présent article des Statuts devra être modifié de manière à refléter l’augmentation du capital
souscrit.
5.4.4 La Société peut acquérir et/ou racheter ses propres actions conformément aux conditions prescrites dans la loi du
10 août 19115 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée (la «Loi») et tout autre loi applicable.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée par le président et cet acte est signé par les membres du
directoire de l’Assemblé et par le notaire soussigné à 11 heures.
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en
raison du présent acte sont évalués à EUR 2.000.-.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes comparants, en cas de divergence entre le texte
français et anglais, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
51779
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: M. PETER, M.-T. WICH, M. LAUE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42333. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055454/308.
(160014885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Ciupinski Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 201.114.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the fifteenth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
FRAM spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a Polish company having its registered office at Polskiej Organizacji
Wojskowej 29, app. 2, 90-248 Lodz (Poland), and registered in the Polish Register of Entrepreneurs under number KRS
0000554689,
here represented by Mr. Philippe AFLALO, company’s director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23,
rue Aldringen,
by virtue of a proxy dated of December 8
th
, 2015.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of CIUPINSKI INVESTMENTS, (the “Company”), a société à responsabilité
limitée incorporated by a deed given under private seal on June 12
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1940 of August 9
th
, 2013 and registered with the Luxembourg Trade and Companies
register under number B 201.114. The Articles have been amended by a deed of the undersigned notary on October 14
th
, 2015, in process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
- that the capital of the Company is fixed at THIRTY THOUSAND EURO (30,000.- EUR) represented by THIRTY
THOUSAND (30,000) shares with a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each, all fully paid-up;
- that the appearing party, prenamed, is the sole owner of all the shares and declares that it has full knowledge of the
articles of incorporation and the financial standing of the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory
and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the appearing party, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company
as at December 10, 2015, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation,
are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company’s activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of
the terminated Company, the balance sheet of the Company as at December 10, 2015, being only one information for all
purposes;
- following to the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company’s managers are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there shall be proceeded to the cancellation of all issued shares;
- the books and documents of the company shall be lodged during a period of five years at L-1118 Luxembourg, 23, rue
Aldringen.
No confusion of patrimony between the dissolved company and the asset of, nor the reimbursement to the sole share-
holder can be made, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to be counted from
51780
L
U X E M B O U R G
the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated has
demanded the creation of security.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by
reason of the present deed are estimated approximately at one thousand four hundred sixty five euro (EUR 1,465.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the proxyholder of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
FRAM spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, une société régie par les lois polonaises, ayant son siège social à
Polskiej Organizacji Wojskowej 29, app. 2, 90-248 Lodz (Pologne), et immatriculée auprès du «Polish Register of Entre-
preneurs» sous le numéro KRS 0000554689,
ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 8 décembre 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société CIUPINSKI INVESTMENTS, (la «Société»), société à responsa-
bilité limitée constituée suivant acte sous seing privé en date du 12 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1940 du 9 août 2013 et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 201.114. Les statuts ont été modifiés suivant un acte du notaire soussigné en date du 14 octobre 2015,
en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
- que le capital social de la Société s'élève à TRENTE MILLE EUROS (30.000,- EUR) représenté par TRENTE MILLE
(30.000) parts sociales d’une valeur nominale de UN EURO (1,- EUR) chacune, entièrement libérées;
- que la partie comparante, pré-qualifiée, est seule propriétaire de toutes les parts sociales et qu’elle déclare avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d’associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que la partie comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 10 décembre 2015,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
- l’associée unique est investie de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif
de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 10 décembre 2015 étant seulement un
des éléments d’information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
- il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les parts sociales;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1118 Luxembourg,
23, rue Aldringen.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à, l’associée
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication du présent acte et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura
exigé la constitution de sûretés.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille quatre cent soixante cinq euros (EUR 1.465,-).
51781
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la
comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. AFLALO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40757. Reçu soixante-quinze
euros 75,- EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016055781/112.
(160015871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
ADF GLF LUX A2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 199.397.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ADF GLF HK A2 Limited, a company incorporated and existing under the laws of Hong Kong having its registered
office at 11, Rutonjee House, 12/F, Duddel Street, unit 1202 Central Hong Kong with registration no. 2273421
here represented by Jan Dobrzensky, residing in Luxembourg, by virtue of a duly given proxy.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of ADF GLF Lux A2 S.à r.l, a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 199397, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-
Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 August 2015, published with the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 2723 on 3 October 2015 (hereinafter the “Company”). The articles of asso-
ciation have not been amended since.
The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement and may validly
deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred twelve thousand five hundred euro
(112,500);
2. Amendment of article 3 of the articles of association; and
3. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the undersigned notary to
enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to increase the Company’s share capital by an amount of one hundred twelve thousand
five hundred euro (112,500) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
up to a new amount of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000) through the issuance of:
i) ninety (90) class A shares,
ii) twelve thousand four hundred and ninety (12,490) class B shares,
iii) twelve thousand four hundred and ninety (12,490) class C shares,
iv) twelve thousand four hundred and ninety (12,490) class D shares,
v) twelve thousand four hundred and ninety (12,490) class E shares,
vi) twelve thousand four hundred and ninety (12,490) class F shares,
vii) twelve thousand four hundred and ninety (12,490) class G shares,
51782
L
U X E M B O U R G
viii) twelve thousand four hundred and ninety (12,490) class H shares,
ix) twelve thousand four hundred and ninety (12,490) class I shares,
x) twelve thousand four hundred and ninety (12,490) class J shares,
having a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the shares to be issued and listed under i) through x) (including) are
being referred to as the “Newly Issued Shares”), to be subscribed for by the Sole Shareholder.
The Newly Issued Shares so subscribed by the Sole Shareholder, here represented as aforementioned, have been fully
paid-up by a contribution in cash consisting of four hundred fifteen thousand nine hundred seventy-seven euro (EUR
415,977); so that the amount of four hundred fifteen thousand nine hundred seventy-seven euro (EUR 415,977) is as of
now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of four hundred fifteen thousand nine hundred seventy-seven euro (EUR 415,977)
consists of one hundred twelve thousand five hundred euro (112,500) for the share capital and three hundred three thousand
four hundred seventy-seven euro (EUR 303,477) for the share premium.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend article 3 of the articles of association of the Company which shall henceforth
read as follows:
“ Art. 3. The Company’s share capital is set at one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000) consisting of the
following shares:
a) Twelve thousand five hundred (12,500) class A shares with a par value of one euro (EUR 1) each;
b) Twelve thousand five hundred (12,500) class B shares with a par value of one euro (EUR 1) each;
c) Twelve thousand five hundred (12,500) class C shares with a par value of one euro (EUR 1) each;
d) Twelve thousand five hundred (12,500) class D shares with a par value of one euro (EUR 1) each;
e) Twelve thousand five hundred (12,500) class E shares with a par value of one euro (EUR 1) each;
f) Twelve thousand five hundred (12,500) class F shares with a par value of one euro (EUR 1) each;
g) Twelve thousand five hundred (12,500) class G shares with a par value of one euro (EUR 1) each;
h) Twelve thousand five hundred (12,500) class H shares with a par value of one euro (EUR 1) each;
i) Twelve thousand five hundred (12,500) class I shares with a par value of one euro (EUR 1) each; and
j) Twelve thousand five hundred (12,500) class J shares with a par value of one euro (EUR 1) each.
Under the terms and conditions provided by law, the Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 2.600,-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ADF GLF HK A2 Limited, une société incorporée et existante selon les lois de Hong-Kong, ayant son siège social au
11, Rutonjee House, 12/F, Duddel Street, unit 1202 Central Hong Kong, immatriculé sous le numéro 2273421;
ici représentée par Jan Dobrzensky, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée.
La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante est l’associé unique (le «Associé Unique») de ADF GLF Lux A2 S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199397, constituée selon acte reçu par Maître Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg en date du 6 août 2015, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2723 le 3 octobre 2015 (la «Société»). Les statuts n’ont pas été modifiés
depuis lors.
51783
L
U X E M B O U R G
La comparante représentant l’intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation et peut
valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500);
2. Modification de l’article 3 des statuts de la Société; et
3. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’Associé Unique adopte, et requiert le notaire
instrumentant d’acter, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de cent douze mille
cinq cents euros (EUR 112.500) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à cent
vingt-cinq mille euros (EUR 125.000) par l’émission de:
i) quatre-vingt-dix (90) parts sociales de catégorie A,
ii) douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie B,
iii) douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie C,
iv) douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie D,
v) douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie E,
vi) douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie F,
vii) douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie G,
viii) douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie H,
ix) douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie I et
x) douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie J,
ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune (les parts sociales devant être émises and listées de i) à x) (inclus)
sont définies comme les «Nouvelles Parts Sociales»), souscrites par l’Associé Unique.
Les Nouvelles Parts Sociales ainsi souscrites par l’Associé Unique, ici représenté comme il est dit, ont été intégralement
payées par un apport en numéraire de quatre cent quinze mille neuf cent soixante-dix-sept euros (EUR 415.977); de telle
manière que le montant total de quatre cent quinze mille neuf cent soixante-dix-sept euros (EUR 415.977) est maintenant
à la disposition de la Société ainsi qu’il l’a été justifié au notaire soussigné.
La contribution totale d’un montant de quatre cent quinze mille neuf cent soixante-dix-sept euros (EUR 415.977) se
compose de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500) attribués au capital social et de trois cent trois mille quatre
cent soixante-dix-sept euros (EUR 303.477) attribués au compte de prime d’émission.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide à l’unanimité de modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 3. Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000), représenté par
a) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
b) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
c) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie C ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
d) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie D ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
e) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie E ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
f) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie F ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
g) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie G ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
h) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie H ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie I ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
et
j) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune
Selon les termes et conditions prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution
de l’assemblée générale des associés, adoptée selon la procédure requise pour modifier les présents statuts».
<i>Frais et Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est
évalué à environ EUR 2.600,-.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
51784
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. DOBRZENSKY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38307. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055636/158.
(160016005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
XYLLYX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 103.277.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth of January.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “XYLLYX S.à r.l.”, a private limited liability
company ("société à responsabilité limitée") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and
having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of
Luxembourg, section B, under the number 103.277, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed dated October 1
st
, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1252 of December 7
th
, 2004.
The Meeting is presided by Mr Eric LECLERC, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Géraldine YERNAUX, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer, with retroactive effect on January 1
st
, 2016, of the registered office of the Company from L-1449
Luxembourg, 18, rue de l'Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Subsequent amendment of the statutes.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves, with retroactive effect on January 1
st
, 2016, to transfer the registered office of the Company
from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 5,
first sentence of the statutes, as follows:
“ Art. 5. First sentence. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Lu-
xembourg).
51785
L
U X E M B O U R G
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,
the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le huit janvier.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des associés de XYLLYX S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue
de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 103.277, (la "So-
ciété"), constituée suivant acte reçu en date du 1
er
octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1252 du 7 décembre 2004.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine YERNAUX, employée, demeurant professionnellement à
Howald.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement
à Howald.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de
l'Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Modification afférente des statuts.
B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux repré-
sentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le
notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent
avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449
Luxembourg, 18, rue de l'Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence l'article 5, première
phrase des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Première phrase. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
51786
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. LECLERC, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 14 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/846. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055574/109.
(160014195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Twinhope Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 148.955.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of December.
Before us Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- WINHOPE FINANCE LIMITED, a limited company, incorporated under the laws of British Virgin Islands, having
its registered office at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, British Virgin Islands
(BVI Company Number 1552148),
here represented by Mr Christophe Fender, Director of companies, professionally residing in L-1274 Howald, 23, rue
des Bruyères, by virtue of a power of attorney under private seal issued on December 21
st
, 2015,
Such proxy, after signature “ne varietur” by the proxyholder and by the undersigned notary will remain attached to the
present minutes for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact that:
I.- the appearing party is the sole owner of the total shares issued of TWINHOPE FINANCE S.A. (the «Company»), a
société anonyme, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri, incorporated by deed of
Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on 27 October 2009, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations («Mémorial C») number 2257 of 18 November 2009; the Articles of Incorporation of which
have been amended pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary then residing in Sanem, on 28 September
2010, published in the said Mémorial C, number 2444, of 12 November 2010, and for the last time pursuant to a deed of
Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on 24 January 2013, published in the said Mémorial C,
number 705 of 22 March 2013.
- the Company is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 148955.
II.- the Company has an issued and paid up share capital of three hundred and thirty-two thousand Euro (EUR 332,000),
divided into thirty-two (32) shares with a par value of ten thousand three hundred and seventy-five Euro (EUR 10,375)
each.
III.- the appearing party herewith expressly declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect
as the business activity of the Company has ceased and to act as liquidator of the Company;
IV.- the appearing party declares having full knowledge of the bylaws of the Company and is perfectly aware of the
financial situation of the Company;
V.- the appearing party, being sole owner of the shares and liquidator of the Company, hereby declares:
i. that all assets have been realised and/or that all assets are to become the property of the sole shareholder;
ii. that all liabilities towards third parties known to the Company shall be taken over by the Shareholder and/or that all
liabilities towards third parties actually known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
51787
L
U X E M B O U R G
iii. regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and outstanding today, that it will irrevocably
assume the obligation to pay for such liabilities, with the result that the liquidation of the Company is to be considered
closed;
iv. that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their
mandates;
v. that the corporate books and accounts of the Company shall be kept during a period of five years at the former registered
office.
vi. that the shareholder's register of the Company shall be cancelled;
However, the Company's assets shall not be mixed with the assets of nor attributed to the capital of the sole shareholder
before the expiry of 30 days from the date of publication of the present deed (article 69(2) of the law on commercial
companies) and provided that during this period no person declares himself as creditor of and demands payment of any
outstanding debt due from the Company hereby dissolved.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French Text, the English version will prevail.
Whereof, the present deed is drawn up in Hesperange, in the notary's office, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, said person signed together with us, the
Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Martine DECKER notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
- WINHOPE FINANCE LIMITED, une société anonyme, constituée sous le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant
son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques
(BVI Company Number 1552148),
ici représentée par Monsieur Christophe Fender, dirigeant de sociétés, demeurant professionnellement à L-1274 Howald,
23, rue des Bruyères en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée le 21 décembre 2015,
laquelle procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I.- le comparant est propriétaire de la totalité des actions de la TWINHOPE FINANCE S.A. (la «Société»), une société
anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri, constituée suivant acte reçu par Maître
Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2257 du 18 novembre 2009; les statuts de laquelle ont été modifiés suivant un acte
reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire alors de résidence à Sanem, en date du 28 septembre 2010, publié audit
Mémorial C, numéro 2444, du 12 novembre 2010, et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 2013, publié audit Mémorial C, numéro 705 du 22 mars 2013.
- la Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.955.
II.- la Société a un capital social entièrement souscrit et libéré de trois cent trente-deux mille euros (332.000,-EUR),
divisé en trente-deux (32) actions avec une valeur nominale de dix mille trois cent soixante-quinze euros (10.375,-EUR);
III.- le comparant prononce présentement la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat, l'activité de la
Société ayant cessé, et d'agir en tant que liquidateur de la Société;
IV.- le comparant déclare avoir pleinement connaissance des statuts de la Société et connaître la situation financière de
la Société;
V.- le comparant agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:
i. que tous les actifs ont été réalisés et/ou que tous les actifs à devenir la propriété de l'actionnaire unique;
ii. que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été pris en charge par l'actionnaire unique et/ou que
tous les passifs actuellement connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
iii. par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la Société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-
vocablement l'obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;
iv. que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société, pour
l'exercice de leurs mandats respectifs;
v. que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à l'ancien siège social;
vi. qu'il sera procédé à l'annulation du registre aux actions de la Société;
51788
L
U X E M B O U R G
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'actionnaire
unique ne pourra se faire avant l'expiration du délai de trente jours à compter de la publication du présent acte (article 69
(2) de la loi sur les sociétés commerciales) et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée
n'aura exigé la constitution de sûretés.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom et prénom, état et demeure,
il a signé ensemble avec nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Fender, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42428. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 22 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055540/110.
(160015370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Fideres Capital I Funding, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 197.122.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the thirty-first day of December.
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There APPEARED:
Fideres Capital I GP, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 6 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered in the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 196796, acting in its capacity as general partner for
and on account of Fideres Capital I SCSp, a special limited partnership (société en commandite speciale) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Gabriel Lippmann, Grand-
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 196822,
hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, professionally residing in Résidence du Midi, 13, avenue François Clément,
L-5612 Mondorf-les-Bains (Grand-Duchy of Luxembourg),
by virtue of a proxy under private seal delivered to him on December 29, 2015, which, after having been signed ne
varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the
purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state that:
1. Fideres Capital I Funding S. à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its
registered office at 6, rue Gabriel Lippmann, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five
hundred pounds sterling (GBP 12,500.00), registered with the RCS Luxembourg under number B 197122.
The company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri BECK, on 22 May 2015, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1827 on 22 July 2015;
2. the capital of the Company was fixed at twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500) divided into
twelve thousand five hundred (12,500) fully paid shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each;
3. the appearing party is the sole shareholder of the Company;
4. the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect as the business activity of the Company
has ceased;
5. the appearing party being the sole owner of the shares and acting as liquidator of the Company declares that:
- declares that the activity of the Company has ceased;
- that the Company has no more liabilities;
- all assets constituting of cash receivables have been realised and have become the property of the sole shareholder;
- all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
51789
L
U X E M B O U R G
- it irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company and other potential liabilities
presently unknown to the Company and therefore not paid to date;
6. with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;
7. full discharge is granted to the managers of the Company, namely Duncan Smith, Class A Manager and Ian Boyland,
Class B Manager for the exercise of their mandates, except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;
8. there should be proceeded to the cancellation of all issued shares and or the shareholders register;
9. the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at Augentius (Luxembourg)
S.A., E Building, Parc d'Activite Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Luxembourg.
Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to the
sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies
dated 10 August 1915, as amended from time to time) to be counted from the day of publication of the present deed, and
only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated has demanded the creation of security.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are estimated approximately at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the proxy holder of the
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy holder
of the appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by her surname,
first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trente et unième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Fideres Capital I GP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés,
Luxembourg sous le numéro B 196796, agissant en sa qualité d'associé gérant commandité au nom et pour le compte de
Fideres Capital I SCSp, une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue Gabriel
Lippmann, L- 5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxem-
bourg sous le numéro B 196822,
représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé, demeurant professionnellement à la Résidence du Midi, 13, ave-
nue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 29 décembre 2015, laquelle, après avoir été signée
ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. Fideres Capital I Funding S. à r.l une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à 6, rue Gabriel Lippmann, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital de douze
mille cinq cents livres sterling (12.500,00 GBP) enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 197.122.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, en date du 22 mai 2015, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1827 le 22 juillet 2015;
2. Le capital social de la Société a été fixé à douze mille cinq cents livres sterling (12.500,00 GBP) et se divisant en
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales entièrement libérées d'une valeur nominale d'un livre sterling (1,00 GBP)
chacune, entièrement libérées;
3. La comparante est l'associée unique de la Société;
4. La comparante a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute activité;
5. La comparante, prénommée, étant l’associée unique de la Société et agissant en sa qualité de liquidateur de la Société,
déclare:
- que l’activité de la Société a cessé;
- que la Société n’a plus de passif;
- que tous les actifs constitués de liquidités ont été réalisés et tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;
- que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
51790
L
U X E M B O U R G
- qu'elle assume et paye irrévocablement au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs actuellement
inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;
6. de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;
7. décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société, Duncan Smith, gérant de catégorie A and Ian Boyland,
gérant de catégorie B pour l'exercice de leurs mandats respectifs sauf dans les cas de négligence grave et de faute grave;
8. il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les parts et ou du registre des actionnaires;
9. les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à Augentius (Luxembourg)
S.A., batiment E, Parc d'Activite Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Luxembourg.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à, l’actionnaire
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura
exigé la constitution de sûretés.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte,
sont évalués approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la demande de la même
mandataire de la comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant
par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2016. GAC/2016/219. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 25 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055877/119.
(160015893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
AMPLEXOR Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 26.127.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2015i>
L'Assemblée Générale de la société à responsabilité limitée, AMPLEXOR Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social
à L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 26.127, a pris acte de nommer Monsieur Udo MERZ, né le 14 décembre 1967 à Serrig (Allemagne), demeurant
à D-54439 Saarburg, 3, Saarblick et Monsieur Thomas Detzel, né le 28 janvier 1963 à Luxembourg, demeurant à L-2428
Luxembourg, 72, rue Nicolas Ries, en tant que gérants supplémentaires de la société avec effet au 1
er
janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Référence de publication: 2016061458/15.
(160023041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
CiArt Productions, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8393 Olm, 13A, rue de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 148.982.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016059468/9.
(160019949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
51791
L
U X E M B O U R G
Eaglestone Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 600.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.828.
Suite à une cession de parts sociales en date du 26 novembre 2015, la société TREBORASSET Sàrl, société de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce de Luxembourg sous le numéro B 141275, a transféré la propriété de cent vingt mille (120.000) parts sociales de
classe B de un (1) Euro chacune de la société à responsabilité limitée EAGLESTONE LUX Sàrl, ayant son siège social au
44, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg à EAGLEASSET Sàrl.
Le capital social est dorénavant réparti comme suit:
TREBORASSET Sàrl., ayant son siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg
sous le numéro B 141.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360.000 parts sociales de classe A
120.000 parts sociales de classe B
EAGLEASSET Sàrl., ayant son siège social au 16, Allée Marconi,
L-2120 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg
sous le numéro B 176.808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.000 parts sociales de classe B
Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Pour avis sincère et conforme
EAGLESTONE LUX S.à r.l.
- / JALYNE S.A.
Signatures
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2016060948/26.
(160021611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Global Bond Series V, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.027.
Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du
26 janvier 2016:
- acceptation de la démission de Monsieur Lukasz Malecki en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 22 janvier
2016;
- nomination, en tant que nouvel administrateur de la Société, de Madame Marketa Stranska, née le 27 septembre 1973
à Praha 10 (République Tchèque) et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
avec effet au 22 janvier 2016. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020;
- confirmation que le conseil d'administration de la Société est depuis le 22 janvier 2016 composé des administrateurs
suivants:
* Monsieur Fabrice Rota;
* Monsieur Shehzaad Atchia; et
* Madame Marketa Stranska.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2016.
<i>Pour la Société
i>Marketa Stranska
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016060392/24.
(160021006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
51792
ADF GLF LUX A2 S.à r.l.
A.L.S. S.à r.l.
AMPLEXOR Luxembourg S.à r.l.
Bonativo Global S.à r.l.
CiArt Productions
Ciupinski Investments
Eaglestone Lux S.à r.l.
Ecommerce Business 11 S.à r.l
Elvea Capital S.à r.l.
Energy Power S.A.
Fideres Capital I Funding, S.à.r.l.
Fondation Hôpitaux Robert Schuman
Fortan European Investments S.A.
Fratrix S.à r.l.
GBL Verwaltung S.A.
Global Bond Series V, S.A.
Haarslev Holding S.à r.l.
Hasten Property Holdings S.à r.l.
Holmes S.A.
Iberinvest S.A.
ICG European Fund 2006 S.à r.l.
IHS Global Luxembourg S.à r.l.
Immobilière Etoile 2 S.à r.l.
International Institute of Diamond Grading & Research Holdings
Kerima S.A.
KFA Holdings Luxco S.à r.l.
L.F.L. Société civile immobilière
Luxconnect S.A.
Millem Invest S.à r.l.
NORD S.à.r.l.
OMNIUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Prévention.Sécurité.Santé
ProjektPlus S.à r.l.
SAF-Holland S.A.
Samir S.A.
Signal Credit Opportunities (Lux) Investco I S.à r.l.
Sonae Sierra Brazil B.V.
Sonae Sierra Brazil B.V.
Stable II S.à r.l.
Stentex Holding
TAD Luxembourg S.à r.l.
Tinsel Group S.A.
Tomasa Investments S.à r.l.
Tricadia Credit Investments S.à r.l.
Triton Masterluxco 4 S.à r.l.
Twinhope Finance S.A.
XYLLYX S.à r.l.