logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 705

9 mars 2016

SOMMAIRE

1741 Asset Management Funds Sicav  . . . . . . .

33802

Aequitas Europe 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

33801

Antin Infrastructure Partners Luxembourg I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33820

ArcelorMittal Tubular Products Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33820

CCp IV Archer 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33827

EC Eco Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33799

Great German Nursing Homes A  . . . . . . . . . .

33801

Great German Nursing Homes D  . . . . . . . . . .

33801

Groupe Immobilier Luxembourgeois Sàrl  . . .

33801

KaiserStone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33805

KPB 2 Core S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33810

LSF9 Balta Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

33794

Palinvest Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33796

Palladian Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

33797

PATRIZIA Res Publica Hessen I HoldCo S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33797

PATRIZIA Res Publica Hessen I TopCo S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33797

PH North America S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

33797

Pollyane Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

33798

Profconsult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33825

Professional Beauty Services S.A.  . . . . . . . . . .

33798

Quadia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33799

Ravenwood, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33799

RBS (Luxembourg) Agriculture S.A.  . . . . . . .

33800

Redditch Propco Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

33800

Regenbogenzwei S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33826

Regenbogenzwei S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33827

Residential Assembly JV . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33800

Turchese Trading e Investimentos S.A. . . . . . .

33826

Umbrella Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33827

Vista Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33803

Vivaro Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33804

White River Holdco Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

33804

Wholesale & Logistics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

33805

W. Lanneau & Cie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33804

WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33805

XLNT S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33803

Yaro Invest SA/SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33803

Zenith Fund S.A., SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . .

33802

Zephyr'07-S.A. SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . .

33802

33793

L

U X E M B O U R G

LSF9 Balta Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.512.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 197.728.

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of December.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

LSF9 Balta Issuer S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under the number B 198084 (the Sole Shareholder),

Here represented by Mrs Alexandra FUENTES, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, through its proxyholder, requests the undersigned notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds 12,100 (twelve thousand one hundred) ordinary shares, with a nominal value of EUR 125

(one hundred and twenty-five euro) each, representing the entire share capital of LSF9 Balta Investments S.à r.l., a société
à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under the number
B 197728 (the Company). The Company was incorporated on 10 June 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°2090 of 14 August 2015. The articles of association
of the Company (the Articles) were amended for the last time on 10 August 2015 pursuant to a deed of Maître Henri Beck,
residing in Echternach, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°2767 of 7 October 2015.

II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance

with Article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(1) Amendment and restatement of (i) the article 11 (Representation of the Company) and (ii) the article 13 (Meetings

of the Board of Managers) of the Articles;

(2) Acknowledgement of the resignation of Mr. Deruyck, Mr. Destito and Mr. Kolbeck, as managers of the Company;
IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the article 11 (Representation of the Company) and (ii) the article 13 (Meetings

of the Board of Managers) of the Articles so that they shall from now on read as follows:

“ Art. 11. Representation of the Company. The Company shall either be bound by the sole signature of its sole manager

(if applicable) or the sole signature of any member of the Board of Managers in office.”

“ Art. 13. Meetings of the Board of Managers. Every board meeting shall be held at the registered office of the Company

in the Grand Duchy of Luxembourg or such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as the Board of Managers may
from time to time determine.

Written notices of any meeting of the Board of Managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram,

telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of
emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been
informed on the agenda of the meeting beforehand. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax

or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their votes by telephone confirmed in writing. The Board
of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the Board of Managers.

The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Notwithstanding the foregoing, resolutions of the Board of Managers may also be passed in writing which resolutions

will be proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened
and held. Such resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager, with a majority signed in Luxembourg. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.”

33794

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Mr. Deruyck, Mr. Destito and Mr. Kolbeck, as managers of the

Company, with effect as of the date of the present meeting, and resolves to grant them interim discharge for the performance
of their duties as managers of the Company.

The Sole Shareholder therefore acknowledges that as of the date hereof the board of managers of the Company is

composed as follows:

- Mr Philippe Detournay;
- Mr Patrick Steinhauser; and
- Mr Philippe Jusseau.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,400.- (one thousand four hundred Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the

appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and that at the request of the proxy-
holder of the appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will
prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signs

together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

A COMPARU:

LSF9 Balta Issuer S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, dont le siège

social est situé au Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché du Luxembourg,
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 198084 (l'Associé Unique),

Ici représentée par Madame Alexandra FUENTES, employée privée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire d'acter que:
I. L'Associé Unique détient 12.100 (douze mille cents) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 125 EUR

(cent vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de LSF9 Balta Investments S.à r.l., une société
à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au Atrium
Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 197728 (la Société). La Société a été constituée le 10 juin 2015
suivant un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2090 du 14 août
2015. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 10 août 2015 suivant un acte de Maître
Henri Beck, résidant à Echternach, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2767 du 7 octobre
2015.

II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires de la Société conformément à l'article

200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:
(1) Modification et reformulation de (i) l'article 11 (Représentation de la Société) et (ii) de l'article 13 (Réunion du

Conseil de Gérance) des Statuts;

(2) Constatation des démissions de Mr. Deruyck, Mr. Destito et Mr. Kolbeck, en tant que gérants de la Société.

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 11 (Représentation de la Société) et (ii) l'article 13 (Réunion du Conseil

de Gérance) des Statuts, de telle sorte qu'ils devront désormais être lus respectivement de la manière suivante:

« Art. 11. Représentation de la Société. La Société sera engagée soit par la seule signature de son gérant unique (le cas

échéant) ou par la seule signature de tout membre en fonction du conseil de gérance».

« Art. 13. Les Réunions du Conseil de Gérance. Toutes les réunions du conseil de gérance seront tenues au siège social

de la Société au Grand Duché du Luxembourg ou dans un autre lieu au sein du Grand Duché du Luxembourg tel que le
déterminera le Conseil de Gérance de temps à autre.

33795

L

U X E M B O U R G

Les notifications écrites de toute réunion du Conseil de Gérance seront délivrées à tous les gérants, par écrit ou par

télégramme, télécopie ou télex, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas de
circonstances exceptionnelles. Il est possible de passer outre cette convocation si tous les gérants de la société sont présents
ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont été préalablement informés de l'ordre du jour de la réunion. Une notification
séparée n'est pas requise pour les réunions tenues à une heure et un endroit déterminé dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil de Gérance.

Tout gérant peut agir lors n'importe quelle réunion du Conseil de Gérance en nommant par écrit, télégramme, télécopie

ou télétexte un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent aussi exprimer leurs voix par téléphone confirmé
par écrit. Le Conseil de Gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres sont
présents ou représentés au Conseil de Gérance.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les résolutions du Conseil de Gérance peuvent aussi être passées par écrit,

lesquelles résolutions seront légitimes et valides dès lors qu'elles auront été adoptées lors d'un Conseil de Gérance dûment
et convenablement tenue. De telles résolutions consisteront en un ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés
par chacun et tous les gérants, avec une majorité accordée au Luxembourg. La date de telles résolutions sera la date de la
dernière signature».

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique constate les démissions de Mr. Deruyck, Mr. Destito and Mr. Kolbeck, en tant que gérants de la

Société, avec effet à la date de la présente assemblée et décide de leur donner décharge pour leur performance et leur devoir
en tant que gérant de la Société.

L'Associé Unique déclare également qu'à la date de la présente assemblée, le conseil de gérance de la Société sera

constituée comme suit:

- Mr Philippe Detourney;
- Mr Patrick Steinhauser; et
- Mr Philippe Jusseau.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés approximativement à la somme de EUR 1.400,- (mille
quatre cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare à la requête du mandataire de l'Associé Unique que le présent

acte a été établi en anglais, suivi d'une version française à la requête du mandataire de l'Associé Unique, et qu'en cas de
divergences entre les versions anglaises et françaises, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la même date qu'en tête du présent acte, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, le mandataire de l'Associé Unique a signé ensemble avec le

notaire l'original du présent acte.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/29243. Reçu soixante-quinze

euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 28 December 2015.

Référence de publication: 2015211595/154.
(150236950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Palinvest Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 144.982.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 20 juin 2014.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Régis PIVA (demeurant professionnellement: 24, rue Saint Ma-

thieu L-2138 Luxembourg) est renouvelé pour une période de quatre ans.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016003182/11.
(160001106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

33796

L

U X E M B O U R G

Palladian Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 181.214.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers que la société Amicorp Luxembourg S.A., agent domiciliataire, a dénoncé, avec

effet immédiat le siège social de la société PALLADIAN LUXEMBOURG S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit
Luxembourgeois, ayant un capital social de EUR 12,500.-, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B 181214, situé jusqu'alors au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Amicorp Luxembourg S.A.
Représentée par Mr. Fabio Mastrosimone
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2016003186/16.
(160001335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

PATRIZIA Res Publica Hessen I HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 181.332.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Harald Siewert, ist mit Wirkung zum 21. Dezember 2015 als Geschäftsführer

der Gesellschaft zurückgetreten.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind nun Dr. Bernhard Engelbrecht und Frank Kewitz.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PATRIZIA Res Publica Hessen I HoldCo S.à r.l.
<i>VERTRETER

Référence de publication: 2016003190/14.
(160001101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

PATRIZIA Res Publica Hessen I TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 181.331.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Harald Siewert, ist mit Wirkung zum 21. Dezember 2015 als Geschäftsführer

der Gesellschaft zurückgetreten.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind nun Dr. Bernhard Engelbrecht und Frank Kewitz.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PATRIZIA Res Publica Hessen I TopCo S.à r.l.
<i>VERTRETER

Référence de publication: 2016003191/14.
(160001100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

PH North America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 252.220.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.216.

En date du 27 novembre 2015, 1.732.000.000 (un milliard sept cent trente-deux millions) parts sociales de la Société,

d'une valeur nominale de 0.01 USD (un cent de dollar américain) chacune, détenues par Yum! Restaurants International
Management LLC, une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant son siège
social sis au 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, DE 19801, États-Unis d'Amérique, ont été trans-
férées à PH International Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché

33797

L

U X E M B O U R G

de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.788.

Il en résulte que l'actionnariat de la Société se compose désormais comme suit:
- PH International Holdings II S.à r.l.: 23.490.000.000 (vingt-trois milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions) parts

sociales;

- PH International Holdings I S.à r.l.: 1.732.000.000 (un milliard sept cent trente-deux millions) parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2016003197/22.
(160000960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Pollyane Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 145.901.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 18 Décembre 2015, accepte, à compter du 31 août 2015, la démission d'un administrateur, à

savoir:

- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-

nellement au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte, à compter du 18 Décembre 2015, de nommer un administrateur, à savoir:
- Madame Emilie GALLAIS, administrateur, née le 03 mai 1978 à Coutances (France), domiciliée professionnellement

au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
L'Assemblée Générale décide, à compter du 18 Décembre 2015, de renouveler le mandat d'un administrateur et du

commissaire aux comptes, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, président du conseil d'administration et administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg,

domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.

- ZIMMER &amp; PARTNERS S.A., commissaire aux comptes, domiciliée professionnellement au 50, rue Charles Martel

L-2134 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Conformément à la circulaire RCSL 15/2 du 13 février 2015, le représentant permanent de la société Luxglobal Mana-

gement S.à r.l. est le suivant:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 50,

rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.

La société Zimmer &amp; Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016003202/30.
(160001166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Professional Beauty Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 106.163.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2015.

L'assemblée générale de la société PROFESSIONAL BEAUTY SERVICES S.A. s'est réunie en date du 20 mai 2015

afin de délibérer des points suivants portés à l'ordre du jour, à savoir:

1. - Acceptation de la démission de Madame Lucinda K. Treat de sa fonction d'administrateur de la Société;
2. - Nomination de Madame Mitra Hormozi en qualité de nouvel administrateur de la Société, en remplacement de

l'administrateur démissionnaire.

<i>Première résolution:

L'assemblée générale accepte la démission de Madame Lucinda K. Treat de sa fonction d'administrateur de la Société

et ce, avec effet au 30 avril 2015.

33798

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer avec effet au 30 avril 2015 Madame Mitra Hormozi (née le 22 mars 1969 à

New-York - États-Unis) en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de l'administrateur démissionnaire
jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui aura lieu en 2020.

Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse professionnelle de Madame Mitra Hormozi est L-9237 DIEKIRCH,

3, Place Guillaume.

Luxembourg, le 20 mai 2015.

Référence de publication: 2016003205/23.
(160001394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Quadia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 172.242.

<i>Extrait de résolution spéciale prise par la société QUADIA S.à r.l.

Il résulte des résolutions prises par QUADIA S.à r.l. le 29.12.2015 que:
Monsieur  Guillaume  Taylor,  associé  unique  de  la  société  QUADIA  S.à  r.l.,  demeurant  à  Bourg-de-Four  24,  1204,

Genève, Suisse, cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait, à la société QUADIA SA, rue du Conseil-
Général 20, 1205, Genève, Suisse, qui accepte, la pleine propriété de la totalité de ses parts sociales soit douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales, de valeur nominale EUR 1,00.

L'associé unique de la société QUADIA S.à r.l.,10A, rue Henri M. Schnadt, L - 2530, Luxembourg, devient donc la

société QUADIA SA, rue du Conseil-Général 20, 1205, Genève, Suisse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS FAS

Référence de publication: 2016003208/17.
(160000952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Ravenwood, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 185.363.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la Société Ravenwood S.à r.l. en liquidation volontaire par acte du notaire Maître Edouard Delosch

en date du 21 décembre 2015, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du
23 décembre 2015. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à partir du 23 décembre 2015
au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Exequtive Services S.àr.l.
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2016003213/16.
(160002224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

EC Eco Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 177.705.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au Luxembourg,

<i>le 27 Novembre 2015 à 12.00 heures.

<i>Première résolution

Décision de transférer le siège social de la société du L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch au 24, rue Astrid, L-1143

Luxembourg.

33799

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes:
FIN-CONTRÔLE S.A, R.C.S. Luxembourg B 42.230 ayant pour adresse professionnelle L-1882 Luxembourg, 12 rue

Guillaume Kroll.

<i>Quatrième résolution

Nomination en remplacement du Commissaire aux Comptes FIDUCIARY TUCCI &amp; PARTNERS S.A., R.C.S Lu-

xembourg B 177770 ayant pour adresse professionnelle L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04/01/2016.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016002845/23.
(160000836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Residential Assembly JV, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 136.721.

Il est porté à connaissance des tiers que suite à un acte de cession de parts en date du 22 décembre 2015, l'associé RP

Residential Assembly S.à r.l. a transféré 450 parts sociales représentant la totalité de ses parts sociales, au nouvel associé,
Luxe France S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 15 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange,
Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B139710.

Les parts sociales de la Société sont donc détenues de la manière suivante:

- Luxze S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales,

- Luxe France S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016003215/17.
(160001161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

RBS (Luxembourg) Agriculture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 132.134.

Je, soussignée Özgül Gülbey, démissionne en tant qu'administrateur du Conseil d'Administration de RBS (Luxembourg)

Agriculture S.A. et demande au Conseil d'Administration de me relever de mes fonctions d'administrateur avec effet à
partir du 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Mme Özgül Gülbey.

Référence de publication: 2016003226/11.
(160001316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Redditch Propco Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 196.483.

Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé
- de nommer Carl Tash avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité de

gérant pour une durée indéterminée à compter du 24 décembre 2015

- de modifier l'adresse professionnelle de Thierry Drinka, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

- de modifier l'adresse professionnelle de Julien Petitfrère, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

33800

L

U X E M B O U R G

- de noter la décision des gérants de la Société de transférer le siège social de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015

- de noter le changement d'adresse de l'associé de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2-4 rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002316/21.
(160000081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Great German Nursing Homes A, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 133.032.

EXTRAIT

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift
<i>Vertretungsbevollmächtigter

Référence de publication: 2016060401/12.
(160021349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

Great German Nursing Homes D, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 133.033.

EXTRAIT

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift
<i>Vertretungsbevollmächtigter

Référence de publication: 2016060402/12.
(160021375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

G.I.L., Groupe Immobilier Luxembourgeois Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4463 Soleuvre, 1, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 68.500.

Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour G.I.L. S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016060403/12.
(160021247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

Aequitas Europe 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 875.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 92.773.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

33801

L

U X E M B O U R G

<i>Pour Aequitas Europe 1 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016060154/11.
(160021188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

Zenith Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 169.757.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 10 décembre 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère
Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme

ZENITH FUND SA, SICAV-SIF, société d'investissement à capital variable, fonds d'investissement spécialisé ayant

eu son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

Ce même jugement a dit que les frais sont à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Carmen RIMONDINI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2016003396/17.
(160001024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Zephyr'07-S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.886.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale statutaire du 23 novembre 2015

L'assemblée a décidé:
- de réélire Messieurs Serge D'ORAZIO et Stéphane RIES, résidant tous deux professionnellement au 43 Boulevard

Royal, L-2955 Luxembourg en tant qu'administrateurs pour un nouveau mandat se terminant à l'assemblée générale sta-
tutaire de 2016.

- de coopter Mr Aurélien BARON, résidant professionnellement au 11 rue Aldringen, L-2960 Luxembourg en tant

qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2016, en remplacement de Mr Lieven JACOBS.

- de réélire Deloitte Audit, en qualité de réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat se terminant à l'assemblée

générale statutaire de 2016.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour ZEPHYR'07-S.A. SICAV-SIF
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2016003397/19.
(160001064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

1741 Asset Management Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 131.432.

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration datée du 23 novembre 2015:

Le conseil d'administration de 1741 Asset Management Funds SICAV a approuvé le transfert du siège social de la société

du 31, Z. A. Bourmicht, L-8070 Bertrange au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre

2015.

Luxembourg, le 29 décembre 2015.

<i>Pour 1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2016003398/15.
(160000970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

33802

L

U X E M B O U R G

XLNT S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 67.431.

Suite à la dénonciation du contrat de domiciliation, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg agissant en

sa qualité d'agent domiciliataire, déclare que le siège social de la société XLNT S.A., société anonyme, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B-67.431, n'est plus situé au 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2015.

<i>Pour: XLNT S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme

Référence de publication: 2016003389/15.
(160001489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Yaro Invest SA/SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire.

R.C.S. Luxembourg B 192.842.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 2015, enregistré

à Luxembourg Actes Civils, le 6 juillet 2015, relation 1LAC/2015/20970, que la société Yaro Invest SA/SPF (la «Société)
a été dissoute et liquidée par décision de l'actionnaire unique réunissant entre ses mains la totalité des actions de la Société.

Les livres et les documents sociaux de la Société resteront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège social à L-1528

Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Maître Frank Molitor.

Référence de publication: 2016003390/16.
(160001546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Vista Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.493.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 17 décembre 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 décembre 2015, 2LAC/2015/29254, aux droits
de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "VISTA
FINANCE (en liquidation)", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 97493, ayant son siège social au 25, Bou-
levard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger, alors notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 26 du 8 janvier 2004. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du même notaire,
en date du 18 novembre 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 698 du 5 avril 2006.

- La société a été mise en liquidation suivant acte notarié du notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2015, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, Monsieur

Winkler Jean-Pierre, né le 11 février 1949 à Schaarbeek (B), demeurant à Museum Street, c/o Wazni Jewellery, Doha,
Qatar et au commissaire-vérificateur, la société anonyme «A Group S.A.», avec siège social au au 3, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 62465, pour l'accomplissement
de leur fonction concernant la liquidation de la société.

- L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.

33803

L

U X E M B O U R G

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant 5 années au L-1724 Luxembourg, 25, Boulevard Prince

Henri.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Référence de publication: 2016003360/32.
(160001472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Vivaro Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 107.199.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 11 mars 2014 à 9.00 heures.

L'assemblée accepte de renouveler le mandat de président du conseil d'administration de Monsieur Joeri STEEMAN et

ce jusqu'à l'assemblée générale de 2016;

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016003361/11.
(160001109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

W. Lanneau &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 151.795.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du Rapport de l'Assemblée générale extraordinaire des associés de W. Lanneau &amp; Cie

L'assemblée des associés est tenue, extraordinairement, au siège social en date du 29 décembre 2015 à 11 heures.

<i>Résolutions

1. L'Assemblée constate qu'il n'y a plus d'activité au sein de la société depuis le 2 octobre 2015. L'assemblée approuve

la liquidation volontaire de la société W. Lanneau &amp; Cie avec effet au 2 octobre 2015.

Au 2 octobre 2015, la société est donc dissoute et liquidée.
2. L'Assemblée approuve que les livres comptables et documents sociaux de la société seront conservés à l'adresse

suivante: 5, rue Prince Jean L-4740 Pétange et ce pour une durée minimale de cinq ans.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

Werner Lanneau / Ann Stevens.

Référence de publication: 2016003365/20.
(160001317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

White River Holdco Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.266.875,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 177.742.

Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, les associés ont décidé
- d'acter et d'accepter la démission de Jerome Silvey de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015
- d'acter et d'accepter la démission de Peggy Murphy de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015
- de nommer Carl Tash avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité de

gérant pour une durée indéterminée à compter du 24 décembre 2015

- de modifier l'adresse professionnelle de Thierry Drinka, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

- de noter la décision des gérants de la Société de transférer le siège social de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015

- de noter le changement d'adresse de l'un des Associés de la Société, Blue River Holdings Lux S.à r.l., du 5 rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015

33804

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016003367/21.
(160001056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Wholesale &amp; Logistics S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 174.699.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2015 que:
L'Assemblée Générale accepte la démission de
- Monsieur Tom BEICHT, demeurant à L - 8479 Eischen, 14, Bettenwiss, né le 25.06.1970 à Luxembourg, et de
- Monsieur Freddy D'HERCKERS, demeurant à B - 4850 Montzen, 45, rue Gustave Demoulin, né le 24.12.1955 à

Wegnez (Belgique)

de leurs mandats d'Administrateurs de la société avec effet au 1 

er

 janvier 2016.

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Jan VANDENNEUCKER, demeurant à B - 3320 Hoegaarden, 28b, Henri

Dotremontstraat, né le 27.08.1964 à Tienen (Belgique) comme Administrateur et Administrateur-Délégué de la société
avec effet au 1 

er

 janvier 2016 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2018 statuant sur les comptes 2017 et entérinne la

décision du Conseil d'Administration du 18 décembre 2015 de nommer Monsieur Jan VANDENNEUCKER comme Pré-
sident du Conseil d'Administration à partir du 1 

er

 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2015.

WHOLESALE &amp; LOGISTICS S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016003383/24.
(160000733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 46.541.678,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 157.627.

Suite à la signature d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé en date du 18 décembre 2015, WPP

Luxembourg Europe S.à r.l, associé de la Société, a cédé la totalité des 7.000.000 parts sociales préférentielles de classe B
détenues dans la Société à WPPIH 2001, Inc., autre associé de la Société.

Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2016003387/15.
(160001432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

KaiserStone, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 202.584.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le seize décembre,
Par  devant  Maître  Danielle  KOLBACH,  notaire  de  résidence  à  Redange-sur-Attert,  Grand-Duché  de  Luxembourg,

soussignée.

A COMPARU:

33805

L

U X E M B O U R G

WellnesStone, société anonyme de droit Luxembourgeois, avec siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B197443

ici dûment représentée par Sara Lecomte, employée privée demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert en

vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée à Luxembourg en date du 15 décembre 2015.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le représentant de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, es-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société ano-

nyme qu'ils déclarent constituer (la «Société»).

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "KaiserStone".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale

au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le placement collectif en biens immobiliers.
En conséquence la société a pour objet d'investir en biens immobiliers, à savoir les immeubles, les droits réels sur des

immeubles, les actions avec droit de vote émises par les sociétés immobilières liées, les droits d 'option sur des immeubles,
les parts d'autres organismes de placement en biens immobiliers, les certificats immobiliers, les droits découlant de contrats
donnant un ou plusieurs biens en location-financement immobilière à la société, ainsi que tous autres biens, parts ou droits
qui seraient définis comme biens immobiliers ou toutes autres activités qui seraient autorisées par la réglementation ap-
plicable à la société.

A titre accessoire, la société peut procéder à toutes opérations et toutes études ayant trait à tous biens immobiliers tels

que décrits ci-avant et accomplir tous actes qui se rapportent aux biens immobiliers tels que l'achat, la transformation,
l'aménagement,  la  location,  la  sous-location,  la  gestion,  l'échange,  la  vente,  le  lotissement,  la  mise  sous  le  régime  de
copropriété, l'intéressement, par voie de fusion ou autrement, à toute entreprise ayant un objet similaire ou complémentaire
et, en général, toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La société ne peut agir
comme promoteur immobilier si ce n'est à titre occasionnel. La société peut également donner en location-financement des
biens immobiliers, avec ou sans option d'achat.

Toujours à titre accessoire ou temporaire, la société peut effectuer des placements en valeurs mobilières autres que celles

décrites ci-dessus et détenir des liquidités. Ces placements seront diversifiés de façon à assurer une répartition adéquate du
risque. Dans l'hypothèse où la société détiendrait pareilles valeurs mobilières, la détention de ces valeurs mobilières devra
être compatible avec la poursuite à court ou moyen terme de la politique de placement de la société et lesdites valeurs
mobilières devront en outre être inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières d'un ou négociables sur un marché
réglementé d'un Etat membre de l'Union Européenne de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public dont la
liquidité est assurée. Les liquidités peuvent être détenues dans toutes les monnaies sous la forme de dépôts à vue ou à terme
ou de tous instruments du marché monétaire susceptibles d'être aisément mobilisés. La société peut effectuer le prêt de
titres dans les conditions permises par la loi.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques
se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec

tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille Euros (EUR 350.000,-), représenté par mille (1.000) actions

d'une valeur nominale de trois cent cinquante Euros (EUR 350,-) chacune.

33806

L

U X E M B O U R G

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues con-

jointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes
revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la
société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur
ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les admi-
nistrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition

du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de
l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur

peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par

l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit

par téléfax un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses
collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion,

il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à
la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de

disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de catégorie A

ensemble avec un administrateur de catégorie B, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature,
sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés
par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs
fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

33807

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art 12. L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, ou un ou plusieurs réviseurs

d'entreprises pour exercer une surveillance sur la société.

La durée de leur mandat ne peut excéder six années, ils sont rééligibles. L'assemblée peut les révoquer à tout moment.
L'assemblée fixe leur rémunération.
Si le nombre des commissaires ou des réviseurs d'entreprises est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de

moitié, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement
des commissaires ou réviseurs d'entreprises manquants.

Lorsque la société remplira les conditions requises par la loi et que la présence d'un réviseur d'entreprises deviendra

indispensable, le mandat des commissaires aux comptes s'éteindra à la plus prochaine assemblée générale ordinaire suivant
la date de nomination du ou des premiers réviseurs d'entreprises.

Inversement, si la société n'est plus tenue de maintenir le mandat des réviseurs d'entreprises, il pourra être mis fin à leur

mandat lors de l'assemblée générale ordinaire constatant cet état et nommant un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société,
à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier

mercredi de juin à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable
suivant.  Les  autres  assemblées  générales  des  actionnaires  pourront  se  tenir  au  lieu  et  heure  spécifiés  dans  les  avis  de
convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires

en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme
mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance

de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale;

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2016.
La première assemblée générale annuelle pourra se tenir dans les dix-huit (18) qui suivent la constitution de la société.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire aux comptes sont nommés par l'assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société

Par  dérogation  à  l'article  7  des  statuts,  le  premier  président  du  conseil  d'administration  est  désigné  par  l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

33808

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

Le capital social de la société de trois cent cinquante mille Euros (EUR 350.000,-), représenté par mille (1.000) actions

d'une valeur nominale de trois cent cinquante Euros (EUR 350,-) chacune, est intégralement libéré et souscrit pas Well-
nesStone, préqualifié ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément sur le vu d'un certificat
bancaire.

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions et les libérer

intégralement par des versements en numéraire de sorte que la somme de trois cent cinquante mille Euros (EUR 350.000,-),
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Autorisation de commerce - activités réglementées

Le notaire soussigné a informé les comparants qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou bien dans l'éventualité

où la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable en possession
d'une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s'acquitter de toutes autres formalités aux fins de rendre
possible l'activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par les com-
parants.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique, WellnesStone, préqualifié, représentant l'inté-

gralité du capital social a pris les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 6 rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs pour une période maximale de quatre (4) ans, chacun pour un mandat

expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2019.

- Jean Edouard Carbonnelle, né le 14 mai 1953 à Uccle (Belgique), résidant professionnellement au Boulevard de la

Woluwe, 58, 1200 Bruxelles, Belgique, Administrateur catégorie A

- Ingrid Daerden, née le 12 janvier 1974 à Bilzen (Belgique), résidant professionnellement au Boulevard de la Woluwe,

58, 1200 Bruxelles, Belgique, Administrateur catégorie A

- David Arendt, président du Conseil d'administration, né le 4 avril 1953 à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

résidant professionnellement à Parishaff, L-2315 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, Administrateur de caté-
gorie A

- Gérard Birchen, né le 13 décembre 1961 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), résidant professionnellement au 6, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, Administrateur de catégorie B

- Karoline Willot, née le 11 janvier 1983 à Uccle (Belgique), résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, Administrateur de catégorie B.

3. Est nommé réviseur d'entreprises agréée aux comptes de la société Audit Conseil Services S.à r.l., avec siège social

au 204, route d'Arlon, L-8010 Strassen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B142685.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture, le mandataire du comparant prémentionné, connu par le notaire par ses nom, prénom, état civil et

résidence, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 17 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21969. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211513/222.
(150237216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

33809

L

U X E M B O U R G

KPB 2 Core S.C.S., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 202.543.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December.
Before Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

THERE APPEARED:

1. KQ GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under

the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number
B 181.737,

here represented by Ms. Virginie Mangeon, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal in Luxembourg, on 10 December 2015; and

2. KQ S.C.S. SICAV-SIF, a société en commandite simple incorporated and organised under the laws of the Grand-

Duchy of Luxembourg, qualifying as investment company with variable capital - specialised investment fund (société
d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), having its registered office at 205, route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
registration number B 182.554,

here represented by Ms. Virginie Mangeon, above named, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg,

on 10 December 2015.

The proxies given, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as here above stated, have requested the officiating notary to document the following

limited partnership agreement of a société en commandite simple to be incorporated and governed by the relevant laws and
the present articles of incorporation.

<i>Limited partnership agreement

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Name. There is hereby formed a "société en commandite simple" under the name of "KPB 2 Core S.C.S."

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Partnership"), and in particular by the law of August
10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended (the "1915 Law"), as well as by the present limited partnership agreement

(the "Limited Partnership Agreement").

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Partnership is established in Luxembourg (Grand -Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary General Meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Limited Partnership Agreement and
in accordance with this Limited Partnership Agreement and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the
1915 Law, as amended or restated from time to time ("Luxembourg Law").

2.3 However, the Sole Manager of the Partnership is authorised to transfer the registered office of the Partnership within

the city of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Partnership, the registered office of the Partnership may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Partnership's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a
Luxembourg Partnership. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager.

2.5 The Partnership may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Object. The objects of the Partnership are:
3.1 to purchase or otherwise acquire, develop and manage real estate asset, which is located in a state being a full member

of the European Economic Area or the OECD and which is either developed, under development or destined for an im-
mediate development (“Real Estate”); or

3.2 to hold shares in any company the sole object and purpose of which is pursuant to its articles or other constitutional

documents to purchase or otherwise acquire, develop and manage Real Estate which is located in a state being a full member
of the European Economic Area or the OECD and which is either developed, under development or destined for an im-
mediate development ("Real Estate Companies"); for the avoidance of doubt, the Partnership may only invest in project

33810

L

U X E M B O U R G

developments on properties owned by the Partnership provided that a third party property developer assumes development
risks;

3.3 to enter into any and all contracts and agreements for carrying out the purpose of the Partnership and for administration

and operation of the Partnership, and pay any expenses connected therewith;

3.4 to acquire interests and create subsidiaries by means of equity or debt or by combination of both;
3.5 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any Real Estate as the Sole Manager thinks fit and/or to sell,

exchange and dispose of shares held in Real Estate Companies for such consideration as the Sole Manager thinks fit;

3.6 to the extent appropriate, enter into contractual arrangements with its subsidiaries and/or other entities in which it

holds an interest to assume management, holding or financing activities and other functions of a managing holding company;

3.7 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager incidental or conducive to the attainment of
all or any of the Partnership's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Partnership will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.

"Real Estate" includes
(a) properties consisting of land and building (rented flat property, business property and mixed used properties);
(b) undeveloped properties and properties under development provided that the building license provides for the use as

rented flat property, business property or mixed used property;

(c) long-term investment rights in relation to real property, in particular heritable building rights, co-ownership rights

and lease-hold-rights;

(d) any other meaning which the Commission de Surveillance du Secteur Financier and the laws and ordinances which

are respectively applicable in Luxembourg provide for this term; and

(e) objects which are necessary for the management of the assets in the meaning of the foregoing letters (a) to (d).
For the avoidance of doubt, the Partnership may only invest in project developments on properties owned by the Part-

nership provided that a third party property developer assumes development risks.

4. Duration.
4.1 The Partnership is established for an unlimited duration.
4.2 The death, legal incapacity, dissolution, insolvency, bankruptcy, winding-up, gestion contrôlée, sursis de paiement,

compromis avec les créanciers, court control liquidation or any other cause of incapacity of a Limited Partner or a General
Partner will not result in the dissolution of the Partnership.

Chapter II. - Capital, Interests

5. Capital.
5.1 The Partnership's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and divided into twelve thousand

five hundred (12,500) partnership interest with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and represented by one (1) unlimited
partnership interest (the "GP Interest") and twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) limited partnership interests
(together the "LP Interests" and each an "LP Interest"), all fully paid up. The GP Interest and the LP Interests are together
referred to as the "Interests" and each an "Interest".

5.2 So far as permitted by law, the authorised capital of the Partnership is fixed at thirty seven million Euro (EUR

37,000,000). The General Partner shall have the power to issue Interests to the Limited Partners, and increase the capital
of the Partnership within the limits of its authorised capital for a period ending five years after the publication date of the
Limited Partnership Agreement in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

5.3 Such authorisation may be renewed by decision of a General Meeting.
5.4 The realisation of the authorised capital will take place by the creation and the issue of new Interests with a par value

of one Euro (EUR 1.-) each and will benefit from the same rights as Interests previously issued.

5.5 KQ GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised

under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number
B 181.737 has been allotted one (1) GP Interest and is the sole unlimited partner of the Partnership (the "General Partner").

5.6 The holders of the LP Interests are together referred to as the "Limited Partners" and each a "Limited Partner". The

General Partner and the Limited Partners are together referred to as the "Partners".

5.7 The Interests issued by the Partnership shall only be in registered form.
5.8 All LP Interests have equal rights subject to as otherwise provided for in this Limited Partnership Agreement and

all GP Interests have equal rights subject to as otherwise provided for in this Limited Partnership Agreement.

6. Indivisibility of interests. Each Interest is indivisible.

33811

L

U X E M B O U R G

7. Transfer of interests.
7.1 Any GP Interest may only be transferred with the unanimous consent of all of the Partners.
7.2 To the extent permitted by law, any LP Interests are freely transferable between Partners or to third parties.
7.3 Any transfer of Interest must be evidenced by way of written documents and comply with the formalities set out in

article 1690 of the Luxembourg civil code.

8. Management of the partnership.
8.1 The Partnership will be managed by the General Partner acting as manager (the "Manager") who shall be appointed

by a resolution of the General Meeting passed in accordance with Luxembourg Law and this Limited Partnership Agree-
ment.

8.2 As long as the Partnership has only one Manager, being KQ GP S.à r.l., it is referred to in this Limited Partnership

Agreement as the "Sole Manager".

8.3 The Sole Manager shall be vested with the broadest powers to manage the Partnership, to perform all acts of admi-

nistration and disposition in the name and in the interest of the Partnership and which are consistent with the Partnership's
object and to represent the Partnership vis-à-vis third parties.

8.4 All powers not expressly reserved by law or this Limited Partnership Agreement to the General Meeting shall be

within the competence of the Sole Manager.

8.5 The Limited Partners shall take no part in the operation of the Partnership or the management or control of its business

and affairs, and shall have no right or authority to act for the Partnership or to take any part in, or to interfere with, the
conduct or management of the Partnership other than as provided by 1915 Law or set forth in this Limited Partnership
Agreement.

9. Resignation and removal of a general partner as a manager.
9.1 The General Partner may be removed as manager at any time without cause with a six months notice period by

means of a resolution of the General Meeting.

9.2 The General Partner may also be removed as manager at any time for cause (i.e. in case of fraud, gross negligence

or wilful misconduct), by means of a resolution of the General Meeting.

9.3 For the avoidance of doubt, the approval of the General Partner as manager is not required, to validly decide on its

removal.

9.4 In the event of the removal, resignation, death, legal incapacity, dissolution, insolvency, bankruptcy, winding-up,

gestion contrôlée, sursis de paiement, compromis avec les créanciers, court control liquidation or any other cause of inca-
pacity of the Sole Manager, the Partnership will not terminate and the general meeting of the Partners shall promptly take
such steps as shall be necessary in order to appoint a new Manager. In this case, any Partner shall have the right to convene
the general meeting of the Partners. The resolution shall be adopted in the manner required to amend the Limited Partnership
Agreement.

9.5 If need be (in case the General Partner to be replaced is the Sole Manager), the general meeting of the Partners shall

cause the Partnership's share capital to be increased for the purpose of creating one (1) new unlimited partnership interest
to a new general partner. The General Meeting may decide the redemption by the Partnership or the cancellation of the
former GP Interest and the General Partner by adhering to this Limited Partnership Agreement agrees to such redemption
in such situation at a price corresponding to the nominal value of the GP Interest.

9.6 The retiring General Partner (being the Sole Manager) shall make available to the successor "General Partner" such

documents and records and provide such assistance as the successor "General Partner" may reasonably request for the
purposes of performing its functions as "General Partner".

9.7 The General Partner's resignation as a Manager shall only take effect upon the effective appointment of its successor

or as decided by the General Meeting.

10. Representation of the partnership. Subject as provided by Luxembourg Law and this Limited Partnership Agreement,

the following are authorised, by their sole signature, to represent and/or bind the Partnership:

10.1 the Sole Manager, acting by any legal representative or representatives;
10.2 any other person to whom such a power has been delegated to him by the Sole Manager. For the avoidance of

doubt, no powers will be delegated by the Sole Manager to any Limited Partner and no Limited Partner may represent the
Partnership.

11. Liability of the partners.
11.1 The General Partner, in its capacity of unlimited partner, shall be indefinitely liable with the Partnership (indéfi-

niment et solidairement responsable) for all of the liabilities of the Partnership to the extent provided for by Luxembourg
Law.

11.2 Subject to the applicable provisions of the Luxembourg Law, the Limited Partners shall not act on behalf of the

Partnership other than by exercising their rights as partners in General Meetings and shall only be liable for the debts and
losses of the Partnership up to the amount of the funds which they have promised to contribute to the Partnership.

33812

L

U X E M B O U R G

12. General meeting.
12.1 Convening notices to general meetings of Partners (the "General Meeting") are validly addressed to the Partners

when sent to their place of residence or any other address as previously indicated by the relevant Partner to the Partnership.
The convening notice shall include the date and place of the General Meeting as well as the agenda of the meeting. In the
event of a General Meeting convened to amend the Limited Partnership Agreement, the agenda shall indicate the proposed
amendments to the Limited Partnership Agreement and, where applicable, the text of those which concern the objects or
the form of the Partnership.

12.2 A legal representative of the Sole Manager may act as chairman in all General Meetings.
12.3  Resolutions  of  the  General  Meeting  (including  resolutions  relating  to  amendments  of  the  Limited  Partnership

Agreement) unless a more strict stipulation is provided by law shall be taken at the simple majority of the Interests present
or represented, except for resolutions relating to the winding-up, for which the provisions of article 15 of this Limited
Partnership Agreement shall apply.

12.4 Each Interest gives right to one vote.
12.5 Nevertheless, and in any case, each resolution will need the approval of the General Partner, such approval(s) not

to be unreasonably withheld.

12.6 The annual General Meeting will be held in Luxembourg on the last Thursday in March following the end of the

financial year at such place and on such date as specified in the convening notices.

12.7 Extraordinary General Meetings may be held in places and time indicated in the convening notices. The General

Meeting may be convened either by the Sole Manager or by Limited Partners representing 50% of the share capital.

12.8 Partners may not change the nationality of the Partnership otherwise than by unanimous vote of the Partners and

no Partner may be obliged to increase its commitment to the Partnership without such Partner's consent.

12.9 A General Meeting may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening

requirements and formalities if all of the Partners have waived the relevant convening requirements and formalities either
in writing or, at the relevant General Meeting, in person or by an authorised representative.

12.10 A Partner may be represented at a General Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar

means) a proxy or attorney who need not be a Partner.

12.11 The Partners are entitled to participate in a General Meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present for the calculation of quorum and majority conditions and voting.
These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting where deliberations shall
be online without interruption.

13. Business year.
13.1 The Partnership's financial year starts on 1 

st

 October and ends on the 30 

st

 September of the next year.

13.2 Each year, at the end of the financial year, the Sole Manager will prepare the annual accounts of the Partnership

in accordance with the applicable legal provisions (the "Annual Accounts") which will be submitted to the Partners for
approval during the annual General Meeting.

14. Distributions on interests.
14.1 The General Meeting upon recommendation of the Sole Manager shall decide on the allocation of the results

provided that, in case of distributions, such distributions shall be made as follows:

14.2 The General Meeting upon recommendation of the General Partner can decide that the profits of the Partnership

shall be distributed to the Partners.

14.3 Such General Meeting may nevertheless also decide that the profits be carried forward or allocated to a distributable

reserve.

14.4 For any class entitled to distributions, the General Partner may at any time decide to pay interim dividends in

compliance with the conditions set forth by law.

15. Dissolution and liquidation.
15.1 The decision of dissolution and winding-up of the Partnership shall be validly taken if it is carried by at least the

half of the Partners representing at least three-quarters of the share capital. The consent of the General Partner is required,
such consent not to be unreasonably withheld.

15.2 A General Partner may act as liquidator.
15.3 After payment of all debts and any liabilities of the Partnership and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the Partners in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the
same economic result as the distribution rules set for dividend distributions as set out under article 14 of this Limited
Partnership Agreement.

16. Interpretation and Luxembourg law.
16.1 In this Limited Partnership Agreement:
16.1.1 a reference to:

33813

L

U X E M B O U R G

(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,

state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)

thereof.

16.1.2 the words "include" or "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general

words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by word indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

16.1.3 the headings to this Limited Partnership Agreement do not affect their interpretation or construction.
16.2 In addition to this Limited Partnership Agreement, the Partnership is also governed by all applicable provisions of

Luxembourg Law.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Partnership and shall terminate on 30 September

2016.

The first annual General Meeting shall be held on 30 March 2017.

<i>Subscription

The Partnership's capital has been subscribed as follows:

GP Interest:
Subscriber

Subscribed

capital

Number of

GP interests

KQ GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 1.-

1

LP Interests:
Subscriber

Subscribed

capital

Number of

LP interests

KQ S.C.S. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,499.-

12,499

All the one (1) GP Interest and the twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) LP Interests have been fully paid

in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the
Partnership, as has been proven to the notary.

<i>First extraordinary general meeting of partners

The above Partners of the Partnership representing the totality of Interests and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary General Meeting and have unanimously passed the following reso-
lutions:

1) The Partnership's registered office address is fixed at 35F, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg.

2) As set out in the articles of incorporation, KQ GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) having its registered office at 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 181.737, is appointed
sole manager.

<i>Expenses

The expenses, remunerations or charges, in any form whatsoever which shall be borne by the Partnership as a result of

its formation, are estimated at about one thousand eight hundred Euro (EUR 1.800,-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above named

person, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing person, in case
of divergence between the English and the German versions, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary, by surname, first name,

civil status and residence, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:

Am elften Dezember des Jahres zweitausendundfünfzehn,
Vor der unterzeichnenden Notarin, Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

33814

L

U X E M B O U R G

1. KQ GP S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (beschränkt haftende Gesellschaft) nach Luxemburger Recht mit

Geschäftssitz in 205 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, im Handelsregister des Großher-
zogtums Luxemburg unter der Nummer B 181.737 angemeldet,

vertreten durch Ms. Virginie Mangeon, Arbeitnehmer, geschäftsansässig in Luxemburg, handelnd aufgrund einer ihr

am 10. Dezember 2015 in Luxemburg erteilten Vollmacht;

2.  KQ  S.C.S.  SICAV-SIF,  eine  société  en  commandite  simple  (Kommanditgesellschaft)  nach  Luxemburger  Recht,

qualifiziert als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - Spezialinvestmentfonds (société d'investissement à capital
variable - fonds d'investissement spécialisé), mit Geschäftssitz in 205 route d' Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, beim Handelsregister des Großherzogtums Luxemburg unter der Nummer B 182.554 angemeldet,

vertreten durch Ms. Virginie Mangeon, oben genannt, handelnd aufgrund einer ihr am 10. Dezember 2015 in Luxemburg

erteilten Vollmacht.

Die Vollmachten wurden von der Erschienenen und dem amtierenden Notar mit dem Vermerk ne varietur unterzeichnet

und dieser Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser Urkunde bei den Registerbehörden eingereicht zu werden;

Die so vertretenen Parteien baten den Notar um Beurkundung des nachstehenden Gesellschaftsvertrags zum Zwecke

der Gründung einer société en commandite simple (Kommanditgesellschaft) nach den maßgeblichen gesetzlichen Bestim-
mungen sowie dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag.

<i>Gesellschaftsvertrag

Kapitel I - Rechtsform, Name, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft

1. Rechtsform - Name. Hiermit wird eine "société en commandite simple" (Kommanditgesellschaft) errichtet, deren

Name "KPB 2 Core S.C.S." lautet und die den für sie maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Gesetz
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das "Gesetz von 1915") und diesem Gesellschaftsvertrag (der "Gesell-
schaftsvertrag") unterliegt (die "Gesellschaft").

2. Eingetragener Geschäftssitz.
2.1 Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2.2 Durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die gemäß den Bestimmungen dieses Ge-

sellschaftsvertrags sowie der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere
des Gesetzes von 1915 ("Luxemburger Recht"), über die für die Verabschiedung von Satzungsänderungen erforderliche
Beschlussfähigkeit verfügt, kann der eingetragene Geschäftssitz auch an einen anderen Ort innerhalb des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.

2.3 Der Alleinige Geschäftsführer der Gesellschaft ist jedoch berechtigt, den Geschäftssitz an einen anderen Ort inner-

halb der Gemeinde Luxemburg zu verlegen.

2.4  Sollte  sich  eine  Situation  ergeben  oder  unmittelbar  zu  erwarten  sein,  in  der  aufgrund  militärischer,  politischer,

wirtschaftlicher oder sozialer Ereignisse die Gesellschaft ihre gewöhnliche Geschäftstätigkeit an ihrem Geschäftssitz nicht
ausüben kann, kann der Geschäftssitz der Gesellschaft bis zu einer Normalisierung der Situation vorübergehend in das
Ausland verlegt werden; die Nationalität der Gesellschaft wird durch so eine vorübergehende Maßnahme nicht berührt;
die Gesellschaft bleibt im Falle einer solchen vorübergehenden Verlegung ihres Geschäftssitzes eine Luxemburger Ge-
sellschaft. Über eine solche Verlegung des Geschäftssitzes ins Ausland entscheidet der Alleinige Geschäftsführer.

2.5 Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigstellen innerhalb und außerhalb des Großherzogtums Luxemburg

errichten.

3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist es,
3.1 Immobilien zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, zu entwickeln und zu verwalten, die in einem Staat belegen

sind, der Vollmitglied der Europäischen Gemeinschaften oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung ist, wobei diese Immobilien bebaut, unbebaut oder kurzfristig für eine Bebauung vorgesehen sein können;
sowie

3.2 Anteile an Gesellschaften zu halten, deren ausschließlicher satzungsmäßiger Geschäftsgegenstand und Geschäfts-

zweck darin besteht, Immobilien zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, zu entwickeln und zu verwalten, die in einem
Staat belegen sind, der Vollmitglied der Europäischen Gemeinschaften oder der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung ist, wobei diese Immobilien bebaut, unbebaut oder kurzfristig für eine Bebauung vorgesehen
sein können ("Immobiliengesellschaften"); klarstellend wird insoweit festgestellt, dass die Gesellschaft sich nur an Pro-
jekten zur Entwicklung von ihr gehörenden Immobilien beteiligen darf, sofern ein von der Gesellschaft unabhängiger
Bauträger mit dem Entwicklungsprojekt verbundene Risiken übernimmt;

3.3 zum Zwecke der Verfolgung des Gesellschaftszwecks sowie der Verwaltung und der Führung der Gesellschaft

jedwede Verträge und Vereinbarungen abzuschließen und in diesem Zusammenhang anfallende Kosten zu tragen;

3.4 durch Einsatz von Eigenkapital und/oder Fremdkapital Beteiligungen zu erwerben und Tochterunternehmen zu

errichten;

33815

L

U X E M B O U R G

3.5 Immobilien zu verkaufen, verpachten, tauschen, vermieten oder sonst darüber zu verfügen, so wie es der Alleinige

Geschäftsführer als zweckmäßig erachtet, und/oder Anteile an Immobiliengesellschaften für eine nach Auffassung des
Alleinige Geschäftsführers angemessene Gegenleistung zu verkaufen, zu tauschen oder sonst darüber zu verfügen;

3.6 in angemessenem Umfang mit Tochterunternehmen und/oder anderen Unternehmen, an denen die Gesellschaft

beteiligt  ist,  aufgrund  entsprechender  vertraglicher  Vereinbarungen  Geschäftsführungs-,  Verwaltungs-  oder  Finanzie-
rungsfunktionen bzw. andere Aufgaben einer geschäftsführenden Holdinggesellschaft zu übernehmen;

3.7 sämtliche Handlungen (einschließlich des Abschlusses, der Ausfertigung und der Durchführung von Verträgen,

Urkunden und sonstigen Vereinbarungen jeder Art mit oder zugunsten einer beliebigen Person) vorzunehmen, die nach
Auffassung des Alleinigen Geschäftsführers in Zusammenhang mit der Verfolgung aller bzw. einzelner Gesellschafts-
zwecke oder der Ausübung aller oder einzelner Befugnisse der Gesellschaft erforderlich oder zweckmäßig sind;

JEWEILS  UNTER  DEM  VORBEHALT,  dass  die  Gesellschaft  ohne  eine  entsprechende  nach  Luxemburger  Recht

erteilte Erlaubnis keine Geschäfte tätigen wird, die eine Erbringung von erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistungen be-
inhalten oder für die sonst nach Luxemburger Recht eine besondere Gewerbeerlaubnis erforderlich ist.

"Immobilien" beinhaltet
(a) entsprechende aus Land und Gebäuden bestehende Objekte (Mietwohnungen, Gewerbeobjekte, gemischt genutzte

Immobilien);

(b) unbebaute und sich im Zustand der Bebauung befindliche Grundstücke, sofern diese aufgrund einer vorliegenden

Baugenehmigung für eine Nutzung als Mietwohnung, Gewerbeobjekt oder eine gemischte Nutzung bestimmt sind;

(c) langfristige Rechte an Grundstücken, insbesondere Erbbaurechte, Miteigentumsrechte oder andere grundstücksglei-

che Rechte;

(d) jeglichen sonstigen Immobilien im Sinne der Luxemburger Finanzaufsicht sowie der jeweils in Luxemburg geltenden

Gesetze und Verordnungen; sowie

(e) Objekte, die für die Verwaltung von Vermögenswerten im Sinne der vorstehenden Unterabsätze (a) bis (d) erfor-

derlich sind.

Klarstellend wird festgestellt, dass die Gesellschaft sich nur an Projekten zur Entwicklung von ihr gehörenden Immo-

bilien beteiligen darf, sofern ein von der Gesellschaft unabhängiger Bauträger mit dem Entwicklungsprojekt verbundene
Risiken übernimmt.

4. Dauer der Gesellschaft.
4.1 Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.
4.2 Im Falle des Todes, der Geschäftsunfähigkeit, der Auflösung, der Insolvenz, des Konkurses, der Abwicklung, einer

gestion contrôlée (kontrollierten Verwaltung), eines sursis de paiement (Stundung von Zahlungen), eines compromis avec
les créanciers (Vergleichs mit Gläubigern), einer gerichtlichen Liquidation oder anderweitig bedingten Handlungsunfä-
higkeit eines Kommanditisten oder Komplementärs wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

Kapitel II - Gesellschaftskaptial, Anteile an der Gesellschaft

5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) und ist aufgeteilt in zwölftausend-

fünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-), wobei ein (1) dieser sämtlich
voll eingezahlten Anteile an dem Kapital der Gesellschaft Komplementäranteil (die "Komplementäranteile") ist und zwölf-
tausendvierhundertundneunundneuntzig (12.499) weitere Anteile an dem Kapital der Gesellschaft Kommanditanteile (die
"Kommanditanteile" bzw. einzeln ein "Kommanditanteil" genannt) sind. Die Komplementäranteile und die Kommandi-
tanteile werden nachstehend die "Gesellschaftsanteile" bzw. einzeln ein "Gesellschaftsanteil" genannt.

5.2  Sofern  es  das  Gesetz  erlaubt,  das  authorisierte  Kapital  der  Gesellschaft  beträgt  siebendreissig  Millionen  (EUR

37,000,000). Der Komplementär ist berechtigt, Gesellschaftsanteile an die Kommanditisten auszugeben und innerhalb
eines Zeitraums von fünf Jahren ab der Veröffentlichung des Gesellschaftsvertrages in dem Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations das Gesellschaftskapital zu erhöhen, ohne dass dabei der Betrag des authorisierten Kapitals über-
schritten werden darf.

5.3 Diese Befugnis kann durch Beschluss einer Gesellschafterversammlung erneuert werden.
5.4 Die Inanspruchnahme des authorisierten Kapitals erfolgt durch Schaffung und Ausgabe neuer Gesellschaftsanteile

mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-), die jeweils mit den gleichen Rechten verbunden sind wie bereits zuvor
ausgegebene Kommanditanteile.

5.5 KQ GP S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (beschränkt haftende Gesellschaft) nach Luxemburger Recht

mit Geschäftssitz in 205 route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, beim Handelsregister des Groß-
herzogtums Luxemburg unter der Nummer B 181.737 angemeldet, sind ein (1) Komplementäranteil zugeteilt worden und
ist alleiniger unbeschränkt haftender Gesellschafter der Gesellschaft (der "Komplementär").

5.6 Die Inhaber der Kommanditanteile werden gemeinsam die "Kommanditisten" bzw. jeweils einzeln ein "Komman-

ditist" genannt. Der Komplementär und die Kommanditisten werden auch zusammen die "Gesellschafter" genannt.

5.7 Anteile an der Gesellschaft werden ausschließlich als Namensanteile ausgegeben.

33816

L

U X E M B O U R G

5.8 Außer sofern in diesem Gesellschaftsvertrag anders bestimmt sind mit allen Kommanditanteilen die gleichen Rechte

verbunden; ebenso sind außer sofern in diesem Gesellschaftsvertrag anders bestimmt mit allen Komplementäranteilen die
gleichen Rechte verbunden.

6. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Eine Teilung von Gesellschaftsanteilen an der Gesellschaft ist ausgeschlossen.

7. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.
7.1 Komplementäranteile können nur mit Zustimmung sämtlicher Gesellschafter übertragen werden.
7.2 Sofern rechtlich zulässig sind Kommanditanteile zwischen den Gesellschaftern und gegenüber Dritten frei über-

tragbar.

7.3 Eine Übertragung von Gesellschaftsanteilen muss stets schriftlich dokumentiert sein und den Formvorschriften des

Art. 1690 des Luxemburger Zivilgesetzbuches entsprechen.

8. Geschäftsführung der Gesellschaft.
8.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von dem Komplementär als Geschäftsführer (die "Geschäftsführer") geführt,

wobei die Bestellung der Geschäftsführer durch gemäß Luxemburger Recht und diesem Gesellschaftsvertrag gefassten
Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgt.

8.2 Sofern die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, nämlich die KQ GP S.à r.l., wird dieser Geschäftsführer in

diesem Gesellschaftsvertrag der "Alleinige Geschäftsführer" genannt.

8.3 Der Alleinige Geschäftsführer ist mit den umfassendsten zulässigen Befugnissen zur Führung der Geschäfte der

Gesellschaft sowie zur Vornahme jeglicher Verwaltungshandlungen und Verfügungen im Namen und im Interesse der
Gesellschaft und im Einklang mit dem Zweck der Gesellschaft ausgestattet und berechtigt, die Gesellschaft gegenüber
Dritten zu vertreten.

8.4 Alle Rechte und Befugnisse, die nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder gemäß diesem Gesellschaftsvertrag

der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers.

8.5 Die Kommanditisten sind an der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, an der Führung oder Überwachung von deren

Geschäften, Geschäftstätigkeit oder den sonstigen Angelegenheiten der Gesellschaft nicht beteiligt und sind nicht befugt,
die Gesellschaft zu vertreten oder an der Führung der Geschäfte der Gesellschaft teilzunehmen bzw. diese zu beeinflussen,
außer sofern und soweit in dem Gesetz von 1915 oder in diesem Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt ist.

9. Rücktritt und Abberufung eines Komplementärs als Geschäftsführer.
9.1 Der Komplementär kann ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung und unter Wahrung einer Frist von sechs Monaten abberufen werden.

9.2 Weiterhin kann der Komplementär jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aus wichtigem Grund

(d.h. wegen betrügerischer Handlungen oder eines grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Fehlverhaltens) abberufen werden.

9.3 Klarstellend wird festgestellt, dass ein Beschluss über die Abberufung des Komplementärs zu seiner Gültigkeit nicht

der Zustimmung des Komplementärs bedarf.

9.4 Im Falle des Todes, des Rücktritts, der Abberufung, der Geschäftsunfähigkeit, der Auflösung, der Insolvenz, des

Konkurses, der Abwicklung, einer gestion contrôlée (kontrollierten Verwaltung), eines sursis de paiement (Stundung von
Zahlungen), eines compromis avec les créanciers (Vergleichs mit Gläubigern), einer gerichtlichen Liquidation oder an-
derweitig bedingten Geschäftsunfähigkeit des Alleingesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, vielmehr wird
die Gesellschafterversammlung unverzüglich die Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um einen neuen Geschäfts-
führer  zu  bestellen.  In  einem  solchen  Fall  ist  jeder  Gesellschafter  zur  Einberufung  einer  Gesellschafterversammlung
berechtigt. Für die Beschlussfassung gelten in einem solchen Fall die gleichen Bestimmungen wie für eine Änderung des
Gesellschaftsvertrags.

9.5 Sofern erforderlich (falls der zu ersetzende Komplementär der Alleinige Geschäftsführer ist), wird die Gesellschaf-

terversammlung eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals beschließen, damit so für einen neuen Komplementär ein (1)
neuer Komplementäranteil geschaffen werden kann. Die Gesellschafterversammlung kann die Einziehung oder Vernich-
tung des vorherigen Komplementäranteils gegen Zahlung eines Betrages in Höhe des Nennwerts des Komplementäranteils
beschließen, der Komplementär erklärt hierzu seine Zustimmung, indem er diesen Gesellschaftsvertrag als für ihn ver-
bindlich akzeptiert.

9.6 Der ausscheidende Komplementär (und Alleinige Geschäftsführer) wird seinem Nachfolger als Komplementär der

Gesellschaft alle Urkunden und Unterlagen zur Verfügung stellen und jegliche Unterstützung gewähren, die dieser in
angemessenem Rahmen zum Zwecke der Wahrnehmung seiner Aufgaben als Komplementär verlangen mag.

9.7 Das Ausscheiden des Komplementärs aus seiner Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft tritt erst mit der

wirksamen Bestellung seines Nachfolgers in Kraft, außer sofern durch Beschluss der Gesellschafterversammlung etwas
anderes bestimmt ist.

10. Vertretung der Gesellschaft. Außer sofern nach Luxemburger Recht oder diesem Gesellschaftsvertrag eine andere

Regelung gilt sind folgende Personen für die Gesellschaft alleine zeichnungsberechtigt bzw. berechtigt, die Gesellschaft
zu vertreten und/oder zu verpflichten:

10.1 der Alleinige Geschäftsführer, vertreten durch seine (gesetzlichen) Vertreter;

33817

L

U X E M B O U R G

10.2  jede  andere  Person,  der  von  dem  Alleinigen  Geschäftsführer  entsprechende  Vertretungsbefugnisse  übertragen

worden sind. Klarstellend wird festgestellt, dass der Alleinige Geschäftsführer keine Kommanditisten zur Vertretung der
Gesellschaft ermächtigen wird und dass kein Kommanditist berechtigt ist, die Gesellschaft zu vertreten.

11. Haftung der Gesellschafter.
11.1 Der Komplementär haftet in seiner Eigenschaft als persönlich haftender Gesellschafter uneingeschränkt und ge-

samtschuldnerisch (indéfiniment et solidairement responsable) für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft, soweit nach
Luxemburger Recht eine solche Haftung gegeben ist.

11.2 Unbeschadet geltender Bestimmungen des Luxemburger Rechts werden die Kommanditisten ausschließlich inso-

weit für die Gesellschaft tätig, als dass sie in den Gesellschafterversammlungen ihre Gesellschafterrechte wahrnehmen,
und haften nur bis in Höhe der von ihnen jeweils übernommenen Beteiligung an der Gesellschaft für Verbindlichkeiten
oder Verluste der Gesellschaft.

12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Einladungen an die Gesellschafter zu Versammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft (die "Gesellschafter-

versammlung") erfolgen wirksam, indem sie an die von den einzelnen Gesellschaftern der Gesellschaft jeweils mitgeteilten
Wohnsitz- oder sonstigen Adresse übermittelt werden. Aus den Einladungen müssen Zeit und Ort der Gesellschafterver-
sammlung  sowie  deren  Tagesordnung  ersichtlich  sein.  Soll  in  einer  Gesellschafterversammlung  eine  Änderung  des
Gesellschaftsvertrages beschlossen werden, muss die vorgeschlagene Änderung des Gesellschaftsvertrages aus der Ta-
gesordnung ersichtlich sein; soll der Gesellschaftszweck oder die Rechtsform der Gesellschaft geändert werden, muss der
volle Wortlaut der vorgeschlagenen Änderung in der Einladung enthalten sein.

12.2 In allen Gesellschafterversammlungen kann der Vorsitz von einem entsprechend ermächtigten Vertreter des Al-

leinigen Geschäftsführers übernommen werden.

12.3 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung (auch sofern sie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages zum Ge-

genstand haben) werden, sofern das Gesetz keine strengere Regelung vorsieht, mit einfacher Mehrheit der Stimmen der
auf der Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter gefasst; dies gilt nicht für eine Beschlussfassung über
eine Abwicklung der Gesellschaft gemäß den insoweit maßgeblichen Bestimmungen von Ziffer 15 dieses Gesellschafts-
vertrages.

12.4 Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme.
12.5 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen stets der Zustimmung des Komplementärs, der diese Zu-

stimmung jedoch nicht willkürlich verweigern darf.

12.6 Die jährlich abzuhaltende ordentliche Gesellschafterversammlung findet am letzten Donnerstag des Monats März

nach dem Ende eines Geschäftsjahres in Luxemburg statt, wobei Ort und Zeit der Versammlung jeweils in der Einladung
mitzuteilen sind.

12.7 Darüber hinaus können außerordentliche Gesellschafterversammlungen einberufen werden, wobei Ort und Zeit

der Versammlung in der jeweiligen Einladung mitzuteilen sind. Die Einberufung einer Gesellschafterversammlung kann
entweder durch den Alleinigen Geschäftsführer, oder durch Kommanditisten erfolgen, die mindestens 50% der stimmbe-
rechtigten Anteile halten.

12.8 Die nationale Zugehörigkeit der Gesellschaft kann nur durch einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter geändert

werden; kein Gesellschafter kann gegen seinen Willen verpflichtet werden, seine Beteiligung an der Gesellschaft zu er-
höhen.

12.9 Eine Gesellschafterversammlung kann auch in rechtswirksamer Weise beraten und Beschlüsse verabschieden, ohne

dass alle Bestimmungen über ihre Einberufung und weitere Formerfordernisse eingehalten sind, sofern alle Gesellschafter
auf die Einhaltung der entsprechenden Frist- und Formvorschriften verzichtet haben, wobei ein solcher Verzicht in Schrift-
form erfolgen oder im Verlauf der entsprechenden Gesellschafterversammlung persönlich oder durch einen ermächtigten
Vertreter erklärt werden kann.

12.10  Gesellschafter  können  einen  Stimmrechtsbevollmächtigten  oder  sonstigen  Vertreter,  der  nicht  selber  Gesell-

schafter  sein  muss,  schriftlich  (auch  per  Fax,  E-Mail  oder  in  vergleichbarer  Form)  Vollmacht  erteilen,  sie  auf  einer
Gesellschafterversammlung zu vertreten.

12.11 Eine Teilnahme an Gesellschafterversammlungen kann auch per Videokonferenz oder durch Einsatz anderer

Telekommunikationsmittel erfolgen, die eine Identifizierung des betreffenden Gesellschafters ermöglichen, der dann bei
der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Mehrheitsverhältnisse bei Abstimmungen als anwesend gilt. Die einge-
setzten Übertragungsmittel müssen so beschaffen sein, dass eine effektive Teilnahme an der Versammlung in Echtzeit
ununterbrochen gewährleistet ist.

13. Geschäftsjahr.
13.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Oktober und endet am 30. September des darauf folgenden

Jahres.

13.2 Der Alleinige Geschäftsführer wird zum Ende eines jeden Geschäftsjahres einen den gesetzlichen Bestimmungen

entsprechenden Jahresabschluss (der "Jahresabschluss") erstellen und den Gesellschaftern zur Genehmigung im Rahmen
der ordentlichen Gesellschafterversammlung vorlegen.

33818

L

U X E M B O U R G

14. Ausschüttungen auf Gesellschaftsanteile.
14.1 Die Gesellschafterversammlung beschließt aufgrund eines Vorschlags des Alleinigen Geschäftsführers über die

Ergebnisverwendung, wobei eventuell erfolgende Ausschüttungen wie folgt vorgenommen werden:

14.2 Die Gesellschafterversammlung kann auf Vorschlag des Komplementärs beschließen, dass die Gewinne der Ge-

sellschaft an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

14.3 Unabhängig davon kann die Gesellschafterversammlung auch beschließen, dass die Gewinne vorgetragen oder

ausschüttungsfähigen Rücklagen zugeführt werden.

14.4 Der Komplementär kann jederzeit bestimmen, dass auf ausschüttungsberechtigte Anteile gemäß den gesetzlichen

Bestimmungen Abschlagszahlungen geleistet werden.

15. Auflösung und Liquidation.
15.1 Ein Beschluss, die Gesellschaft aufzulösen und abzuwickeln, gilt als verbindlich getroffen, wenn ihm mindestens

die Hälfte der Gesellschafter zustimmen und diese Gesellschafter mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten.
Auch bedarf ein solcher Beschluss der Zustimmung des Komplementärs, der diese Zustimmung nicht willkürlich verwei-
gern darf.

15.2 Das Amt des Liquidators kann von dem Komplementär übernommen werden.
15.3 Nach Begleichung aller Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft sowie der Liquidationskosten erfolgt die

Verteilung des Nettoliquidationserlöses zwischen den Gesellschaftern unter entsprechender Anwendung der Bestimmun-
gen  von  Ziffer  14  dieses  Gesellschaftsvertrages  dergestalt,  dass  wirtschaftlich  das  gleiche  Ergebnis  wie  bei  der  dort
geregelten Verteilung auszuschüttender Dividenden erzielt wird.

16. Vertragsauslegung und Luxemburger Recht.
16.1 In diesem Gesellschaftsvertrag:
16.1.1 steht
(a) ein grammatikalisches Geschlecht jeweils für alle grammatikalischen Geschlechter;
(b) der Singular stets auch für den Plural und vice versa (außer sofern sich aus dem Zusammenhang etwas anderes

ergibt);

(c)  der  Begriff  "Person"  für  natürliche  Personen,  Unternehmen,  Personengesellschaften,  Kapitalgesellschaften  oder

sonstige Körperschaften, Regierungs- oder Verwaltungseinheiten bzw. -behörden, Staaten oder ihre Untergliederungen,
Joint Ventures, Gemeinschaftsunternehmen oder sonstige Vereinigungen, Betriebsräte oder sonstige Mitarbeitervertretun-
gen (jeweils unabhängig davon, ob diese eine eigene Rechtspersönlichkeit haben);

(d) umfasst eine Bezugnahme auf ein Gesetz bzw. eine Gesetzesbestimmung jeweils alle geänderten und neu verab-

schiedeten (geänderten oder unveränderten) Fassungen dieses Gesetzes bzw. dieser gesetzlichen Bestimmung;

16.1.2 ist eine Verwendung des Wortes "einschließlich" (include/including) stets im Sinne von "insbesondere" (without

limitation) zu versehen, wobei auch ansonsten allgemeine Begriffe nicht in einem restriktiven oder einschränkenden Sinn
zu verstehen sind, wenn sie in Zusammenhang mit einer vorangehenden oder nachfolgenden Aufzählung verschiedener
Handlungsweisen, Umstände, Gegenstände oder Beispiele verwendet werden;

16.1.3 dienen Überschriften nur der Übersichtlichkeit und sind für das Verständnis bzw. die Auslegung dieses Gesell-

schaftsvertrages unbeachtlich.

16.2 Neben diesem Gesellschaftsvertrag sind auch alle einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts für die

Gesellschaft maßgeblich.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt mit deren Gründung und endet am 30. September 2016.
Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung findet am 30. Marz 2017 statt.

<i>Zeichnung von Anteilen

Die Anteile am Kapital der Gesellschaft sind wie folgt gezeichnet worden:

Komplementäranteil:
Zeichner

Gezeichnetes

Kapital

Zahl der

Anteile

KQ GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 1.-

1

Kommanditanteil:
Zeichner

Gezeichnetes

Kapital

Zahl der

Anteile

KQ S.C.S. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.499,-

12.499

Der Komplementäranteil und die Kommanditanteile sind in voller Höhe in bar eingezahlt worden; somit steht der Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft zur freien Verfügung, wofür gegenüber dem Notar
ein entsprechender Nachweis erbracht wurde.

33819

L

U X E M B O U R G

<i>Erste Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Die vorstehend genannten Gesellschafter der Gesellschaft halten sämtliche Anteile an der Gesellschaft, verzichten auf

alle Frist- und Formvorschriften für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung, halten hiermit eine außerordentliche
Gesellschafterversammlung ab, und verabschieden hiermit einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in 35F, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

2) Wie in der Satzung festgelegt, wird KQ GP S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à responsa-

bilité  limitée)  mit  Geschäftssitz  in  205,  route  d'Arlon,  L-1150  Luxemburg,  R.C.S.  Luxemburg,  Nummer  181.737,  als
alleiniger Geschäftsführer bestimmt.

<i>Kosten

Sämtliche Kosten, Auslagen und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft entstehen, werden

von der Gesellschaft getragen und belaufen sich schätzungsweise auf eintausendachthundert Euro (EUR 1.800,-).

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und beherrscht, erklärt hiermit dass diese Urkunde auf

Wunsch des Erschienenen in englischer Sprache verfasst wurde und weiterhin auf Wunsch des Erschienenen der englischen
Fassung  dieser  Urkunde  eine  deutsche  Fassung  nachgestellt  wurde,  wobei  im  Falle  von  Abweichungen  zwischen  der
englischen Fassung und der deutschen Fassung stets die englische Fassung maßgeblich ist.

Notariell beurkundet in Luxemburg, an dem in dieser Urkunde eingangs genannten Tage.
Diese  Urkunde  wurde  den  Erschienenen  vorgelesen,  wobei  Vor-  und  Nachname,  Personenstand  und  Anschrift  des

Erschienenen dem Notar bekannt sind, woraufhin die Erschienenen und der Notar die Originalausfertigung dieser Urkunde
wie folgt unterschrieben haben:

Gezeichnet: V. MANGEON, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39741. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. Dezember 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015210465/585.
(150236472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

ArcelorMittal Tubular Products Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 79.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016060171/9.
(160021342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

Antin Infrastructure Partners Luxembourg I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.777.543,80.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 185.719.

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

(A) Antin Infrastructure Partners II-1 FPCI, a French professional private equity investment fund (fonds professional

de capital investissement) subject to the simplified procedure (béneficiant d’une procedure allégée) as defined in article L
214-159 of the French Monetary and Financial Code, having its office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, represented
by Antin Infrastructure Partners SAS, its management company, having its registered office at 374, rue Saint-Honoré,
F-75001 Paris, registered with the Paris trade and companies registry under number 789 002 300, represented by Mr Alain
Rauscher, President of Antin Infrastructure Partners SAS, having his professional address at 374, rue Saint-Honoré, F-75001
Paris,

33820

L

U X E M B O U R G

here represented by Allen &amp; Overy, société en commandite simple, itself represented by Mr Olivier Thill, lawyer, having

his professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 10 December 2015;

(B) Antin Infrastructure Partners II-2 FPCI, a French professional private equity investment fund (fonds professional

de capital investissement) subject to the simplified procedure (béneficiant d’une procedure allégée) as defined in article L
214-159 of the French Monetary and Financial Code, having its office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, represented
by Antin Infrastructure Partners SAS, its management company, having its registered office at 374, rue Saint-Honoré,
F-75001 Paris, registered with the Paris trade and companies registry under number 789 002 300, represented by Mr Alain
Rauscher, President of Antin Infrastructure Partners SAS, having his professional address at 374, rue Saint-Honoré, F-75001
Paris,

here represented by Allen &amp; Overy, société en commandite simple, itself represented by Mr Olivier Thill, lawyer, having

his professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 10 December 2015; and

(C) Antin Infrastructure Partners II LP, a Partnership registered as a limited partnership in England under the Limited

Partnerships Act 1907 with number LP015630, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners II Luxem-
bourg GP, S.à r.l. whose registered office is 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered  with  the  Luxembourg  trade  and  companies  register  under  the  number  B  179.122,  represented  by  Mr  Alain
Rauscher and Mr José Maria Trias, duly authorised,

here represented by Allen &amp; Overy, société en commandite simple, itself represented by Mr Olivier Thill, lawyer, having

his professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 10 December 2015,

(together, the Shareholders).
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent the

entire share capital of “Antin Infrastructure Partners Luxembourg I”, a private limited liability company (société à res-
ponsabilité limitée) established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 37A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 23 January 2014, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations N°1415 dated 3 June 2014 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 185.719 (the Company). The articles of association of the Company have been amended several times and
for the last time by a deed of the undersigned notary dated 30 September 2015, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 3306 dated 12 December 2015.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 1,434,000 (one million four hundred

thirty-four thousand Pounds Sterling), in order to raise it from its current amount of GBP 2,343,543.80 (two million three
hundred forty-three thousand five hundred forty-three Pounds eighty Pence Sterling) to an amount of GBP 3,777,543.80
(three million seven hundred seventy-seven thousand five hundred forty-three Pounds and eighty Pence Sterling) by the
issuance of 143,400,000 (one hundred forty-three million four hundred thousand) new shares having a par value of GBP
0.01 (one Pence Sterling) each;

2. Intervention and subscription to the new shares by Daphne Coinvest LP;
3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company (the Articles); and
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to

any manager of the Company, with full power of substitution, to proceed under his/her sole signature to the registration of
the newly issued shares in the share register of the Company in the name and on behalf of the Company.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 1,434,000 (one million

four hundred thirty-four thousand Pounds Sterling),

in order to raise it from its previous amount of GBP 2,343,543.80 (two million three hundred forty-three thousand five

hundred forty-three Pounds eighty Pence Sterling), represented by 234,354,380 (two hundred thirty-four million three
hundred fifty-four thousand three hundred eighty) ordinary shares having a par value of GBP 0.01 (one Pence Sterling)
each,

to an amount of GBP 3,777,543.80 (three million seven hundred seventy-seven thousand five hundred forty-three Pounds

and eighty Pence Sterling), represented by 377,754,380 (three hundred seventy-seven million seven hundred fifty-four
thousand three hundred eighty) ordinary shares having a par value of GBP 0.01 (one Pence Sterling) each,

by way of the issuance of 143,400,000 (one hundred forty-three million four hundred thousand) new shares of the

Company having a par value of GBP 0.01 (one Pence Sterling) each (the New Shares).

33821

L

U X E M B O U R G

The Shareholders resolve that the 143,400,000 (one hundred forty-three million four hundred thousand) New Shares

shall be offered for subscription at this Meeting to Daphne Co-invest LP, a Partnership registered as a limited partnership
in England under the Limited Partnerships Act 1907 with number LP016722, acting through its general partner, Antin
Infrastructure Partners II Luxembourg GP, S.à r.l., having its registered office at 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 179.122 and represented by
Mr Alain Rauscher and Mr José Maria Trias, duly authorised.

The Shareholders further resolve that the New Shares shall be subscribed and fully paid in cash for a subscription price

per New Share of GBP 0.01 (one Pence Sterling) and that the issuance of the New Shares shall be effective immediately
before the amendment of the Articles to reflect the issuance of the New Shares.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following intervention for the subscription to the New Shares and the

full payment of the subscription price of the New Shares, as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Daphne Co-invest LP, here represented by Allen &amp; Overy, société en commandite simple, itself represented by Mr

Olivier Thill, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on December 2015,
signed and attached to this deed, declares to subscribe in cash to 143,400,000 (one hundred forty-three million four hundred
thousand) New Shares having a nominal value of GBP 0.01 (one Pence Sterling) each, and to fully pay their subscription
price, by way of a cash payment in an aggregate amount of GBP 1,434,000 (one million four hundred thirty-four thousand
Pounds Sterling).

All the 143,400,000 (one hundred forty-three million four hundred thousand) New Shares have been fully subscribed

and paid up by a contribution in cash by Daphne Co-invest LP, so that the sum of GBP 1,434,000 (one million four hundred
thirty-four thousand Pounds Sterling) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the
undersigned notary who expressly bears witness to it. The Meeting acknowledges that the cash payments in consideration
for the issuance of the New Shares in the aggregate amount of GBP 1,434,000 (one million four hundred thirty-four thousand
Pounds Sterling) are allocated to the share capital account of the Company.

As a consequence of this share capital increase, the Shareholders and Daphne Co-invest LP hold the Company’s shares,

corresponding  to  377,754,380  (three  hundred  seventy-seven  million  seven  hundred  fifty-four  thousand  three  hundred
eighty) ordinary shares of the Company having a par value of GBP 0.01 (one Pence Sterling) each, as follows:

Antin Infrastructure Partners II LP, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . .

143,098,160 (one hundred forty-three million

ninety-eight thousand one hundred sixty)

shares;

Antin Infrastructure Partners II-1 FPCI, prenamed: . . . . . . . . . . . . . .

62,257,903 (sixty-two million two hundred

fifty-seven thousand nine hundred three)

shares;

Antin Infrastructure Partners II-2 FPCI, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . 28,998,317 (twenty-eight million nine hundred

ninety-eight thousand three hundred

seventeen) shares; and

Daphne Co-invest LP, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143,400,000 (one hundred forty-three million

four hundred thousand) shares.

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377,754,380 (three hundred seventy-seven

million seven hundred fifty-four thousand

three hundred eighty) shares.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders of the Company resolve to amend article 5 of the Articles,

which shall be henceforth reworded as follows:

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 3,777,543.80 (three million seven hundred

seventy-seven thousand five hundred forty-three Pounds and eighty Pence Sterling), represented by 377,754,380 (three
hundred seventy-seven million seven hundred fifty-four thousand three hundred eighty) shares having a nominal value of
GBP 0.01 (one Pence Sterling) each."

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorises any manager of the Company, with full power of substitution, to proceed under his/her sole
signature to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities
in connection therewith in the name and on behalf of the Company.

33822

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2750.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing person and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le onze décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

(A) Antin Infrastructure Partners II-1 FPCI, un fonds professionnel de capital investissement bénéficiant d’une procédure

allégée, tel que défini dans l'article L 214-159 du Code Monétaire et Financier français, ayant son siège au 374, rue Saint-
Honoré, F-75001 Paris, représentée par Antin Infrastructure Partners SAS, sa société de gestion, ayant son siège social au
374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
789 002 300, représentée par Monsieur Alain Rauscher, Président de Antin Infrastructure Partners SAS, ayant son adresse
professionnelle au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris,

ici représenté par Allen &amp; Overy, société en commandite simple, elle-même représentée par Mr Olivier Thill, juriste,

ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 décembre 2015;

(B) Antin Infrastructure Partners II-2 FPCI, un fonds professionnel de capital investissement bénéficiant d’une procédure

allégée, tel que défini dans l'article L 214-159 du Code Monétaire et Financier français, ayant son siège au 374, rue Saint-
Honoré, F-75001 Paris, représentée par Antin Infrastructure Partners SAS, sa société de gestion, ayant son siège social au
374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
789 002 300, représentée par Monsieur Alain Rauscher, Président de Antin Infrastructure Partners SAS, ayant son adresse
professionnelle au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris,

ici représenté par Allen &amp; Overy, société en commandite simple, elle-même représentée par Mr Olivier Thill, juriste,

ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 décembre 2015; et

(C) Antin Infrastructure Partners II LP, une société en commandite (limited partnership) de droit anglais soumise au

Limited Partnerships Act 1907 et enregistrée sous le numéro LP 15630, agissant au travers de son associé commandité
(general partner), Antin Infrastructure Partners II Luxembourg GP, S.à r.l. ayant son siège social au 37A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 179.122, représenté par M. Alain Rauscher and M. José Maria Trias, dûment autorisés,

ici représentée par Allen &amp; Overy, société en commandite simple, elle-même représentée par Mr Olivier Thill, juriste,

ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 décembre 2015,

(ensemble, les Associés).
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, aux termes de la capacité en laquelle ils agissent, ont demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce

qu'ils représentent la totalité du capital social de "Antin Infrastructure Partners Luxembourg I", une société à responsabilité
limitée organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-duché de Luxembourg,

constituée selon acte du notaire soussigné du 23 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

N°1415 du 3 juin 2014 et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.719
(la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprise et pour la dernière fois par un acte du notaire
soussigné du 30 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 3306 du 10 décembre
2015.

Les Associés reconnaissent que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son

ordre du jour:

<i>Agenda

1. Décision d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de GBP 1.434.000 (un million quatre cent

trente-quatre mille Livres Sterling), afin de le faire passer de son montant actuel de GBP 2.343.543.80 (deux millions trois
cent quarante-trois mille cinq cent quarante-trois Livres quatre-vingts Pence Sterling) à un montant de GBP 3,777,543.80
(trois millions sept cent soixante-dix-sept mille cinq cent quarante-trois Livres quatre-vingts Pence Sterling) par l'émission

33823

L

U X E M B O U R G

de 143.400.000 (cent quarante-trois millions quatre cent mille) nouvelles parts sociales ordinaires ayant chacune une valeur
nominale de GBP 0,01 (un Pence Sterling);

2. Intervention et souscription des nouvelles parts sociales par Daphne Co-invest LP;
3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts); et
4. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, avec tout pouvoir de substitution, afin d’effectuer, par sa seule
signature, l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société au nom
et pour le compte de la Société.

Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de GBP 1.434.000 (un

million quatre cent trente-quatre mille Livres Sterling)

afin de le porter de son montant actuel de GBP 2.343.543,80 (deux millions trois cent quarante-trois mille cinq cent

quarante-trois Livres quatre-vingts Pence Sterling), représenté par 234.354.380 (deux cent trente-quatre million trois cent
cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingts) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de GBP 0,01 (un Pence
Sterling) chacune,

à un montant de GBP 3.777.543,80 (trois millions sept cent soixante-dix-sept mille cinq cent quarante-trois Livres

quatre-vingts Pence Sterling), représenté par 377.754.380 (trois cent soixante-dix-sept millions sept cent cinquante-quatre
mille trois cent quatre-vingts) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de GBP 0,01 (un Pence Sterling) chacune,

par l'émission de 143.400.000 (cent quarante-trois millions quatre cent mille) nouvelles parts sociales ayant chacune

une valeur nominale de GBP 0,01 (un Pence Sterling) (les Nouvelles Parts Sociales).

Les Associés décident que les 143.400.000 (cent quarante-trois millions quatre cent mille) Nouvelles Parts Sociales

seront offertes à la souscription lors de cette Assemblée à Daphne Co-invest LP, une société en commandite (limited
partnership) de droit anglais soumise au Limited Partnerships Act 1907 et enregistrée sous le numéro LP016722, agissant
au travers de son associé commandité (general partner), Antin Infrastructure Partners II Luxembourg GP, S.à r.l. ayant son
siège social au 37A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 179.122 et représenté par M. Alain Rauscher and M. José Maria Trias, dûment autorisés.

Les Associés décident en outre que les Nouvelles Parts Sociales seront souscrites et intégralement libérées en numéraire

pour un prix de souscription par Nouvelle Part Sociale de GBP 0,01 (un Pence Sterling) et que l’émission des Nouvelles
Parts Sociales sera effective immédiatement avant la modification des Statuts reflétant l’émission des Nouvelles Parts
Sociales.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d’accepter et d’enregistrer l’intervention suivante concernant la souscription aux Nouvelles Parts

Sociales et la libération intégrale du prix de souscription des Nouvelles Parts Sociales, de la manière suivante:

<i>Interventions - Souscription - Paiement

Daphne Co-invest LP, ici représentée par Allen &amp; overy, société en commandite simple, elle-même représentée par M.

Olivier Thill, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le décembre
2015, signée et annexée au présent acte, déclare souscrire en numéraire aux 143.400.000 (cent quarante-trois millions quatre
cent mille) Nouvelles Parts Sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR0,01 (un Pence Sterling), et libérer inté-
gralement leur prix de souscription au moyen d’un paiement en numéraire d’un montant total de GBP 1.434.000 (un million
quatre cent trente-quatre mille Livres Sterling);

Toutes les Nouvelles Parts Sociales ont été intégralement souscrites libérées en numéraire par Daphne Co-invest LP,

de sorte que la somme de GBP 1.434.000 (un million quatre cent trente-quatre mille Livres Sterling) est à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément. L’Assemblée constate que les
paiements en numéraire relatifs à l’émission des Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de GBP 1.434.000 (un
million quatre cent trente-quatre mille Livres Sterling) sont alloués au compte de capital social de la Société.

Suite à cette augmentation de capital social, les Associés et Daphne Coinvest LP détiennent les parts sociales de la

Société, correspondant à 377.754.380 (trois cent soixante-dix-sept millions sept cent cinquante-quatre mille trois cent
quatre-vingts) parts sociales ordinaires de la Société, comme suit:

Antin Infrastructure Partners II LP, susmentionné: . . . . . . . . . . . . . .

143.098.160 (cent quarante-trois millions

quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante)

parts sociales;

Antin Infrastructure Partners II-1 FPCI, susmentionné: . . . . . . . . . . . 62.257.903 (soixante-deux millions deux cent

cinquante-sept mille neuf cent trois)

parts sociales;

Antin Infrastructure Partners II-2 FPCI, susmentionné: . . . . . . . . . . .

28.998.317 (vingt-huit millions neuf cent

quatre-vingt-dix-huit mille trois cent dix-sept)

33824

L

U X E M B O U R G

parts sociales; et

Daphne Co-invest LP, susmentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143.400.000 (cent quarante-trois millions

quatre cent mille) parts sociales.

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377.754.380 (trois cent soixante-dix-sept

millions sept cent cinquante-quatre mille

trois cent quatre-vingts) parts sociales.

<i>Troisième résolution

A la suite de la première résolution, les Associés décident de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui

donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de GBP 3.777.543,80 (trois millions sept cent

soixante-dix-sept mille cinq cent quarante-trois Livres quatre-vingts Pence Sterling), représenté par 377.754.380 (trois cent
soixante-dix-sept millions sept cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingts) parts sociales d’une valeur nominale
de GBP 0,01 (un Pence Sterling) chacune."

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués

ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société, avec tout pouvoir de substitution, d'effectuer par
sa seule signature l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société
et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point au nom et pour le compte de la Société.

<i>Frais

Les dépens coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu'ils soient et lesquels sont encourus par la Société en

raison du présent acte sont estimés à approximativement EUR 2.750.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est

établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: O. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 21 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/29360. Reçu soixante-quinze

euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211054/275.
(150237373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Profconsult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 143.809.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quinze, le 28/12/2015

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «PROFCONSULT S.à r.l.», ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 15 Décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 148 du 22 Janvier 2009. La société a été mise en liquidation suivant acte notarié du
12 novembre 2015.

L'Assemblée se compose de:
1) SILK ROAD GROUP SA, 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, RCB 81231
Ensuite l'associé représentant l'intégralité du capital social à pris les résolutions suivantes:
I. - L'Assemblée prend connaissance du rapport du liquidateur et approuve celui-ci.

33825

L

U X E M B O U R G

II. - L'assemblée entend le rapport de Monsieur Gérard Reis sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion

du liquidateur.

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction, à la société INVEST CONTROL S.à.r.l., de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.
III. - Clôture de la liquidation:
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société PROFCONSULT S.à r.l. à définitivement

cessé d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

partir d'aujourd'hui à 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

SILK ROAD GROUP SA
Signatures

Référence de publication: 2015211735/33.
(150237844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Regenbogenzwei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 112.032.

Je, soussigné,
Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING,
demeurant professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, né le 22.03.1965 à Heerlen (Pays-Bas),
démissionne, par la présente, du mandat d’administrateur de la société anonyme:
Regenbogenzwei S.A.
ayant son siège social au 50, rue Charles Martel 1 

er

 étage L-2134 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 112.032
Date effective: le 30 Décembre 2015.

Hendrik H.J. KEMMERLING.

Référence de publication: 2016003231/16.
(160001737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Turchese Trading e Investimentos S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 146.459.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 22 décembre 2015

<i>Résolutions:

- Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée décide d'élire:
Monsieur Gaëtan Bock, employé privé, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Administrateur et Président; Monsieur Julien Nicaud, employé privé, demeurant professionnellement au 26, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur;

Monsieur Denis Callonego, employé privé, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, Administrateur.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturé au 31.12.2017.
- L'Assemblée prend acte de la démission présentée par International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l. de sa

fonction de Commissaire aux Comptes de la Société.

L'Assemblée décide d'élire, en son remplacement, la société FCS Services, ayant son siège social au 2, Place de Stras-

bourg, L-2562 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS B 186.493.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturé au 31.12.2015.
- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 8, rue de Beggen, L-1220

Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

33826

L

U X E M B O U R G

TURCHESE TRADING E INVESTIMENTOS S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2016003343/27.
(160001123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Umbrella Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 63.182.700,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 158.071.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance tenu en date du 9 décembre 2015:

La  démission  du  gérant,  Dominique  Robert  de  Lisle  YATES,  ayant  son  adresse  à  13  chemin  du  Pontet,  CH-1291

Commugny, a été acceptée avec effet au 31 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2016003344/12.
(160002656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Regenbogenzwei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 112.032.

Je, soussigné,
Monsieur Rob SONNENSCHEIN,
demeurant professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, né le 30.08.1955 à Eindhoven (Pays-

Bas),

démissionne, par la présente, du mandat d'administrateur de la société anonyme:
Regenbogenzwei S.A.

ayant son siège social au 50, rue Charles Martel 1 

er

 étage L-2134 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 112.032
Date effective: le 31 Août 2015.

Rob SONNENSCHEIN.

Référence de publication: 2016003232/17.
(160001737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

CCp IV Archer 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.520,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 202.605.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth of December.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

CCP IV Archer JV S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by Luxembourg

law, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, in the process of registration with the Trade
and Companies Register of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred ninety euros (EUR 12,500.-)
(the Sole Shareholder),

here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, whose professional address is at 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on December 14 

th

 , 2015,

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to this deed for the purpose of registration.

33827

L

U X E M B O U R G

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “CCP IV Archer 1 S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any
securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real estate whatever the
acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1.  The  share  capital  of  the  Company  is  fixed  at  twelve  thousand  five  hundred  and  twenty  euros  (EUR  12,520.-)

represented by:

(i) twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares (the Ordinary Shares);
(ii) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares); and
(iii) ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares).
all in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, and each having the

specific distribution rights as determined in the present Articles.

5.2. The Class A Shares and the Class B Shares are collectively hereafter referred to as the Redeemable Shares, and the

Redeemable Shares, collectively with the Ordinary Shares, are hereafter referred to as the Shares.

5.3. Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders

of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.

33828

L

U X E M B O U R G

5.4. Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder The Ordinary

Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders..

5.5. The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares

and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the
Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be
available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.

5.6. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.

5.7. If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(i) the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the

Company from income in respect of the Company’s assets and investments (including, but not limited to dividends, interest
and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).

(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company’s assets and

investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the holders of the Redeemable Shares in
accordance with the following payment priorities and modalities:

(a) first, an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A

Shares annually on a pro rata basis; and

(b) second, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class B Shares annually on a pro rata

basis.

If all the Class B Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to

step (a) will be paid to the holders of the Class A Shares on a pro rata and pari passu basis.

(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the

holders of the Ordinary Shares on a pro rata and pari passu basis.

5.8. For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such

distribution.

Art. 6. Shares.
6.1. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries

implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

6.2. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
6.3. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

6.4. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The

Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The Shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at
least three quarters of the share capital.

6.5. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is

not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares.
7.1. In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole

shareholder or shareholders, any class of Shares at a redemption/repurchase price as determined by the Board of Managers
and approved by the sole shareholder or shareholders (the Redemption Price).

7.2. The redemption and/or the repurchase of Shares in accordance with article 7 of these Articles is permitted provided

that:

(i) a class of Shares is always redeemed and/or repurchased in full at the same time, it being understood that the Ordinary

Shares may be redeemed and/or repurchased in full only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable
Shares;

(ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the board of

managers, are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the
Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or these
Articles;

(iii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried

forward and any amounts drawn from the Company’s reserves available for such purpose, less any losses of the current
financial  year,  any  losses  carried  forward  and  sums  to  be  allocated  in  reserve  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of
Luxembourg and these Articles; and

33829

L

U X E M B O U R G

(iv) the redemption and/or repurchase is made on the context of a reduction of the capital of the Company. The redemption

and/or repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 12 of these Articles. For the avoidance
of  doubt,  the  amount  of  the  share  capital  reduction  shall  be  paid  to  the  holders  of  the  class  of  shares  subject  to  such
redemption and/or repurchase.

7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be made

in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class B Shares and ending with the Class A Shares). The Ordinary
Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable Shares.

7.4. In the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of a class

of Shares, such class of Shares give right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available
Amount  (or  any  other  amount  resolved  by  the  General  Meeting  in  accordance  with  the  conditions  prescribed  for  the
amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be higher than such Available Amount),
in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date no earlier than eight (8) days before the
date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.

7.5. The Available Amount in relation to the Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital Gain Profits

of the Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the board of managers
would have been entitled to dividend distributions according to Article 16 of the Articles, increased by (i) any freely
distributable reserves (including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii) as the case may be
by the amount of the share capital reduction relating to the Redeemable Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses
(including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of
the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without any double counting).

7.6. For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward

Income Profits).

7.7. In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits

(including carried forward Income Profits) and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may
not include Capital Gain Profits.

7.8. In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital Gain

Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.

7.9. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming/repurchasing each class of Shares.

III. Management - Representation

Art. 8. Appointment and removal of managers.
8.1.  The  Company  is  managed  by  one  manager  or  by  at  least  three  (3)  managers  appointed  by  a  resolution  of  the

shareholders, which sets the term of its mandate. The managers need not be shareholders.

8.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any time,

with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 9. Board of managers.
9.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board), which will be constituted by

one manager of category A (the A Manager) and two or more managers of category B (the B Managers). The A Manager
and the B Managers are collectively referred to herein as Managers.

9.2. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
9.3. Procedure
(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in

principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least

one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a
majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B manager

33830

L

U X E M B O U R G

are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no
chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

9.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of its A Manager or by the joint

signature of any two B Managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been

delegated.

Art. 10. Sole manager.
10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 11. Liability of the managers. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 12. General meetings of shareholders and shareholders’ circular resolutions.
12.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda

of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v)  A  shareholder  may  grant  written  power  of  attorney  to  another  person,  shareholder  or  otherwise,  in  order  to  be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions by
a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters

of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 13. Sole shareholder.
13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the

Law to the General Meeting.

13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.

13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

33831

L

U X E M B O U R G

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the

value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d’entreprises agréés).

15.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by

the Law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such
Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed to
the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the Ordinary Shares.

16.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve,
to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders. If profits are to be distributed
to the shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary
Shares and the Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares.

16.3. The sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim

accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:

(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits

carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by these Articles;

(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim

accounts; and

(iii) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking into account the assets of the Company.
16.4. The Income Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, Capital Gain Profits will be

distributed only to the holders of the Redeemable Shares and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares, in each case in accordance with the provisions of article 5.7.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by the Law.

17.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be

physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.

17.3. After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net

assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on a pro rata and pari passu basis, provided that:

(i) the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on a pro rata and pari

passu basis;

(ii) the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on a pro rata

and pari passu basis;

(iii) the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on a pro rata and

pari passu basis; and

(iv) the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares

on a pro rata and pari passu basis.

VII. General provisions

18.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

33832

L

U X E M B O U R G

18.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board

meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

18.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2016.

<i>Subscription and payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred (12,500) shares in re-

gistered form, to ten (10) class A redeemable shares and to ten (10) class B redeemable shares each one having a nominal
value of one euro (EUR 1,-), and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand and five hundred
twenty euros (EUR 12,520.-),

The amount of twelve thousand and five hundred twenty euros (EUR 12,520.-) is at the Company’s disposal and evidence

thereof has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

<i>is appointed as A Manager:

- Mr. Yves BARTHELS, born on October 10 

th

 , 1973 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing profes-

sionally at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg; and

<i>are appointed as B Managers:

- Mr. Romain DELVERT, born on June 26 

th

 , 1973, in Tours, France, residing professionally at 16, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg;

- Mr. Mark TERRY, born on January 10 

th

 , 1977, in Arawa, Papua New Guinea, residing professionally at Berkeley

Square, Berkeley Square House, 8 

th

 floor, GB-W1J 6DB London.

2. The registered office of the Company is located at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states that at request of the above appearing party, the

present deed is drawn up in English, followed by a French version and that in the case of divergences between the English
text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day stated above written.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned

notary.

Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am fünfzehntenten Tag des Monats Dezember,
Ist vor Uns, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

CCP IV Archer JV S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg,

mit eingetragenem Sitz unter 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, deren Eintragung im Handels- und Gesellschafts-
register Luxemburg anhängig ist, mit einem Stammkapital von EUR 12.500,-- (der Einzige Gesellschafter),

vertreten durch Frau Isabel DIAS, Privatbeamtin, mit Geschäftsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg,

kraft einer am 14.Dezember 2015 ausgestellten Vollmacht,

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Stellvertreter der erschienenen Partei und den

unterzeichnenden Notar, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt.

33833

L

U X E M B O U R G

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Ge-

sellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée),  welche  hiermit  gegründet  wird,  wie  folgt  zu
beurkunden:

I. Bezeichnung - Sitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Bezeichnung. Der Name der Gesellschaft ist „CCP IV Archer 1 S.à r.l.“ (nachstehend die Gesellschaft). Die

Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die der Gesetzgebung des
Großherzogtums unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert
(nachstehend das Gesetz), sowie gegenwärtiger Satzung (die Satzung).

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen

Beschluss des Verwaltungsrates an einen anderen Ort innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden. Er kann durch einen
Beschluss der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, an einen anderen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2. Zweigniederlassungen, Filialen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat beschließen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind, und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die Verbindung der-
selben mit dem Ausland behindern könnten, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese Entwick-
lungen oder Ereignisse ein endgültiges Ende gefunden haben. Derartige provisorische Maßnahmen haben keinen Einfluss
auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes die luxemburgische
Nationalität behält.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen, in Luxemburg oder im Ausland, an Gesellschaften oder

Unternehmen in jeglicher Form und an Immobilien, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die
Gesellschaft  Aktien,  Anteile  und  andere  Beteiligungspapiere,  Anleihen,  Rentenwerte,  Geldmarkteinlagen  und  andere
Schuldtitel aller Art und im Allgemeinen alle Wertschriften und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten
Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden, durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonst wie erwerben. Sie
kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen. Des
Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren. Die Gesellschaft kann, ungeachtet der Erwerbsmodalitäten, in Immobilien
investieren, einschließlich, ohne Begrenzung, des Erwerbs im Zuge eines Verkaufs oder einer Vollstreckung von Sicher-
heiten.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Angeboten. Sie kann,

jedoch nur durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder
Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich, ohne Begrenzung, die Erlöse aus Kre-
ditverbindlichkeiten, an ihre Tochtergesellschaften, angegliederte Gesellschaften und jede andere Gesellschaft verleihen.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus zur Absicherung ihrer eigenen Verpflichtungen oder Verpflichtungen anderer Ge-
sellschaften und, im Allgemeinen, zu ihren eigenen Gunsten oder zugunsten von anderen Gesellschaften oder Personen,
Garantien gewähren und einige oder alle ihre Vermögenswerte verpfänden, übertragen, belasten oder ihre Vermögenswerte
anderweitig als Sicherheiten verwenden. Klarstellend wird festgehalten, dass die Gesellschaft der Regulierung unterlie-
genden Tätigkeiten im Finanzsektor nicht ohne vorherige Erteilung der erforderlichen Genehmigung nachgehen darf.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu

verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurs-, Zins- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist zur Durchführung jeglicher gewerblichen, finanziellen oder industriellen Vorgänge und jed-

weder Rechtsgeschäfte in Bezug auf Immobilien oder bewegliche Vermögensgegenstände befugt, die sich unmittelbar oder
mittelbar auf ihren Unternehmensgegenstand beziehen oder ihm dienlich sind.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,

Insolvenz, Konkurs oder ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, aufgelöst.

II. Stammkapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundertzwanzig Euro (EUR 12.520.-), bestehend aus:
(i) zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die Stammanteile);
(ii) zehn (10) rückzahlbaren Anteilen der Klasse A (die Anteile der Klasse A); und

33834

L

U X E M B O U R G

(iii) zehn (10) rückzahlbaren Anteilen der Klasse B (the Anteile der Klasse B, und, zusammen mit den Anteilen der

Klasse A, die Rückzahlbaren Anteile),

alle in registrierter Form, im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,--) und alle gezeichnet und vollständig eingezahlt,

und jeweils mit den spezifischen in dieser Satzung definierten Ausschüttungsrechten.

5.2. Die Anteile der Klasse A und die Anteile der Klasse B werden nachfolgend zusammen als die Rückzahlbaren

Anteile, und die Rückzahlbaren Anteile, zusammen mit den Stammanteilen, als die Geschäftsanteile bezeichnet.

5.3. Jeder Halter eines Stammanteils wird nachfolgend einzeln als ein Stammgesellschafter bezeichnet und die Halter

der Stammanteile werden nachfolgend als die Stammgesellschafter bezeichnet.

5.4. Jeder Halter eines Rückzahlbaren Anteils wird nachfolgend einzeln als ein Rückzahlbarer Gesellschafter bezeichnet.

Die  Stammgesellschafter  und  die  Rückzahlbaren  Gesellschafter  werden  nachfolgend  zusammen  als  die  Gesellschafter
bezeichnet.

5.5. Die Gesellschaft kann ein Sonderkapitalrücklagenkonto (special capital reserve account) und/oder Anteilskapital-

rücklagenkonto (share premium account) bezüglich der Geschäftsanteile unterhalten und auf solchen Konten werden der
Betrag oder der Wert von etwaigen Sonderkapitalrücklagen/Anteilskapitalrücklagen in Verbindung mit den Geschäftsan-
teilen registriert. Auf diese Art und Weise auf solchen Konten registrierte Beträge stellen frei ausschüttbare Rücklagen der
Gesellschaft dar und stehen zur Ausschüttung an die Gesellschafter zur Verfügung, gemäß dieser Satzung.

5.6. Der Betrag des Sonderkapitalrücklagenkontos und/oder des Anteilskapitalrücklagenkontos darf zum Zwecke der

Rückzahlung und/oder des Rückkaufs jeder Klasse von Geschäftsanteilen gemäß Artikel 7 dieser Satzung, des Ausgleichs
etwaiger verzeichneter Nettoverluste, der Ausschüttung an die Gesellschafter oder der Einzahlung in die gesetzliche Rück-
lage der Gesellschaft verwendet werden.

5.7. Sollten die Gesellschafter eine Gewinnausschüttung beschließen, müssen diese Gewinne wie nachstehend erläutert

ausgeschüttet werden:

(i) die Halter der Stammanteile haben, auf einer pro rata Basis, einen Anspruch auf alle ausschüttbaren Gewinne, die

die Gesellschaft aus Einkünften aus ihren Vermögenswerten und Investitionen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf,
Dividenden, Zinsen und anderer Erträge, die in Großbritannien ein Einkommen für steuerliche Zwecke darstellen) bezieht
(zusammen die Veräußerungsgewinne);

(ii) alle ausschüttbaren Gewinne, die die Gesellschaft aus Kapitalgewinnen aus ihren Vermögenswerten und Investiti-

onen, welche nicht unter die Veräußerungsgewinne fallen, bezieht (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Kapitalerlöse,
Liquidations- und Veräußerungserlösen) (gemeinsam die Kapitalerlösgewinne) dürfen ausschließlich an die Halter von
Rückzahlbaren Gesellschaftern, gemäß der folgenden Auszahlungsprioritäten und -modalitäten, ausgeschüttet werden:

(a) erstens, ein Betrag von 0,50% des gesamten Nennwertes der Anteile der Klasse A an die Halter der Anteile der

Klasse A, jährlich auf einer pro rata Basis; und

(b) zweitens, werden etwaige verbleibenden Kapitalerlösgewinne an die Halter der Anteile der Klasse B ausgeschüttet,

jährlich auf einer pro rata Basis.

Falls alle Anteile der Klasse B zurückgekauft und eingezogen wurden, werden alle Kapitalerlösgewinne, die nach der

Auszahlung gemäss Punkt (a) verbleiben, an die Halter der Anteile der Klasse A, jährlich auf einer pro rata und pari passu
Basis, ausgeschüttet,

(iii) alle Erlöse, welche nicht unter die Veräußerungsgewinne und die Kapitalerlösgewinne fallen (die Verbleibenden

Gewinne) werden an die Halter der Stammanteile auf einer pro rata und pari passu Basis ausgeschüttet.

5.8. Klarstellend wird festgehalten, dass Gewinne nur an die Gesellschafter ausgeschüttet werden dürfen, wenn die

Gesellschafter eine solche Ausschüttung beschlossen haben.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Jeder Geschäftsanteil berechtigt seinen Halter zu einer Stimme bei den Hauptversammlungen. Die Inhaberschaft

eines Geschäftsanteils impliziert die Annahme dieser Satzung und die Beschlüsse des einzigen Gesellschafters oder der
Hauptversammlung.

6.2. Die Geschäftsanteile sind unteilbar soweit die Gesellschaft betroffen ist.
6.3. Mitberechtigte von Geschäftsanteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft von einem gemeinsamen Vertreter,

der aus ihrem Kreis oder anderweitig zu bestellen ist, vertreten lassen.

6.4. Soweit die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, steht es diesem frei, seine Geschäftsanteile zu übertragen. Hat

die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, steht es den Gesellschaftern frei, ihre Geschäftsanteile untereinander zu übertra-
gen. Eine Übertragung von Geschäftsanteilen auf Nicht-Gesellschafter bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung,
welche mit einer Dreiviertelmehrheit erteilt wird.

6.5. Die Übertragung von Geschäftsanteilen muss notariell oder privatschriftlich beurkundet werden. Eine solche Über-

tragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn diese gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen
Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

Art. 7. Rückzahlung und/oder Rückkauf von Geschäftsanteilen.
7.1. Im Laufe eines beliebigen Geschäftsjahres hat die Gesellschaft nach Wahl ihres einzigen Gesellschafters oder ihrer

Gesellschafter die Möglichkeit, eine Klasse von Geschäftsanteilen zu einem vom Verwaltungsrat festgelegten und vom

33835

L

U X E M B O U R G

einzigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern genehmigten Rückzahlungs-/Rückkaufspreis (der Rückzahlungs-
preis), zurückzuzahlen oder zurückzukaufen.

7.2. Die Rückzahlung und/oder der Rückkauf von Geschäftsanteilen gemäß Artikel 7 dieser Satzung ist unter den fol-

genden Bedingungen erlaubt:

(i) eine Klasse von Geschäftsanteilen wird immer vollständig und gleichzeitig zurückgezahlt und/oder zurückgekauft,

wobei klargestellt wird, dass die Stammanteile erst nach der Rückzahlung und/oder dem Rückkauf aller Rückzahlbaren
Anteile vollständig zurückgezahlt oder zurückgekauft werden kann;

(ii) das Nettovermögen der Gesellschaft, wie es sich aus den vom Verwaltungsrat erstellten Zwischenabschlüssen der

Gesellschaft ergibt, liegt nicht, und fällt nach der Rückzahlung und/oder dem Rückkauf nicht, unter den Betrag des Stamm-
kapitals der Gesellschaft zuzüglich der nicht ausgeschütteten Rücklagen, die gemäß der Gesetze des Großherzogtums
Luxemburg und/oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden dürfen;

(iii) der Rückzahlungspreis überschreitet nicht den Betrag der Gewinne des laufenden Geschäftsjahres, zuzüglich et-

waiger Gewinnvorträge und etwaiger aus den zur Verfügung stehenden Rücklagen der Gesellschaft entnommenen Beträge,
abzüglich jeglicher Verluste des laufenden Geschäftsjahres, jeglicher Verlustvorträge und der Summen, die gemäß der
Gesetze des Großherzogtums Luxemburg und dieser Satzung als Rücklagen einzubehalten sind; und

(iv) die Rückzahlung und/oder der Rückkauf erfolgt im Rahmen einer Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft.

Die Rückzahlung und/oder der Rückkauf wird von den Gesellschaftern gemäß Artikel 12 dieser Satzung beschlossen.
Klarstellend wird festgehalten, dass der Betrag der Herabsetzung des Stammkapitals an die Halter der Klassen von Ge-
schäftsanteilen, die von der Rückzahlung und/oder dem Rückkauf betroffen sind, ausgezahlt wird.

7.3. Im Falle der Rückzahlung und/oder des Rückkaufs von Rückzahlbaren Anteilen sollte diese Rückzahlung und/oder

dieser Rückkauf in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge erfolgen (d.h. beginnend mit den Anteilen der Klasse B und
endend mit den Anteilen der Klasse A). Die Rückzahlung und/oder der Rückkauf der Stammanteile kann nur nach Rück-
zahlung und/oder Rückkauf der Rückzahlbaren Anteile erfolgen.

7.4. Im Falle einer Kapitalherabsetzung im Wege einer Rückzahlung und/oder eines Rückkaufs und Einziehung einer

Klasse von Anteilen, gibt diese Klasse von Anteilen deren Haltern auf einer pro rata Basis im Verhältnis zu ihrer Beteiligung
an dieser Klasse einen Anspruch auf den Verfügbaren Betrag (oder auf jeden anderen Betrag, der von der Hauptversamm-
lung gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, beschlossen wird, sofern dieser andere
Betrag niemals den Verfügbaren Betrag übersteigt), jeweils auf Basis eines Zwischenabschlusses der Gesellschaft, der am
Tag der Rückzahlung und/oder des Rückkaufs und der Einziehung der betroffenen Klasse von Geschäftsanteilen nicht älter
als acht (8) Tage ist.

7.5. Der Verfügbare Betrag in Bezug auf jede Klasse von Rückzahlbaren Anteilen beläuft sich auf den gesamten Betrag

der Kapitalerlösgewinne der Gesellschaft (einschließlich der Kapitalerlösgewinnvorträge), sofern die Gesellschafter und/
oder der Verwaltungsrat zur Ausschüttung von Dividenden gemäß Artikel 16 dieser Satzung berechtigt gewesen wären,
zuzüglich  (i)  jeder  frei  ausschüttbare  Rücklagen  (einschließlich  Sonderkapitalrücklagenkonto  und/oder  Anteilskapital-
rücklagenkonto) und (ii) gegebenenfalls des Betrages der Kapitalherabsetzung in Bezug auf die einzuziehende Klasse von
Rückzahlbaren Anteile, jedoch abzüglich (i) etwaiger Verluste (einschließlich Verlustvorträgen) und (ii) der Summen, die
gemäß  der  gesetzlichen  Bestimmungen  und  dieser  Satzung  als  Rücklagen  einzubehalten  sind,  in  jedem  Falle  laut  des
jeweiligen Zwischenabschluss (ohne Doppelzählung).

7.6. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass der Verfügbare Betrag keine Veräußerungsgewinne (einschließlich

Veräußerungsgewinnvorträge) beinhaltet.

7.7. Im Falle einer Rückzahlung und/oder einer Rückkaufs der Stammanteile, kann der Rückzahlungspreis Veräuße-

rungsgewinne  (einschließlich  Veräußerungsgewinnvorträge)  und  Verbleibende  Gewinne  (einschließlich  Verbleibende
Gewinnvorträge), jedoch keine Kapitalerlösgewinne, beinhalten.

7.8. Im Falle von der Rückzahlung und/oder des Rückkaufs der Rückzahlbaren Anteile, kann der Rückzahlungspreis

Kapitalerlösgewinne (einschließlich Kapitalerlösgewinnvorträge), jedoch keine Veräußerungsgewinne, beinhalten.

7.9. Der Betrag des Sonderkapitalrücklagenkontos und/oder Anteilskapitalrücklagenkontos darf zum Zweck der Rück-

zahlung/des Rückkaufs jeder Klasse von Geschäftsanteilen benutzt werden.

III. Verwaltung - Vertretung

Art. 8. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
8.1. Die Gesellschaft wird entweder von einem einzigen oder von wenigsten drei (3) Geschäftsführern verwaltet. Diese

werden durch einen Beschluss der Hauptversammlung bestellt, welcher ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen
keine Gesellschafter sein.

8.2. Die Geschäftsführer und zusätzliche oder als Ersatz bestellte Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jedem

Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.

Art. 9. Verwaltungsrat.
9.1. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt worden, bilden diese zusammen einen Verwaltungsrat (der Verwaltungsrat),

welcher sich aus einem Geschäftsführer der Kategorie A (der A Geschäftsführer) und zwei oder mehr Geschäftsführern

33836

L

U X E M B O U R G

der Kategorie B (zusammen die B Geschäftsführer) zusammensetzt. Der A Geschäftsführer und die B Geschäftsführer
werden nachstehend zusammen als die Geschäftsführer bezeichnet.

9.2. Vollmachten des Verwaltungsrates
(i) Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung

der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen unter den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates, der alle Befugnisse hat,
um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft überein-
stimmen.

(ii)  Der  Verwaltungsrat  kann  besondere  und  begrenzte  Vollmachten  für  bestimmte  Angelegenheiten  an  einen  oder

mehrere Vertreter übertragen.

9.3. Verfahren
(i) Auf Wunsch von einem (1) der Geschäftsführer findet eine Versammlung des Verwaltungsrates, an einem in der

Bekanntmachung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii)  Eine  schriftliche  Bekanntmachung  einer  jeden  Versammlung  des  Verwaltungsrates  geht  allen  Geschäftsführern

spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und
Umstand sodann in der Bekanntmachung darzulegen sind.

(iii) Eine Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend oder vertreten

sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung bekannt ist. Auf eine Bekanntmachung kann ein Ge-
schäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Bekanntmachungen
sind  nicht  erforderlich,  wenn  es  sich  um  eine  Versammlung  handelt,  welche  örtlich  und  zeitlich  im  Voraus  in  einem
Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Verwaltungsrat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Verwaltungsrates vertreten zu lassen.

(v) Der Verwaltungsrat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder ver-

treten ist und mindestens ein (1) A Geschäftsführer und ein (1) B Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates sind wirksam, wenn sie von einer Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen
Geschäftsführer gefasst werden und mindestens ein (1) A Geschäftsführer und ein (1) B Geschäftsführer anwesend oder
vertreten sind. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden
der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen
Geschäftsführern unterzeichnet werden.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an

einer Versammlung des Verwaltungsrates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einan-
der zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme
an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (Zirkularbeschlüsse der Geschäfts-

führer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen
Versammlung des Verwaltungsrates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

9.4. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift ihres A Geschäftsführers

oder durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei (2) B Geschäftsführern gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der durch den Rat mit Spezialvoll-

machten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 10. Einziger Geschäftsführer.
10.1. Sofern die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, sind sämtliche in der Satzung enthaltenen Bezugnahmen

auf den Verwaltungsrat oder die Geschäftsführer als Bezugnahmen auf den einzigen Geschäftsführer zu verstehen.

10.2.  Die  Gesellschaft  wird  gegenüber  Dritten  in  allen  Angelegenheiten  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Ge-

schäftsführers gebunden.

10.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der durch den einzigen Geschäfts-

führer mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Verpflich-

tungen, die sie im Namen der Gesellschaft gültig eingegangen sind, unter der Bedingung, dass solche Verpflichtungen in
Übereinstimmung mit der Satzung und des Gesetzes sind.

IV. Gesellschafter

Art. 12. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
12.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Gesellschafterbeschlüsse werden in Hauptversammlungen (die Hauptversammlung) oder im Umlaufverfahren (die

Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

33837

L

U X E M B O U R G

(ii) Soweit Gesellschafterbeschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden sollen, ist der Wortlaut der Beschlüsse gemäß

den Bestimmungen dieser Satzung an sämtliche Gesellschafter zu senden. Von allen Gesellschaftern im Umlaufverfahren
gefasste Beschlüsse sind genauso gültig und verbindlich wie die in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen
Hauptversammlungen gefasste Beschlüsse; und sind auf den Tag der letzten Unterzeichnung zu datieren.

(iii) Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
12.2. Einberufungsbekanntmachungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheitserfordernisse und Abstimmungsverfahren
(i) Die Gesellschafter werden auf Initiative eines beliebigen Geschäftsführers oder Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Stammkapitals vertreten, zu Hauptversammlungen eingeladen oder schriftlich befragt.

(ii) Schriftliche Einberufungsbekanntmachungen einer jeden Hauptversammlung sind den Gesellschaftern gegenüber

mindestens acht (8) Tage vor dem anberaumten Versammlungsdatum bekanntzugeben, mit Ausnahme von dringenden
Fällen, deren Art und Umstände in der Einberufungsbekanntmachung anzugeben sind.

(iii) Die Hauptversammlungen finden zu den Zeiten und an den Orten statt, die in der Einberufungsbekanntmachung

angegeben sind.

(iv) Eine Hauptversammlung kann ohne vorherige Zusendung einer Einberufungsbekanntmachung abgehalten werden,

sofern sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die Hauptversammlung sich als ordnungsgemäß einberufen
betrachtet und die Gesellschafter über die Tagesordnung informiert sind.

(v) Ein Gesellschafter kann sich aufgrund einer schriftlichen Vollmacht durch eine andere Person, bei welcher es sich

ebenfalls um einen Gesellschafter handeln kann, in Hauptversammlungen vertreten lassen.

(vi) Die Gesellschafter sind in Hauptversammlungen oder bei im Umlaufverfahren zu fassenden Beschlüsse beschluss-

fähig,  wenn  mehr  als  die  Hälfte  des  Stammkapitals  anwesend  oder  vertreten  ist.  Wird  diese  Mehrheit  bei  der  ersten
Hauptversammlung oder im ersten schriftlichen Verfahren nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Hauptversammlung geladen oder zu einem zweiten schriftlichen Verfahren aufgefordert; die Gesellschafter
sind in einer zweiten Abstimmung ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei

Viertel des Stammkapitals vertreten, geändert werden.

(viii) Jede Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft sowie Ausweitung der Verpflichtungen der Gesellschafter

gegenüber der Gesellschaft bedürfen eines einstimmigen Beschlusses der Gesellschafter.

Art. 13. Alleingesellschafter.
13.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche der

Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

13.2.  Bezugnahmen  innerhalb  dieser  Satzung  auf  die  Gesellschafter,  die  Hauptversammlung  oder  die  Schriftlichen

Gesellschafterbeschlüsse gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

13.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnausschüttung - Aufsicht

Art. 14. Geschäftsjahr und Feststellung des Jahresabschlusses.
14.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden

Kalenderjahres.

14.2. Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinnund Verlustkonten der Gesellschaft, sowie ein

Inventar mit Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, mit einem Anhang, der alle Verpflichtungen und
Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

14.3. Jeder Gesellschafter kann das obengenannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
14.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des

gegebenen Geschäftsjahres entweder bei der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege von Umlaufbeschlüssen der
Gesellschafter genehmigt.

Art. 15. Wirtschaftsprüfer.
15.1. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, sind die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft von einem oder mehreren ge-

nehmigten externen Wirtschaftsprüfer(n) (réviseurs d’entreprises agréés) kontrolliert.

15.2. Die Hauptversammlung ernennt die genehmigten externen Wirtschaftsprüfer, wenn es diese gibt, und bestimmt

deren Anzahl und Vergütung und Amtszeit, die den Zeitraum von sechs (6) Jahren nicht überschreiten darf, aber sie können
wiedergewählt werden.

Art. 16. Gewinnausschüttung.
16.1. Vom Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) der vom Gesetz vorgeschriebenen Rücklage

(die Gesetzliche Rücklage) zugeführt. Diese Anforderung entfällt, sobald und so lange die Gesetzliche Rücklage einen
Betrag in Höhe von zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht. Jeder Betrag, der der Gesetzlichen Rücklage zuge-
wiesen wurde, kann nur unter den Stammgesellschaftern ausgeschüttet werden.

33838

L

U X E M B O U R G

16.2. Der Alleingesellschafter oder die Hauptversammlung der Gesellschafter bestimmen die Verteilung des verbleib-

enden Jahresüberschusses. Sie können den verbleibenden Jahresüberschuss ganz oder teilweise auf ein Rücklagenkonto
einzahlen, oder eine Rückstellung, einen Gewinnvortrag auf das darauffolgende Geschäftsjahr oder eine Dividendenaus-
schüttung an die Gesellschafter vornehmen. Im Falle einer Ausschüttung von Gewinnen an die Gesellschafter werden die
Veräußerungsgewinne und die Verbleibenden Gewinne nur an die Halter von Stammanteilen ausgeschüttet und die Kapi-
talerlösgewinne werden nur an die Halter von Rückzahlbaren Anteilen ausgeschüttet.

16.3. Der Alleingesellschafter oder die Hauptversammlung der Gesellschafter können auf Grundlage des vom Verwal-

tungsrat erstellten Zwischenabschlusses, der bestätigt, dass genügend Geldmittel zur Verfügung stehen, die Ausschüttung
von Zwischendividenden beschließen, vorausgesetzt dass:

(i) der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des Geschäftsjahres erzielten Gewinne, zuzüglich der vorgetragenen

Gewinne und der ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich der vorgetragenen Verluste und der Beträge, die der Ge-
setzlichen Rücklage zuzuführen sind, nicht übersteigen;

(ii) die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird vom Verwaltungsrat innerhalb von zwei (2) Monaten

ab dem Datum des Zwischenabschlusses getroffen; und

(iii) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind, unter Einbeziehung der Vermögenswerte der Gesellschaft, nicht

gefährdet.

16.4. Die Veräußerungsgewinne werden nur an die Halter von Stammanteilen, die Kapitalerlösgewinne werden nur an

die Halter von Rückzahlbaren Anteilen und die Verbleibenden Gewinne werden nur an die Halter der Stammanteile aus-
geschüttet, jeweils gemäß den Voraussetzungen des Artikels 5.7 dieser Satzung.

VI. Auflösung - Liquidation

17.1. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleingesellschafters oder durch Beschluss der Hauptversammlung,

die dabei die für Änderungen der Satzung erforderliche Beschlussfähigkeit und Mehrheit aufweisen muss, aufgelöst werden,
soweit nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben.

17.2. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt

(die natürliche oder juristische Personen sein können), die der Alleingesellschafter oder die Hauptversammlung ernannt
werden, die ihre Vollmachten und Vergütung bestimmt.

17.3. Nach Auszahlung der Gesamtheit der Schulden und Belastungen der Gesellschaft, und der Kosten der Liquidation,

wird das Nettovermögen gleichmäßig zwischen den Haltern der Geschäftsanteile auf einer pro rata und pari passu Basis
unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet:

(i) die Veräußerungsgewinne können nur an die Halter der ausstehenden Stammanteile auf einer pro rata und pari passu

Basis ausgeschüttet werden;

(ii) die Kapitalerlösgewinne können nur an die Halter der ausstehenden Rückzahlbaren Anteile auf einer pro rata und

pari passu Basis ausgeschüttet werden;

(iii) die Verbleibenden Gewinne können nur an die Halter der ausstehenden Stammanteile auf einer pro rata und pari

passu Basis ausgeschüttet werden; und

(iv) die der Gesetzlichen Rücklage zugewiesenen Beträge werden nur an die Halter der ausstehenden Stammanteile auf

einer pro rata und pari passu Basis ausgeschüttet werden.

VII. Allgemeine Bestimmungen

18.1  Mitteilungen  und  Benachrichtigungen  können  angefertigt  oder  es  kann  darauf  verzichtet  werden,  Zirkularbe-

schlüsse  der  Geschäftsführer  und  der  Gesellschafter  werden  schriftlich,  durch  Telefax,  E-Mail  oder  im  Wege  anderer
elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

18.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.

18.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form erfolgen, vorausgesetzt es werden alle

gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen
der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise Zirkularbe-
schlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben
Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

18.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden

Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die
die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

<i>Übergangsregelung

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Datum die Urkunde und endet am 31. Dezember 2016.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Der Einzige Gesellschafter, vertreten wie oben beschrieben, zeichnet:

33839

L

U X E M B O U R G

(v) zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen

(vi) zehn (10) rückzahlbaren Anteilen der Klasse A; und

(vii) zehn (10) rückzahlbaren Anteilen der Klasse B

alle in registrierter Form, im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-), und erklärt die vollständige Bareinlage dieser

Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundertzwanzig Euro (EUR 12.520.-).

Der Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundertzwanzig Euro (EUR 12.520.-) steht der Gesellschaft zur freien Ver-

fügung und ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

<i>Schatzung der Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung entstehen, werden ungefähr eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400.-) betragen.

<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat ihr Einziger Gesellschafter, welche die Gesamtheit der gezeich-

neten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Folgenden werden für unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:

<i>wird als A Geschäftsführer ernannt:

- Herr Yves BARTHELS, geboren am 10. Oktober 1973 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit Geschäfts-

anschrift unter 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

<i>werden als B Geschäftsführer ernannt:

- Herr Romain DELVERT, geboren am 26. Juni 1973 in Tours, Frankreich, mit Geschäftsanschrift unter 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg; et

- Herr Mark TERRY, geboren am 10. Januar 1977 in Arawa, Papua-Neu-Guinea, mit Geschäftsanschrift unter Berkeley

Square, Berkeley Square House, 8 

th

 floor, GB-W1J 6DB London.

2. Sitz der Gesellschaft ist in 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde

auf Anfrage der erschienenen Partei in der englischen Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst worden
ist. Auf Anfrage der erschienenen Partei, und dass im Falle von Unvereinbarkeiten zwischen der englischen und der deut-
schen Fassung die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Die vorliegende notarielle Urkunde ist in Luxemburg am vorgenannten Datum aufgenommen worden.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei laut verlesen wurde, hat besagter Bevollmäch-

tigter zusammen mit Mir, Notar, die vorliegende notarielle Urkunde unterzeichnet.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 décembre 2015. 2LAC/2015/28918. Reçu soixante-quinze euros EUR

75,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211215/724.

(150237879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

33840


Document Outline

1741 Asset Management Funds Sicav

Aequitas Europe 1 S.à r.l.

Antin Infrastructure Partners Luxembourg I

ArcelorMittal Tubular Products Luxembourg S.A.

CCp IV Archer 1 S.à r.l.

EC Eco Invest S.A.

Great German Nursing Homes A

Great German Nursing Homes D

Groupe Immobilier Luxembourgeois Sàrl

KaiserStone

KPB 2 Core S.C.S.

LSF9 Balta Investments S.à r.l.

Palinvest Lux S.A.

Palladian Luxembourg S.à r.l.

PATRIZIA Res Publica Hessen I HoldCo S.à r.l.

PATRIZIA Res Publica Hessen I TopCo S.à r.l.

PH North America S.à r.l.

Pollyane Investment S.A.

Profconsult S.à r.l.

Professional Beauty Services S.A.

Quadia S.à r.l.

Ravenwood, S.à r.l.

RBS (Luxembourg) Agriculture S.A.

Redditch Propco Lux S.à r.l.

Regenbogenzwei S.A.

Regenbogenzwei S.A.

Residential Assembly JV

Turchese Trading e Investimentos S.A.

Umbrella Holdings

Vista Finance

Vivaro Holdings S.A.

White River Holdco Lux S.à r.l.

Wholesale &amp; Logistics S.A.

W. Lanneau &amp; Cie

WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l.

XLNT S.A.

Yaro Invest SA/SPF

Zenith Fund S.A., SICAV-SIF

Zephyr'07-S.A. SICAV-SIF