This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 704
9 mars 2016
SOMMAIRE
Am Haferstück S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33774
BNP Paribas Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33757
Claircy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33783
Compas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33784
DKV Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33784
DWS Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33753
Eperlan Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33785
Field Conseil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33785
Flabeg Management S.à r.l. & Partners S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33746
Freif II Master Refineries I S.à r.l. . . . . . . . . .
33785
Generali European Real Estate Investments
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33786
HC Property Heureka I Alpha S.à r.l. . . . . . . .
33762
HC Property Heureka II Beta S.à r.l. . . . . . . .
33761
HC Property Heureka IV Delta S.à r.l. . . . . . .
33777
Interfund Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33746
Kaps Stars Belle Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33786
KGJ Investments S.A., SICAV-SIF . . . . . . . . .
33786
Kleopatra Holdings GP S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33782
Logwin AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33749
Mapple Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
33781
Mapple Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
33777
M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l. . . . . .
33754
MUGC/HS Asian USD Bond Fund . . . . . . . . .
33751
NIH VI Aleph Management S.à r.l. & Partners
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33746
Niovilu S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33787
NN (L) CMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33752
No-Nail Boxes (Europe) S.A. . . . . . . . . . . . . . .
33761
Novatech Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
33788
Occitan Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33788
Opera Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33787
Opernplatz (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33787
Paloma Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
33771
P & B Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33788
P & B Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33757
San Maurizio SCA SICAV-SIF . . . . . . . . . . . .
33762
Seiler S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33792
SOF-10 Beagle JVCo Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . .
33783
Sof-10 Cod Holdings Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . .
33783
Stateland International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33792
Stateland International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33792
Syré Zahntechnik S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33792
Trèves Offices SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33774
T.T.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33792
UFP Timing Global Select . . . . . . . . . . . . . . . .
33782
W.P. Stewart Holdings Fund . . . . . . . . . . . . . .
33752
33745
L
U X E M B O U R G
Interfund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 8.074.
Notice is hereby given to the shareholders of INTERFUND that the
ANNUAL ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
will be held in Luxembourg at the registered office of the Company, 9-11 rue Goethe, on <i>March 29thi> , 2016 at 10.00
am Luxembourg time with the following agenda:
<i>Agenda:i>
•
Board of Directors and External Auditors' Reports.
•
Approval of Sub-Fund's Financial Statements as at 31st December, 2015.
Presentation and approval of the SICAV's consolidated Financial Statements as at December 31st, 2015.
•
Director's legal responsibilities discharge for activities rendered during 2015 Financial Year.
•
Statutory Nominations.
Resolutions will be passed by a simple majority of shareholders present or represented.
Shareholders may vote by proxy. Proxies must be received at INTERFUND SICAV's registered office at least 48 hours
prior to the meeting.
The Shareholders wishing to attend the Meeting may request admission ticket to Fideuram Bank (Luxembourg) S.A.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016073785/21.
Flabeg Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. NIH VI Aleph Management S.à r.l. & Partners S.C.A.).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 198.569.
In the year two thousand and fifteen, on the fourth of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporate partnership limited by shares established and
existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name “NIH VI Aleph Management S.à r.l. & Partners S.C.A.” (he-
reinafter, the Company), with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198569, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary, dated July 3, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 2421, dated September 8, 2015, and whose articles of incorporation have never been amended since.
The meeting is chaired by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, having her professional address at 13, route
de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Marisa Gomes, employee, with professional address at 13, route de Luxembourg,
L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Laetitia ZUANEL, employee, with professional address at 13, route de Luxembourg,
L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to state that:
The shareholders present or duly represented by virtue of two (2) proxies and the number of their shares are shown on
an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be registered with these minutes.
As appears from said attendance list, one hundred percent (100%) of the Company’s share capital, presently set at thirty-
one thousand Euro (EUR 31.000,00), are present or represented at the present general meeting so that the meeting can
validly decide on all the items of its agenda.
<i>Agendai>
I. Change of name of the Company from “NIH VI Aleph Management S.à r.l. & Partners S.C.A.” to “Flabeg Management
S.à r.l. & Partners S.C.A.”.
II. Subsequent amendment of article 1 of the Company’s articles of incorporation, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 1. There exists a partnership limited by shares under the name of “Flabeg Management S.à r.l. & Partners S.C.A.”,
which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law
of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of
33746
L
U X E M B O U R G
association (hereinafter, the Articles) and by any securityholders agreement which may be entered into from time to time
between the Company’s Shareholders (the Securityholders Agreement).”
III. Acknowledgement of the change of name of the Company’s general partner from “NIH VI Aleph Management S.à
r.l.” to “Flabeg Management S.à r.l.”.
IV. Amendment of article 5 paragraph 5 of the Company’s articles of incorporation, which shall henceforth read as
follows:
“ Art. 5. Paragraph 5. The Management Share shall be held by Flabeg Management S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) established and existing under Luxembourg law, having its registered office at
1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies under number B 198510, as shareholder with unlimited liability and manager (hereinafter, the Manager).”
<i>Resolutionsi>
I. The meeting resolves to change the name of the Company from “NIH VI Aleph Management S.à r.l. & Partners
S.C.A.” to “Flabeg Management S.à r.l. & Partners S.C.A.”.
II. The meeting resolves to amend article 1 of the Company’s articles of incorporation, which shall henceforth read as
follows:
“ Art. 1. There exists a partnership limited by shares under the name of “Flabeg Management S.à r.l. & Partners S.C.A.”,
which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law
of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of
association (hereinafter, the Articles) and by any securityholders agreement which may be entered into from time to time
between the Company’s Shareholders (the Securityholders Agreement).”
III. The meeting resolves to acknowledge the change of name of the Company’s general partner from “NIH VI Aleph
Management S.à r.l.” to “Flabeg Management S.à r.l.”.
IV. The meeting resolves to amend article 5 paragraph 5 of the Company’s articles of incorporation, which shall hen-
ceforth read as follows:
“ Art. 5. Paragraph 5. The Management Share shall be held by Flabeg Management S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) established and existing under Luxembourg law, having its registered office at
1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies under number B 198510, as shareholder with unlimited liability and manager (hereinafter, the Manager).”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.
The document having been read to the members of the bureau and the proxy holder of the appearing persons, who are
known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le quatre décembre.
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions établie et existant au Grand-
Duché de Luxembourg sous la dénomination «NIH VI Aleph Management S.à r.l. & Partners S.C.A.» (ci-après, la Société),
ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 198569, constituée par acte du notaire soussigné,
en date du 3 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2421, en date du 8 septembre
2015, et dont les statuts constitutifs n’ont jamais été amendés depuis.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse profes-
sionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Ms Marisa Gomes, employée, ayant son adresse professionnelle au 13, route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Ms Laetitia Zuanel, employée, ayant son adresse professionnelle au 13, route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
33747
L
U X E M B O U R G
Les actionnaires présents ou dûment représentés en vertu de deux (2) procurations données le 23 octobre 2015, et le
nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le
notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Il appert de cette liste de présence que cent pourcent (100%) du capital social de la Société, actuellement fixé à trente-
et-un mille Euro (EUR 31.000,00), est présent ou représenté à la présente assemblée générale, de sorte que l’assemblée
peut valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour.
<i>Ordre du jouri>
I. Changement de nom de la Société de «NIH VI Aleph Management S.à r.l. & Partners S.C.A.» en «Flabeg Management
S.à r.l. & Partners S.C.A.».
II. Modification consécutive de l’article 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination de «Flabeg Management S.à r.l. &
Partners S.C.A.», qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après,
les Statuts) et par tout pacte de détenteur de titres qui serait entré en vigueur entre les actionnaires le cas échéant (Le Pacte
de Détenteur de Titres).»
III. Prise de connaissance du changement de nom de l’associé commandité de la Société de «NIH VI Aleph Management
S.à r.l.» en «Flabeg Management S.à r.l.».
IV. Modification de l’article 5 paragraphe 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Paragraphe 5. L’Action de Commandité est détenue par Flabeg Management S.à r.l., une société à responsabilité
limitée établie et existant selon la loi du Luxembourg, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L 1736 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) et enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198510, en tant qu’actionnaire à responsabilité
illimité et commandité (ci-après, le Gérant).»
<i>Résolutionsi>
I. L’assemblée décide de changer le nom de la Société de «NIH VI Daled Management S.à r.l. & Partners S.C.A.» en
«Flabeg Management S.à r.l. & Partners S.C.A.».
II. L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination de «Flabeg Management S.à r.l. &
Partners S.C.A.», qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après,
les Statuts) et par tout pacte de détenteur de titres qui serait entré en vigueur entre les actionnaires le cas échéant (Le Pacte
de Détenteur de Titres).»
III. L’assemblée décide de prendre connaissance du changement de nom de l’associé commandité de la Société de «NIH
VI Aleph Management S.à r.l.» en «Flabeg Management S.à r.l.».
IV. L’assemblée décide de modifier l’article 5 paragraphe 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Paragraphe 5. L’Action de Commandité est détenue par Flabeg Management S.à r.l., une société à responsabilité
limitée établie et existant selon la loi du Luxembourg, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L 1736 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) et enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198510, en tant qu’actionnaire à responsabilité
illimité et commandité (ci-après, le Gérant).»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du
notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Gomes, Zuanel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29501. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
33748
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015211678/145.
(150237068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Logwin AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An den Längten.
R.C.S. Luxembourg B 40.890.
Hiermit wird allen Aktionären der Logwin AG ("die Gesellschaft") mitgeteilt, dass eine
ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT
am <i>13. April 2016i> um 10.00 Uhr im Novotel Luxembourg Kirchberg, 6, rue de Fort Niedergruenewald, L-2226 Lu-
xemburg, stattfinden wird.
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2016 der Logwin AG
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr
2. Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr
3. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises) für das am 31. Dezember 2015 beendete Ge-
schäftsjahr
4. Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2015 beendete Ge-
schäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2015
beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2015 zu
genehmigen.
5. Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von 25.019.137,94 EUR
wie folgt zu verwenden:
Ein Zwanzigstel des Jahresüberschusses - 1.250.956,90 EUR - werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Der
Restbetrag von 23.768.181,04 EUR wird als Gewinnrücklage eingestellt.
6. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2015
beendeten Geschäftsjahres
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am
31. Dezember 2015 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.
7. Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern - Statutarische Ernennung:
Bestellung von
Herrn Sebastian Esser
Herrn Dr. Michael Kemmer
Herrn Dr. Yves Prussen
Herrn Dr. Antonius Wagner
zu Mitgliedern des Verwaltungsrats mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversamm-
lung 2017.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Herren Sebastian Esser, Dr. Michael Kemmer, Dr. Yves Prussen und Dr. An-
tonius Wagner zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Logwin AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der
ordentlichen Jahreshauptversammlung 2017 zu bestellen.
8. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Luxembourg, Société coopérative, mit
Sitz in L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 39, Avenue John F. Kennedy, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2016 zu bestellen.
9. Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr
2015 auf insgesamt 120.000,00 EUR festzusetzen.
Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen
Bei der ordentlichen Hauptversammlung ist keine Anwesenheitsmehrheit erforderlich. Die Beschlüsse der ordent-
lichen Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gefasst.
Grundkapital, Stimm- und sonstige Rechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 131.202.165,00 EUR und ist eingeteilt in
146.257.596 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien, wovon 1.813.545 Stückaktien von der Gesellschaft
im Laufe der Geschäftsjahre 2014 und 2015 erworben wurden. Jede Aktie, die 1.813.545 von der Gesellschaft
erworbenen Aktien ausgenommen, gewährt eine Stimme, die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 144.444.051.
Nach Kenntnis der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung keine Aktie, die 1.813.545 von der Gesellschaft
erworbenen Aktien ausgenommen, vom Stimmrecht ausgeschlossen. Aktionäre, die mindestens fünf Prozent (5%)
33749
L
U X E M B O U R G
des gezeichneten Aktienkapitals halten, können nach dem Luxemburgischen Gesetz vom 24. Mai 2011 über die
Ausübung verschiedener Aktionärsrechte in Hauptversammlungen börsennotierter Gesellschaften ("Gesetz über
Aktionärsrechte") die Aufnahme eines oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlungen ver-
langen und haben das Recht, Beschlussvorschläge bezüglich der Tagesordnungspunkte der Hauptversammlungen
einzureichen. Ein entsprechender schriftlicher Antrag muss der Gesellschaft, zusammen mit einer Begründung oder
mit einem Beschlussvorschlag, auf postalischem oder auf elektronischem Weg an folgende Adresse mitgeteilt wer-
den:
Logwin AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 298
gegenantraege@hce.de
Der Antrag hat die Adressdetails des Absenders zur Bestätigung des Eingangs des Verlangens bei der Gesellschaft zu
beinhalten. Das entsprechende Verlangen hat der Gesellschaft spätestens am 22. März 2016 zuzugehen.
Teilnahmebedingungen
Gemäß dem vorgenannten Gesetz über Aktionärsrechte dürfen nur Aktionäre an der Hauptversammlung teilnehmen
und abstimmen, die am 30. März 2016 um Mitternacht (Luxemburger Zeit) ("Luxemburgischer Stichtag") Aktionäre der
Gesellschaft sind. Etwaige Änderungen hinsichtlich ihres Aktienbesitzes nach dem Luxemburgischen Stichtag werden bei
der Bestimmung der Teilnahme- und/oder Stimmberechtigung bei der Hauptversammlung nicht berücksichtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt,
die sich vor der Hauptversammlung in Textform (z.B. per E-Mail) in deutscher, englischer oder französischer Sprache
angemeldet und der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme nachgewiesen haben.
Im Interesse der Aktionäre und im Einklang mit der Satzung wurde der Zeitpunkt, bis zu dem ein Einreichen der
Anmeldung zur Hauptversammlung möglich ist, über den Luxemburgischen Stichtag hinaus verlängert. Die Anmeldung
muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse daher bis spätestens am 06. April 2016 zugehen:
Logwin AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 289
registration@hce.de
Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erfolgt
durch eine in deutscher, englischer oder französischer Sprache erstellte Bescheinigung der Depotbank, bei welcher der
Aktionär seine Aktien an der Logwin AG hält. Die Bescheinigung muss der Gesellschaft unter der oben stehenden Adresse
ebenfalls spätestens bis zum 06. April 2016 zugehen.
Den zur Teilnahme berechtigten Personen werden nach fristgerechter Anmeldung Eintrittskarten zugeschickt, auf deren
Rückseite ein Vollmachtsformular abgedruckt ist.
Vollmachtserteilung
Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Zu diesem Zweck müssen diese Aktionäre sich, wie in
den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 06. April 2016 anmelden. Bevollmächtigte werden unter Vorlage der
Eintrittskarte und einer rechtmäßig erteilten Vollmacht zur Teilnahme an der Hauptversammlung zugelassen. Falls Akti-
onäre ihre Depotbank zur Vertretung ihrer Stimmrechte bevollmächtigen wollen, müssen sie die unterschriebene Vollmacht
bis spätestens zum 12. April 2016 bei ihrer Depotbank hinterlegen. Die Depotbank ist berechtigt, Untervollmacht zu er-
teilen.
Stimmrechtsvertreter
Die Logwin AG möchte den Aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet an, von der
Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.
Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisung erteilen möchten,
können hierzu das auf der Rückseite der Eintrittskarte zu der Hauptversammlung abgedruckte Formular zur Erteilung der
Vollmacht und Weisungen zu den abstimmungsfähigen Punkten der Tagesordnung verwenden. Zu diesem Zweck müssen
diese Aktionäre sich, wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 06. April 2016 anmelden. Mit der Eintritts-
karte erhalten die Aktionäre ein Formular. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular muss spätestens am Dienstag,
12. April 2016, an folgender Anschrift auf postalischem oder elektronischem Weg eingehen:
Logwin AG
33750
L
U X E M B O U R G
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 289
vollmacht@hce.de
Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Falls die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt
werden, müssen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist
eine solche Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten Aktionäre montags bis freitags zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr
unter der Telefonnummer +49 (0) 89 210 27222.
Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem anderen Bevollmächtigten
als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung
einer Vollmacht ein Formular auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen
form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.
Briefwahl
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre Stimmen per Briefwahl
abgeben. Hierzu kann das Formular verwendet werden, das die Aktionäre auf der Rückseite der Eintrittskarte finden. Zu
diesem Zweck müssen diese Aktionäre sich, wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 06. April 2016
anmelden. Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl muss bis spätestens zum 12. April 2016 auf postalischem oder elekt-
ronischem Weg bei der
Logwin AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 289
briefwahl@hce.de
eingegangen sein.
Weitere Informationen über die Hauptversammlung
Weitere Informationen bezüglich der Hauptversammlung können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.log-
win-logistics.com abgerufen werden. Anfragen zu den Dokumenten richten Sie bitte an:
Logwin AG
Investor Relations
ZIR Potaschberg
5, an de Längten
L-6776 Grevenmacher
Luxemburg, den 07. März 2016
Logwin AG
Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2016075084/155.
MUGC/HS Asian USD Bond Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
La mise en liquidation du MUGC/HS ASIAN USD BOND FUND (the "Fund") a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 Février 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016072963/9.
(160036925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
33751
L
U X E M B O U R G
NN (L) CMF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 40.811.
As the value of the assets of the Company's sub-fund NN (L) CMF Euro Short Term Governments (the "Sub-Fund")
has decreased to an amount determined by the board of directors to be the minimum level needed to operate the Sub-Fund
in an economically efficient manner and that therefore the liquidation of the Sub-Fund would be in the best interest and to
the benefit of the shareholders (the "Liquidation").
Notice is hereby given that a
GENERAL MEETING
of the shareholders of the Sub-Fund will be held under private deed at the registered office of the Company on <i>29 Marchi>
<i>2016i> at 2 PM Luxembourg time (the "Meeting") to consider and resolve upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement of shareholders present or represented as being duly convened and informed of the agenda of the
Meeting without specific notice in accordance with Art. 28 para. 2 of the Company's articles of association;
2. Liquidation of the Sub-Fund and subsequent cancellation of all the outstanding shares inscribed in the books of
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. at the date of the Liquidation.
3. Effectiveness of the Liquidation as of 31 March 2016 or any later date as may reasonably be decided by NN Invest-
ment Partners Luxembourg S.A., acting in its capacity as the Company's management company;
4. Miscellaneous.
Shareholders are informed that the board of directors has decided to suspend new subscriptions, redemption and con-
version exchanges into the Sub-Fund's share classes as from 9 March2016.
The cost related to the Liquidation will be borne by NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Liquidation proceeds that are not payable to shareholders due to, inter alia, non-availability of the shareholder at its
registered address or incorrect bank account details will be transferred to the Caisse de Consignation at the close of the
liquidation.
The liquidation may not be tax neutral, and shareholders are encouraged to seek advise from their tax advisor in case
of doubt regarding the potential taxation impact resulting from the liquidation.
The above changes will be reflected in the next version of the prospectus of the Company which will be available to
shareholders free of charge upon request at the registered office of the Company.
Luxembourg, 9 March 2016
The Board of Directors of NN (L) CMF
Référence de publication: 2016075636/755/34.
W.P. Stewart Holdings Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.524.
The
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
of W.P. Stewart Holdings Fund (the "Company"), will be held at 11.00 AM (local time) on <i>March 29, 2016i> at the
registered office of the Company, 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg for the following purposes:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the management report and the report of the auditors for the financial year ended December 31, 2015.
2. To approve the audited annual report of the Company for the fiscal year ended December 31, 2015.
3. To grant discharge to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended
December 31, 2015.
4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Shareholders
and until his or her successor is duly elected and qualified:
Yves Prussen
Bertrand Reimmel
Louis Mangan
Silvio Cruz
5. To appoint Ernst & Young, Luxembourg, as independent auditors of the Company for the forthcoming fiscal year.
6. To transact such other business as may properly come before the Meeting.
33752
L
U X E M B O U R G
Voting:
Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of
the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.
Voting Arrangements:
Holders of shares that are not registered in the Company's shareholders register who want to attend the Meeting are
required to deposit a written declaration at the registered office of the Company no later than March 23, 2016. This written
declaration needs to be issued by their bank or allied institution of Euroclear Nederland where the shares of the Company
are held in custody, stating the name of the shareholder and the number of shares held in his/her name, and shall serve as
ticket of admission to the Meeting. Once such declaration is issued, those shares will be blocked for further trading until
after the Meeting.
Shareholders who will not be able to attend the Meeting to vote in person may be represented by proxy, the form of
which is available at the registered offices of the Company.
The audited financial report is available from the registered office of the Company and the Fund Agent and will be sent
to shareholders who specifically request to receive a copy thereof. It can also be downloaded directly from AB's website:
www.abglobal.com or www.wpstewart.nl/ShareholderReports.aspx
Registered Office
W.P. Stewart Holdings Fund
c/o AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, Rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Tel: +352 46 39 36 151
Fund Agent
KAS Bank N.V.
Spuistraat 172
P.O. Box 24001
1012 VT Amsterdam
The Netherlands
Luxembourg, March 9/17, 2016
The Board of Directors of W.P. Stewart Holdings Fund
Référence de publication: 2016075637/755/52.
DWS Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 160.062.
The shareholders of the SICAV DWS Concept are hereby invited to the
FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
taking place on <i>18 March 2016i> at 11:00 CET at the registered office of the SICAV.
<i>Agenda:i>
1. Change of name of the SICAV to "Deutsche Concept".
2. Miscellaneous points.
Shareholders who submit the depositary's receipt of a credit institution by 14 March 2016 at the latest, indicating that
the shares are held and blocked until the end of the extraordinary general meeting, are entitled to participate and exercise
their voting right at the extraordinary general meeting. Shareholders may also choose to be represented by a proxy, who is
authorised for such purpose in writing.
The items on the agenda of the extraordinary general meeting require a quorum of 50% of issued shares as well as a
two-third majority of the shares present or represented. In case the above-mentioned quorum is not met at the extraordinary
general meeting, a second extraordinary general meeting will be convened at the same address in accordance with Lux-
embourg law to vote on the above-mentioned items on the agenda. No quorum is applicable for such meeting and resolutions
are passed by a two-third majority of the shares present or represented.
Shareholders may request the draft of the updated articles of association at the registered office of the SICAV.
Luxembourg, February/March 2016
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016071340/755/23.
33753
L
U X E M B O U R G
M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 171.314.
In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of February,
Before Maître Danielle KOLBACH, Notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
M&G Real Estate Debt Fund II L.P., a Guernsey limited partnership having its registered office at Third Floor, La
Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, recorded with the Guernsey Registry under number
1736,
here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, with professional address in 66, Grand-Rue, B.P. 66, L-8510
Redange-sur-Attert, Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in Guernsey on 4 February 2016;
which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain
attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) representing the entire share capital of the Com-
pany of M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 51, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register under B171314,
incorporated pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, on 8 December 2009, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°170 of 27 January 2010 (hereafter the “Company”). The articles
of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach,
prenamed on 27 January 2016, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party requested the undersigned notary to state the following agenda:
<i>Agendai>
1. To reduce the corporate capital of the Company by an amount of six thousand, three hundred and twenty Pounds
Sterling and four hundred and sixteen thousandths (GBP 6,320.416) so as to reduce it from its current amount of three
hundred and thirty three thousand, one hundred and thirty six Pounds Sterling and seven hundred and one thousandths
(GBP 333,136.701) represented by three hundred and thirty three million, one hundred and thirty six thousand, seven
hundred and one (333,136,701) shares with a par value of one thousandth sterling pound (GBP 0.001) each to an amount
of three hundred and twenty-six thousand, eight hundred and sixteen pounds sterling and two hundred and eight five
thousandths (GBP 326,816.285) by the cancellation of six million, three hundred and twenty thousand, four hundred and
sixteen (6,320,416) shares of the Company with a nominal value of one thousandth sterling pound (GBP 0.001) each held
by the Company itself;
2. To reduce the Company's share premium account by an amount of six million, three hundred and fourteen thousand,
and ninety five Pounds Sterling and three hundred and eighty four thousandths (GBP 6,314,095.384) so as to reduce it from
its current amount of three hundred and twenty million, three hundred and sixteen thousand, and sixty-four Pounds Sterling
and one hundred and nine thousandths (GBP 320,316,064.109) to an amount of three hundred and fourteen million, one
thousand, nine hundred and sixty eight Pounds Sterling and seven hundred and twenty-five thousandths (GBP
314,001,968.725);
3. To allot the total amount arising from items 1) and 2) of this agenda to the reimbursement of the Sole Shareholder;
4. Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company so as to reflect the above decrease
of the share capital of the Company;
5. To authorise Ms. Alexandra Fantuz with full power of substitution, to record the capital reduction in the share register
of the Company.
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to reduce the corporate capital of the Company by an amount of six thousand, three hundred and
twenty Pounds Sterling and four hundred and sixteen thousandths (GBP 6,320.416) so as to reduce it from its current
amount of three hundred and thirty three thousand, one hundred and thirty six Pounds Sterling and seven hundred and one
thousandths (GBP 333,136.701) represented by three hundred and thirty three million, one hundred and thirty six thousand,
seven hundred and one (333,136,701) shares with a par value of one thousandth sterling pound (GBP 0.001) each to an
amount of three hundred and twenty-six thousand, eight hundred and sixteen Pounds Sterling and two hundred and eight
five thousandths (GBP 326,816.285) by the cancellation of six million, three hundred and twenty thousand, four hundred
and sixteen (6,320,416) shares of the Company with a nominal value of one thousandth sterling pound (GBP 0.001) each
held by the Company itself;
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to reduce the Company's share premium account by an amount of six million, three hundred and
fourteen thousand, and ninety five Pounds Sterling and three hundred and eighty four thousandths (GBP 6,314,095.384)
33754
L
U X E M B O U R G
so as to reduce it from its current amount of three hundred and twenty million, three hundred and sixteen thousand, and
sixty-four Pounds Sterling and one hundred and nine thousandths (GBP 320,316,064.109) to an amount of three hundred
and fourteen million, one thousand, ninety hundred and sixty eight Pounds Sterling and seven hundred and twenty-five
thousandths (GBP 314,001,968.725)
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to allocate the total amount arising from the reductions of both the share capital and the share
premium of the Company to the reimbursement of the Sole Shareholder.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the resolutions adopted here above, the meeting resolves to amend article 5.1 of the articles of
incorporation of the Company which now shall read as follows:
“The Company's share capital is set at three hundred and twenty-six thousand, eight hundred and sixteen Pounds Sterling
and two hundred and eight five thousandths (GBP 326,816.285) represented by three hundred and twenty-six million, eight
hundred and sixteen thousand, and two hundred and eighty-five (326,816,285) shares with a nominal value of one thou-
sandth sterling pound (GBP 0.001) each.”
The rest of article 5 and the articles of incorporation of the Company remain unchanged.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to authorise Ms. Alexandra Fantuz with full power of substitution, to record the capital reduction
in the share register of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing party,
this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed is drawn up in Redange-sur-Attert, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the above appearing party, who is known to the undersigned
notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the notary this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille seize, les quatre jours du mois de février,
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
M&G Real Estate Debt Fund II L.P., un Guernsey limited partnership ayant son siège social au Third Floor, La Plaiderie
Chambers, La Plaiderie, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, immatriculé au Guernsey Registry sous le numéro 1736,
ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à 66, Grand-Rue, B.P. 66,
L-8510 Redange-sur-Attert, Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2016, à Luxembourg;
ladite procuration, signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'associée unique (l'«Associé Unique») représentant l'intégralité du capital social de M&G Real Estate
Finance 2 Co. S.à r.l, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B171314, constituée suivant
un acte de Maître Joëlle Baden, notaire, résidant à Luxembourg, en date du 8 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N°170 du 27 janvier 2010 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés
en dernier lieu suivant un acte de Maître Danielle Kolbach, prénommée, en date du 27 janvier 2016, pas encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du jour
de l'assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de six mille trois cent vingt livres sterling et quatre cent seize
millièmes (GBP 6.320,416) de manière à le ramener de son montant actuel de trois cent trente-trois mille cent trente-six
livres sterling et sept cent un millième (GBP 333.136,701) représenté par trois cent trente-trois millions cent trente-six
mille sept cent une (333.136.701) parts sociales ayant une valeur nominale d'un millième livre sterling (GBP 0,001) chacune
pour un montant de trois cent vingt-six mille huit cent seize livres sterling et deux cent quatre-vingt-cinq (GBP 326.816,285)
33755
L
U X E M B O U R G
millièmes par l'annulation de six millions trois cent vingt mille quatre cent seize (6.320.416) parts sociales d'une valeur
nominale d'un millième de livre sterling (GBP 0,001,-) chacune détenues par la Société elle-même.
2. Réduction du compte de prime d'émission de la Société d'un montant de six millions trois cent quatorze mille, quatre-
vingt-quinze livres sterling et trois cent quatre-vingt-quatre millièmes (GBP 6.314.095,384) de manière à le ramener de
son montant actuel de trois cent vingt millions trois cent seize mille, soixante-quatre livres sterling et cent neuf millièmes
(GBP 320.316.064,109) à un montant de trois cent quatorze millions mille neuf cent soixante-huit livres sterling et sept
cent vingt-cinq millièmes (GBP 314.001.968,725);
3. Affectation du montant total issu des points 1) et 2) de cet agenda au remboursement à l'associé unique de la Société;
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital social actée
ci-dessus;
5. Pouvoirs à accorder à Madame Alexandra Fantuz agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, de procéder
à l'enregistrement de la réduction de capital dans le registre des parts sociales de la Société.
Après que les points suivants aient été approuvés par l'assemblée, l'assemblée a décidé d'adopter à l'unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de six mille trois cent vingt livres sterling et
quatre cent seize millièmes (GBP 6.320,416) de manière à le ramener de son montant actuel de trois cent trente-trois mille
cent trente-six livres sterling et sept cent un millième (GBP 333.136,701) représenté par trois cent trente-trois millions cent
trente-six mille sept cent une (333.136.701) parts sociales ayant une valeur nominale d'un millième livre sterling (GBP
0,001) chacune à un montant de trois cent vingt-six mille huit cent seize livres sterling et deux cent quatre-vingt-cinq (GBP
326.816,285) millièmes par l'annulation de six millions trois cent vingt mille quatre cent seize (6.320.416) parts sociales
d'une valeur nominale d'un millième de livre sterling (GBP 0,001) détenues par la Société elle-même.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de réduire le compte de prime d'émission de la Société d'un montant de six millions trois cent quatorze
mille, quatre-vingt-quinze livres sterling et trois cent quatre-vingt-quatre millièmes (GBP 6.314.095,384) de manière à le
ramener de son montant actuel de trois cent vingt millions trois cent seize mille soixante-quatre livres sterling et cent neuf
millièmes (GBP 320.316.064,109) à un montant de trois cent quatorze millions mille neuf cent soixante-huit livres sterling
et sept cent vingt-cinq millièmes (GBP 314.001.968,725).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'affecter la quantité totale découlant de la réduction du capital social et du compte de prime d'émis-
sion de la Société au remboursement à l'Associé Unique de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées précédemment, l'assemblée décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la
Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de trois cent vingt-six mille huit cent seize livres sterling et deux cent quatre-
vingt-cinq (GBP 326.816,285) millièmes représenté par trois cent vingt-six millions huit cent seize mille deux cent quatre-
vingt-cinq (326.816.285) parts sociales d'une valeur nominale d'un millième de livre sterling (GBP 0,001) chacune.»
Le reste de l'article 5 des statuts de la Société demeure inchangé.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de donner tout pouvoir à Madame Alexandra Fantuz, agissant individuellement, avec pouvoir de
substitution, de procéder à l'enregistrement de la réduction de capital dans le registre des parts de la Société.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de
la réduction de son capital sont évalués environ mille huit cents livres sterling (EUR 1.800,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénoms, état
et demeure, la prédite personne a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 08 février 2016. Relation: DAC/2016/1975. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
33756
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016066167/166.
(160028551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
P & B Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 174.109.
EXTRAIT
DATA GRAPHIC S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi L-1720 Luxembourg, rue
Heinrich Heine, 8, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156 243 informe
le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 30 décembre 2015 de son mandat de
Commissaire de la société P&B GROUP S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174 109 et dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, 128
Boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016003167/16.
(160000808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
BNP Paribas Plan, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 77.227.
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of February.
Before the undersigned Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held:
an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of BNP Paribas Plan (hereafter referred to as the
“Company”), a société d'investissement à capital variable having its registered office at L-5826 Hesperange, 33, rue de
Gasperich (R.C.S. Luxembourg B 77.227), incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, then notary residing
in Luxembourg, on August 7
th
, 2000, published in the Mémorial C number 646 of September 9
th
, 2000. The Articles of
Incorporation were amended for the last time under a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on the
September 16
th
, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 2347
of October 3
rd
, 2011.
The Meeting is opened at 10.30 a.m. and is presided by Mr. Guillaume DEBAUVE, private employee, residing profes-
sionally in Hesperange, who appoints Mrs. Amina LAHRI, private employee, in Hesperange, as Secretary.
The Meeting elects Mr. Didier LAMBERT, residing professionally in Hesperange, as Scrutineer.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The Shareholders were convened to the Meeting by letter containing the Agenda, sent to them by letter on 19
th
January
2016, and published in the Mémorial C and in the Luxemburger Wort and in the Letzebuerger Journal on 19
th
January
2016 and 3
rd
February 2016.
II. The shareholders represented, and the number of its shares is shown on an attendance list, signed by the Chairman,
the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary.
This list as well as the proxy signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration
authorities.
III. A first meeting of shareholders duly convened, was held on 18
th
January 2016 in order to decide on the same agenda.
This meeting could not take any decision because the legal quorum of presence was not met.
IV. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the
Agenda.
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 25 April 2016:
1) Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
33757
L
U X E M B O U R G
2) Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6 April
2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August 1915
as amended.
3) Article 14(3):
Replacement of “the closing price on the order acceptance date” by “the last known closing price on the valuation day”
for the listed assets valuation price;
4) Article 16:
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director by using the same
terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
5) Article 19:
Cancellation of the possibility to jointly manage the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
6) Article 20:
Cancellation of the following condition relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Company
to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law of 12 July
2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions at
the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
7) Article 22:
Replacement of the title of the article “invalidation clause” by “conflict of interest”
After deliberation, the Meeting took the following resolutions which were carried by at least two-thirds of the votes
cast:
<i>First resolutioni>
The general Meeting decides to update the Articles of Association of the Company as following:
Art. 4. Registered office. “The Company's registered office is located in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
In the case where the Board of Directors considers that extraordinary political, economic or social events might com-
promise the Company's normal operations at the registered office or ease of communication with said registered office or
by said office with other countries have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad
until said abnormal situation no longer exists. However, any such temporary measure shall have no effect on the Company's
nationality, which, notwithstanding the above mentioned temporary transfer of the registered office, shall continue to be a
Luxembourg company.
The Company may, by simple decision of the Board of Directors, open branches or offices in the Grand Duchy of
Luxembourg or elsewhere.
The registered office may be moved by simple decision of the Board of Directors, either within the commune or, within
the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxembourg.”
Art. 8. Share form. “All shares, regardless of the sub-fund, category or class to which it belongs, may be in registered,
bearer, or dematerialised form as decided by the Board of Directors.
Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended
(the “Companies Act”).
Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act.
Dematerialised shares shall be issued as described by the Act of 6 April 2013 on dematerialised securities.
Within the limits and conditions set by the Board of Directors, shares issued in one of these three forms may be converted
into another form. The shareholder requesting the conversion may have to pay the costs of such operation.
The Company acknowledges only one shareholder per share. If a share is jointly owned, if title is split or if the share is
disputed, individuals or legal entities claiming a right to the share shall appoint a sole representative to represent the share
with regard to the Company. The Company shall be entitled to suspend the exercise of all rights attached to the share until
said representative has been appointed.”
Art. 14. Net asset value. “The Company shall calculate the net asset value of each sub-fund, the net asset value per share
for each category and class and the issue, conversion and redemption prices at least twice per month, at to a frequency to
be set by the Board of Directors.
33758
L
U X E M B O U R G
The net asset value of each sub-fund shall be equal to the total value of the assets of said sub-fund less the sub-fund's
liabilities.
The net asset value per share is obtained by dividing the net assets of the sub-fund in question by the number of shares
issued for said sub-fund, considering, where applicable, the breakdown of the net assets of said sub-fund between the
various share categories and classes of such sub-fund.
Said net value shall be expressed in the currency of the sub-fund in question or in any other currency that the Board of
Directors may choose.
The day on which the net asset value is dated shall be referred to in these Articles of Association as the “Calculation
Date”.
The valuation methods shall be as follows:
The Company's assets include:
1. cash in hand and cash deposits, including interest accrued but not yet received and interest accrued on these deposits
until the payment date;
2. all notes and bills payable on demand and amounts receivable (including the results of sales of securities before the
proceeds have been received);
3. all securities, units, shares, bonds, option or subscription rights and other investments and securities which are the
property of the Company;
4. all dividends and distributions to be received by the Company in cash or securities that the Company is aware of;
5. all interest accrued but not yet received and all interest generated up to the payment date by securities which are the
property of the Company, unless such interest is included in the principal of these securities;
6. the Company's formation expenses, insofar as these have not been written down;
7. all other assets, whatever their nature, including prepaid expenses.
Without prejudice to the specific provisions applicable to any sub-fund, category and/or class, the value of these assets
shall be determined as follows:
1. the value of cash in hand and cash deposits, bills and drafts payable at sight and amounts receivable, prepaid expenses,
and dividends and interest due but not yet received, shall comprise the nominal value of these assets, unless it is unlikely
that this value could be received; in that event, the value will be determined by deducting an amount which the Company
deems adequate to reflect the actual value of these assets;
2. the value of shares or units in undertakings for collective investment shall be determined on the basis of the last net
asset value available on the valuation day;
3. the valuation of all securities listed on a stock exchange or any other regulated market which functions regularly, is
recognised and accessible to the public, is based on the last known closing price on the valuation day, and, if the securities
concerned are traded on several markets, on the basis of the last known closing price on the major market on which they
are traded. If the last known closing price is not a true reflection, the valuation shall be based on the probable sale price
estimated by the Board of Directors in a prudent and bona fide manner.
4. unlisted securities or securities not traded on a stock exchange or another regulated market which functions in a regular
manner, is recognised and accessible to the public, shall be valued on the basis of the probable sale price estimated in a
prudent and bona fide manner by a qualified professional appointed for this purpose by the Board of Directors.
5. securities denominated in a currency other than the currency in which the sub-fund concerned is denominated shall
be converted at the exchange rate prevailing on the valuation day.
6. the Board of Directors is authorised to draw up or amend the rules in respect of the relevant valuation rates. Decisions
taken in this respect shall be included in the prospectus.
7. derivative financial instruments shall be valued according to the rules decided by the Board of Directors and described
in the prospectus. These rules shall have been approved in advance by the Company's auditor and the supervisory authorities.
The Company's liabilities include:
1. all loans, matured bills and accounts payable;
2. all known liabilities, whether or not due, including all contractual obligations due and relating to payment in cash or
kind, including the amount of dividends announced by the Company but yet to be paid;
3. all reserves, authorised or approved by the Board of Directors, including reserves set up in order to cover a potential
capital loss on certain of the Company's investments;
4. any other undertakings given by the Company, except for those represented by the Company's equity. For the valuation
of the amount of these other liabilities, the Company shall take account of all the charges for which it is liable, including,
without restriction, the costs of amendments to the Articles of Association, the prospectus and any other documents relating
to the Company, management, performance and other fees and extraordinary expenses, any taxes and duties payable to
government departments and stock exchanges, the costs of financial charges, bank charges or brokerage incurred upon the
purchase and sale of assets or otherwise. When assessing the amount of these liabilities, the Company shall take account
of regular and periodic administrative and other expenses on a pro rata temporis basis.
33759
L
U X E M B O U R G
The assets, liabilities, expenses and fees not allocated to a sub-fund, category or class shall be apportioned to the various
sub-funds, categories or classes in equal parts or, subject to the amounts involved justifying this, proportionally to their
respective net assets. Each of the Company's shares which is in the process of being redeemed shall be considered as a
share issued and existing until closure on the valuation day relating to the redemption of such share and its price shall be
considered as a liability of the Company as from closing on the date in question until such time as the price has been duly
paid. Each share to be issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be considered
as issued as from closing on the calculation date of its issue price and its price shall be considered as being an amount due
to the Company until such time as it has been duly received by the Company. As far as possible, account shall be taken of
any investment or disinvestment decided by the Company until the valuation day.
The total amount of annual fees payable by a sub-fund, category or class of share shall never exceed 5% (five per cent)
of its average net assets.
If it considers that the net asset value calculated is not representative of the real value of the Company's shares, or if
since the calculation there have been significant developments on the markets concerned, the Board of Directors may decide
to have it updated on that same day, and shall determine a new net asset value in a prudent and bona fide manner.”
Art. 16. Directors. “A Board of Directors comprised of at least three members shall manage the Company. Board
members do not need to be Company shareholders. The General Meeting of shareholders shall appoint them for a term of
office of six years at most, which shall be renewable.
The General Meeting may remove a director from office at will.
In case of vacancy of the office of a director appointed by the General Meeting of shareholders, the remaining directors
so appointed may fill the vacancy on a provisional basis. In such circumstances, the next General Meeting of shareholders
shall make the final appointment.”
Art. 19. Daily management. “The Company's Board of Directors may delegate its powers relating to the daily manage-
ment of the Company's business (including the right to act as the Company's authorised signatory) and to represent it for
said management either to one or more directors or to one or more agents who need not necessarily be Company share-
holders. Said individuals shall have the powers conferred on them by the Board of Directors. They may sub-delegate their
powers, if authorised by the Board of Directors. The Board of Directors may also grant all special mandates by notarised
power of attorney or by private power of attorney.”
Art. 20. Investment policy. “The Board of Directors, applying the principle of the spreading of risks, shall be fully
empowered to determine the investment policy and restrictions of the Company and each of its sub-funds, and the guidelines
to be followed for the management of the Company, in compliance with the law and subject to the following conditions:
1. The Company may invest in any transferable securities and money market instruments officially listed on a stock
exchange or traded on a regulated market, operating regularly, that is recognised and open to the public, in any country;
2. Overall, the Company may not invest more than 10% of the assets of each sub-fund in UCITS and other undertakings
for collective investment, apart for certain sub-funds if mentioned in their investments policy;
3. The Board of Directors may specify that a sub-fund's investment policy should be the replication of the composition
of an equity or bond index within the limits authorised by law and the supervisory authorities;
4. The Company may invest, in accordance with the principle of risk-spreading, at least 35% and up to 100% of its assets
in different issues of transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the
European Union, by its local authorities, or by a state that is not part of the European Union or by international public
organisations to which one or more Member States of the European Union belong. These securities must come from at
least six different issues, and the securities belonging to a single issue must not account for more than 30% of the net asset
value of the sub-fund.
5. A sub-fund of the Company may subscribe, acquire and/or hold shares of one or more other sub-funds (referred to as
“target sub-funds”) of the Company provided that:
- the target sub-funds do not in turn invest in this sub-fund;
- the proportion of assets that each target sub-fund invests in other target-sub-funds of the Company does not exceed
10%;
- any voting rights attached to the shares of the target sub-funds are suspended for as long as they are held by the sub-
fund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any events, for as long as these target sub-fund shares are held by the Company, their value shall not be taken into
consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of
net assets required by the law;
6. The Board of Directors may create “feeder sub-funds” under the conditions provided for by law.”
Art. 22. Conflict of interest. “No contract and transaction that the Company may enter into with other companies or
firms may be affected or invalidated by the fact that one or more directors or executive directors of the Company has/have
any interest whatsoever in such other company or firm or by the fact that he is a director, shareholder or partner, executive
director or employee thereof.
33760
L
U X E M B O U R G
The director or executive director of the Company who is a director, executive director or employee of a company or
firm with which the Company signs contracts or otherwise does business shall not thereby be deprived of the right to
deliberate, vote and act in connection with matters related to such contracts or such business. In the event a director or an
executive director has a personal interest in a Company transaction, said director or executive director shall inform the
Board of Directors of his personal interest and shall not deliberate or take part in the vote on said transaction. A report on
said transaction and on the personal interest of such director or non-executive director shall be submitted at the next meeting
of shareholders.”
<i>Second resolutioni>
These changes will be effective as from 25 April 2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).
There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned at 11.00 a.m.
Whereof this deed is drawn up in Hesperange on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the bureau of the Meeting, who are known to the undersigned notary
by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the notary this deed.
Signé: G. DEBAUVE, A. LAHRI, D. LAMBERT, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5584. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 25 février 2016.
Référence de publication: 2016071444/227.
(160035373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.
HC Property Heureka II Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.998.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 120.511.
AUSZUG
Die Geschäftsführung nimmt zur Kenntnis, dass
1. die Andresse der Geschäftsführer sich wie folgt geändert hat:
Herr Peter Gillert: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg
Herr Andreas Oster: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg
Herr Ralf Schlautmann: Börsenplatz 1, D-70174 Stuttgart, Deutschland
2. Prega Investments B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts, mit dem Sitz in 200,
Prins Bernhardplin, NL-1097 JB, Amsterdam, die Niederlanden hat ihre 66.306 Anteile an der Gesellschaft an Spezial-
Sondervermögen GREHI vertreten durch seine verwaltungs IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit dem Sitz in 61, Ferdinandstraße, D-20095
Hamburg, Deutschland
Den 26. Februar 2016.
HC Property Heureka II Beta S.à r.l.
Référence de publication: 2016072226/21.
(160036291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
No-Nail Boxes (Europe) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone d'activité Salzbach.
R.C.S. Luxembourg B 91.982.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle le 28 août 2015i>
L'assemblée décide de nommer Fiducia Audit S.à r.l., ayant son siège social au 8 rue Adolphe Fischer L-1520 Luxem-
bourg, enregistré sous le numéro RCS Luxembourg B180.814 en tant que Réviseur d'Entreprises pour l'exercice se clôturant
au 31 décembre 2015.
33761
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A.i>
Référence de publication: 2016003146/13.
(160000913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
HC Property Heureka I Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.350.900,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 120.510.
AUSZUG
Die Geschäftsführung nimmt zur Kenntnis, dass
1. die Andresse der Geschäftsführer sich wie folgt geändert hat:
Herr Peter Gillert: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg
Herr Andreas Oster: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg
Herr Ralf Schlautmann: Börsenplatz 1, D-70174 Stuttgart, Deutschland
2. Prega Investments B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts, mit dem Sitz in 200,
Prins Bernhardplin, NL-1097 JB, Amsterdam, die Niederlanden hat ihre 79.125 Anteile an der Gesellschaft an Spezial-
Sondervermögen GREHI vertreten durch seine verwaltungs IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit dem Sitz in 61, Ferdinandstraße, D-20095
Hamburg, Deutschland
Den 1. März 2016.
HC Property Heureka I Alpha S.à r.l.
Référence de publication: 2016074094/21.
(160038735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
San Maurizio SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 204.312.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the twenty-sixth day of February,
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
I. San Maurizio Management, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197055, represented by Mr Marc BERNA, Lawyer, residing
professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on February 25
th
, 2016.
II. FONSICAR S.A. SICAR, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered
office at 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 114.725, represented by Mr Marc BERNA, Lawyer, residing professionally
in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on February 25
th
, 2016.
The said proxies, after haviing been initialed and signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the officiating notary to enact the following
articles of association of a partnership limited by shares “société en commandite par actions” which they declare to establish
as follows:
Title I. Form - Name - Registered office - Purpose - Duration
Art. 1. Form and name. There exists among the managing general partner, “associé-gérant commandité“, (the General
Partner) and the limited partners, “actionnaires commanditaires“, (the Limited Shareholders, together with the General
Partner, the Shareholders), a Luxembourg partnership limited by shares, “société en commandite par actions“, organised
as an investment company with variable capital, “société d’investissement à capital variable (SICAV)“, qualifying as a
specialised investment fund, “fonds d’investissement spécialisé“, under the name of San Maurizio SCA SICAV-SIF (he-
reinafter the Company), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the Law) and notably the law of 10
33762
L
U X E M B O U R G
August 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law), the Luxembourg law of 13 February 2007 relating
to specialised investment funds, as amended (the SIF Law) and these articles of association (the Articles).
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a simple resolution of the General
Partner. The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of an extraordinary general meeting of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of
these Articles.
In the event of extraordinary political or military developments or such other imminent or already occurred events that
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company.
The Company may have offices, branches (whether or not a permanent establishment) and subsidiaries either in Lu-
xembourg or abroad.
Art. 3. Purpose. The exclusive purpose of the Company is the collective investment of its funds in any kind of assets
eligible under the SIF Law in order to spread the investment risks and to ensure for the investors the benefit of the results
of the management of its assets according to its investment objective and policy in compliance with the provisions of the
SIF Law.
The investment objective and strategy of the Company are more fully described in the Company’s Private Placement
Memorandum (the PPM).
The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, in particular,
without limitation, grant any assistance, advances or guarantees and raise funds except by way of public offering, especially
through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and
generally issue securities of any type and secure the repayment of any money borrowed from third parties or from its
Shareholders as further described in the PPM.
To the largest extend permitted by Law, the Company may take any measures, carry out any transaction and perform
all commercial, technical and financial operations, linked directly or indirectly to its purpose and which it may deem useful
for the accomplishment and development of its purpose.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited period of time. Each compartment of the Company may
have such duration as indicated in the Company’s PPM.
Title II. Share capital - Transfer of shares - Redemption of shares - Distribution rights
Art. 5. Share Capital. The minimum share capital of the Company shall be equal to one million two hundred fifty thousand
Euro (1,250,000,-EUR). This minimum must be reached within twelve months following the authorisation of the Company
by the Luxembourg supervisory authority of the financial sector “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (the
CSSF).
The initial share capital of the Company upon incorporation shall be set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000)
represented by ten (10) management shares (the Management Shares) held by the General Partner equally in each com-
partment and three hundred (300) limited shares (the Limited Shares) held by the Limited Shareholders all with no par
value and fully paid up.
The share capital of the Company shall be represented by shares of different classes and shall at any time be equal to
the total net assets of the Company as determined in accordance with the provisions of these Articles.
Art. 6. Classes and Types of shares. The Company is a multi-compartment structure, with each compartment representing
a specific portfolio of assets and liabilities.
The rights of investors and of creditors concerning a compartment or which have arisen in connection with the creation,
operation or liquidation of a compartment are limited to the assets of that compartment.
The assets of a compartment are exclusively available to satisfy the rights of investors in relation to that compartment
and the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operations or the liquidation of
that compartment.
The General Partner may, at any time, issue additional classes of shares and/or different types of shares within the
different classes, which may carry different rights and obligations inter alia with regard to their fee structure, subscription
and/or redemption procedures, eligible investors, income and profit entitlements, investment policy, as may be specified
from time to time in the PPM.
The following classes of shares representing the different compartments of the Company and carrying different rights
and obligations as set forth more specifically in the PPM will be initially offered for subscription to the investors:
- Class A shares, representing compartment I;
- Class B shares; representing compartment II.
Art. 7. Form of Shares. The Company will issue shares in registered form only.
33763
L
U X E M B O U R G
All issued shares of the Company will be registered in the share register which will be kept by the Company or by one
or more persons designated thereto by the Company and such register shall contain the name of each owner of registered
shares as communicated to the Company, the residence or elected domicile as communicated to the Company and the
number of shares held and the amount paid up on each share.
Shareholders will provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent.
In the event that a Shareholder does not provide an address, the General Partner may permit a notice to this effect to be
entered into the register and the Shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the Company, or
such other address as may be so entered into by the General Partner from time to time, until another address is duly provided
to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as entered in the register by
means of a written notification to the General Partner.
The inscription of the Shareholder’s name in the register shall evidence and prove his right of ownership. Upon request,
each Shareholder shall receive a written notice of his shareholding.
The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such
share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) must appoint a sole attorney to represent such shareholding
in dealings with the Company. The failure to appoint such attorney shall result in a suspension of all rights attached to such
share(s). Moreover, in the case of joint Shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds,
distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative
of all joint holders, or to all joint Shareholders together, at its absolute discretion.
The Company may issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to
participate proportionally in any distribution and liquidation proceeds of the relevant compartment.
Art. 8. Issue and subscription for Shares. The Limited Shares are only offered to well-informed investors within the
meaning of Article 2 of the SIF Law (a Well-informed Investor).
A Well-Informed investor is an institutional investor, a professional investor or any other investor who meets the fol-
lowing criteria:
a) he has confirmed in writing that he adheres to the status of well-informed investor; and
b) he invests a minimum of the equivalent of one hundred and twenty five thousand Euro (125,000 EUR) in the Fund;
or
he has been the subject of an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, by
an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of
Directive 2009/65/EC certifying his expertise, his experience and his knowledge in adequately apprising an investment in
the specialised investment fund.
The compliance of each subscriber with the status of Well-Informed Investor will be verified by the General Partner or
any agent to which such function has been delegated by the General Partner.
Investors wishing to subscribe for Limited Shares must deliver a signed subscription agreement (the Subscription
Agreement), which upon acceptance shall be counter-signed by the General Partner latest on the predetermined subscription
date as determined by the General Partner from time to time (the Subscription Date). The execution of a Subscription
Agreement constitutes a commitment to subscribe for Limited Shares under the terms and conditions set forth in the
Subscription Agreement, the present Articles as well as the terms and conditions set out in the PPM. The General Partner
may fix a minimum subscription amount and may where he determines appropriate levy a subscription charge.
Upon acceptance of the Subscription Agreement by the General Partner, investors must contribute their commitment as
set forth in the Subscription Agreement and shares will only be issued subsequently. The issue price must be received no
later than the 30
th
business day prior to the relevant Subscription Date.
The General Partner is authorised to issue, at any time, an unlimited number of additional fully or partly paid-up Limited
Shares of any class or type. The General Partner may decide to issue new shares in one or several compartments. Shares
to be newly issued in a compartment shall be offered on a pre-emptive basis to the existing Shareholders on a compartment
by compartment basis in the proportion of the capital represented by their shares in the respective compartment. Each newly
issued Limited Share of one specific class entitles its holder to the same rights and obligations of the holders of existing
Limited Shares of the same class.
The General Partner may impose restrictions in respect of the number of eligible investors and the conditions to be met
by an eligible investor. The General Partner shall have the power to impose such restrictions as it deems necessary for the
purpose notably of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by a) any person in breach of these Articles,
the PPM, the Law or requirement of any country or governmental authority, or b) any person in circumstances which in
the opinion of the General Partner might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any other
pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered. For such purpose the General
Partner may:
- decline to issue any share and decline to register any transfer of shares where it appears to him that such registration
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such share being held by a person who is precluded
from holding shares in the Company;
33764
L
U X E M B O U R G
- at any time require any person whose name is registered in the register of Shareholders to support it with any infor-
mation, supported by affidavit, which he may consider necessary for the purpose of determining whether or not legal or
beneficial ownership of such Shareholder’s shares rests or will rest in a person that is precluded from holding shares in the
Company; and
- where it appears that any person that is precluded from holding shares in the Company is a legal or beneficial owner
of shares or holds shares, cause the repurchase of the shares from any such shareholder.
The General Partner may delegate to any duly selected agent the power to receive the payments in connection with the
Limited Shares to be issued as well as the power to process the issue and delivery of the new Limited Shares.
The shares have no par value.
Shares are issued at the latest available net asset value per share provided such net asset value is no older than six months.
Where the latest available net asset value does not in the opinion of the General Partner represent the fair value of the
applicable net asset value due to any material or other change of circumstances, the General Partner may order a new
calculation of the net asset value for the purpose of determining the applicable issue price.
The General Partner may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind, in compliance with the legal
requirements connected to such consideration.
Art. 9. Transfer and Conversion of Shares. Limited Shares are freely transferable between Shareholders and between
Shareholders and entities connected to a Shareholder. For the purpose of the preceding provision, a connected entity is (i)
any entity in which the Shareholder who contemplates to transfer its shares, holds more than 50% of the share capital and
voting rights, (ii) any entity that holds more than 50% of the share capital and voting rights of the Shareholder contemplating
to transfer its shares, or (iii) any entity which is under common holding for more than 50% of the share capital and voting
rights with such Shareholder.
Limited Shares may only be transferred to other Well-informed Investors.
Before any shares may be transferred to other Well-informed Investors, they must be offered on a pre-emptive basis to
the existing Shareholders on a compartment by compartment basis in the proportion of the capital represented by their
shares in the respective compartment.
Any transfer of shares shall be given effect by a written declaration of transfer to be registered in the register of Share-
holders, dated and signed by the transferor and transferee.
Shares of a certain class may not be converted into shares of another class.
Art. 10. Pledging of Shares. Shareholders are not allowed to pledge or grant a security interest in any of their shares
without the prior written consent of the General Partner.
Art. 11. Redemption of Shares. Redemption requests by Shareholders will only be accepted and processed after an initial
lock-up period of five years as from the authorisation of the Company by the CSSF, which may be extended for an additional
two years at the sole discretion of the General Partner. Redemption rights may be suspended as further described in the
PPM.
The General Partner may further decide at its own initiative to proceed to a compulsory redemption of shares where:
- the participation of a Shareholder is likely to put the Company, or the General Partner in a situation of breach of any
law or regulation;
- the participation of a Shareholder is likely to cause the Company, the General Partner or any Shareholder an economic
material disadvantage, including additional taxation, which they would not suffer in the absence of the said participation;
- if in the reasonable opinion of the General Partner, such redemption would allow the Company not to fall under the
registration of shares under the U.S Securities Act of 1933 as amended or similar, or the Company from registration under
the U.S. Investment Company Act of 1940 as amended or similar;
- such other circumstances as the General Partner may reasonably determine in its sole discretion and in the interest of
all the Shareholders.
Shareholders may request in writing redemption of their shares to the appointed administrative agent with the prior
approval of the General Partner, with a notice period of at least ninety (90) business days. Where the aggregate redemption
request exceeds ten percent (10%) of the net asset value of the compartment the General Partner may in its sole discretion
defer redemptions for a reasonable amount of time. The net redemption proceeds will be remitted under the terms and
conditions as further determined in the PPM.
Shares which are to be redeemed by the Company as a cause of compulsory redemption, may be redeemed by the
Company after a minimum notice period of thirty (30) business days given by the General Partner in writing to the Sha-
reholder counting from the disclosure of the intention of the General Partner to redeem such shares.
The shares shall be redeemed at the net asset value per share of the relevant compartment as determined at the latest
Valuation Day (as defined below) provided such Valuation Day has occurred less than six months before the day of the
contemplated redemption.
33765
L
U X E M B O U R G
Where the latest available net asset value does not in the opinion of the General Partner represent the fair value of the
applicable net asset value due to any material or other change of circumstances, the General Partner may order a new
calculation of the net asset value for the purpose of determining the applicable redemption price.
Art. 12. Net Asset Value. The net asset value (the Net Asset Value) is expressed in Euro unless where otherwise specified
in the specifications of a compartment in the PPM. The Net Asset Value is calculated up to three decimal places on a class
by class basis by the duly appointed administrative agent of the Company under the supervision of the General Partner on
each valuation day (a Valuation Day) as indicated in the PPM but in no event less than once a year.
The Net Asset Value is determined in respect to each compartment by calculating the difference between the total assets
directly referable to the relevant compartment and the sum of the liabilities directly referable to the same compartment.
The Net Asset Value per share of a given class is determined by dividing the Net Asset Value of a compartment by the
number of shares representing that compartment.
The assets of each compartment of the Company shall be deemed to include:
- all securities, debt securities, shares and units of investment funds, options and other investment and securities owned
or contracted for by the Company on account of such compartment;
- all cash in hand or on deposit for the account of such compartment, including any outstanding accrued interest;
- all bills and demand notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
- all stock dividends, cash dividends, cash distributions receivable by the Company in respect of investments of the
compartment to the extend the information thereon is reasonably available to the Company;
- all interest accrued on any interest bearing securities held by the Company for the account of the compartment, except
to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security;
- the Company's or relevant compartment’s preliminary expenses, to the extent that such expenses have not already been
written-off;
- all other assets whatever their nature, including real estates, attributable to such compartment and advance payments.
The liabilities of each compartment of the Company shall be deemed to include:
- all loans, bills, promissory notes and accounts payable;
- all accrued or payable administrative expenses (including but not limited to the General Partner’s fees, the adminis-
trative agent’s fees and the depositary’s fees);
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,
involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
Company regarding the relevant compartment but not yet paid;
- a provision for any future taxes based on capital and income to the Valuation Day and any other provisions authorised
or approved by the General Partner; and
- all other liabilities of each compartment of the Company of any, except liabilities represented by shares in the Company.
For the purpose of the Net Asset Value calculation:
- shares in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall not be deemed
to be existing;
- shares of the Company to be redeemed shall be treated as existing and until paid, the price therefore shall be deemed
to be a liability of the Company;
- all investments, cash balances and other assets of the Company not expressed in Euro, shall be valued after taking into
account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value; and
- effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on
such Valuation Date, to the extent practicable.
All assets and liabilities of the Company shall be valued at fair value in compliance with the accounting principles
applicable to the Company. The General Partner, in its discretion and in good faith, may permit some other method of
valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.
In determining the Net Asset Value of the Company, generally accepted valuation principles and in particular the
following principles shall be used as guidelines:
1. the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued and not yet received, is deemed to be the full amount thereof, unless in any case
the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount
as may be considered appropriate in such case to reflect the value thereof;
2. securities listed and traded on one or several regulated markets shall be valued at their last known available price on
such markets;
3. securities that are not listed shall be determined by the General Partner in a manner so as to reflect their fair market
value on the basis of the reasonably foreseeable sales price thereof determined prudently and in good faith;
33766
L
U X E M B O U R G
4. units or shares of other funds or undertakings for collective investments or assimilated entities shall be valued at their
last fair market value or where applicable their last available stock market value or any other price as the General Partner
may determine on a fair value basis;
5. any property right shall be valued by one or more independent real estate expert(s), in respect of the relevant location
of the property appointed by the General Partner. Recognised property valuation standards such as RICS/TEGOVA will
be followed. Such valuation shall be carried out at least once a year and may be used during the following twelve months
for the purpose of calculating the Net Asset Value unless where the deviation of such method of valuation is in the interest
of the Company and/or where significant material changes require a new valuation; and
6. all other assets of any nature shall be valued at their fair market value as determined in good faith under the direction
of the General Partner referring to applicable market standards as applied from time to time such as INREV guidelines or
EVCA guidelines or any other valuation standard as may best reflect a fair valuation.
The only currency used in the calculation of the Net Asset Value of each compartment and in the consolidated accounts
of the Fund shall be the Euro.
The General Partner may, at its sole discretion, permit any other valuation method on a consistent basis to be used if
such method better reflects the fair value of any asset of the Company.
Art. 13. Temporary suspension of the determination of the Net Asset Value and redemption of shares. The General
Partner may suspend the determination of the Net Asset Value in case of i) a breakdown in the normal means of information,
communication or calculation normally used for the valuation of any asset of the Company, ii) when the calculation of the
Net Asset Value of the underlying assets is suspended, iii) when as a result of political, economic, military or monetary
emergency, the disposal or accurate valuation of one or several assets of the Company is impracticable and iv) as further
determined in the PPM.
Any such suspension shall be notified to the Shareholders.
Where the circumstances cause a suspension of the calculation of the Net Asset Value, the General Partner may refuse
redemption proceeds. In addition, the General Partner may refuse redemption proceeds if as a result of redemption, the Net
Asset Value of the Company would fall below the minimum capital required by the SIF Law or if the General Partner
reasonably deems it necessary to do so in order to comply with any laws and regulations applicable to the Company or any
of the Company’s affiliates and service providers.
Title III. Management
Art. 14. General Partner. The Company shall be managed by San Maurizio Management, a Luxembourg private limited
liability company, having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197055, who shall be the General
Partner and thus personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of the
assets of the Company.
The General Partner shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of
the Company except where the 1915 Law expressly assigns a power to the general meeting of Shareholders. No Limited
Shareholder shall intervene or participate in the management of the Company.
In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from acting as
general partner of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided that an admi-
nistrator, who does not need to be a Shareholder, is appointed to effect urgent or mere administrative acts, until a general
meeting of Shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At
such general meeting, the Shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amend-
ing the Articles, a successor manager.
Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the General Partner.
Art. 15. Corporate signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly engaged by the signature of the General
Partner, as determined in the General Partner’s own bylaws, or by the individual or joint signatures of any other persons
to whom authority has been delegated by the General Partner.
Art. 16. Delegation of powers. The General Partner may to the extent permitted by Law delegate its powers in the conduct
of the daily management of the Company.
The General Partner may further appoint any officers, including one or more general managers that it deems necessary
for the operation and management of the Company. Such appointments may be revoked at any time by the General Partner.
The appointed officers need not to be Shareholders of the Company.
The General Partner may furthermore appoint other agents, or confer other special powers of attorney by notarial deed
or under private seal to agents, who need not to be members of the General Partner and who will have the powers as
determined by the General Partner.
Art. 17. Investment policies and restrictions. The General Partner has the power to determine the investment policies
and strategies of each compartment of the Company and the course of conduct of the management and business affairs of
the Company, in compliance with applicable laws and regulations.
33767
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or entity
shall be affected or invalidated by the sole fact that the General Partner or any one or more of the directors or officers of
the General Partner is interested in, or is a director, associate officer or employee of such other company or entity.
Any director or any officer of the General Partner who serves as director, associate, officer or employee of any such
company or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such
affiliation with such other company or entity, be ipso jure prevented from voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.
Where a director of the General Partner may have an opposite interest from the interests of the Company in a specific
transaction, such director shall however immediately reveal the conflict of interest to the board of directors of the General
Partner who shall ultimately decide in compliance with the Company’s conflict of interests policy whether the concerned
director has to abstain from voting in respect of any such transaction.
The General Partner shall act exclusively in the best interests of the Company and its Shareholders.
Any transactions in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the Company shall be
specially reported to the next following general meeting, before any other resolution is put to vote.
Art. 19. Indemnification. The Company may indemnify to the fullest extent permitted by Law any director, officer,
executive or authorised representative of the General Partner, or where the case may be its heirs, executors and adminis-
trators, against claims, damages, liabilities, expenses (including reasonable legal and other professional fees and disbur-
sements), fines resulting from judgments, settlements or similar, incurred by reason of its activities on behalf of the
Company, except in relation to matters judicially determined (or advised by a private counsel of the Company where a
private settlement is reached) to be primarily attributable to the bad faith, gross negligence, willful misconduct or fraud of
the concerned director, officer, executive or authorised representative of the General Partner.
The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which any of the aforementioned parties may
be entitled.
Title IV. General meetings of shareholders
Art. 20. Powers and voting rights. The general meeting of the Shareholders represents the entire body of the Shareholders
of the Company. Unless otherwise provided herein or by Law any resolution of the general meeting is passed by simple
majority vote of the present or represented Shareholders regardless of the proportion of the share capital represented. Any
resolution shall however in addition require the consent of the General Partner.
Each share entitles its holder to one (1) vote at any general meeting of the Shareholders.
A fractional share shall not confer any voting right, unless together with other fractional shares that the respective
Shareholder holds, their number is such that they represent one or more whole shares.
Art. 21. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held every year at the Company’s registered
office or at any other address in Luxembourg indicated in the announcements or the convening notice. The annual general
meeting shall be held on the 3
rd
Thursday of the month of May at 11 a.m unless this day is not a business day, in which
case the meeting shall be held on the following business day.
Art. 22. Other General Meetings. The General Partner may convene other general meetings or meetings per compartment
at such place and time as may be specified in the announcements or convening notice.
Art. 23. Notice. Convening notices for every general meeting shall contain the agenda and other relevant information
and take the form of announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) calendar days, and eight (8)
days before the meeting, in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper. Al-
ternatively, provided all the shares are in registered form, a general meeting may be convened by the General Partner
pursuant to a notice setting out the agenda and sent to the shareholders by registered letter at least eight (8) calendar days
prior to the meeting. Such notice shall contain all the relevant information such as the conditions of admission to the meeting,
the agenda and refer to the quorums and majorities required at such meeting.
Provided all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of
the agenda, the general meeting may take place without convening notice.
The General Partner may determine any additional conditions which must be fulfilled by the Shareholders in order to
participate in such general meeting provided such requirements are set forth in the convening notice.
A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing in writing or by telefax or any other means
of transmissions ensuring the authenticity of the document and the identification of its authors as his/her proxy another
person who need to be a Shareholder.
Art. 24. Proceedings. The general meeting shall be presided by the General Partner or by a person designed by the
General Partner.
The chairman of the general meeting of the Shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of the Shareholders may elect one scrutineer.
The aforementioned shall form together the board of the general meeting of the Shareholders.
33768
L
U X E M B O U R G
Art. 25. Nationality, Amendment of the Articles and increase of commitments. The general meeting of Shareholders
may, with the prior consent of the CSSF, amend from time to time the Articles with a majority of at least two-thirds of the
votes cast and a quorum representing at least half of the share capital and with the announcement or the convening notice
indicating the agenda with the proposed amendments to the Articles as well as the specific text of any proposed amendments
to the object or form of the Company.
A second general meeting may be convened in the event the foresaid quorum is not reached. Such convening notice
shall be published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the Mémorial C,
Receuil des Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspapers. Such notice shall further reproduce the agenda
of the General Meeting and indicate the date and results of the previous general meeting. The second general meeting shall
deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented and adopt resolutions with a majority of at least
two-thirds of the votes cast.
The General Partner holds in any case a veto right in respect of the resolutions submitted to vote.
The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with
the unanimous consent of the Shareholders.
Title V. Accounts - Distributions
Art. 26. Financial year and accounts. The accounting year of the Company is annual. The first accounting year shall end
on 31
st
December 2016.
Each following accounting year shall commence on the 1
st
of January and shall end on the 31
st
of December of the
same year.
Each year, the General Partner prepares the annual report in compliance with the SIF Law. Such annual report must
include a balance sheet or a statement of assets and liabilities, a profit and loss account, a report on the activities of the past
financial year as well as any other significant information. The annual accounts are prepared in compliance with Luxem-
bourg generally accepted accounting principles (LUXGAAP)
The annual general meeting of Shareholders shall consider and, if thought fit, adopt the annual accounts and vote on the
discharge of the General Partner and the allocation of the results of the Company in accordance with these Articles.
Art. 27. Auditor. In accordance with the SIF Law, the accounting information contained in the annual report of the
Company shall be audited by a Luxembourg based independent auditor “réviseur d’entreprise agréé”.
Art. 28. Distributions. Subject to the requirement of the 1915 Law, distributions, if any, shall be payable by the Company
on its shares upon decision by the General Partner in accordance with the Company’s PPM.
No distribution shall be made if after such distribution the share capital of the Company would fall below the minimum
capital required by the SIF Law.
Title VI. Dissolution - Liquidation - Merger of compartments
Art. 29. Dissolution and liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by
one or several duly appointed liquidators by the general meeting of Shareholders and approved by CSSF. The liquidation
proceedings shall be carried out pursuant to the 1915 Law and where applicable the specific provisions of the SIF Law.
The Company may at any time be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders in
accordance with the quorum and majority requirements as determined for the amendment of the Articles.
Whenever the share capital of the Company falls below two-thirds (2/3) of the legally required minimum, the question
of the dissolution of the Company must be submitted to a general meeting of the Shareholders for which no quorum shall
be prescribed and dissolution may be resolved by simple majority of the Shareholders represented at the meeting.
Whenever the capital of the Company falls below one fourth (1/4) of the minimum capital, the question of the dissolution
of the Fund must be submitted to a general meeting of the Shareholders for which no quorum shall be prescribed and
dissolution may be resolved by Shareholders holding one-fourth of the shares represented at the meeting.
Such general meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from the ascertainment that
the net assets of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum, as the case may be.
The net proceeds of liquidation in respect to each compartment, or as the case may be, of each type of share within each
compartment, shall be distributed by the liquidator(s) to the holders of shares of the relevant class and type in proportion
to their holding of such shares in such compartment and type and whether such proceeds shall be distributed in kind or
cash.
Additionally created compartments may be created for a specific term. Where the case may be, the relevant compartment
will terminate on the arrival of the term without resulting in the liquidation of the Company except whenever the Company
is composed of only one compartment.
The General Partner may further decide to terminate one compartment or merge the assets and liabilities of one com-
partment to those of another compartment or a newly created compartment. Whenever the General Partner may decide to
proceed to such transaction, notice will be provided to the Shareholders of the concerned compartments at least one (1)
33769
L
U X E M B O U R G
month before the transaction in order to allow them to redeem their shares prior to the execution of the intended amalga-
mation or termination.
The Company shall serve notice in writing to the Shareholders of the relevant compartment, which will indicate the
reasons and the procedure for the redemption operations.
The Company shall base these redemptions on the Net Asset Value taking into account liquidation expenses.
The amounts that have not been claimed by the Shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of a class
or type shall be deposited with the public trust office “Caisse de Consignation” to be held for the benefit of the persons
entitled thereto.
Title VII. General
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law,
the 1915 Law and the SIF Law as amended from time to time.
<i>Transitory provisionsi>
1. The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and will end on 31
st
December 2016.
2. The first annual general meeting of Shareholders will be held in 2017.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers prenamed and represented as stated here above, declare to subscribe for the following shares as follows:
1. San Maurizio Management, prenamed and represented as stated here-above . . . . .
10 Management Shares
2. FONSICAR S.A. SICAR, prenamed and represented as stated here-above . . . . . . 300 Limited Shares, consisting
in 150 class A shares and
150 class B shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310 Shares
The 10 Management Shares and the 300 Limited Shares have been fully paid in cash, so that the sum of thirty-one
thousand Euro (EUR 31,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proven to the notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 3,000 (three thousand euros).
<i>General meeting of the shareholdersi>
The above-named parties, representing the entire subscribed capital of the Company and considering themselves as
having been duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the meeting has passed the following resolution:
<i>First resolutioni>
The registered office of the Company is set at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
A3T S.A., having its registered office at 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, R.C.S. Lu-
xembourg B158687, is appointed as independent auditor of the Company. The term of office of the independent auditor
shall be one year and end at the first annual general meeting of Shareholders to be held in 2017.
<i>Declarationi>
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 and article 103 of the 1915 Law have
been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillments.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above named person, this
deed is worded in English only with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of the Luxembourg law
dated 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended.
Signé: M. BERNA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6655. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
33770
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016074951/475.
(160039305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Paloma Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 167.425.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December,
Before Us Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of Paloma Investment S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 167.425 (the “Company”), incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, on 7 March 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1073 of 26
April 2012. The articles of association of the Company have not been amended since that time.
The meeting is presided by Mrs. Sofia Da Chao, notary clerk, residing professionally in Pétange. The chairman appoints
as secretary Mrs. Marisa Gomes, employee, residing professionally in Pétange. The meeting elects as scrutineer Mrs. Marisa
Gomes, employee, residing professionally in Pétange.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman states that the shareholder represented at the
Meeting and the number and classes of shares owned by it have been mentioned on an attendance list (the “Attendance
List”) signed by the proxy-holder of the shareholder represented; this Attendance List, drawn up by the members of the
bureau, after having been signed ne varietur by the members of the bureau, will remain attached to the present deed. The
proxy of the represented shareholder will also remain attached to this deed, after having been initialled ne varietur by the
proxy-holder of the represented shareholder.
The chairman further declares and requests the undersigned notary to state:
I. that the shareholder of the Company waived the prior convening notice to the Meeting and declared having been fully
informed of the agenda of the Meeting sufficiently in advance;
II. that it appears from the Attendance List that the shares representing the entire share capital of the Company are duly
represented at this Meeting, by virtue of a proxy, which is consequently regularly constituted and may validly deliberate
and resolve on its agenda known by the shareholder;
III. that the agenda of the present Meeting is as follows:
1. Declaration regarding (i) the publication of the Merger Proposal (as defined below), (ii) the documents made available
at the registered office of the Company pursuant to Article 267 (1) a), b) and c) of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the “Law”), (iii) the waiver of the requirement for the sole manager of the Company and the sole
manager of the Absorbing Company (as defined below) to establish a report on the merger, in accordance with Article 265
(3) of the Law, and (iv) the waiver of the requirement for an examination and establishment of a report on the Merger
Proposal by independent experts, in accordance with Article 266 (5) of the Law;
2. Approval of the merger proposal between the Absorbing Company and the Company dated 18 November 2015 (the
“Merger Proposal”);
3. Approval of, and decision to proceed to, the merger of the Company by the absorption of the Company by Mapple
Europe Holdings S.à r.l. (the “Absorbing Company”) whereby the Company shall transfer, following its dissolution without
liquidation, all of its assets and liabilities to the Absorbing Company (the “Merger”), in accordance with the provisions of
Article 259 (1) of the Law and the terms of the Merger Proposal and acknowledgement of certain changes regarding the
restructuration of initially planned to occur further to the Merger;
4. Acknowledgement of the effectiveness of the Merger in conformity with Article 272 of the Law, without prejudice
to the provisions of Article 273 of the Law in relation to the effects of the Merger vis-à-vis third parties;
5. Acknowledgement of the creditors' rights with respect to the Merger;
6. Decision to grant discharge to the sole manager of the Company for the performance of his duties during his mandate;
and
7. Miscellaneous.
After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting DECLARES that (i) the Merger Proposal has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on 21 November 2015, number 3166, page 151935, (ii) the documents mentioned at Article 267 (1) a), b) and
33771
L
U X E M B O U R G
c) have been available at the registered office of the Company at least one month before the date of the present Meeting,
(iii) the sole shareholder has waived the requirement for the sole manager to establish a report on the Merger, in accordance
with Article 265 (3) of the Law and (iv) the sole shareholder of the Company has waived the the requirement for an
examination and establishment of a report on the Merger Proposal by independent experts, in accordance with Article 266
(5) of the Law.
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVES to approve the Merger Proposal.
<i>Third resolutioni>
The Meeting RESOLVES to approve and proceed to the Merger with dissolution but without liquidation of the Company
by the transfer of all its assets and liabilities to the Absorbing Company, in accordance with the provisions of Article 259
(1) of the Law and the terms of the Merger Proposal.
The Meeting further ACKNOWLEDGES that the contribution by the Absorbing Company of all the shares of SCI du
8 Boulevard Durandy (the “SCI”) to Société Immobilière du 20 rue Monsieur SAS, referred to in the preamble of the Merger
Proposal and initially planned to take place subsequently to the Merger, will not be carried out due to a lack of required
consent from Barclays being the lender of the SCI.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting ACKNOWLEDGES the effectiveness of the Merger in conformity with Article 272 of the Law, without
prejudice to the provisions of Article 273 of the Law according to which the Merger shall be effective towards third parties
as from the date of publication of this Meeting and the general meeting of the shareholders of the Absorbing Company
approving the Merger, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting ACKNOWLEDGES that the creditors of the Company or the Absorbing Company may demand within
two months from the publication of the minutes of the present meeting in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations that their claims be secured, if they substantiate that the satisfaction thereof is threatened by the Merger, in
conformity with article 268 of the Law. The president of the district court in which the company owing the debt has its
registered office shall be competent to decide with respect to the demand of the creditor(s).
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting RESOLVES to grant discharge to the sole manager of the Company for the performance of its duties during
its mandate.
<i>Statement of the notaryi>
The undersigned notary attests, in conformity with the provisions of Article 271 (2) of the Law, the existence and the
validity of the legal acts and formalities performed in connection with the Merger and that all formalities with respect to
the Merger Proposal and the Merger have duly been fulfilled.
<i>Declarationi>
Whereof, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the members of the bureau of the Meeting,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the members of the bureau of the Meeting, who are known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, they signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trente décembre.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand Duché de Luxembourg,
a été tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée») de Paloma Investment S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 167.425
(la «Société»), constituée par acte de Me Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, en date du 7 mars 2012, publiée
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1073 du 26 avril 2012. Les statuts de la Société n'ont pas
été modifiés depuis cette date.
L'Assemblée est présidée par Mme. Sofia Da Chao, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange. Le
président désigne comme secrétaire Mme. Marisa Gomes, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange.
L'assemblée désigne comme scrutateur Mme. Marisa Gomes, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange.
33772
L
U X E M B O U R G
Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le président déclare que l'associé représenté à l'Assemblée et le nombre de
parts sociales détenues par lui a été mentionné sur une liste de présence (la «Liste de Présence») signée par le mandataire
de l'associé représenté; cette Liste de Présence, établie par les membres du bureau, après avoir été signée ne varietur, par
les membres du bureau, restera annexée au présent acte. La procuration de l'associé représenté restera également annexée
au présent acte, après avoir été paraphée par le mandataire de l'associé représenté.
Le président expose ensuite et prie le soussigné notaire d'acter:
I. que l'associé de la Société a renoncé à son droit de convocation préalable à l'Assemblée et a déclaré avoir été pleinement
informé de l'agenda de l'Assemblée suffisamment en avance;
II. qu'il ressort de la Liste de Présence que les parts sociales représentant le capital social complet de la Société sont
pleinement représentées à cette Assemblée, en vertu d'une procuration, qui est par conséquent régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et décider sur l'agenda connu par l'associé;
III. que l'agenda de la présente Assemblée est le suivant:
1. Déclarations concernant (i) la publication du Projet de Fusion (tel que défini ci-dessous), (ii) les documents rendus
disponibles au siège social de la Société conformément à l'Article 267 (1) a), b) et c) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), (iii) la renonciation à l'exigence pour le gérant unique de la Société
et le gérant unique de la Société Absorbante (telle que définie ci-dessous) d'établir un rapport sur la fusion, conformément
à l'Article 265 (3) de la Loi, et (iv) la renonciation à l'exigence d'un rapport sur le Projet de Fusion par des experts indé-
pendants, conformément à l'article 266 (5) de la Loi;
2. Approbation du projet de fusion entre la Société Absorbante et la Société daté du 18 novembre 2015 (le «Projet de
Fusion»);
3. Approbation de, et décision de procéder à, la fusion de la Société par l'absorption de la Société par Mapple Europe
Holdings S.à r.l. (la «Société Absorbante») par laquelle la Société va transférer, suivant sa dissolution sans liquidation,
l'intégralité de son actif et de son passif à la Société Absorbante (la «Fusion»), conformément à l'article 259 (1) de la Loi
et les termes du Projet de Fusion et prise d'acte de certains changements concernant la restructuration telle qu'initialement
prévue devant intervenir après la Fusion;
4. Prise d'acte de l'effectivité de la Fusion conformément à l'Article 272 de la Loi, sans préjudice des dispositions de
l'Article 273 de la Loi en relation aux effets de la Fusion envers les tiers;
5. Prise de connaissance des droits des créanciers par rapport à la Fusion;
6. Décision de donner décharge au gérant unique de la Société pour l'accomplissement de ses devoirs durant son mandat;
et
7. Divers.
Après délibération, l'Assemblée prend unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DECLARE que (i) le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
le 21 novembre 2015, numéro 3166, page 151935, (ii) les documents mentionnés à l'Article 267 (1) a), b) et c) ont été rendu
disponibles au siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente Assemblée, (iii) l'associé unique a
renoncé à l'exigence pour le gérant unique d'établir un rapport sur la Fusion, conformément à l'Article 265 (3) de la Loi et
(iv) l'associé unique de la Société a renoncé à l'exigence de l'examen et l'établissement d'un rapport sur le Projet de Fusion
par des experts indépendants conformément à l'Article 266 (5) de la Loi.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'approuver le Projet de Fusion.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'approuver et de procéder à la Fusion par la dissolution sans liquidation de la Société par le
transfert de l'intégralité de son actif et de son passif à la Société Absorbante, conformément à l'Article 259 (1) de la Loi et
aux termes du Projet de Fusion.
L'Assemblée PREND ACTE que la contribution par la Société Absorbante de toutes les parts sociales de la SCI du 8
Boulevard Durandy (la «SCI») à la Société Immobilière du 20 rue Monsieur SAS, telle que mentionnée par le préambule
du Projet de Fusion et devant initialement intervenir subséquemment à la Fusion, ne sera pas effectuée à cause de l'absence
du consentement requis de Barclays étant le prêteur de la SCI.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée PREND ACTE de l'effectivité de la Fusion conformément à l'Article 272 de la Loi, sans préjudice des
provisions de l'Article 273 de la Loi selon lequel la Fusion sera effective envers les tiers à la date de publication de la
présente Assemble et de l'assemblée générale des associés de la Société Absorbante approuvant la Fusion, au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
33773
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée PREND ACTE que les créanciers de la Société ou de la Société Absorbante peuvent demander dans les
deux mois à compter de la publication du procès-verbal de la présente assemblée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations que leurs créances soient garanties s'ils justifient que l'exercice des droits qui en résulte est menacée par la
Fusion, conformément à l'Article 268 de la Loi. Le président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la société
débitrice a son siège est compétent pour décider de la demande du/des créancier(s).
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de donner décharge au gérant unique de la Société pour l'accomplissement de ses devoirs durant
son mandat.
<i>Déclaration notarialei>
Le soussigné notaire atteste, en conformité avec les dispositions de l'Article 271 (2) de la Loi, l'existence et la validité
des actes juridiques et formalités réalisés en relation avec la Fusion et que toutes les formalités concernant le Projet de
Fusion et la Fusion ont été dûment satisfaites.
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les membres du
bureau l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes
personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Le document ayant été lu aux membres du bureau, connus du notaire par leur nom, prénom, statut civil et résidence, ils
ont signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Gomes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/98. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016074895/188.
(160040009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Trèves Offices SA, Société Anonyme.
Capital social: EUR 3.078.000,00.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 7, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 140.084.
Am Haferstück S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 49.673.
PROJET COMMUN DE FUSION
ENTRE:
TREVES OFFICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue du Fort Eli-
sabeth, L-1463 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 140.084 (la «Société Absorbante»),
Représentée par Messieurs Marc CROHAIN et Gabriel ÜZGEN en leur qualité d'administrateur, dûment habilités aux
fins des présentes suivant résolution du conseil d'administration de la Société Absorbante en date du 03/03/2016,
ET
AM HAFERSTÜCK S.A., une société anonyme ayant son siège social au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B
sous le numéro 49.673 (la «Société Absorbée»)
Représentée par Messieurs Marc GIORGETTI et Paul FEIDER en leur qualité d'administrateur, dûment habilités aux
fins des présentes suivant résolution du conseil d'administration de la Société Absorbée en date du 03/03/2016.
La Société Absorbante ensemble avec la Société Absorbée étant désignées ci-après comme les «Sociétés Fusionnantes».
Conformément aux Articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée, (la «Loi»),
33774
L
U X E M B O U R G
(1) le conseil d'administration de la Société Absorbante; et
(2) le conseil d'administration de la Société Absorbée,
ont élaboré ensemble le projet commun de fusion par voie d'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante
(le «Projet de Fusion»), dans le but de préciser les modalités de ladite Fusion et ont déclaré ce qui suit:
- La fusion susmentionnée est motivée par la réalisation d'un projet immobilier commun portant sur la construction d'un
bâtiment à usage de bureaux sur les terrains détenus par chacune des Sociétés Fusionnantes;
- Conformément à l'Article 265 (3) de la Loi, l'actionnaire unique de chacune des Sociétés Fusionnantes a renoncé à son
droit à l'établissement d'un rapport écrit des organes de direction des Sociétés Fusionnantes expliquant et justifiant d'un
point de vue juridique et économique le Projet de Fusion et en particulier le rapport d'échange des actions;
- Conformément à l'Article 266 (5) de la Loi, l'actionnaire unique de chacune des Sociétés Fusionnantes a renoncé à son
droit de faire examiner le Projet de Fusion et en particulier le rapport d'échange des actions par le biais d'un expert indé-
pendant;
- Cependant, conformément à l'article 266 (3) de la Loi, un rapport sera établi par un réviseur d'entreprises agréé, portant
sur la description des actifs et passifs transférés dans le cadre de la Fusion ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés;
- Le Projet de Fusion sera déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié un mois au moins
avant la date de la réunion de l'assemblée générale de l'actionnaire unique de la Société Absorbante et de la réunion de
l'assemblée générale de l'actionnaire unique de la Société Absorbée, appelées à se prononcer sur le Projet de Fusion, au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations conformément aux Articles 262 et 9 de la Loi;
- La fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la «Fusion») devra satisfaire aux dispositions
de la Loi;
- Conformément aux dispositions de l'article 268 de la Loi, les créanciers des Sociétés Fusionnantes dont la créance est
antérieure à la date de publication du constat de Fusion auront la faculté de demander à un juge la constitution d'une sûreté
dans les deux mois à compter de la date de publication de ce constat de Fusion si l'opération de Fusion réduit leur gage;
- La Fusion est soumise à la condition de l'approbation de ladite Fusion par l'assemblée générale de l'actionnaire unique
de la Société Absorbante et par l'assemblée générale de l'actionnaire unique de la Société Absorbée, devant se tenir devant
notaire;
- La Société Absorbée n'ayant pas d'employés, la Fusion restera sans conséquence sur l'emploi;
- Suite à la Fusion, la Société Absorbante conservera sa forme juridique, sa dénomination, son siège social et son numéro
d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Ainsi, de ce qui précède, il est convenu ce qui suit:
Art. 1
er
. Transmission de patrimoine à titre universel. Conformément aux Articles 257 et suivants de la Loi, et
notamment l'Article 274 de la Loi, à la Date Effective, tant entre les Sociétés Fusionnantes qu'à l'égard des tiers:
La Société Absorbée transmettra de manière universelle et sans limitation ni restriction tous les éléments d'actif et de
passif de son patrimoine à la Société Absorbante, et notamment parmi les éléments d'actifs transférés, l'élément immobilier
suivant:
Une parcelle inscrite au cadastre comme suit:
Commune de Niederanven, section B de Senningen -
Numéro 1190/4165, d'une contenance de 66 ares 43 centiares.
L'élément immobilier ci-avant désigné appartient à la Société Absorbée depuis la vente de la parcelle par Mme veuve
Camille Quaring suivant acte du 08/07/1999 par-devant le notaire Frank Baden. L'élément immobilier n'est grevé d'aucune
hypothèque.
Art. 2. Rapport d'échange - Modalités d'attribution des actions.
(i) Le rapport d'échange des actions de la Société Absorbée contre des actions de la Société Absorbante est établi à 1
(une) action de la Société Absorbée contre 307,8 (trois cent sept et huit dixièmes) actions de la Société Absorbante.
(ii) La Société Absorbante émettra 30.780 (trente mille sept cent quatre-vingt) nouvelles actions, d'une valeur nominale
de EUR 100,- (cent Euros) chacune à l'actionnaire unique de la Société Absorbée et les actions de la Société Absorbée
seront annulées à la Date Effective.
(iii) La Société Absorbante augmentera son capital, qui est actuellement de EUR 3.078.000 (trois millions soixante-dix-
huit mille Euros) représenté par 30.780 (trente mille sept cent quatre-vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 100,-
(cent Euros) chacune.
(iv) Il résulte du rapport d'échange ci-dessus arrêté que l'actionnaire unique de la Société Absorbée devrait recevoir, en
échange des 100 (cent) actions composant le capital social de la Société Absorbée, 30.780 (trente mille sept cent quatre-
vingt) actions de la Société Absorbante à créer par cette dernière à titre d'augmentation de capital.
(v) Il est décidé d'inscrire dans le bilan de la Société Absorbante une prime de fusion d'un montant correspondant à la
différence entre le montant de l'augmentation du capital social de la Société Absorbante et la valeur de l'actif net comptable
de la Société Absorbée tel qu'il résulte des comptes annuels arrêtés au 31/12/2015.
33775
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Droits éventuellement réservés à des catégories particulières d'actionnaire (Article 261 paragraphe 2 f) de la
Loi). En l'absence d'actionnaire ou porteurs de titres autres que des actions ayant des droits spéciaux, aucun droit ou autre
mesure ne sera assuré par la Société Absorbante.
Art. 4. Avantages particuliers attribués aux membres du conseil d'administration des Sociétés Fusionnantes (Article 261
paragraphe 2 g) de la Loi). Il n'y a pas de bénéfices ou avantages particuliers prévus en faveur des membres du conseil
d'administration des Sociétés Fusionnantes.
Art. 5. Effet de la Fusion et imputation des opérations dans le bilan de la société absorbante. L'actif et le passif transférés
à la valeur comptable à la Société Absorbante sont évalués suivant les comptes annuels de la Société Absorbée au 31
décembre 2015.
Tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront considérés d'un point de vue comptable et fiscal comme transférés
à la Société Absorbante avec effet au 1
er
janvier 2016 et tous les bénéfices faits et toutes les pertes encourues par la Société
Absorbée après cette date seront réputés du point de vue comptable et fiscal, comme faits et encourus au nom et pour
compte de la Société Absorbante.
Art. 6. Date Effective, Approbation de la Société Absorbante. La Fusion sera effective, d'un point de vue juridique, entre
les Sociétés Fusionnantes à la date de la dernière assemblée générale extraordinaire des Sociétés Fusionnantes devant se
tenir devant un notaire pour approuver la Fusion ainsi qu'il résulte de l'Article 272 de la Loi (la «Date Effective»). La Fusion
sera effective envers les tiers à la date de la dernière publication dans la gazette officielle luxembourgeoise, Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, du procès-verbal de l'assemblée générale de de la Société Absorbante et du procès
verbal de l'assemblée générale de de la Société Absorbée devant se tenir devant notaire luxembourgeois, approuvant la
Fusion, tel que mentionné à l'Article 273 de la Loi.
A compter de la Date Effective, la Société Absorbée cessera d'exister par l'effet de la Fusion.
Art. 7. Mise à disposition de la documentation relative à la Fusion aux sièges sociaux. Les documents visés à l'Article
267 paragraphes 1 a), b) de la Loi, en particulier:
a) le Projet de Fusion;
b) les comptes annuels, y inclus les rapports de gestion des Sociétés Fusionnantes relativement aux trois dernières années,
incluant les comptes annuels des Sociétés Fusionnantes au 31 décembre 2014; et
c) un état comptable de la Société Absorbée daté du 31 décembre 2015 et un état comptable de la Société Absorbante
daté du 31 décembre 2015;
sont disponibles pour inspection de tout actionnaire au siège social des Sociétés Fusionnantes à compter de la date des
présentes.
Copie intégrale ou partielle des susdits documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
Art. 6. Formalités - Impôts. En ce qui concerne les formalités, la Société Absorbante:
- Effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- Fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra
pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- Effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée devra transférer à la Société Absorbante les originaux
de tous documents relatifs à leur constitution, tous actes, avenants, contrats, accords et opérations de toutes sortes, ainsi
que les livres comptables et archives y relatives et les documents comptables, titres de propriété de tous biens, justificatifs
de toutes opérations conclues, sûretés et contrats, archives, reçus et tous autres documents relatifs aux actifs et droits
apportés.
Tous les frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante. La Société
Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des
exercices non encore imposés définitivement.
Art. 8. Divers. Le Projet de Fusion est régi et devra être interprété conformément à la Loi. Les juridictions de la ville de
Luxembourg devront avoir une compétence exclusive pour connaître de tout litige relatif au Projet de Fusion. Par suite,
toute procédure, procès ou action relatifs au Projet de Fusion devront être portés devant lesdites juridictions.
Le Projet de Fusion est établi en 2 (deux) exemplaires.
A Luxembourg, le 3 mars 2016.
TREVES OFFICES SA
Représentée par
Marc CROHAIN / Gabriel ÜZGEN
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>AM HAFERSTÜCK S.A.
Représentée par
33776
L
U X E M B O U R G
Marc GIORGETTI / Paul FEIDER
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016075047/141.
(160040188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
HC Property Heureka IV Delta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.218.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 120.513.
AUSZUG
Die Geschäftsführung nimmt zur Kenntnis, dass
1. die Adresse der Geschäftsführer sich wie folgt geändert hat:
Herr Peter Gillert: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg
Herr Andreas Oster: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg
Herr Ralf Schlautmann: Börsenplatz 1, D-70174 Stuttgart, Deutschland
2. Prega Investments B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts, mit dem Sitz in 200,
Prins Bernhardplin, NL-1097 JB, Amsterdam, die Niederlanden hat ihre 49.441 Anteile an der Gesellschaft an Spezial-
Sondervermögen GREHI vertreten durch seine Verwaltungsgesellschaft IntReal International Real Estate Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit dem Sitz in 61, Ferdinandstraße,
D-20095 Hamburg, Deutschland
Den 1. März 2016.
HC Property Heureka IV Delta S.à r.l.
Référence de publication: 2016075305/21.
(160040143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Mapple Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 133.642.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December,
Before Us Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
was held:
an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of Mapple Europe Holdings S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 133.642 (the “Company”), incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary
residing in Luxembourg, on 12 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2913 of 14 December 2007. The articles of association of the Company have not been amended since that time.
The meeting is presided by Mrs. Sofia Da Chao, notary clerk, residing professionally in Pétange. The chairman appoints
as secretary Mrs. Marisa Gomes, employee, residing professionally in Pétange. The meeting elects as scrutineer Mrs. Marisa
Gomes, employee, residing professionally in Pétange.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman states that the shareholder represented at the
Meeting and the number and classes of shares owned by it have been mentioned on an attendance list (the “Attendance
List”) signed by the proxy-holder of the shareholder represented; this Attendance List, drawn up by the members of the
bureau, after having been signed ne varietur by the members of the bureau, will remain attached to the present deed. The
proxy of the represented shareholder will also remain attached to this deed, after having been initialled ne varietur by the
proxy-holder of the represented shareholder.
The chairman further declares and requests the undersigned notary to state:
I. that the shareholder of the Company waived the prior convening notice to the Meeting and declared having been fully
informed of the agenda of the Meeting sufficiently in advance;
II. that it appears from the Attendance List that the shares representing the entire share capital of the Company are duly
represented at this Meeting, by virtue of a proxy, which is consequently regularly constituted and may validly deliberate
and resolve on its agenda known by the shareholder;
III. that the agenda of the present Meeting is as follows:
33777
L
U X E M B O U R G
1. Declaration regarding (i) the publication of the Merger Proposal (as defined below), (ii) the documents made available
at the registered office of the Company pursuant to Article 267 (1) a), b) and c) of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the “Law”), (iii) waiver of the requirement for the sole manager of the Company and the sole
manager of the Absorbed Company (as defined below) to establish a report on the merger, in accordance with Article 265
(3) of the Law, and (iv) waiver of the requirement for an examination and establishment of a report on the Merger Proposal
by independent experts, in accordance with Article 266 (5) of the Law;
2. Approval of the merger proposal between the Company and the Absorbed Company, dated 18 November 2015 (the
“Merger Proposal”);
3. Approval of, and decision to proceed to, the merger of the Company by the absorption of the Paloma Investment S.à
r.l. (the “Absorbed Company”) by the Company whereby the Absorbed Company shall transfer, following its dissolution
without liquidation, all of its assets and liabilities to the Company (the “Merger”), in accordance with the provisions of
Article 259 (1) of the Law and the terms of the Merger Proposal and acknowledgement of certain changes regarding the
restructuration of initially planned to occur further to the Merger;
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of seventy-seven thousand one hundred Euros (EUR
77,100) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to an amount of
eighty-nine thousand six hundred Euros (EUR 89,600) by the issue of seven hundred seventy-one (771) shares, having a
nominal value of one hundred Euros (EUR 100) each, having the same rights and obligations as those attached to the
existing shares (the “New Shares”) and allocation to the difference between the fair market value of the Absorbed Company
and the amount of the capital increase to the merger premium account of the Company;
5. Allocation of the New Shares to the sole shareholder of the Absorbed Company, in accordance with the Merger
Proposal;
6. Acknowledgement of the effectiveness of the Merger in conformity with Article 272 of the Law, without prejudice
to the provisions of Article 273 of the Law in relation to the effects of the Merger vis-à-vis third parties;
7. Acknowledgement of the creditors' rights with respect to the Merger; and
8. Miscellaneous.
After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting DECLARES that (i) the Merger Proposal has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on 21 November 2015, number 3166, page 151935, (ii) the documents mentioned at Article 267 (1) a), b) and
c) have been available at the registered office of the Company at least one month before the date of the present Meeting,
(iii) the sole shareholder has waived the requirement for the sole manager to establish a report on the Merger, in accordance
with Article 265 (3) of the Law and (iv) the sole shareholder of the Company has waived the requirement for an examination
and establishment of a report on the Merger Proposal by independent experts, in accordance with Article 266 (5) of the
Law.
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVES to approve the Merger Proposal.
<i>Third resolutioni>
The Meeting RESOLVES to approve and proceed to the Merger with dissolution but without liquidation of the Absorbed
Company by the transfer of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company, in accordance with the
provisions of Article 259 (1) of the Law and the terms of the Merger Proposal.
The Meeting further ACKNOWLEDGES that the contribution by the Company of all the shares of SCI du 8 Boulevard
Durandy (the “SCI”) to Société Immobilière du 20 rue Monsieur SAS, referred to in the preambule of the Merger Proposal
and initially planned to take place subsequently to the Merger, will not be carried out due to a lack of required consent from
Barclays being the lender of the SCI.
<i>Fourth resolutioni>
In accordance with the Merger Proposal, the Meeting RESOLVES to increase the share capital of the Company by an
amount of seventy-seven thousand one hundred Euros (EUR 77,100) so as to raise it from its current amount of twelve
thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to an amount of eighty-nine thousand six hundred Euros (EUR 89,600) by the
issue of the New Shares.
The Meeting further RESOLVES to allocate the difference between the fair market value of the Absorbed Company
and the amount of the capital increase corresponding to an amount of twenty-three million one hundred twenty-two thousand
three hundred eighty-eight Euros and twenty-two Cents (EUR 23,122,388.22) to the merger premium account of the Com-
pany.
33778
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting RESOLVES to allocate the New Shares to the sole shareholder of the Absorbed Company, in accordance
with the Merger Proposal.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting NOTES that the general meeting of shareholders of the Absorbed Company has approved the Merger
Proposal and the Merger earlier on the date hereof.
The Meeting ACKNOWLEDGES the effectiveness of the Merger in conformity with Article 272 of the Law, without
prejudice to the provisions of Article 273 of the Law according to which the Merger shall be effective towards third parties
as from the date of publication of this Meeting and the general meeting of the shareholders of the Absorbed Company
approving the Merger, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting ACKNOWLEDGES that the creditors of the Company or the Absorbed Company may demand within
two months from the publication of the minutes of the present meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations that their claims be secured, if they substantiate that the satisfaction thereof is threatened by the Merger, in
conformity with article 268 of the Law. The president of the district court in which the company owing the debt has its
registered office shall be competent to decide with respect to the demand of the creditor(s).
<i>Statement of the notaryi>
The undersigned notary attests, in conformity with the provisions of Article 271 (2) of the Law, the existence and the
validity of the legal acts and formalities performed in connection with the Merger and that all formalities with respect to
the Merger Proposal and the Merger have duly been fulfilled.
<i>Declarationi>
Whereof the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the members of the bureau of the Meeting,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the members of the bureau of the Meeting, who are known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, they signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trente décembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
a été tenue:
une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée») de Mapple Europe Holdings S.à r.l., une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lipp-
mann, L-5365 Munsbach et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 133.642 (la «Société»), constituée par acte de Me Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, en date du 12 novembre
2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 2913 du 14 décembre 2007. Les statuts de
la Société n'ont pas été modifiés depuis cette date.
L'Assemblée est présidée par Mme Sofia Da Chao, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange. Le
président désigne comme secrétaire Mme Marisa Gomes, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange.
L'assemblée désigne comme scrutateur Mme Marisa Gomes, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange.
Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le président déclare que l'associé représenté à l'Assemblée et le nombre de
parts sociales détenues par lui a été mentionné sur une liste de présence (la «Liste de Présence») signée par le mandataire
de l'associé représenté; cette Liste de Présence, établie par les membres du bureau, après avoir été signée ne varietur, par
les membres du bureau, restera annexée au présent acte. La procuration de l'associé représenté restera également annexée
au présent acte, après avoir été paraphée par le mandataire de l'associé représenté.
Le président expose ensuite et prie le soussigné notaire d'acter:
I. que l'associé de la Société a renoncé à son droit de convocation préalable à l'Assemblée et a déclaré avoir été pleinement
informé de l'agenda de l'Assemblée suffisamment en avance;
II. qu'il ressort de la Liste de Présence que les parts sociales représentant le capital social complet de la Société sont
pleinement représentées à cette Assemblée, en vertu d'une procuration, qui est par conséquent régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et décider sur l'agenda connu par l'associé;
III. que l'agenda de la présente Assemblée est le suivant:
1. Déclarations concernant (i) la publication du Projet de Fusion (tel que défini ci-dessous), (ii) les documents rendus
disponibles au siège social de la Société conformément à l'Article 267 (1) a), b) et c) de la loi du 10 août 1915 sur les
33779
L
U X E M B O U R G
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), (iii) la renonciation à l'exigence pour le gérant unique de la Société
et le gérant unique de la Société Absorbée (telle que définie ci-dessous) d'établir un rapport sur la fusion, conformément à
l'Article 265 (3) de la Loi, et (iv) la renonciation à l'exigence d'un rapport sur le Projet de Fusion par des experts indépen-
dants, conformément à l'article 266 (5) de la Loi;
2. Approbation du projet de fusion entre la Société Absorbée et la Société daté du 18 novembre 2015 (le «Projet de
Fusion»);
3. Approbation de, et décision de procéder à, la fusion de la Société par l'absorption de Paloma Investment S. à r.l. (la
«Société Absorbée») par la Société par laquelle la Société Absorbée va transférer, suivant sa dissolution sans liquidation,
l'intégralité de son actif et de son passif à la Société (la «Fusion»), conformément à l'article 259 (1) de la Loi et les termes
du Projet de Fusion et prise d'acte de certains changements concernant la restructuration telle qu'initialement prévue devant
intervenir après la Fusion;
4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-dix-sept mille cent euros (EUR 77.100) afin
de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) à un montant de quatre-vingt-neuf mille
six cent euros (EUR 89.600) par l'émission de sept cent soixante et onze (771) parts sociales, ayant une valeur nominale
de cent euros (EUR 100) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux parts sociales existantes (les
«Nouvelles Parts Sociales») et allocation de la différence entre la valeur de marché de la Société Absorbée et le montant
de l'augmentation de capital à un compte de prime de fusion de la Société;
5. Allocation des Nouvelles Parts Sociales à l'associé unique de la Société Absorbée, conformément au Projet de Fusion;
6. Prise d'acte de l'effectivité de la Fusion conformément à l'Article 272 de la Loi, sans préjudice des dispositions de
l'Article 273 de la Loi en relation aux effets de la Fusion envers les tiers;
7. Prise de connaissance des droits des créanciers par rapport à la Fusion; et
8. Divers.
Après délibération, l'Assemblée prend unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DECLARE que (i) le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
le 21 novembre 2015, numéro 3166, page 151935, (ii) les documents mentionnés à l'Article 267 (1) a), b) et c) ont été rendu
disponibles au siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente Assemblée, (iii) l'associé unique a
renoncé à l'exigence pour le gérant unique d'établir un rapport sur la Fusion, conformément à l'Article 265 (3) de la Loi et
(iv) l'associé unique de la Société a renoncé à l'exigence de l'examen et l'établissement d'un rapport sur le Projet de Fusion
par des experts indépendants conformément à l'Article 266 (5) de la Loi.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'approuver le Projet de Fusion.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'approuver et de procéder à la Fusion par la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée
par le transfert de l'intégralité de son actif et de son passif à la Société, conformément à l'Article 259 (1) de la Loi et aux
termes du Projet de Fusion.
L'Assemblée PREND ACTE que la contribution par la Société de toutes les parts sociales de la SCI du 8 Boulevard
Durandy (la «SCI») à la Société Immobilière du 20 rue Monsieur SAS, telle que mentionnée par le préambule du Projet
de Fusion et devant initialement intervenir subséquemment à la Fusion, ne sera pas effectuée à cause de l'absence du
consentement requis de Barclays étant le prêteur de la SCI.
<i>Quatrième résolutioni>
Conformément au Projet de Fusion, l'Assemblée DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de
soixante-dix-sept mille cent euros (EUR 77.100) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros
(EUR 12.500) à un montant de quatre-vingt-neuf mille six cent euros (EUR 89.600) par l'émission des Nouvelles Parts
Sociales.
L'Assemblée DECIDE ensuite d'allouer la différence entre la valeur de marché de la Société Absorbée et le montant de
l'augmentation de capital correspondant à un montant de vingt-trois millions cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-
huit euros et vingt-deux centimes (EUR 23.122.388,22) au compte de prime de fusion de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Parts Sociales à l'associé unique de la Société Absorbée, conformément
au Projet de Fusion.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée PREND NOTE que l'assemblée générale des associés de la Société Absorbée a approuvé le Projet de
Fusion et la Fusion un peu plus tôt ce-jour.
33780
L
U X E M B O U R G
L'Assemblée PREND ACTE de l'effectivité de la Fusion conformément à l'Article 272 de la Loi, sans préjudice des
provisions de l'Article 273 de la Loi selon lequel la Fusion sera effective envers les tiers à la date de publication de la
présente Assemble et de l'assemblée générale des associés de la Société Absorbante approuvant la Fusion, au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée PREND ACTE que les créanciers de la Société ou de la Société Absorbée peuvent demander dans les deux
mois à compter de la publication du procès-verbal de la présente assemblée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations que leurs créances soient garanties s'ils justifient que l'exercice des droits qui en résulte est menacée par la Fusion,
conformément à l'Article 268 de la Loi. Le président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la société débitrice
a son siège est compétent pour décider de la demande du/des créancier(s).
<i>Déclaration notarialei>
Le soussigné notaire atteste, en conformité avec les dispositions de l'Article 271 (2) de la Loi, l'existence et la validité
des actes juridiques et formalités réalisés en relation avec la Fusion et que toutes les formalités concernant le Projet de
Fusion et la Fusion ont été dûment satisfaites.
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé à Pétange, en date des présentes.
Le notaire instrumentant, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les membres du
bureau l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes
personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Le document ayant été lu aux membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom, statut civil et résidence,
ils ont signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Gomes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/97. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016075407/220.
(160040011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Mapple Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 133.642.
L'an deux mille seize, le treize janvier.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg soussigné.
A comparu:
Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange,
représentant la société Mapple Europe Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et enregistrée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 133.642 (la «Société»), constituée par acte de
Me Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, en date du 12 novembre 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et des Associations numéro 2913 du 14 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes
d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 décembre 2015 (numéro 2052/15 de son répertoire), pas encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (l'«Acte»),
agissant en vertu d'une procuration annexée au prédit Acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 décembre
2015, et priant le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Que suite à l'augmentation du capital documentée dans l'Acte, le premier paragraphe de l'article cinq (5) des statuts de
la Société est modifié comme suit dans la version anglaise et dans la version française:
Version anglaise:
“The share capital of the Company is set at eighty-nine thousand six hundred Euros (EUR 89,600.-) divided into eight
hundred ninety-six (896) shares, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid
up.”
33781
L
U X E M B O U R G
Version française:
«Le capital social émis de la Société est fixé à quatre-vingt-neuf mille six cent euros (EUR 89.600,-) divisé en huit cent
quatre-vingt-seize (896) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, chaque part sociale
étant entièrement libérée.»
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite en interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1340. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016075408/37.
(160040011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
UFP Timing Global Select, Fonds Commun de Placement.
Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen
sowie aufsichtsbehördlichen Bestimmungen beschlossen, den Fonds UFP Timing Global Select zum 01. September 2015
(00:00 Uhr) in den von der MK LUXINVEST S.A. mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, verwalteten Teilfonds
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select des Umbrella-Fonds International Asset Management
Fund zu verschmelzen.
Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. stellt fest, dass die Durchführung dieser Verschmelzung zum
01. September 2015 (00:00 Uhr) abgeschlossen ist und der oben genannte Fonds aufgrund der Verschmelzung unterge-
gangen ist.
Luxemburg, den 09. März 2016
Alceda Fund Management S.A.
Référence de publication: 2016075635/8040/14.
Kleopatra Holdings GP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.839.
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 décembre 2015, les décisions suivantes ont été prises:
Démission de l'administrateur suivant à compter du 4 décembre 2015:
- Monsieur Victor Scott Consoli en qualité d'administrateur de classe A de la Société.
Cooptation de l'administrateur suivant à compter du 4 décembre 2015:
- Monsieur William Kourakos, né le 4 mars 1955 à Maine, Etats-Unis, avec adresse professionnelle à Perella Weinberg
Partners, 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, en qualité d'administrateur de classe A de la Société.
Nomination des administrateurs suivants à compter du 18 décembre 2015 et jusqu'à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires:
- Monsieur Sébastien Rimlinger, né le 23 septembre 1975 à Sarreguemines, France, avec adresse professionnelle au
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité d'administrateur de classe B de la Société.
- Monsieur William Kourakos, né le 4 mars 1955 à Maine, Etats-Unis, avec adresse professionnelle à Perella Weinberg
Partners, 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, en qualité d'administrateur de classe A de la Société.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil d'administration de la Société est comme suit:
- Monsieur William Kourakos, Administrateur A
- Monsieur Patrick L.C. van Denzen, Administrateur A
- Monsieur Alexis Pourchet, Administrateur A
- Monsieur Florian Kawohl, Administrateur A
- Monsieur Bruno Deschamps, Administrateur A
- Monsieur Jason Clarke, Administrateur A
- Madame Gwenaëlle Cousin, Administrateur B
- Monsieur Fabrice Rota, Administrateur B
- Monsieur Julien Goffin, Administrateur B
- Monsieur Christoph Tschepe, Admnistrateur B
- Monsieur Sébastien Rimlinger, Administrateur B
33782
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kleopatra Holdings GP S.A.
Fabrice Rota
<i>Administrateur Bi>
Référence de publication: 2015211517/35.
(150237366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.
SOF-10 Beagle JVCo Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 13.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 191.603.
Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, les associés ont décidé
- d'acter et d'accepter la démission de Thierry Drinka de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015
- de nommer Nicolas Piotto avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité
de gérant pour une durée indéterminée à compter du 24 décembre 2015
- de modifier l'adresse professionnelle de Julien Petitfrère, Gérant, du 3 rue W.A. Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- de noter la décision des gérants de la Société de transférer le siège social de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015
- de noter le changement d'adresse d'un des associés de la Société, SOF-10 Beagle Holdings Lux S.à r.l., du 5 rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2016002410/20.
(160000074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Sof-10 Cod Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 150.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 191.732.
Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé
- d'acter et d'accepter la démission de Jerome Silvey de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015
- de modifier l'adresse professionnelle de Thierry Drinka, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- de modifier l'adresse professionnelle de Julien Petitfrère, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- de noter la décision des gérants de la Société de transférer le siège social de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015
- de noter le changement d'adresse de l'associé de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2-4 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2016002411/20.
(160000060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Claircy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 172.551.
<i>Extract of the resolutions taken by the sole shareholder on december 14 i>
<i>thi>
<i> 2015i>
1. The resignation of Mr Etienne JOANNES, born on 5 March 1976 in Saint-Mard (Belgium), residing professionally
at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as Manager of the Company with effect as of the date of the present resolutions.
33783
L
U X E M B O U R G
2. The nomination of Mr. Maxime TOQUE, born on 6 February 1987 in Cholet (France), residing professionally at
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as Manager of the Company with effect as of the date of the present resolutions
and for an unlimited period of time
Certified true copy
Suit la traduction en français de ce qui précède:
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 14 décembre 2015i>
1. Monsieur Maxime TOQUE, employé privé, né le 6 février 1987 à Cholet (France) demeurant professionnellement
au 412F, route d'Esch, L 2086 Luxembourg, est nommé en tant que nouveau Gérant de la société pour une période illimitée
2. La démission de Monsieur Etienne JOANNES né le 5 mars 1976 à Saint-Mard (Belgique) demeurant professionnel-
lement au 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de son mandat de gérant est actée avec effet immédiat.
Fait à Luxembourg, le 14
th
December 2015.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2016002767/23.
(160001174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Compas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 114.428.
Il est notifié que la Société a pris acte en date du 14 décembre 2015 que:
- Monsieur Alexander K. van Beek, né le 20 juin 1971 à 's-Gravenhage (Pays-Bas), résidant au 8, rue D'Aviau, 33000
Bordeaux (France) a été nommé en tant que administrateur A, de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et jusqu'au 30
juin 2017.
Résultant des décisions susmentionnées, le Conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- M. Robert van 't HOEFT, administrateur B;
- M. Martinus C.J. WEIJERMANS, administrateur B;
- M. Simon P.M. SCHOONE, administrateur A;
- M. Dennis A.B.J.E. ALBADA JELGERSMA, administrateur A;
- M. Alexander K. van BEEK, administrateur A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAS S.A.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Administrateur Bi>
Référence de publication: 2016002776/21.
(160001420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
DKV Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 45.762.
<i>Auszug aus dem Protokoll außerordentliche Hauptversammlung DKV Luxembourg S.A. vom Freitag, den 18. Dezemberi>
<i>2015.i>
Zu TOP 1
Herr Pit Hentgen (*08.11.1961) wohnhaft in 4, Rue Breit, L-3392 Roedgen scheidet zum 31.12.2015 als Mitglied des
Verwaltungsrates der DKV Luxembourg S.A. aus.
Gemäß Vorschlag des Verwaltungsrates beruft die Hauptversammlung zum 01.01.2016
- Herrn Christian Strasser (*17.04.1971), wohnhaft in 11, Avenue Dr. Klein in L-5630 Mondorf-les-Bains
als Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrates bis zur Generalversammlung im Jahre 2017.
Référence de publication: 2016002816/15.
(160001307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
33784
L
U X E M B O U R G
Eperlan Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 96.316.
<i>Extrait des Résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 18.06.2015i>
<i>Cinquième résolution:i>
L'Assemblée décide de rectifier la dénomination du Réviseur d'Entreprises Agréé soit: BDO Audit, Société Anonyme,
ayant son siège social au 2, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 147.570 en remplacement du Réviseur d'Entreprises Agréé de
la Société BDO Compagnie Fiduciaire SA ayant son siège social au 2, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg ,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 71.178. Le mandat
de BDO Audit, Société Anonyme, prendra effet rétroactivement à la date du 22 novembre 2013 jusqu'à l'Assemblée Gé-
nérale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EPERLAN PARTICIPATIONS S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016002857/19.
(160001471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Field Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.
R.C.S. Luxembourg B 123.914.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 2013i>
Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale tenue le 6 décembre 2013 que Monsieur William VERMEERSCH
demeurant professionnellement 24 rue Robert KRIEPS 4702 - PETANGE a été nommé comme Gérant de catégorie B. La
durée de son mandat est indéterminée.
Pétange, le 4 janvier 2016.
Pour extrait conforme
Ph. DENIS / D. GHEZA
<i>Gérant A / Gérant Bi>
Référence de publication: 2016002898/15.
(160000991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Freif II Master Refineries I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.175.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 décembre 2015i>
En date du 29 décembre 2015 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Harald Thul en tant que gérant de classe B de la Société et ce avec effet au 29 décembre
2015.
- de nommer Sophie Zintzen, née le 2 décembre 1979 à Verviers en Belgique, demeurant professionnellement au 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société, et ce avec effet au 29 décembre 2015
pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de classe A:i>
- Juan Diego Vargas
- Adi Joseph Blum
- Daren Schneider
<i>Gérants de classe B:i>
- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.
33785
L
U X E M B O U R G
- Neela Gungapersad
- Sophie Zintzen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Sophie Zintzen
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016002921/28.
(160000781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Generali European Real Estate Investments S.A., Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 121.362.
EXTRAIT
Suite aux résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 15 décembre 2015, il a été décidé de transférer
le siège social de la Société du 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-
duché de Luxembourg, avec effet au 18 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2015.
Référence de publication: 2016002924/13.
(160001436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Kaps Stars Belle Etoile, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, CC Belle Etoile.
R.C.S. Luxembourg B 163.236.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extrait de la réunion du Conseil de Gérance du 10 décembre 2015i>
Le Conseil de gérance de KAPORAL BELGIUM a décidé de fermer sa succursale, KAPS STARS BELLE ETOILE,
avec effet au 30 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2016003011/13.
(160002225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
KGJ Investments S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 172.712.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Sociétéi>
Avec effet au 7 décembre 2015 le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Abel van Staveren demeurant
professionnellement 33, rue du Puits Romain, bâtiment Vitrum, L-8070 Bertrange, et Madame Jennifer Kelly demeurant
professionnellement 14, Par-la-Ville Road, BER-HM 08 Hamilton en tant qu'administrateurs délégués à la gestion jour-
nalière de la Société.
Monsieur van Staveren et Madame Kelly sont nommés pour une durée indéterminée et ont le pouvoir d'engager la Société
par leur signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016003018/16.
(160001428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
33786
L
U X E M B O U R G
Niovilu S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2435 Luxembourg, 4, rue Pierre-Joseph Redouté.
R.C.S. Luxembourg B 195.566.
Il est porté à la connaissance des tiers que le siège social de la société "NIOVILU S.à r.l." a été transféré à L-2435
Luxembourg, 4, rue Pierre-Joseph Redouté.
Les adresses des associés/gérants Monsieur Andreas APOSTOLIDIS et Madame Koumouli AIKATERINI sont, suite
à ce transfert de siège social, également modifiées en L-2435 Luxembourg, 4, rue Pierre-Joseph Redouté.
Luxembourg, le 10/12/2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la Société
i>Andreas APOSTOLIDIS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016003145/16.
(160000776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Opera Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 156.787.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Le dépôt L110011686 du 29 janvier 2011 mentionne que Messieurs Griffin Jonathan, Ehlinger Jean-Christophe, Doherty
Mark, Harris Neil Gerard, Kidd Michael Rob ont été nommés en tant que gérant de la Société. Or, cette information est
erronée et il convient donc de lire comme suit:
M. Griffin Jonathan, Ehlinger Jean-Christophe et M. Doherty Mark ont été nommés Gérant B de la société.
M. Harris Neil Gerard et M. Kidd Michael Robert ont été nommés Gérant A de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003151/17.
(160001463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Opernplatz (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 156.790.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Le dépôt L110011696 du 19 janvier 2011 mentionne que Messieurs Griffin Jonathan, Ehlinger Jean-Christophe, Doherty
Mark, Harris Neil Gerard, Kidd Michael Rob ont été nommés en tant que gérant de la Société. Or, cette information est
erronée et il convient donc de lire comme suit:
M. Griffin Jonathan, Ehlinger Jean-Christophe et M. Doherty Mark ont été nommés Gérant B de la société.
M. Harris Neil Gerard et M. Kidd Michael Robert ont été nommés Gérant A de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003152/17.
(160001464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
33787
L
U X E M B O U R G
Occitan Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 67.922.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 30 décembre 2015, le liquidateur de la Société:
- Prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister;
- Décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir du 30
décembre 2015 au siège social de l'agent domiciliataire de la Société situé au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 05 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003156/15.
(160002233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
P & B Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 174.109.
EXTRAIT
M. Alain NOULLET, né le 2 novembre 1960 à Berchem Sainte Agathe (Belgique), demeurant professionnellement
L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de
sa démission en date du 30 décembre 2015 de son mandat d'administrateur de la société P&B GROUP S.A., société anonyme
de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174 109
et dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alain NOULLET.
Référence de publication: 2016003166/15.
(160000808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Novatech Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 115.052.
L'an deux mille quinze.
Le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVATECH PARTICIPATIONS S.A.,
avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 115.052 (NIN 2006 22 05 831),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 2006, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations numéro 944 du 13 mai 2006,
au capital social de trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur
nominale de dix Euro (€ 10.-) chacune, entièrement libérées.
L'assemblée est présidée par Madame Sara CRAVEIRO, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echter-
nach, 9, Rabatt,
qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Mariette SCHOU, employée,
demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.
Le bureau étant ainsi constitué Madame la Présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la version anglaise des statuts.
2.- Refonte complète des statuts afin de prévoir la possibilité d'avoir un actionnaire unique.
33788
L
U X E M B O U R G
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer la version anglaise des statuts.
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts, afin de prévoir la possibilité d'avoir un
actionnaire unique, et qui seront de la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de NOVATECH PARTICIPATIONS S.A..
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution
de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des action-
naires.
Le siège de la société pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'admi-
nistration ou de l'administrateur unique.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres admi-
nistratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra faire de l'intermédiation commerciales sur les marchés.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, indus-
trielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, finan-
cières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100)
actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10.-) chacune.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions au porteur sont soumises aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un
conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
33789
L
U X E M B O U R G
Administration - Surveillance
Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-
présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqué dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour
voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, courriel ou fax.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation
du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la
réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les action-
naires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 10. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un
registre spécial et signés par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux
administrateurs ou l'administrateur unique.
Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir
tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts
de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.
Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-
nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps.
Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d'administrateur-délégué.
Art. 13. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle du
délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore
33790
L
U X E M B O U R G
- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pou-
voirs, ou
- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'adminis-
tration.
Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats,
laquelle ne peut pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 16. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le troisième vendredi du mois de novembre à 15.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par
l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire
au(x) commissaire(s).
Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des
règles y relatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Disposition générale
Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Madame la Présidente lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: S. CRAVEIRO, M. SCHOU, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11284. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 24 décembre 2015.
Référence de publication: 2015211685/180.
(150236786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.
33791
L
U X E M B O U R G
Stateland International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 89.950.
<i>Rectificatif du dépôt du 23 décembre 2015 (No L150234010)i>
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016061856/11.
(160022832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
Stateland International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 89.950.
<i>Rectificatif du dépôt du 23 décembre 2015 (No L150234009)i>
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016061857/11.
(160022835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
Seiler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3117 Bergem, 1, Fassburgergronn.
R.C.S. Luxembourg B 190.790.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016061842/10.
(160022824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
Syré Zahntechnik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 80.794.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016061860/10.
(160022843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
T.T.F., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 10, rue de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 90.872.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016061861/10.
(160022466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
33792
Am Haferstück S.A.
BNP Paribas Plan
Claircy S.à r.l.
Compas S.A.
DKV Luxembourg S.A.
DWS Concept
Eperlan Participations S.A.
Field Conseil S.à r.l.
Flabeg Management S.à r.l. & Partners S.C.A.
Freif II Master Refineries I S.à r.l.
Generali European Real Estate Investments S.A.
HC Property Heureka I Alpha S.à r.l.
HC Property Heureka II Beta S.à r.l.
HC Property Heureka IV Delta S.à r.l.
Interfund Sicav
Kaps Stars Belle Etoile
KGJ Investments S.A., SICAV-SIF
Kleopatra Holdings GP S.A.
Logwin AG
Mapple Europe Holdings S.à r.l.
Mapple Europe Holdings S.à r.l.
M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l.
MUGC/HS Asian USD Bond Fund
NIH VI Aleph Management S.à r.l. & Partners S.C.A.
Niovilu S.à.r.l.
NN (L) CMF
No-Nail Boxes (Europe) S.A.
Novatech Participations S.A.
Occitan Investments S.A.
Opera Holding S.à r.l.
Opernplatz (GP) S.à r.l.
Paloma Investment S.à r.l.
P & B Group S.A.
P & B Group S.A.
San Maurizio SCA SICAV-SIF
Seiler S.à r.l.
SOF-10 Beagle JVCo Lux S.à r.l.
Sof-10 Cod Holdings Lux S.à r.l.
Stateland International S.A.
Stateland International S.A.
Syré Zahntechnik S.à r.l.
Trèves Offices SA
T.T.F.
UFP Timing Global Select
W.P. Stewart Holdings Fund