This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 506
22 février 2016
SOMMAIRE
4m Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24242
ACHM International Management Company
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24244
Affinia Luxembourg Finance S.à r.l. . . . . . . . .
24245
Alcentra Global Special Situations Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24258
Apreamare S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24246
Argor, Société Financière d'Entreprises et de
Projets Industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24243
Asport I & W, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24243
Assuralux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24243
AS Tower S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24243
Atlas Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24246
ATM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24246
Auberge du Pont, Wiltz s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
24245
Au Galop s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24243
BMT International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24282
Builders Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
24248
Capital Safety Canada Holdings S.à r.l. . . . . .
24266
Capital Safety Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
24264
Catalyst EPF II Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
24246
Catelan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24287
Commerce de Bois à Luxembourg S.à r.l. . . . .
24243
Contractors Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . .
24248
Corridor (West Gate) Pledgeco S.à r.l. . . . . . .
24285
Cyvalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24246
DZPB II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24248
Epicerie Clair Chêne S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
24247
Epicerie Mercante S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
24247
European Sovereign Bond Protection Facility
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24279
Franklin Templeton Investment Funds . . . . . .
24248
Gamma Holdco (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
24247
Georose 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24247
H. & S. Nutzfahrzeuge GmbH . . . . . . . . . . . . .
24247
IPD Luxembourg G.m.b.H . . . . . . . . . . . . . . . .
24268
Patron Capital Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
24251
Sky (Logistics) Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
24285
Swisstar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24244
Teal Darlaston S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24244
T-Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24245
Trans Ardennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24245
Transmar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24244
Transmar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24244
Transmar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24244
Treveria Thirty S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24245
Vabermain Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24242
Valentin Capital Management S.A. . . . . . . . . .
24242
Vector International Investments S.à r.l. . . . .
24242
Vesera Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24242
Vita-Cars S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24242
24241
L
U X E M B O U R G
Vector International Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 190.839.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004253/9.
(160001827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Vabermain Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 175.750.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004261/9.
(160002214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Valentin Capital Management S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 75.100.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004264/9.
(160001742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Vesera Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 175.751.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004269/9.
(160002215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Vita-Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7595 Reckange (Mersch), 45, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 148.853.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004273/9.
(160002542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
4m Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 45.597.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004301/9.
(160002664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
24242
L
U X E M B O U R G
Argor, Société Financière d'Entreprises et de Projets Industriels, Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 11.733.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004379/9.
(160002946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
AS Tower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9099 Ingeldorf, rue du XXII Mai 2008, Z.I. Walebroch.
R.C.S. Luxembourg B 117.713.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004383/9.
(160002756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Asport I & W, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9099 Ingeldorf, rue du XXII Mai 2008, Z.I. Walebroch.
R.C.S. Luxembourg B 101.921.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004386/9.
(160002755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Assuralux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4750 Pétange, 10, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 87.151.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004387/9.
(160002923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Au Galop s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 16, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 162.871.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004392/9.
(160003448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
C.B.L., Commerce de Bois à Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 180.506.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004479/9.
(160003565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
24243
L
U X E M B O U R G
Swisstar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 19, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 55.461.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004188/9.
(160001748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Teal Darlaston S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 70.944.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004197/9.
(160002343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Transmar Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 84.675.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004233/9.
(160002371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Transmar Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 84.675.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004234/9.
(160002372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Transmar Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 84.675.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004235/9.
(160002373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
ACHM International Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 159.009.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004354/9.
(160003393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
24244
L
U X E M B O U R G
Auberge du Pont, Wiltz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9554 Wiltz, 11, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 102.084.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MS GESTION SA
<i>Bureau Comptable et Fiscal
i>14 avenue de la Gare
L-9233 DIEKIRCH
Référence de publication: 2016004393/13.
(160003568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Affinia Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 172.486.202,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 161.119.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016004323/11.
(160002966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
T-Lux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3467 Dudelange, 28, rue Alexandre Fleming.
R.C.S. Luxembourg B 188.501.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016004192/10.
(160001933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Treveria Thirty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 125.660.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016004205/10.
(160002069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Trans Ardennes, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 146.585.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 04/01/2016.
Référence de publication: 2016004232/10.
(160001826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
24245
L
U X E M B O U R G
Catalyst EPF II Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.510,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 191.808.
Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016004468/12.
(160003090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Cyvalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 132.201.
Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016004543/12.
(160002695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Apreamare S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 152.800.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Référence de publication: 2016004376/10.
(160002875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Atlas Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 73.538.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016004389/10.
(160003364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
ATM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 80.346.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016004390/10.
(160003598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
24246
L
U X E M B O U R G
Epicerie Clair Chêne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 51, rue Clair Chêne.
R.C.S. Luxembourg B 156.395.
Le Bilan au 07 septembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 07 janvier 2016.
EPICERIE CLAIR CHÊNE S.A R.L.
L-4061 ESCH/ALZETTE
Référence de publication: 2016004580/12.
(160003490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Epicerie Mercante S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4204 Esch-sur-Alzette, 12, rue Large.
R.C.S. Luxembourg B 177.560.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 07 janvier 2016.
EPICERIE MERCANTE S.A R.L.
L-4204 ESCH/ALZETTE
Référence de publication: 2016004595/12.
(160003447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
H. & S. Nutzfahrzeuge GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5324 Contern, 1A, rue des Chaux.
R.C.S. Luxembourg B 107.931.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016004683/10.
(160002900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Georose 3, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé.
R.C.S. Luxembourg B 42.585.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016004663/10.
(160003310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Gamma Holdco (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 160.352.
Les comptes annuels en date du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004655/10.
(160003292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
24247
L
U X E M B O U R G
DZPB II, Fonds Commun de Placement.
Das koordinierte Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 22. Februar 2016 wurde beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, im Januar 2016
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Référence de publication: 2016057477/10.
(160016941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Franklin Templeton Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 35.177.
La fusion du compartiment Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Allocation Fund au sein du com-
partiment Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Diversified Conservative Fund est effective depuis le 19 février
2016, minuit, heure de Luxembourg, suite à la décision du conseil d'administration de la Société suivant les termes du
prospectus de la Société en vigueur.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Référence de publication: 2016068471/755/11.
Builders Re, Builders Reinsurance S.A., Société Anonyme,
(anc. Contractors Re, Contractors Reinsurance S.A.).
Siège social: L-1221 Luxembourg, 253, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 191.606.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of December.
Before the undersigned Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch.
There appeared:
Builders Insurance Holdings S.A., a public company limited by shares (société anonyme) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-8422 Steinfort, 69 rue de Hobscheid,
registered with the Luxembourg trade and companies registry under number B180.477,
here validly represented by two directors Mr John Simon MORREY, professionally residing at 69, rue de Hobscheid,
L-8422 Steinfort and Mrs Muriel SOSNOWSKI, professionally residing at 253, rue de Beggen, L-1221 Luxembourg.
Mr John Simon MORREY being represented by virtue of a proxy under private seal which, after having been signed
“ne varietur” by the notary and the appearing parties or their proxyholders, will remain attached to the present deed to be
filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as aforementioned, requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of Contractors Reinsurance S.A., a public company limited by shares
(société anonyme), having its registered office at L-1221 Luxembourg, 253, rue de Beggen, registered with the Luxembourg
trade and companies registry under number B 191.606, incorporated by deed of the undersigned notary, dated October 28
th
, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3389 of November 14
th
, 2014 (the
“Company”).
The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the last time by a deed of the
undersigned notary dated December 4
th
, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The shares are in registered form.
II. The appearing party, duly represented, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis
of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of eight million two hundred thousand US
Dollars (USD 8,200,000), so as to raise it from its current amount of thirty-eight million one hundred thousand US Dollars
(USD 38,100,000) to an amount of forty-six million three hundred thousand US Dollars (USD 46,300,000) by the issue of
eight thousand two hundred (8,200) new shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000) each, subject to
the payment of a global share premium in the amount of seventy-three million eight hundred thousand US Dollars (USD
73,800,000);
2. Subscription and payment;
24248
L
U X E M B O U R G
3. Subsequent amendment of the 1
st
sentence of article 5 of the Company’s articles of association in order to reflect the
new corporate capital of the Company pursuant to the above resolutions.
4. Change of the name of the company from “Contractors Reinsurance S.A.” into “Builders Reinsurance S.A.” shortened
in “Builders Re” with immediate effect and subsequent amendment of article 1 of the Articles.
III. The appearing party has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eight million two hundred
thousand US Dollars (USD 8,200,000), so as to raise it from its current amount of thirty-eight million one hundred thousand
US Dollars (USD 38,100,000) to an amount of forty-six million three hundred thousand US Dollars (USD 46,300,000) by
the issue of eight thousand two hundred (8,200) new shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000) each,
subject to the payment of a global share premium in the amount of seventy-three million eight hundred thousand US Dollars
(USD 73,800,000).
<i>Second resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon “Builders Insurance Holdings S.A.”, represented as stated above, declares to subscribe to the new shares as
indicated above and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of eighty-two million US
Dollars (USD 82,000,000), to be allocated for eight million two hundred thousand US Dollars (USD 8,200,000) to the
share capital account of the Company and for seventy-three million eight hundred thousand US Dollars (USD 73,800,000)
to the share premium account of the Company.
The aggregate cash amount of eighty-two million US Dollars (USD 82,000,000) has been blocked on the bank account
of the Company and a proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, and the cash contribution having been fully carried out, the sole share-
holder resolves to amend the 1
st
sentence of article 5 of the Company’s articles of association, which shall then be read as
follows:
“ Art. 5. Corporate capital. The subscribed capital is set at forty-six million three hundred thousand US Dollars (USD
46,300,000) represented by forty-six thousand three hundred (46,300) shares with a nominal value of one thousand US
Dollars (USD 1,000) each.”
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolves to change the name of the company from “Contractors Reinsurance S.A.” into “Builders
Reinsurance S.A.“ shortened in “Builders Re” with immediate effect.
As a consequence thereof, article 1 of the Articles is amended and shall henceforth have the following wording:
Art. 1. Name and form of the Company. Between those present this day and all persons who will become owners of the
shares mentioned hereafter, a Luxembourg law governed public company limited by shares (société anonyme) is hereby
formed under the name “Builders Reinsurance S.A.” shortened in “Builders Re”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Beringen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representatives of the appearing party, known to the notary by their surnames,
given names, civil status and residences, the said representatives signed together with the notary the present deed.
Follows the French Version:
L’an deux mille quinze, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Builders Insurance Holdings S.A., une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, avec son siège social à L-8422 Steinfort, 69 rue de Hobscheid, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 180.477,
24249
L
U X E M B O U R G
ici représentée par deux administrateurs Monsieur John Simon MORREY, résidant professionnellement au 69, rue de
Hobscheid, L-8422 Steinfort et Madame Muriel SOSNOWSKI, résidant professionnellement au 253, rue de Beggen,
L-1221 Luxembourg.
Monsieur John Simon MORREY étant ici représenté en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration,
après avoir été signée ne varietur par les mandataires de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme susmentionné, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'actionnaire unique de Contractors Reinsurance S.A., une société anonyme, ayant son siège
social à L-1221 Luxembourg, 253, rue de Beggen, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 191606, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 28 octobre 2014, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3389 du 14 novembre 2014 (la «Société») et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 décembre 2015, pas encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations,.
Les actions sont nominatives.
II. La partie comparante, dûment représentée, a reconnu être pleinement informée des résolutions à prendre sur base de
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de huit millions deux cent mille Dollars US (USD
8.200.000) pour le porter de son montant actuel de trente-huit millions cent mille Dollars US (USD 38.100.000) à un
montant de quarante-six millions trois cent mille Dollars US (USD 46.300.000) par l'émission de huit mille deux cents
(8.200) nouvelles actions d'une valeur nominale de mille Dollars US (USD 1.000) chacune, sujet au paiement d’une prime
d’émission de soixante-treize millions huit cent mille Dollars US (USD 73.800.000);
2. Souscription et libération;
3. Modification subséquente de la 1ère phrase de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital
social de la Société conformément aux résolutions ci-dessus.
4. Changement de la dénomination de la société de «Contractors Reinsurance S.A.» en "Builders Reinsurance S.A.", en
abrégé «Builders Re», ce avec effet immédiat et modification de l'article 1 des statuts.
III. La partie comparante a demandé au notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’actionnaire unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de huit millions deux cent mille
Dollars US (USD 8.200.000) pour le porter de son montant actuel de trente-huit millions cent mille Dollars US (USD
38.100.000) à un montant de quarante-six millions trois cent mille Dollars US (USD 46.300.000) par l'émission de huit
mille deux cents (8.200) nouvelles actions d'une valeur nominale de mille Dollars US (USD 1.000) chacune, sujet au
paiement d’une prime d’émission de soixante-treize millions huit cent mille Dollars US (USD 73.800.000);
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Souscription - Libérationi>
«Builders Insurance Holdings S.A.», représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les actions nouvelles
comme indiqué ci-dessus et les libère intégralement par un apport en espèces d’un montant total de quatre-vingt-deux
millions de Dollars US (USD 82.000.000), à affecter à hauteur de huit millions deux cent mille Dollars US (USD 8.200.000)
au compte de capital social de la Société et (ii) à hauteur de soixante-treize millions huit cent mille Dollars US (USD
73.800.000) au compte de prime d’émission de la Société .
Le montant total en espèces de quatre-vingt-deux millions de Dollars US (USD 82.000.000) a été bloqué sur le compte
bancaire de la Société et une preuve de l'existence de la contribution a été donnée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent et l'apport en espèces ayant été entièrement réalisé, il est décidé de modifier
la 1ère phrase de l'article 5 des statuts de la Société, qui doit alors être lue comme suit:
« Art. 5. Capital social. Le capital souscrit est fixé à quarante-six millions trois cent mille Dollars US (USD 46.300.000)
représenté par quarante-six mille trois cents (46.300) actions d'une valeur nominale de mille Dollars US (USD 1.000)
chacune.».
<i>Quatrième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de changer le nom de la société de «Contractors Reinsurance S.A.» en «Builders Reinsurance
S.A."«, en abrégé «Builders Re», avec effet immédiat.
En conséquence, l'article 1 des statuts est modifié et doit alors être lu comme suit:
24250
L
U X E M B O U R G
« Art. 1
er
. Nom et forme de la société. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui
deviendraient propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme de droit luxembourgeois dénommée «Builders
Reinsurance S.A.», en abrégé «Builders Re».
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés
approximativement à sept mille euros (7.000 EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi par une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Beringen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants de la partie comparante, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms,
états et demeures, lesdits mandataires ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. SOSNOWSKI, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/111. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Beringen, le 8 février 2016.
Référence de publication: 2016062864/160.
(160024259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Patron Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.800,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 160.456.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of December,
before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appear:
- Patron Capital L.P. IV, a Guernsey limited partnership, registered under number 1451 at the Guernsey Registry, whose
registered office is at 1
st
Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 1DB, represented by its general
partner, Patron Capital GP L.P. IV, a Guernsey limited partnership, registered under number 1448 at the Guernsey Registry,
whose registered office is at 1
st
Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 1DB, itself acting through
its general partner Patron Capital General Partner IV Limited, a company incorporated in Guernsey, registered under
number 59761 at the Guernsey Registry, whose registered office is at 1
st
Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port,
Guernsey, GY1 1DB and
- Patron Capital, V L.P., a Jersey limited partnership, registered under number 1933 with the Jersey Financial Services
Commission, whose registered office is at 3
rd
Floor Walker House, 28-34 Hill Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PN represented
by its general partner, Patron Capital GP V L.P., a Jersey limited partnership, registered under number 1930 with the Jersey
Financial Services Commission, whose registered office is at 3
rd
Floor Walker House, 28-34 Hill Street, St. Helier, Jersey,
JE4 8PN, itself acting through its general partner Patron Capital GP V Limited, a company incorporated in Jersey, registered
under number 117664 with the Jersey Financial Services Commission, whose registered office is at 3
rd
Floor Walker
House, 28-34 Hill Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PN, (the Shareholders),
hereby represented both by Ms. Isabel DIAS, private employee, professionally residing at L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, by virtue of two powers of attorney given under private seal.
The powers of attorney after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Shareholders
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The Shareholders, represented as stated here above, requests the undersigned notary to record the following:
I. The Shareholders own all the twelve thousand five hundred (12,500) class A shares, one hundred (100) class B shares,
one hundred (100) class C shares, one hundred (100) class D shares, one hundred (100) class E shares, one hundred (100)
class F shares, one hundred (100) class G shares, one hundred (100) class H shares, one hundred (100) class J shares, one
hundred (100) class K shares, one hundred (100) class L shares, one hundred (100) class M shares, one hundred (100) class
N shares, one hundred (100) class P shares, one hundred (100) class Q shares, one hundred (100) class R shares, one hundred
(100) class S shares, one hundred (100) class T shares, one hundred (100) class U shares, one hundred (100) class V shares,
24251
L
U X E M B O U R G
one hundred (100) class W shares, one hundred (100) class X shares, one hundred (100) class Y shares, one hundred (100)
class Z shares, one hundred (100) class Z1 shares and twelve thousand five hundred (12,500) class AA Shares having a
par value of EUR 1 (one Euro) each, representing the entire share capital of Patron Capital Investments S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
with registered office at 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 160.456 (the Company). The Company was incorporated
on 13 April 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1496 of 7 July 2011. The articles of association of the Company (the Articles)
have been amended for the last time on 4 December 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, prenamed, not
yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
II. The Shareholders wish to pass resolutions on the following items:
1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 27,400.- (twenty-seven thousand
four hundred Euro) by an amount of EUR 2,400.- (two thousand four hundred Euro) to an amount of EUR 29,800.- (twenty-
nine thousand and eight hundred Euro) by the issuance of
1. one hundred (100) class AB shares;
2. one hundred (100) class AC shares;
3. one hundred (100) class AD shares;
4. one hundred (100) class AE shares;
5. one hundred (100) class AF shares;
6. one hundred (100) class AG shares;
7. one hundred (100) class AH shares;
8. one hundred (100) class AJ shares;
9. one hundred (100) class AK shares;
10. one hundred (100) class AL shares;
11. one hundred (100) class AM shares;
12. one hundred (100) class AN shares;
13. one hundred (100) class AP shares;
14. one hundred (100) class AQ shares;
15. one hundred (100) class AR shares;
16. one hundred (100) class AS shares;
17. one hundred (100) class AT shares;
18. one hundred (100) class AU shares;
19. one hundred (100) class AV shares;
20. one hundred (100) class AW shares;
21. one hundred (100) class AX shares;
22. one hundred (100) class AY shares;
23. one hundred (100) class AZ shares; and
24. one hundred (100) class AZ1 shares.
Having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each;
2. Subscription and payment of the 2,400 (two thousand four hundred) new shares;
3. Amendment of article 5 of the Articles;
4. Miscellaneous
III. The Shareholders takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand four hundred Euro
(EUR 2,400) to bring it from its current amount of EUR 27,400 (twenty-seven thousand four hundred Euro) to an amount
of EUR 29,800 (twenty-nine thousand and eight hundred Euros) by way of issuance of
1. one hundred (100) class AB shares;
2. one hundred (100) class AC shares;
3. one hundred (100) class AD shares;
4. one hundred (100) class AE shares;
5. one hundred (100) class AF shares;
6. one hundred (100) class AG shares;
7. one hundred (100) class AH shares;
24252
L
U X E M B O U R G
8. one hundred (100) class AJ shares;
9. one hundred (100) class AK shares;
10. one hundred (100) class AL shares;
11. one hundred (100) class AM shares;
12. one hundred (100) class AN shares;
13. one hundred (100) class AP shares;
14. one hundred (100) class AQ shares;
15. one hundred (100) class AR shares;
16. one hundred (100) class AS shares;
17. one hundred (100) class AT shares;
18. one hundred (100) class AU shares;
19. one hundred (100) class AV shares;
20. one hundred (100) class AW shares;
21. one hundred (100) class AX shares;
22. one hundred (100) class AY shares;
23. one hundred (100) class AZ shares; and
24. one hundred (100) class AZ1 shares.
having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.
<i>Subscriptioni>
The 2,400 (two thousand and four hundred) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash by
Patron Capital, V L.P., prenamed, so that the amount of EUR 2,400.- (two thousand and four hundred Euro) is at the free
disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to amend Article 5 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. The Company’s share capital is set at twenty-nine thousand eight hundred (EUR 29,800) represented by twenty-
nine thousand eight hundred (29,800) shares with each share holding the par value of one euro (EUR 1), divided in classes
as follows
1. twelve thousand five hundred (12,500) class A shares;
2. twelve thousand five hundred (12,500) class AA shares;
3. one hundred (100) class B shares;
4. one hundred (100) class C shares;
5. one hundred (100) class D shares;
6. one hundred (100) class E shares;
7. one hundred (100) class F shares;
8. one hundred (100) class G shares;
9. one hundred (100) class H shares;
10. one hundred (100) class J shares;
11. one hundred (100) class K shares;
12. one hundred (100) class L shares;
13. one hundred (100) class M shares;
14. one hundred (100) class N shares;
15. one hundred (100) class P shares;
16. one hundred (100) class Q shares;
17. one hundred (100) class R shares;
18. one hundred (100) class S shares;
19. one hundred (100) class T shares;
20. one hundred (100) class U shares;
21. one hundred (100) class V shares;
22. one hundred (100) class W shares;
23. one hundred (100) class X shares;
24. one hundred (100) class Y shares;
25. one hundred (100) class Z shares;
24253
L
U X E M B O U R G
26. one hundred (100) class Z1 shares;
27. one hundred (100) class AB shares;
28. one hundred (100) class AC shares;
29. one hundred (100) class AD shares;
30. one hundred (100) class AE shares;
31. one hundred (100) class AF shares;
32. one hundred (100) class AG shares;
33. one hundred (100) class AH shares;
34. one hundred (100) class AJ shares;
35. one hundred (100) class AK shares;
36. one hundred (100) class AL shares;
37. one hundred (100) class AM shares;
38. one hundred (100) class AN shares;
39. one hundred (100) class AP shares;
40. one hundred (100) class AQ shares;
41. one hundred (100) class AR shares;
42. one hundred (100) class AS shares;
43. one hundred (100) class AT shares;
44. one hundred (100) class AU shares;
45. one hundred (100) class AV shares;
46. one hundred (100) class AW shares;
47. one hundred (100) class AX shares;
48. one hundred (100) class AY shares;
49. one hundred (100) class AZ shares; and
50. one hundred (100) class AZ1 shares.
Save for the Class A shares and the Class AA shares, each class of shares corresponds to a relevant underlying investment
as determined by the board of managers.”
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
shareholders, the present deed is worded in English, followed by a French version, and that at the request of the proxyholder
of the shareholders, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The deed having been read to the proxyholder of the shareholders, said proxyholder signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huit décembre,
par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Comparaissent:
- Patron Capital L.P. IV, un «Limited Partnership» de Guernesey, inscrit sous le numéro 1451 au registre de Guernesey,
établi et ayant son siège social au 1
st
Floor, Tudor House, le Bordage, St Peter Port, Guernesey GY1 1DB, ici représenté
par son associé commandité, Patron Capital GP L.P. IV, un «Limited Partnership» de Guernesey, inscrite sous le numéro
1448 au registre de Guernesey, établie et ayant son siège social au 1
st
Floor, Tudor House, le Bordage, St Peter Port,
Guernesey GY1 1DB, lui-même ici représenté par son associé commandité Patron Capital General Partner IV Limited, une
société constituée selon les lois de Gibraltar, inscrite sous le numéro 59761 au registre de Guernesey, établie et ayant son
siège social au 1
st
Floor, Tudor House, le Bordage, St Peter Port, Guernesey GY1 1DB; et
- Patron Capital, V L.P., un «limited partnership» de Jersey, enregistré sous le numéro 1933 auprès de la «Jersey Financial
Services Commission», et dont le siège social est au 3
rd
Floor Walker House, 28-34 Hill Street, St. Helier, Jersey, JE4
8PN représenté par son associé commandité, Patron Capital GP V L.P., un «limited partnership» de Jersey, enregistré sous
le numéro 1930 auprès de la «Jersey Financial Services Commission», et dont le siège social est au 3
rd
Floor Walker
House, 28-34 Hill Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PN représenté par son associé commandité Patron Capital GP V Limited,
une société existant selon le droit de Jersey, enregistrée sous le numéro 117664 auprès de la «Jersey Financial Services
24254
L
U X E M B O U R G
Commission», et dont le siège social est au 3
rd
Floor Walker House, 28-34 Hill Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PN (les
«Associés»)
toutes les deux ici représentées par Madame Isabel Dias, employée privée, demeurant professionnellement au 74 avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire agissant pour le compte des Associés et le notaire
instrumentant resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Les Associés représentés tel que décrit ci-dessus, requièrent le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les Associés sont les détenteurs de toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A, cent (100)
parts sociales de classe B, cent (100) parts sociales de classe C, cent (100) parts sociales de classe D, cent (100) parts
sociales de classe E, cent (100) parts sociales de classe F, cent (100) parts sociales de classe G, cent (100) parts sociales
de classe H, cent (100) parts sociales de classe J, cent (100) parts sociales de classe K, cent (100) parts sociales de classe
L, cent (100) parts sociales de classe M, cent (100) parts sociales de classe N, cent (100) parts sociales de classe P, cent
(100) parts sociales de classe Q, cent (100) parts sociales de classe R, cent (100) parts sociales de classe S, cent (100) parts
sociales de classe T, cent (100) parts sociales de classe U, cent (100) parts sociales de classe V, cent (100) parts sociales
de classe W, cent (100) parts sociales de classe X, cent (100) parts sociales de classe Y, cent (100) parts sociales de classe
Z, cent (100) parts sociales de classe Z1 et douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe AA d’une valeur nominale
d’un Euro (EUR 1,-) chacune, représentant l'entier capital social de Patron Capital Investments S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec son siège social au 6, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, ayant un capital social d'un montant de vingt-sept mille quatre cents euro (27.400 EUR) et
immatriculée au du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160456 (la Société). La Société
a été constituée le 13 avril 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1496 du 7 juillet 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été
modifiés pour la dernière fois le 4 décembre 2015 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, prénommée, non encore
publié.
II. Les Associés désirent prendre des résolutions sur les points suivants:
1. Décision d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de 27.400,- EUR (vingt-sept mille quatre
cents Euros) à concurrence de 2.400,- EUR (deux mille quatre cents Euros) pour le porter à 29.800,- EUR (vingt-neuf mille
huit cents Euros) par l'émission de:
1. cent (100) parts sociales de classe AB;
2. cent (100) parts sociales de classe AC;
3. cent (100) parts sociales de classe AD;
4. cent (100) parts sociales de classe AE;
5. cent (100) parts sociales de classe AF;
6. cent (100) parts sociales de classe AG;
7. cent (100) parts sociales de classe AH;
8. cent (100) parts sociales de classe AJ;
9. cent (100) parts sociales de classe AK;
10. cent (100) parts sociales de classe AL;
11. cent (100) parts sociales de classe AM;
12. cent (100) parts sociales de classe AN;
13. cent (100) parts sociales de classe AP;
14. cent (100) parts sociales de classe AQ;
15. cent (100) parts sociales de classe AR;
16. cent (100) parts sociales de classe AS;
17. cent (100) parts sociales de classe AT;
18. cent (100) parts sociales de classe AU;
19. cent (100) parts sociales de classe AV;
20. cent (100) parts sociales de classe AW;
21. cent (100) parts sociales de classe AX;
22. cent (100) parts sociales de classe AY;
23. cent (100) parts sociales de classe AZ; et
24. cent (100) parts sociales de classe AZ1.
2. Souscription et libération des 2.400 (deux mille quatre cents) parts sociales nouvelles;
3. Modification de l'article 5 des Statuts;
4. Divers
III. Les Associés prennent les résolutions suivantes:
24255
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social à hauteur de 2.400 EUR (deux mille quatre cents Euros) pour le
faire passer de son montant actuel de 27.400 EUR (vingt-sept mille quatre cents Euros) à un montant de 29.800 EUR (vingt-
neuf mille huit cents Euros) par voie d’émission de:
1. cent (100) parts sociales de classe AB;
2. cent (100) parts sociales de classe AC;
3. cent (100) parts sociales de classe AD;
4. cent (100) parts sociales de classe AE;
5. cent (100) parts sociales de classe AF;
6. cent (100) parts sociales de classe AG;
7. cent (100) parts sociales de classe AH;
8. cent (100) parts sociales de classe AJ;
9. cent (100) parts sociales de classe AK;
10. cent (100) parts sociales de classe AL;
11. cent (100) parts sociales de classe AM;
12. cent (100) parts sociales de classe AN;
13. cent (100) parts sociales de classe AP;
14. cent (100) parts sociales de classe AQ;
15. cent (100) parts sociales de classe AR;
16. cent (100) parts sociales de classe AS;
17. cent (100) parts sociales de classe AT;
18. cent (100) parts sociales de classe AU;
19. cent (100) parts sociales de classe AV;
20. cent (100) parts sociales de classe AW;
21. cent (100) parts sociales de classe AX;
22. cent (100) parts sociales de classe AY;
23. cent (100) parts sociales de classe AZ; et
24. cent (100) parts sociales de classe AZ1.
d’une valeur nominale d’1 EUR (un Euro) chacune.
<i>Souscriptioni>
Les 2.400 (deux mille quatre cents) parts sociales à émettre ont été pleinement souscrites et libérées, par apport en
numéraire, par Patron Capital, V L.P., prénommée, de telle sorte que le montant de 2.400,- EUR (deux mille quatre cents
Euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné, lequel le reconnaît expres-
sément.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société de telle sorte que celui-ci a désormais la teneur
suivante:
« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt-neuf mille huit cents Euros (EUR 29.800.-), divisé
en vingt-neuf mille huit cents (29.800) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1.-), chacune, et réparties en
classes comme suit:
1. douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A
2. douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe AA
3. cent (100) parts sociales de classe B
4. cent (100) parts sociales de classe C
5. cent (100) parts sociales de classe D
6. cent (100) parts sociales de classe E
7. cent (100) parts sociales de classe F
8. cent (100) parts sociales de classe G
9. cent (100) parts sociales de classe H
10. cent (100) parts sociales de classe J
11. cent (100) parts sociales de classe K
12. cent (100) parts sociales de classe L
24256
L
U X E M B O U R G
13. cent (100) parts sociales de classe M
14. cent (100) parts sociales de classe N
15. cent (100) parts sociales de classe P
16. cent (100) parts sociales de classe Q
17. cent (100) parts sociales de classe R
18. cent (100) parts sociales de classe S
19. cent (100) parts sociales de classe T
20. cent (100) parts sociales de classe U
21. cent (100) parts sociales de classe V
22. cent (100) parts sociales de classe W
23. cent (100) parts sociales de classe X
24. cent (100) parts sociales de classe Y
25. cent (100) parts sociales de classe Z
26. cent (100) parts sociales de classe Z1
27. cent (100) parts sociales de classe AB
28. cent (100) parts sociales de classe AC
29. cent (100) parts sociales de classe AD
30. cent (100) parts sociales de classe AE
31. cent (100) parts sociales de classe AF;
32. cent (100) parts sociales de classe AG
33. cent (100) parts sociales de classe AH
34. cent (100) parts sociales de classe AJ
35. cent (100) parts sociales de classe AK
36. cent (100) parts sociales de classe AL
37. cent (100) parts sociales de classe AM
38. cent (100) parts sociales de classe AN
39. cent (100) parts sociales de classe AP
40. cent (100) parts sociales de classe AQ
41. cent (100) parts sociales de classe AR
42. cent (100) parts sociales de classe AS
43. cent (100) parts sociales de classe AT
44. cent (100) parts sociales de classe AU
45. cent (100) parts sociales de classe AV
46. cent (100) parts sociales de classe AW
47. cent (100) parts sociales de classe AX
48. cent (100) parts sociales de classe AY
49. cent (100) parts sociales de classe AZ; et
50. cent (100) parts sociales de classe AZ1.
Mis à part les parts sociales de classe A et de Classe AA, chaque classe de parts sociales correspond à un certain
investissement déterminé par le conseil de gérance.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la
Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que le mandataire des associés l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête du mandataire des associés, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des associés, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, l'original du
présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 05 janvier 2016. 2LAC/2016/210. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
24257
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Référence de publication: 2016056924/359.
(160016226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Alcentra Global Special Situations Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.163.
In the year two thousand and sixteen, on the first day of February
before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Alcentra Fund S.C.A. SICAV-SIF, an investment company with variable capital (société d'investissement à capital
variable - SICAV) organised as an umbrella specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé - SIF) in the
form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions - SCA) governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and in particular by the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds
qualifying as an alternative investment fund under the Luxembourg law of 13 July 2013 on alternative investment fund
managers transposing the EU directive 2011/61/EU on alternative investment fund managers, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 147219, and having its registered office at 2-4, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, represented by its general partner Alcentra S.à r.l., a private
limited liability company (“société a responsabilité limitée”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 147085, having a share capital of EUR
12,500, acting on behalf of its sub-fund, Clareant Global Special Situations Fund (the “Shareholder”),
hereby represented by Maître Claire Prospert, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal dated Ferbruary 1, 2016.
The said proxy signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the
purpose of registration.
The Shareholder requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of Alcentra
Global Special Situations Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), with registered office at 47,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having been incorporated following a deed of
the undersigned notary dated 12 August 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2263 of 16 September 2008 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
141163 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.
The Shareholder, represented as above mentioned, declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the
basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To set the nominal value of the shares in the Company at an amount of one euro cent (EUR 0.01) and accordingly to
convert the existing one hundred twenty-five (125) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each into
one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.
2 To create ten (10) classes of shares, to be denominated ordinary shares, class A shares, class B shares, class C shares,
class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, and class I shares, having such rights and
privileges attached thereto as set out in the articles of incorporation of the Company following their amendment as per item
4 of the present agenda.
3 To convert the one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares of the Company into one million two hundred
forty-one thousand (1,241,000) ordinary shares, one thousand (1,000) class A shares, one thousand (1,000) class B shares,
one thousand (1,000) class C shares, one thousand (1,000) class D shares, one thousand (1,000) class E shares, one thousand
(1,000) class F shares, one thousand (1,000) class G shares, one thousand (1,000) class H shares, and one thousand (1,000)
class I shares, with a nominal value of one euro cent each (EUR 0.01).
4 To amend article 5, article 21, and article 22 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the
above resolutions.
5 To acknowledge the resignation of Grenville Carr-Jones, Sanjeev Jewootah, Yves Cheret and Kathryn O'Sullivan as
managers of the Company.
6 To approve the appointment of Simon Barnes, Jens Hoellermann and James Algar as managers of the Company.
24258
L
U X E M B O U R G
7 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to set the nominal value of the shares in the Company at an amount of one euro cent (EUR
0.01) and accordingly to convert the existing one hundred twenty-five (125) shares with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-) each into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to create ten (10) classes of shares, to be denominated ordinary shares, class A shares, class
B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, and class I shares,
having such rights and privileges attached thereto as set out in the articles of incorporation of the Company following their
amendment.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to convert the one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares of the Company into
one million two hundred forty-one thousand (1,241,000) ordinary shares, one thousand (1,000) class A shares, one thousand
(1,000) class B shares, one thousand (1,000) class C shares, one thousand (1,000) class D shares, one thousand (1,000)
class E shares, one thousand (1,000) class F shares, one thousand (1,000) class G shares, one thousand (1,000) class H
shares, and one thousand (1,000) I shares, with a nominal value of one euro cent each (EUR 0.01).
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend article 5, article 21 and article 22 of the articles of incorporation of the Company
in order to reflect the above resolutions.
As a result, article 5 shall from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)
divided into:
- one million two hundred forty-one thousand (1,241,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- one thousand (1,000) class A shares (the "Class A Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
all subscribed and fully paid up;
- one thousand (1,000) class B shares (the "Class B Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
all subscribed and fully paid up;
- one thousand (1,000) class C shares (the "Class C Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
all subscribed and fully paid up;
- one thousand (1,000) class D shares (the "Class D Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
all subscribed and fully paid up;
- one thousand (1,000) class E shares (the "Class E Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
all subscribed and fully paid up;
- one thousand (1,000) class F shares (the "Class F Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- one thousand (1,000) class G shares (the "Class G Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
all subscribed and fully paid up;
- one thousand (1,000) class H shares (the "Class H Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
all subscribed and fully paid up; and
- one thousand (1,000) class I shares (the "Class I Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
Articles of Incorporation or by the law.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.”
As a result, article 21 shall from now on read as follows:
" Art. 21. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each
year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to
be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
24259
L
U X E M B O U R G
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s).
In respect of each distribution of dividend, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order
of priority:
- each Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than one per cent (1%) per
annum of the nominal value of such share, then,
- each Class A Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than two per cent (2%) per
annum of the nominal value of such share, then,
- each Class B Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than three per cent (3%) per
annum of the nominal value of such share, then,
- each Class C Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than four per cent (4%) per
annum of the nominal value of such share, then,
- each Class D Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than five per cent (5%) per
annum of the nominal value of such share, then,
- each Class E Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than six per cent (6%) per
annum of the nominal value of such share, then,
- each Class F Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than seven per cent (7%) per
annum of the nominal value of such share, then,
- each Class G Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than eight per cent (8%) per
annum of the nominal value of such share, then,
- each Class H Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than nine per cent (9%) per
annum of the nominal value of such share, then,
- each Class I Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than ten per cent (10%) per
annum of the nominal value of such share, (together the "Profit Entitlement"); and
any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all the shares
forming the then last outstanding class of shares in reverse alphabetical order (starting from the Class I Shares until the
Ordinary Shares).
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment."
As a result article 22 shall from now on read as follows:
“ Art. 22. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by
half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may
be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.
In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, to the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the
Company's debts and liabilities;
(ii) second, to the shareholders for the repayment of the nominal value of their shares in the Company;
(iii) third, to the holders of all classes of shares in such order of priority and in such amount as is necessary to achieve
on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.”
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolved to acknowledge the resignation of Grenville Carr-Jones, Sanjeev Jewootah, Yves Cheret and
Kathryn O'Sullivan as managers of the Company with effect as of the date hereof and resolved to grant each of them full
discharge for the performance of their duties as far as legally possible and to resolve again on the said discharge at the time
the annual general meeting of shareholders will approve the next annual accounts of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholder resolved to appoint the following persons as new managers of the Company, in replacement of the
resigning managers, with immediate effect and for an unlimited period:
- Simon Barnes, private employee, born on 2 December, 1962 in Liverpool, United Kingdom, with professional address
at 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- James Algar, private employee, born on 8 June, 1967 in London, United Kingdom, with professional address at 10
Gresham Street, London EC2V 7JD, United Kingdom, and
24260
L
U X E M B O U R G
- Jens Hoellermann, private employee, born on 26 July, 1971 in Oberhausen, Germany, with professional address at 15,
rue Jean Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to acknowledge that the board of managers of the Company
is from now on composed as follows:
- Simon Barnes;
- James Algar; and
- Jens Hoellermann.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid
capital increase are estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the undersigned notary by his
surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le premier jour du mois de février,
par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Alcentra Fund S.C.A. SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable - (SICAV) organisée comme un fonds
d'investissement spécialisé - (SIF) sous la forme d'une société en commandite par actions - (SCA), régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg et en particulier par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés
qualifiés de fonds d'investissement alternatifs conformément à la loi luxembourgeoise du 13 juillet 2013 relative aux
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et transposant la directive européenne 2011/61/UE relative aux ges-
tionnaires de fonds d'investissement alternatifs, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 147219, et ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, représentée par son actionnaire commandité Alcentra S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147085,
ayant un capital social de EUR 12.500, agissant au nom de son compartiment, Clareant Global Special Situations Fund
(l'«Associé»),
représentée aux fins des présentes par Maître Claire Prospert, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
février 2016.
La prédite procuration, signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes aux fins
d'enregistrement.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Alcentra Global Special
Situations Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 47, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 12 août 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2263 du 16 septembre 2008 et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 141163 (la «Société»). Les statuts de la Société
n'ont pas encore été modifiés.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Fixation de la valeur nominale des parts sociales de la Société à un centime d'euro (EUR 0,01) et en conséquence,
conversion des cent vingt-cinq (125) parts sociales existantes ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune
en un million deux cent cinquante mille (1,250,000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune.
2 Création de dix (10) catégories de parts sociales, devant être dénommées parts sociales ordinaires, parts sociales de
catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de
catégorie E, parts sociales de catégorie F, parts sociales de catégorie G, parts sociales de catégorie H, et parts sociales de
24261
L
U X E M B O U R G
catégorie I, possédant les droits et obligations qui leur sont propres en vertu des statuts de la Société suivant leur modification
prévue au point 4 du présent ordre du jour.
3 Conversion des un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société en un million deux cent
quarante et un mille (1.241.000) parts sociales ordinaires, mille (1.000) parts sociales de catégorie A, mille (1.000) parts
sociales de catégorie B, mille (1.000) parts sociales de catégorie C, mille (1.000) parts sociales de catégorie D, mille (1.000)
parts sociales de catégorie E, mille (1.000) parts sociales de catégorie F, mille (1.000) parts sociales de catégorie G, mille
(1.000) parts sociales de catégorie H, et mille (1.000) parts sociales de catégorie I, ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune.
4 Modification de l'article 5, de l'article 21 et de l'article 22 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-
dessus.
5 Prise d'acte de la démission de Grenville Carr-Jones, Sanjeev Jewootah, Yves Cheret et Kathryn O'Sullivan en tant
que gérants de la Société.
6 Approbation de la nomination de Simon Barnes, Jens Hoellermann and James Algar en tant que gérants de la Société.
7 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé de fixer la valeur nominale des parts sociales de la Société à un centime d'euro (EUR 0,01) et en
conséquence, de convertir les cent vingt-cinq (125) parts sociales existantes ayant une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé de créer dix (10) catégories de parts sociales, devant être dénommées parts sociales ordinaires, parts
sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts
sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F, parts sociales de catégorie G, parts sociales de catégorie H, et parts
sociales de catégorie I, possédant les droits et obligations qui leur sont propres en vertu des statuts de la Société suivant
leur modification prévue au point 4 du présent ordre du jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé de convertir les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société en un
million deux cent quarante et un mille (1.241.000) parts sociales ordinaires, mille (1.000) parts sociales de catégorie A,
mille (1.000) parts sociales de catégorie B, mille (1.000) parts sociales de catégorie C, mille (1.000) parts sociales de
catégorie D, mille (1.000) parts sociales de catégorie E, mille (1.000) parts sociales de catégorie F, mille (1.000) parts
sociales de catégorie G, mille (1.000) parts sociales de catégorie H, et mille (1.000) parts sociales de catégorie I, ayant une
valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé a décidé de modifier l'article 5, l'article 21 et l'article 22 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions
ci-dessus.
L'article 5 sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital émis. Le capital émis de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) divisé en:
- un million deux cent quarante et un mille (1.241.000) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), d'une
valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées;
- mille (1.000) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées;
- mille (1.000) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B») d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées;
- mille (1.000) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C») d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées;
- mille (1.000) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D») d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées;
- mille (1.000) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E») d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées;
- mille (1.000) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F») d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées;
- mille (1.000) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G») d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées;
24262
L
U X E M B O U R G
- mille (1.000) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H») d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées; et
- mille (1.000) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») d'une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci ayant été souscrites et étant entièrement libérées.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales sont identiques sauf disposition contraire imposée par les Statuts ou
la loi.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde du compte prime d'émission peut être utilisé
aux fins de paiement de toutes parts sociales que la Société peut racheter à son/ses associé(s), pour compenser toutes pertes
non réalisées, pour distribuer des dividendes à/aux associé(s) ou pour affecter les fonds à une réserve légale.»
L'article 21 sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 21. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%),
qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque, et aussi longtemps que, la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.
Après affectation à la Réserve Légale, le(s) associé(s) décide(nt) de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils
peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau
ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés.
Pour chaque distribution de dividendes, le montant alloué à cet effet sera distribué dans l'ordre de priorité suivant:
- chaque Part Sociale Ordinaire (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être inférieur
à un pour cent (1%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale, puis,
- chaque Part Sociale de Catégorie A (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être
inférieur à deux pour cent (2%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale, puis,
- chaque Part Sociale de Catégorie B (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être
inférieur à trois pour cent (3%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale, puis,
- chaque Part Sociale de Catégorie C (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être
inférieur à quatre pour cent (4%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale, puis,
- chaque Part Sociale de Catégorie D (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être
inférieur à cinq pour cent (5%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale, puis,
- chaque Part Sociale de Catégorie E (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être
inférieur à six pour cent (6%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale, puis,
- chaque Part Sociale de Catégorie F (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être
inférieur à sept pour cent (7%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale, puis,
- chaque Part Sociale de Catégorie G (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être
inférieur à huit pour cent (8%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale, puis,
- chaque Part Sociale de Catégorie H (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être
inférieur à neuf pour cent (9%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale, puis,
- chaque Part Sociale de Catégorie I (s'il en existe) donne droit à un dividende cumulatif d'un montant ne pouvant être
inférieur à zéro dix pour cent (10%) par année de la valeur nominale de ladite part sociale (ensemble le «Droit au Bénéfice»);
enfin
après allocation du Droit au Bénéfice, le solde du montant des dividendes sera affecté dans son intégralité à toutes les
parts sociales formant alors l'ensemble des catégories de parts sociales dans l'ordre alphabétique inversé (en commençant
par les Parts Sociales de Catégorie I jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires).
Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent, le(s) Gérant
(s) peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Le(s) Gérant(s) déterminera/ont le montant
ainsi que la date de paiement de tels acomptes.
L'article 22 sera dorénavant rédigé comme suit:
“Art. 22. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-
sédant les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le(s) Gérant(s) ou toute autre personne (qui peut être
une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.
En cas de liquidation de la Société, l'ensemble des actifs et de la trésorerie de la Société devra être attribué dans l'ordre
de priorité suivant:
(i) premièrement, aux créanciers (soit par paiement, soit par constitution de provisions suffisantes en vue dudit paiement)
pour toutes les dettes et l'ensemble du passif de la Société;
(ii) deuxièmement, aux associés pour le remboursement de la valeur nominale des parts sociales détenues dans la Société;
24263
L
U X E M B O U R G
(iii) troisièmement, aux détenteurs de toutes les catégories de parts sociales dans un ordre de priorité et pour un montant
permettant d'atteindre globalement le même résultat économique que celui prévu dans les règles de distribution des divi-
dendes.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé a décidé d'accepter la démission de Grenville Carr-Jones, Sanjeev Jewootah, Yves Cheret et Kathryn O'Sul-
livan en tant que gérants de la Société avec effet à la date du présent acte, et a décidé de donner décharge à chacun d'eux
pour l'accomplissement de leur mission dans la mesure légalement possible et de décider à nouveaux quant à ladite décharge
lors de l'assemblée générale annuelle des associés d'approuver les prochains comptes annuels de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé a décidé d'approuver la nomination des personnes suivantes, en tant que nouveaux gérants de la Société, en
remplacement des gérants démissionnaires, avec effet immédiat et pour une période indéterminée:
- Simon Barnes, employé privé, né le 2 décembre 1962 à Liverpool, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle
au 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- James Algar, employé privé, né le 8 juin 1967 à Londres, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 10
Gresham Street, Londres EC2V 7JD, Royaume-Uni; et
- Jens Hoellermann, employé privé, né le 26 juillet, 1971 à Oberhausen, Allemagne, ayant son adresse professionnelle
au 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé a décidé d'accepter que le conseil de gérance de la Société est dès lors
composé de la manière suivante:
- Simon Barnes;
- James Algar; et
- Jens Hoellermann.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec, le notaire soussigné.
Signé: C. Prospert, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 5 février 2016. GAC/2016/1011. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016067168/365.
(160030187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Capital Safety Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 61.767.355,50.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 165.563.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of January.
Before Us, Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch.
THERE APPEARED:
3M West Europe B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, incorporated under the laws of the Ne-
therlands, registered with the Chamber of Commerce under number 60872357, having its registered office at 29,
Molengraaffsingel, NL-2629 JD Delft, the Netherlands (the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Mr. Alessandro MORINI, avvocato, with professional address at 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder, acting on behalf of the appearing party, and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
24264
L
U X E M B O U R G
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
(i) That it is the sole shareholder of Capital Safety Group S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société
à responsabilité limitée), established and having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 165.563
(the “Company”). The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Edouard DELOSCH, notary
at that time residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, dated November 24
th
, 2011, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 315, dated February 6
th
, 2012. The articles of association (the “Articles”)
of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary at that time residing
in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 25
th
, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 3241 dated November 4
th
, 2014;
(ii) That the Sole Shareholder has waived any convening notice right and has thus adopted the following resolutions.
<i>First resolutioni>
IT IS HEREBY RESOLVED to transfer the registered office of the Company from its current address, 59, rue de
Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above first resolution, IT IS HEREBY RESOLVED to amend with immediate effect the first
two paragraphs of the article 2 of the Articles which shall then read as follows:
“ Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Bertrange, Grand Duchy
of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Bertrange by resolution of the
Manager(s).”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notary deed was drawn up in Beringen on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known by the notary by name, surname,
quality and residence, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit La Traduction Française Du Texte Qui Précède.
L'an deux mille seize, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
A COMPARU:
3M West Europe B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, constituée selon les lois des Pays-Bas,
immatriculée à la Chambre de Commerce sous le numéro 60872357, ayant son siège social à 29, Molengraaffsingel,
NL-2629 JD Delft, Pays-Bas (l'«Associée Unique»),
ici représentée par Monsieur Alessandro MORINI, avvocato, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Ro-
main, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, à lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, de-
meurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu’il prenne acte de ce qui suit:
(i) Qu’elle est l'associée unique de Capital Safety Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, établie et ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.563 (la
«Société»), constituée par acte notarié de Maître Edouard DELOSCH, notaire alors de résidence à Rambrouch, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 24 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
315 daté du 6 février 2012, dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés en dernier lieu aux termes d’un acte reçu par
Maître Edouard DELOSCH, notaire alors de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 25 septembre
2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3241, daté du 4 novembre 2014.
(iii) Que l'Associée Unique a renoncé à tout droit de convocation préalable et a partant adopté les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
IL EST DÉCIDÉ de transférer le siège social de la Société lequel est actuellement au 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-
Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
24265
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution ci-dessus, IL EST DÉCIDÉ de modifier avec effet immédiat les deux premiers
paragraphes de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établie dans la municipalité de Bertrange, Grand-Duché de
Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit dans la municipalité de Bertrange par une décision du (des) Gérant
(s).»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Beringen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ce
dernier a signé avec Nous notaire, la présente minute.
Signé: M. MORINI, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 février 2016. Relation: 2LAC/2016/2510. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME
Beringen, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016065815/92.
(160028582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Capital Safety Canada Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.020.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 185.360.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of January.
Before Us, Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch.
THERE APPEARED:
Capital Safety Row Ltd., a private limited company incorporated under the laws of the United Kingdom, registered with
the Registrar of Companies for England and Wales under number 7890846, having its registered office at 5, Merse Road,
bâtiment Moons Moat North Industrial Estate, GB-B98 9HL Redditch, Worcestershire, United Kingdom (the “Sole Sha-
reholder”),
hereby represented by Mr. Alessandro Morini, avvocato, with professional address at 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder, acting on behalf of the appearing party, and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
(i) That it is the sole shareholder of Capital Safety Canada Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), established and having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 185.360 (the “Company”). The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Marc LOESCH,
notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, dated March 13
th
, 2014, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 1285, dated May 20
th
, 2014. The articles of association (the “Articles”)
of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary at that time residing
in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, dated March 19
th
, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1196 dated May 12
th
, 2014;
(ii) That the Sole Shareholder has waived any convening notice right and has thus adopted the following resolutions.
<i>First resolutioni>
IT IS HEREBY RESOLVED to transfer the registered office of the Company from its current address, 59, rue de
Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.
24266
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above first resolution, IT IS HEREBY RESOLVED to amend with immediate effect the first
two paragraphs of the article 2 of the Articles, which shall then read as follows:
“ Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Bertrange, Grand Duchy
of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Bertrange by resolution of the
Manager(s).”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notary deed was drawn up in Beringen on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known by the notary by name, surname,
quality and residence, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit La Traduction Française Du Texte Qui Précède.
L'an deux mille seize, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
A COMPARU:
Capital Safety Row Ltd., private limited company, constituée selon les lois du Royaume-Uni, immatriculée au Registrar
of Companies de l'Angleterre et des Pays de Galles sous le numéro 7890846, ayant son siège social à 5, Merse Road,
bâtiment Moons Moat North Industrial Estate, GB-B98 9HL Redditch, Worcestershire, Royaume-Uni (l'«Associée Uni-
que»),
ici représentée par Monsieur Alessandro Morini, avvocato, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, à lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, de-
meurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu’il prenne acte de ce qui suit:
(i) Qu’elle est l'associée unique de Capital Safety Canada Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.360 (la
«Société»), constituée par acte notarié de Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 13 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1285 daté
du 20 mai 2014, dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés en dernier lieu aux termes d’un acte reçu par Maître Edouard
DELOSCH, notaire de alors résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 19 mars 2014, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1196, daté du 12 mai 2014.
(iii) Que l'Associée Unique a renoncé à tout droit de convocation préalable et a partant adopté les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
IL EST DÉCIDÉ de transférer le siège social de la Société lequel est actuellement au 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-
Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution ci-dessus, IL EST DÉCIDÉ de modifier avec effet immédiat les deux premiers
paragraphes de l'article 2 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établie dans la municipalité de Bertrange, Grand-Duché de
Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit dans la municipalité de Bertrange par une décision du (des) Gérant
(s).»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Beringen, date qu’en tête des présentes.
24267
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ce
dernier a signé avec Nous notaire, la présente minute.
Signé: M. MORINI, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 février 2016. Relation: 2LAC/2016/2509. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME
Beringen, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016065814/94.
(160028583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
IPD Luxembourg G.m.b.H, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 202.129.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of the month of December;
Before the undersigned notary Danielle KOLBACH, residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg);
APPEARED:
The limited company governed by the laws of Hong Kong “IPD Hong Kong Limited”, with registered office in Hong
Kong, 95 Queensway, United Centre, 18
th
floor, apt. F, registered with the Hong Kong Companies' Registry under number
2310569,
here duly represented by its individual authorized to sign director Mr. Eldar MIRZOEV, company director, born in
Tbilissi (Georgia), on January 26, 1982, residing in A-1190 Vienna, Rudolfinergasse 22/2 (Republic of Austria).
Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of a
private limited liability company (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) to establish as follows:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There is hereby established a private limited company („Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“) under the name “IPD Luxembourg G.m.b.H.”, (hereinafter the “Company”) governed by the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (the
“Articles”).
Art. 2. Purpose.
2.1 The object of the Company is the administration of the Company's own assets, the acquisition of participations,
interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests
and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2 The Company may borrow and raise funds in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private
placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds
including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities such as, among others, the providing of loans and
the granting of guarantees or securities in any kind or form, to its subsidiaries or companies in which it has a direct or
indirect interest, even not substantial, or to any company being a direct or indirect corporate unit holder of the Company
or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Affiliated Companies”).
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Affiliated Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create securities over all or over
some of its assets.
2.3 Furthermore, the Company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
2.5 The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect invest-
ments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting,
dividing, exhausting, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6 The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not restrictive.
24268
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of corporate unit
holders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg).
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of corporate unit holders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of asso-
ciation.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Corporate capital - Corporate units
Art. 5. Corporate Capital.
5.1 The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), divided into one hundred and
twenty (120) corporate units without designation of nominal value.
5.2 The Company’s capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of corporate unit holders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own corporate units.
Art. 6. Corporate units.
6.1 The Company’s capital is divided into corporate units, each of them having the same nominal value.
6.2 The corporate units of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several corporate unit holders, with a maximum of forty (40) corporate unit holders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the corporate unit holders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of corporate units - Transfer of corporate units.
7.1 A register of corporate unit holders shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available
for inspection by any corporate unit holder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates
of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant corporate unit holder.
7.2 The Company will recognise only one holder per corporate unit. In case a corporate unit is owned by several persons,
they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to
suspend the exercise of all rights attached to that corporate unit until such representative has been appointed.
7.3 The corporate units are freely transferable among corporate unit holders.
7.4 Inter vivos, the corporate units may only be transferred to new corporate unit holders subject to the approval of such
transfer given by the corporate unit holders at a majority of three quarters of the corporate capital.
7.5 Any transfer of corporate units shall become effective towards the Company and third parties through the notification
of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the corporate units of the deceased corporate unit holder may only be transferred to new
corporate unit holders subject to the approval of such transfer given by the surviving corporate unit holders at a majority
of three quarters of the corporate capital. Such approval is, however, not required in case the corporate units are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased corporate unit holder.
C. Decisions of the corporate unit holders
Art. 8. Collective decisions of the corporate unit holders.
8.1 The general meeting of corporate unit holders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
8.2 Each corporate unit holder may participate in collective decisions irrespective of the number of corporate units which
he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) corporate unit holders, collective decisions
otherwise conferred on the general meeting of corporate unit holders may be validly taken by means of written resolutions.
24269
L
U X E M B O U R G
In such case, each corporate unit holder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded
and shall cast his vote in writing.
8.4 In the case of a sole corporate unit holder, such corporate unit holder shall exercise the powers granted to the general
meeting of corporate unit holders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In
such case, any reference made herein to the “general meeting of corporate unit holders” shall be construed as a reference
to the sole corporate unit holder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting
of corporate unit holders shall be exercised by the sole corporate unit holder.
Art. 9. General meetings of corporate unit holders. In case the Company has more than twenty-five (25) corporate unit
holders, at least one general meeting of corporate unit holders shall be held within six (6) months of the end of each financial
year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening
notice of such meeting. Other meetings of corporate unit holders may be held at such place and time as may be specified
in the respective convening notices of meeting. If all of the corporate unit holders are present or represented at a general
meeting of corporate unit holders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior
notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each corporate unit holder is entitled to as many votes as he holds corporate units.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
corporate unit holders are only validly taken in so far as they are adopted by corporate unit holders holding more than half
of the corporate capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the corporate unit
holders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time
by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast
whichever is the fraction of the corporate capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The corporate unit holders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of corporate unit holders (ii) representing three quarters of the corporate capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of corporate unit holders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of corporate unit holders which shall determine their
remuneration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the corporate unit holders representing more than half of the Company’s corporate capital.
14.3 The general meeting of corporate unit holders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being
class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the
relevant corporate unit holders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of corporate unit holders which shall resolve on
the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of corporate unit holders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
24270
L
U X E M B O U R G
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of corporate unit holders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
corporate unit holders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such
minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of corporate unit holders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by
one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of corporate unit holders has appointed different classes of managers (namely class A ma-
nagers and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature
of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of
such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) corporate unit holders, the operations of the
Company shall be supervised by one or several internal auditors (Rechnungskommissar(e)). The general meeting of cor-
porate unit holders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of corporate unit holders.
24271
L
U X E M B O U R G
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the corporate unit holders of the Company appoint one or more independent qualified auditors (unabhängige(r)
qualifizierte(r) Wirtschaftsprüfer) in accordance with article 69 of the law of December 19, 2002 regarding the trade and
companies’ register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor
(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of corporate unit holders with cause or with
its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the corporate capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a corporate unit holder may also be allocated to the legal reserve
if the contributing corporate unit holder agrees with such allocation.
22.4 In case of a corporate capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the corporate capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of corporate unit holders shall determine
how the remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units they hold
in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premium.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the corporate
unit holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of corporate unit
holders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise pro-
vided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and ends on December 31, 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the one hundred and twenty (120) corporate units have been subscribed by
the sole shareholder, the company “IPD Hong Kong Limited”, pre-designated and represented as said before, and fully
paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.-
EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary,
who expressly attests thereto.
24272
L
U X E M B O U R G
<i>Verificationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of
the amended law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the
subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:
1) The registered office of the Company is established at 296, rue de Neudorf, in L-2222 Luxembourg.
2) Mr. Eldar MIRZOEV, company director, born in Tbilissi (Georgia), on January 26, 1982, residing in A-1190 Vienna,
Rudolfinergasse 22/2 (Republic of Austria), is appointed as manager of the Company for an unlimited term.
3) According to article 19 of the Articles, the Company is validly bound in any circumstances and without any restrictions
by the sole signature of the manager.
<i>Costs and expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred and thirty
Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the legal representative of the appearing party, acting as said before, known to the
notary by name, first name and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierten Tag des Monats Dezember;
Vor der unterzeichnenden Notarin Danielle KOLBACH, mit Amtssitz in Redingen/Attert (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die limited company geregelt nach den Gesetzen Hong Kongs „IPD Hong Kong Limited“, mit Sitz in Hong Kong, 95
Queensway, United Centre, 18
th
floor, apt. F, eingetragen im Hong Kong Companies' Registry unter der Nummer 2310569,
hier rechtmäßig vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Direktor, Herr Eldar MIRZOEV, Gesellschafts-
verwalter, geboren in Tbilissi (Georgien), am 26. Januar 1982, wohnhaft in A-1190 Wien, Rudolfinergasse 22/2 (Republik
Österreich).
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründ-
enden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Gegründet wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung
„IPD Luxembourg G.m.b.H.“, (hiernach die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung (die „Statuten“)
unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen
und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile
und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien,
Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz
allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich
welcher Art begeben wurden.
2.2 Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und
beschaffen. Sie kann - ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie
Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen
und/oder Emissionen von Schuldtiteln, unter anderem die Gewährung von Darlehen, Garantien oder Sicherheiten in jeg-
licher Art und Weise, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesell-
schafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind
(nachfolgend als die „verbundenen Unternehmen“ bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicher-
24273
L
U X E M B O U R G
heiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu
besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder
in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.
2.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder sons-
tigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.
2.4 Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des
effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.
2.5 Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten
Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Ei-
gentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung,
Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise
von beweglichem Vermögen oder Immobilien.
2.6 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-
hundertzwanzig (120) Anteile ohne Angabe des Nominalwertes.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
24274
L
U X E M B O U R G
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-
lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
24275
L
U X E M B O U R G
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
24276
L
U X E M B O U R G
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens
eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii)
durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschrifts-
befugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung ernennt die
Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige qualifizierte Wirtschaftsprüfer ernennen, entfällt die Funktion des
Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinnund
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
24277
L
U X E M B O U R G
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die einhundert (100) Anteile durch die alleinige Gesell-
schafterin, die Gesellschaft „IPD Hong Kong Limited“, vorbezeichnet und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und
voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab
sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Beglaubigungi>
Die unterzeichnende Notarin gibt hiermit an, beglaubigt und ausdrücklich vermerkt zu haben, dass die aufgezählten
Bedingungen des Artikels 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hier erfüllt
worden sind.
<i>Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterini>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienen Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird auf 296, rue de Neudorf, in L-2222 Luxemburg festgelegt.
2) Herr Eldar MIRZOEV, Gesellschaftsverwalter, geboren in Tbilissi (Georgien), am 26. Januar 1982, wohnhaft in
A-1190 Wien, Rudolfinergasse 22/2 (Republik Österreich), wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte
Dauer ernannt.
3) In Einklang mit Artikel 19 der Statuten wird die Gesellschaft rechtmäßig in allen Umständen und ohne Einschrän-
kungen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers vertreten.
<i>Kosten und Auslageni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendeinhundertdreißig
Euro.
<i>Erklärungi>
Die unterzeichnete Notarin, welche die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der
oben genannten erschienen Partei, die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deut-
schen Fassung; gemäß dem Wunsch derselben erschienen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den gesetzlichen Vertreter der erschienenen Partei, handelnd wie zuvor
erwähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns,
der Notarin, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: E. MIRZOEV - D. KOLBACH.
24278
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Diekirch-Actes Civils, le 7 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21013. Reçu: 75,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt.
Redingen/Attert, am 11. Dezember 2015.
Référence de publication: 2015200863/599.
(150225564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
European Sovereign Bond Protection Facility, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 166.304.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand and fifteen, on the third day of December.
Before, the undersigned Maître Cosita Delvaux, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of European Sovereign Bond Protection Facility (hereinafter
the "Company"), a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 2, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 166304, incorporated
by a deed drawn up on 5 January 2012 by Maître Cosita Delvaux, notary then residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy
of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 592, page 28389 dated
6 March 2012, and whose articles of association (the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed of
the undersigned notary, Maître Cosita Delvaux, dated 18 September 2015, and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 3139 on 18 November 2015, page 150645.
The meeting is opened at 12.12 by Mr. Kalin A. Anev, with professional address in Luxembourg, being in the chair (the
"Chairman"), with the consent of the meeting.
The Chairman appointed as secretary, Mr. Florian Zinoecker, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mr. Ralf Jansen, with professional address in Luxembourg.
These appointments having been made, the Chairman declared that and requested the notary to state that:
I.- The shareholder represented (the "Sole Shareholder") and the number of shares held by it are indicated on an atten-
dance list. This list and the proxy, after having been signed by the appearing person, the members of the bureau of the
meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.
II.- This attendance list shows that all the one thousand nine hundred and ten (1,910) shares of the Company, all issued
in registered form, representing 100% of the share capital of the Company, are represented at the present extraordinary
general meeting so that the meeting can validly decide on all the issues of the agenda which are known by the Sole
Shareholder.
III.- The Sole Shareholder of the Company declares to have been duly informed of the holding of the present meeting
and of its agenda and decides to waive all convening notices procedure in relation to this meeting.
IV.- An extraordinary general meeting of the Sole Shareholder held before the undersigned notary, Maître Cosita Del-
vaux on 18 September 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3139 on 18
November 2015, page 150645, resolved to dissolve and liquidate the Company. The same extraordinary general meeting
appointed as liquidator, Mr. Kai Hennen, with professional address at 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg. By resolutions of the Sole Shareholder taken under private seal on 1
st
December
2015, the Sole Shareholder took knowledge of the report of the liquidator, and appointed as auditor to the liquidation
PricewaterhouseCoopers, a Luxembourg société coopérative, having its registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 65477.
V.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Submission of the report of the auditor to the liquidation.
2. Approval of the liquidation accounts and discharge of the liquidator and of the auditor to the liquidation.
3. Closing of the liquidation.
4. Decision to store the registers and company documents during a period of five years following the date of the present
resolutions at the address of the sole shareholder of the Company, the European Financial Stability Facility, at 6a, Circuit
de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
24279
L
U X E M B O U R G
5. Discharge of the members of the board of directors of the Company and of the independent auditor (réviseur d'en-
treprises agréé).
6. Grant of a special power to the liquidator of the Company after the expiration of his mandate to pay the remaining
debts, if any, to distribute to the Sole Shareholder of the Company the balance of the cash that would remain on the bank
account, if any, after payment of the remaining debts, if any, and to complete and sign all the documents necessary to effect
the closing of the liquidation.
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to approve the report dated 1 December 2015 of the auditor to the liquidation in the form
as attached to the present minutes in Schedule 1.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to approve the liquidation accounts, as attached to the report of the liquidator, and to
discharge both the liquidator and auditor to the liquidation, of any present or future responsibilities in relation to the
execution of their respective mandates.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to pronounce the closing of the liquidation of the Company and stated that the Company
ceased to exist.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved that the Company's books and documents will be stored during a period of five years
from the date of the present resolutions at the address of the European Financial Stability Facility, a Luxembourg société
anonyme, having its registered office at 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 153414, at 6a, Circuit
de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to discharge of any present or future responsibility in relation to the execution of their
respective mandates both the members of the board of directors and the independent auditor (réviseur d'entreprises agréé)
of the Company, which were in charge until the liquidation of the Company was pronounced.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to grant a special power to the liquidator of the Company after the expiration of his
mandate to pay the remaining debts, if any, to distribute to the Sole Shareholder of the Company the balance of the cash
that would remain on the bank account, if any, after payment of the remaining debts, if any, and to complete and sign all
the documents necessary to effect the closing of the liquidation.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1.200,-).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed at 12.23.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois de décembre.
Par-devant le soussigné Maître Cosita Delvaux, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique d'European Sovereign Bond Protection Facility (ci-après
la "Société"), une société anonyme régie et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 2, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166304, constituée par acte de Maître Cosita Delvaux, notaire
alors de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 janvier 2012, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 592, page 28389 du 6 mars 2012, et dont les statuts (les "Statuts") ont
24280
L
U X E M B O U R G
été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, Maître Cosita Delvaux, en date du 18 septembre 2015,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3139 du 18 novembre 2015, page 150645.
L'assemblée générale est ouverte à 12h12 par M. Kalin A. Anev, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg,
occupant la présidence de l'assemblée générale (le "Président") avec le consentement de l'assemblée générale.
Le Président a nommé comme secrétaire M. Florian Zinoecker, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg.
L'assemblée générale a élu comme scrutateur M. Ralf Jansen, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg.
Ces nominations ayant été faîtes, le Président a déclaré que et a demandé au notaire d'acter que:
I.- L'actionnaire représenté ("l'Actionnaire Unique") et le nombre d'actions détenues par lui sont renseignés sur une liste
de présence. Cette liste de présence ainsi que la procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante,
les membres du bureau de l'assemblée générale et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enre-
gistrées avec lui.
II.- Il ressort de la liste de présence que les mille neuf cent dix (1.910) actions de la Société, toutes émises sous forme
nominative, représentant 100% du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire de sorte que l'assemblée générale peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour, qui sont
connus de l'Actionnaire Unique.
III.- L'Actionnaire Unique de la Société déclare avoir été correctement informé de la tenue de la présente assemblée
générale et de son ordre du jour et décide de renoncer aux formalités de convocation relatives à cette assemblée générale.
IV.- Une assemblée générale extraordinaire de l'Actionnaire Unique tenue par devant le notaire soussigné, Maître Cosita
Delvaux le 18 septembre 2015, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3139 du 18 novembre
2015, page 150645, a décidé de dissoudre et liquider la Société. La même assemblée générale extraordinaire a nommé
comme liquidateur, M. Kai Hennen, ayant son adresse professionnelle au 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Par résolutions de l'Actionnaire Unique prises sous seing privé le 1
er
dé-
cembre 2015, l'Actionnaire Unique a pris connaissance du rapport du liquidateur et nommé comme commissaire à la
liquidation PricewaterhouseCoopers, une société coopérative luxembourgeoise, ayant son siège social au 2, rue Gerhard
Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477.
V.- L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Soumission du rapport du commissaire à la liquidation.
2. Approbation des comptes de liquidation et décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision de conserver les registres et les livres sociaux pendant une période de cinq ans à compter de la date des
présentes résolutions à l'adresse d'European Financial Stability Facility au 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
5. Décharge des membres du conseil d'administration de la Société et du réviseur d'entreprises agréé.
6. Octroyer un pouvoir spécifique au liquidateur de la Société après l'expiration de son mandat pour payer les dettes
restantes, s'il y a lieu, pour distribuer le cas échéant à l'Actionnaire Unique de la Société le reliquat d'argent qui resterait
sur le compte bancaire après paiement des dettes restantes, s'il y en a, et pour finaliser et signer tous les documents néces-
saires pour effectuer la clôture de la liquidation.
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé d'approuver le rapport en date du 1
er
décembre 2015 du commissaire à la liquidation,
en la forme telle qu'attachée aux présentes minutes en Schedule 1.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé d'approuver les comptes de liquidation, tels qu'attachés au rapport du liquidateur, et de
donner décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation, pour toutes responsabilités présentes ou futures en relation
avec l'exécution de leurs mandats respectifs.
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société et a déclaré que la Société a cessé
d'exister.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de conserver les registres et les livres sociaux de la Société pendant une période de cinq
ans à compter de la date des présentes résolutions à l'adresse d'European Financial Stability Facility, une société anonyme
luxembourgeoise, ayant son siège social au 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Grand-Duché de
24281
L
U X E M B O U R G
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153414,
au 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de décharger de toutes responsabilités présentes ou futures en relation avec l'exécution
de leurs mandats respectifs les membres du conseil d'administration et le réviseur d'entreprises agréé de la Société, qui
étaient en fonction jusqu'à ce que la liquidation de la Société soit prononcée.
<i>Sixième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé d'octroyer un pouvoir spécifique au liquidateur de la Société après l'expiration de son
mandat pour payer les dettes restantes, s'il y a lieu, pour distribuer le cas échéant à l'Actionnaire Unique de la Société le
reliquat d'argent qui resterait sur le compte bancaire après paiement des dettes restantes, s'il y en a, et pour finaliser et signer
tous les documents nécessaires pour effectuer la clôture de la liquidation.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée générale,
l'assemblée générale est close à 12h23.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la personne comparante le présent acte
est rédigé en anglais suivi par une version française, et qu'à la demande de la personne comparante, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
Cet acte notarié a été préparé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Ce document ayant été lu à la personne comparante, qui est connue par le notaire par son nom de famille, prénom, état
civil et résidence, la personne comparante, et le notaire, ont ensemble signé cet acte.
Signé: K. A. ANEV, F. ZINOECKER, R. JANSEN, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 07 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38672. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015200703/186.
(150225903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
BMT International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89D, rue Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 184.270.
In the year two thousand fifteen, the twenty-fifth day of November
Before us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of the public limited liability company (société
anonyme) existing under the name of “BMT International S.A.”, incorporated and governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 89D, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 184.270 and incorporated pursuant to a
deed of Maître Francis Kesseler, public notary residing at Esch-sur-Alzette, dated December 18, 2013, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 869, page 41 668 on April 4, 2014; the articles of association
have been amended for the last time by a deed received on 2 December 2014 (hereafter referred to as the “Company”).
The Meeting was opened by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange,
being in the chair, who appointed as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
1. The agenda of the Meeting is the following:
a. Increase of the share capital of the Company by means of a contribution in cash in order to raise it from its current
amount of twenty-six million three hundred and thirty-one thousand four hundred Euros (EUR 26,331,400.-) to twenty-six
million seven hundred and ninety thousand five hundred and ten Euros (EUR 26,790,510-), by issuing one thousand four
hundred and eighty-one (1,481) new shares, without indication of nominal value (the “New Shares”);
24282
L
U X E M B O U R G
b. Acknowledgement of the report of the board of directors of the Company pursuant to article 32-3 (5) of the law on
commercial companies dated August 10, 1915, as amended from time to time, related to the withdrawal of the preferential
subscription rights of the shareholders (the “Report”) and approval of the withdrawal of the preferential subscription rights
of the shareholders in relation to the issuance of the New Shares;
c. Subscription for and full payment by B.M.T. NV, a public limited liability company (Naamloze Vennootschap),
incorporated and existing under the laws of Belgium, having its registered office at Kortrijksesteenweg 1097 B, 9051 Sint-
Denijs-Westrem, Belgium, registered with the Belgian Register of Legal Persons (Rechtspersonenregister Ghent commer-
cial court division Ghent) (judicial area Oost-Vlaanderen) no. 406.069.021 (hereafter referred to as “BMT NV”) of the
New Shares at par value of three hundred and ten Euros (EUR 310) per New Share plus a share premium in an amount of
EUR 4,290,890, by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 4,750,000.- to the Company;
d. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of
the corporate capital of the Company; and
e. Miscellaneous.
2. The shareholders represented at the Meeting (the “Shareholders”), the proxyholder(s) of the represented Shareholders
and the number of their shares are shown on an attendance list, signed “ne varietur” by the proxyholder(s) of the represented
Shareholders, the members of the bureau and the undersigned notary.
3. As recorded in the aforementioned attendance list, all the eighty four thousand nine hundred forty (84,940) shares of
the Company, without nominal value, are represented at the present Meeting, which is consequently constituted and may
validly deliberate and decide on the different items of the agenda.
4. The Shareholders waive the prior convening notice, considering themselves duly convened and declaring having full
knowledge of the purpose and the agenda of the Meeting.
After the foregoing has been approved by the Shareholders, the Meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting unanimously RESOLVES to increase the share capital of the Company from its current amount of twenty-
six million three hundred and thirty-one thousand four hundred Euros (EUR 26,331,400) to twenty-six million seven
hundred and ninety thousand five hundred and ten Euros (EUR 26,790,510-), by issuing one thousand four hundred and
eighty-one (1,481) New Shares.
<i>Second resolutioni>
The Meeting ACKNOWLEDGES the Report and unanimously RESOLVES to withdraw the preferential subscription
rights of the shareholders of the Company in relation to the issuance of the New Shares.
<i>Third resolutioni>
The Meeting unanimously RESOLVES to approve the subscription and full payment of the New Shares by BMT NV
by means of contribution in cash as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
BMT NV, hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy established
on 23 October 2015 under private seal, DECLARES to subscribe for the New Shares, and to fully pay up the New Shares
at par value of EUR 310 per new share together with a share premium in an amount of EUR 4,290,890, by way of the
contribution in cash, in an aggregate amount of four million seven hundred and fifty thousand Euro (EUR 4,750,000).
The person appearing declares that the New Shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its
disposal the total amount of EUR 4,750,000.-.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Meeting unanimously RESOLVES to amend the article 5.1 of the
articles of association of the Company which will henceforth read as follows:
5.1. Share Capital - share premium - reserves. “The issued share capital of the Company is set at twenty-six million
seven hundred and ninety thousand five hundred and ten Euros (EUR 26,790,510-) divided into eighty-six thousand four
hundred and twenty-one (86,421) shares without indication of nominal value.”
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing parties, who signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour de novembre
24283
L
U X E M B O U R G
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de la société anonyme existant sous la déno-
mination de “BMT International S.A.”, constituée et soumise aux lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 89D, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.270, et constituée par un acte de Maître Francis Kesseler, alors
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 18 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 869, page 41 668, du 4 avril 2014; les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant un acte reçu
le 2 décembre 2014 (la “Société”).
L'Assemblée a été ouverte par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant profession-
nellement à Pétange, assurant la présidence, qui a désigné comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée,
demeurant professionnellement à Pétange.
L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, demeurant professionnellement à Pé-
tange.
Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:
1. L'ordre du jour de l'Assemblée est la suivante:
a. Augmentation du capital social de la Société par un apport en numéraire en vue de l'augmenter de son montant actuel
de vingt-six millions trois cent trente et un mille quatre cent Euros (EUR 26.331.400.-) à vingt-six millions sept cent quatre-
vingt-dix mille cinq cent dix Euros (26.790.510.-) par l'émission de mille quatre cent quatre-vingt-un (1.481) nouvelles
actions, sans indication de la valeur nominale (les “Nouvelles Actions”);
b. Prise de connaissance du rapport du conseil de gérance de la Société en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, lié au retrait des droits préférentiels de souscription des ac-
tionnaires (le “Rapport”) et approbation du retrait des droits préférentiels de souscription des actionnaires en lien avec
l'émission des Nouvelles Actions;
c. Souscription pour, et libération intégrale par B.M.T. NV, une société anonyme (Naamloze Vennootschap), constituée
et existante sous les lois de Belgique, ayant son siège social à Kortrijksesteenweg 1097 B, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Belgique, immatriculée auprès du Registre Belge des Personnes Morales (Rechtspersonenregister Ghent commercial court
division Ghent) (espace judiciaire Oost-Vlaanderen) no. 406.069.021 (ci-après “BMT NV”) des Nouvelles Actions dont
le pair comptable s'élève à trois cent dix Euros (EUR 310.-) par Nouvelle Action, et d'une prime d'émission d'un montant
de EUR 4.290.890.-, par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 4.750.000.-, à la Société;
d. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation du capital social
de la Société; et
e. Divers
2. Les actionnaires représentés à l'Assemblée (les “Actionnaires”), le/les mandataire(s) des Actionnaires représentés
ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence, signée ne varietur par le/les mandataire
(s) des Actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant.
3. Tel qu'enregistré dans la prédite liste de présences, toutes les quatre-vingt-quatre mille neuf cent quarante (84.940)
actions de la Société, sans indication de la valeur nominale, sont représentées à la présente Assemblée, qui est en consé-
quence constituée et peut valablement délibérer et décider sur les différents points de l'ordre du jour.
4. Les Actionnaires renoncent à la convocation préalable, se considérant dûment convoqués et déclarant avoir entière
connaissance de l'objet et de l'ordre du jour de l'Assemblée.
Après que ce qui précède ait été approuvé par les Actionnaires, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DECIDE à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-six
millions trois cent trente et un mille quatre cent Euros (EUR 26.331.400.-) à vingt-six millions sept cent quatre-vingt-dix
mille cinq cent dix Euros (EUR 26.790.510.-), par l'émission de mille quatre cent quatre-vingt-un (1.481) Nouvelles Ac-
tions.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée PREND CONNAISSANCE du Rapport et DECIDE à l'unanimité de supprimer les droits préférentiels de
souscription des actionnaires de la Société en lien avec l'émission des Nouvelles Actions.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE à l'unanimité d'approuver la souscription et la libération intégrale des Nouvelles Actions par
BMT NV par un apport en numéraire comme suit:
24284
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription - Paiementi>
BMT NV, ici représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'une procuration établie
le 23 octobre 2015 par acte sous seing privé, DECLARE souscrire les Nouvelles Actions, et libérer intégralement les
Nouvelles Actions dont le pair comptable s'élève à EUR 310.- par nouvelle action, avec une prime d'émission d'un montant
de EUR 4.290.890.-, par le biais d'un apport en numéraire pour un montant total de quatre millions sept cent cinquante
mille Euros (EUR 4.750.000.-).
La personne comparante déclare que les Nouvelles Actions ont été intégralement libérées en numéraire et que la Société
dispose de la somme de EUR 4.750.000.-.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée DECIDE à l'unanimité de modifier l'article 5.1 des statuts de
la Société qui devra désormais se lire comme suit:
5.1. Capital Social - prime d'émission - réserves. “Le capital social émis est établi à vingt-six millions sept cent quatre-
vingt-dix mille cinq cent dix Euros (EUR 26.790.510.-) divisé en quatre-vingt-six mille quatre cent vingt et un (86.421)
actions sans indication de la valeur nominale”.
Le notaire instrumentant, qui maîtrise la langue anglaise, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent
acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
DONT acte notarié, dressé et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé l'original du présent acte avec le notaire
Signé: Conde, Gomes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1
er
décembre 2015. Relation: EAC/2015/28431. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200597/156.
(150225995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Sky (Logistics) Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Corridor (West Gate) Pledgeco S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 200.269.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN,
ON THE SECOND DAY OF THE MONTH OF DECEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Kensington Italy Office S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 197.593 (the “Sole Shareholder”),
represented by Maître Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy
dated 1 December 2015, which proxy shall be registered together with the present deed,
being the Sole Shareholder of Corridor (West Gate) Pledgeco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited
liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 200.269 (the "Company"),
incorporated on 18 September 2015 pursuant to a deed of Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 16 November
2015 number 3116.
The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Cosita
DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 20 November 2015, not yet published in
the Mémorial.
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
24285
L
U X E M B O U R G
1. The Sole Shareholder holds all the five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital
is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.
2. The item on which a resolution is to be taken is as follows:
Amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so that Article 1 of the articles of association
of the Company reads as follows:
“A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Sky (Logistics) Midco S.à r.l.” (the
“Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Com-
pany will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”
Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend Article 1 of the articles of association of the Company so that Article 1 of the
articles of association of the Company reads as set out in the above agenda.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1,800.-.
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above
appearing party the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN,
AM ZWEITEN TAG DES MONATS DEZEMBER.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Kensington Italy Office S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxem-
burgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 197.593 (der «Alleinige Gesellschafter»),
hier vertreten durch Maître Perrine Reinhart, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 1. Dezember 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei
der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden,
als Alleiniger Gesellschafter der Corridor (West Gate) Pledgeco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft
mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren
Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer B 200.269 (die «Gesellschaft»), gegründet am 18. September 2015 gemäß
Urkunde aufgenommen durch Maître Cosita DELVAUX, Notar mit Amtsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») am 16. November 2015, Nummer
3116.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Cosita DELVAUX,
Notar mit Amtsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 20. November 2015, noch nicht im Mémorial veröf-
fentlicht.
Der Erschienene gibt, in Ausübung seines obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesell-
schaftsanteile, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der Tagesordnung
entschieden werden kann.
2. Der Punkt über den ein Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:
Abänderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft so dass Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wort-
laut hat:
“Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Sky (Logistics) Midco
S.à r.l." (die“Gesellschaft“) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als
Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende lu-
xemburgische Gesetzgebung geregelt.”
24286
L
U X E M B O U R G
Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 1 der
Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie in der Tagesordnung beschrieben.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte
entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 1.800,-.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage
der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung
maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei der dem
amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe zusammen mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. REINHART, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 04 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38548. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12. Dezember 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015200635/107.
(150225928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Catelan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 122.261.
L'an deux mille quinze, le trois décembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de “CATELAN S.A.”, une société anonyme régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 2, Rue Gabriel Lippmann,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 122261, (la “Société”), a été
constituée par acte de Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Lu-
xembourg), en date du 16 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 114 du 5
février 2007 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 mars 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 974 du 8 mai 2010.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le Président désigne, Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement
à Luxembourg, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Monsieur Paul DIEDERICH, diplômé en sciences économétriques, demeurant professionnellement
à Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs;
3. Décharge aux administrateurs;
4. Décharge au commissaire aux comptes.
24287
L
U X E M B O U R G
B) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau ainsi que le notaire, restera annexé au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement;
C) Qu'il appert de ladite liste de présence que toutes les quatre cent cinquante (450) actions représentant l'intégralité du
capital social sont présentes ou représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer “FIDESCO S.A.”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 68578, en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de
la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation,
afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de
la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous verse-
ments d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article
148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice
de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.
L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les
administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de
renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. BRAUN, J-M. POOS, P. DIEDERICH, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 04 décembre 2015. 2LAC/2015/27767. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200650/79.
(150225295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
24288
4m Lux S.A.
ACHM International Management Company S.à r.l.
Affinia Luxembourg Finance S.à r.l.
Alcentra Global Special Situations Luxembourg S.à r.l.
Apreamare S.A.
Argor, Société Financière d'Entreprises et de Projets Industriels
Asport I & W, S.à r.l.
Assuralux S.àr.l.
AS Tower S.à r.l.
Atlas Invest S.A.
ATM S.A.
Auberge du Pont, Wiltz s.à r.l.
Au Galop s.à r.l.
BMT International S.A.
Builders Reinsurance S.A.
Capital Safety Canada Holdings S.à r.l.
Capital Safety Group S.à r.l.
Catalyst EPF II Lux 2 S.à r.l.
Catelan S.A.
Commerce de Bois à Luxembourg S.à r.l.
Contractors Reinsurance S.A.
Corridor (West Gate) Pledgeco S.à r.l.
Cyvalux S.A.
DZPB II
Epicerie Clair Chêne S.à r.l.
Epicerie Mercante S.à r.l.
European Sovereign Bond Protection Facility
Franklin Templeton Investment Funds
Gamma Holdco (Luxembourg) S.à r.l.
Georose 3
H. & S. Nutzfahrzeuge GmbH
IPD Luxembourg G.m.b.H
Patron Capital Investments S.à r.l.
Sky (Logistics) Midco S.à r.l.
Swisstar S.A.
Teal Darlaston S.à r.l.
T-Lux
Trans Ardennes
Transmar Holding S.A.
Transmar Holding S.A.
Transmar Holding S.A.
Treveria Thirty S.à r.l.
Vabermain Sàrl
Valentin Capital Management S.A.
Vector International Investments S.à r.l.
Vesera Sàrl
Vita-Cars S.à r.l.