logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 777

20 mars 2015

SOMMAIRE

Aberdeen Indirect Property Partners Acti-

ve Soparfi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37290

AIE EuroLux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37289

Asia III Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37292

carloscorreiarchitecte s.a. . . . . . . . . . . . . . . .

37294

Carros Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

37251

CCArchitectes s.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37294

CO2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37251

Cordet Co-Investment SCSp  . . . . . . . . . . . .

37251

Creation Design International S.A.  . . . . . .

37250

Custom Sensors & Technologies Luxem-

bourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37251

Digital Services XLIV (GP) S.à.r.l.  . . . . . . .

37257

Digital Services XLV (GP) S.à.r.l.  . . . . . . . .

37268

Espirito Santo Industrial S.A. . . . . . . . . . . . .

37250

Euro Road Services LTD  . . . . . . . . . . . . . . . .

37250

Groupe Renaissance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

37252

Horses One S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37253

House for You S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37253

IIL Investments S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . .

37283

Immobilière des Glacis S. à r.l.  . . . . . . . . . .

37253

Immochelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37254

IN4MATIX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37252

Intellux Capital Management S.A., SPF  . .

37250

Intertrust Management (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37251

Investissements Mobiliers Européens et In-

ternationaux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37252

Ire Hotel II Rad Blu Cologne  . . . . . . . . . . . .

37252

I & S Coiffure S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37253

Jardin du Pain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37251

Jardin Populaire S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37252

JCM Famille s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37253

Köhl Maschinenbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37253

Legio Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37254

L'Européenne du Stationnement  . . . . . . . .

37279

Luxluce S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37254

Marowinia S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37296

MC GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37296

MP B S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37256

Palan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37254

Participating Monetary Organization  . . . .

37255

Participe S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37255

Passiflora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37256

Pasta Mano S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37256

Pasta Mano S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37256

Pasta Mano S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37256

Patron ES Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

37255

Pfaudler Midco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37255

PolyOne Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

37255

UBS Luxembourg Financial Group Asset

Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37287

37249

L

U X E M B O U R G

Euro Road Services LTD, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8210 Mamer, 90, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 166.173.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 10 février 2015.
1. Démission du représentant permanent: L'assemblée prend note de la démission de Monsieur VALENTIM FERREIRA

Manuel de son poste de représentant permanent.

2. Nomination d'un nouveau représentant permanent: L'assemblée nomme comme nouveau représentant permanent

Monsieur BUCHET Patrick né le 11.07.1958 domicilié à 9 Rue du Silo à F - 59185 PROVIN.

Référence de publication: 2015024973/12.
(150027688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Espirito Santo Industrial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 39.299.

<i>Extrait de la décision sur la nomination d'un dépositaire des actions et parts sociales au porteur du 06.02.2015

Le Conseil d'Administration de la société ESPIRITO SANTO INDUSTRIAL S.A.
décide de nommer
FIDUCIAIRE GLACIS SARL, experts comptables, demeurant au
18 A, boulevard de la Foire L -1528 Luxembourg
comme dépositaire des actions et parts sociales au porteur.

Junglinster, le 11 février 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME
Paul LAPLUME

Référence de publication: 2015024967/16.
(150028499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Intellux Capital Management S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 133.634.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 11/02/2015

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11/02/2015.

Signature
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015025093/14.
(150029148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Creation Design International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 105.361.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2015024898/12.
(150029278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37250

L

U X E M B O U R G

CO2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9633 Baschleiden, Poteau de Harlange.

R.C.S. Luxembourg B 146.814.

Les statuts coordonnés au 29 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024897/9.
(150029279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Cordet Co-Investment SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 190.052.

En date du 23 décembre 2014, la dénomination de l'associé commandité et associé gérant commandité CORDET

Carry &amp; Co-Invest GP S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a changé et est désormais
CORDET Co-Investment GP S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024894/12.
(150028710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 103.336.

Une liste de signatures autorisées de la société Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. en fonction au 12 février

2015 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025095/14.
(150028930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Jardin du Pain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 19, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 140.788.

Les comptes annuels au 15 avril 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025136/9.
(150028423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Custom Sensors &amp; Technologies Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Carros Finance Luxembourg S.à r.l.).

Capital social: USD 4.871.151,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 182.766.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024846/10.
(150029024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37251

L

U X E M B O U R G

Jardin Populaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7790 Bissen, 14, rue Jean-Baptiste Kremer.

R.C.S. Luxembourg B 163.754.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025137/9.
(150028422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Ire Hotel II Rad Blu Cologne, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.225.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015025123/11.
(150029252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

IN4MATIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 85.175.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 11 février 2015

«Le  Conseil  d'Administration  décide  de  nommer  en  qualité  de  dépositaire  des  actions  au  porteur  de  la  société

IN4MATIX S.A. la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140
Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025120/12.
(150028436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Investissements Mobiliers Européens et Internationaux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 27.765.

<i>Extrait Procès-Verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 12 février 2015

Le Conseil a désigné Evelyne JASTROW, domiciliataire de sociétés, 4, rue Tony Neuman L 2241 Luxembourg, comme

dépositaire des titres au porteur émis par la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025118/11.
(150028206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Groupe Renaissance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 76.481.

Je soussignée, Madame Ioanna OGANISYAN, administrateur de la société GROUPE RENAISSANCE S.A., inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 76 481, démissionne avec effet immédiat de mes fonctions.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

I. Oganisyan.

Référence de publication: 2015025061/11.
(150028701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37252

L

U X E M B O U R G

House for You S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 26, rue Louis XIV.

R.C.S. Luxembourg B 174.739.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025080/9.
(150028430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

I &amp; S Coiffure S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4777 Pétange, 1, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 147.910.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025086/9.
(150028429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Immobilière des Glacis S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 76.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025089/9.
(150028715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Horses One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 36, rue Raymond Poincarré.

R.C.S. Luxembourg B 160.009.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025079/9.
(150029030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Köhl Maschinenbau, Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 17, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 139.482.

Les comptes annuels au 31.03.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025161/9.
(150028239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

JCM Famille s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 78, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 136.633.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025138/9.
(150028421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37253

L

U X E M B O U R G

Legio Lux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 133.317.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 9 février 2015 à 17.00

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2015025179/14.
(150028892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Luxluce S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 37.761.

Avec effet au 13 janvier 2014, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Transfert du siège social du 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg

- Reclassification de Mr Christoph Langenauer au poste d'administrateur unique, avec effet au 13 janvier 2014;
- Nomination de EQ Audit Sàrl, ayant pour adresse professionnelle le 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B124782,
au poste de Commissaire aux comptes, avec effet au 13 janvier 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXLUCE S.P.F.
TMF (Luxembourg) S.A.
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015025186/18.
(150028554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Immochelle, Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, 5, allée John W. Leonard.

R.C.S. Luxembourg B 147.140.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015025090/11.
(150028569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Palan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 81.424.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 05 février 2015.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2015025363/11.
(150028491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37254

L

U X E M B O U R G

PolyOne Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 1.265.025,00.

Siège social: L-9749 Fischbach, 6, Giällewee.

R.C.S. Luxembourg B 145.542.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025360/10.
(150028588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Pfaudler Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 191.416.

Les statuts coordonnés au 23 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015025358/11.
(150028699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Participating Monetary Organization, Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, 5, allée John W. Leonard.

R.C.S. Luxembourg B 106.922.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015025367/11.
(150028912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Participe S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 66.935.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société Participe

SA, SPF la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxem-
bourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025368/12.
(150028939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Patron ES Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 140.636.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015025351/10.
(150028203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37255

L

U X E M B O U R G

Pasta Mano S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 58.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015025374/11.
(150028304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Pasta Mano S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 58.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015025376/11.
(150028360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Pasta Mano S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 58.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015025372/11.
(150028302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Passiflora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.645.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015025371/12.
(150028540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

MP B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 168.102.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025290/9.
(150028186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37256

L

U X E M B O U R G

Digital Services XLIV (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.469.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XLIV S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law,

having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 23 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name- Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XLIV (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

37257

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

37258

L

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

37259

L

U X E M B O U R G

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20 Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

37260

L

U X E M B O U R G

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XLIV S.àr.l., afore-

mentioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

37261

L

U X E M B O U R G

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XLIV S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 23.

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XLIV (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

37262

L

U X E M B O U R G

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,

37263

L

U X E M B O U R G

welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

37264

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

37265

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

37266

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XLIV S.àr.l. vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2450. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015024912/589.
(150028830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37267

L

U X E M B O U R G

Digital Services XLV (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.462.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XLV S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law, having

its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being registered
with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 23 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name- Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XLV (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

37268

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

37269

L

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager  by  the  remaining  managers until  the  next meeting of shareholders  which shall  resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

37270

L

U X E M B O U R G

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20 Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

37271

L

U X E M B O U R G

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XLV S.àr.l., afore-

mentioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

37272

L

U X E M B O U R G

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XLV S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 23.

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XLV (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

37273

L

U X E M B O U R G

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,

37274

L

U X E M B O U R G

welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den  Fall,  dass der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

37275

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer- Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

37276

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr- Jahresabschluss- Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

37277

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XLV S.àr.l. vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2451. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015024914/589.
(150028721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37278

L

U X E M B O U R G

L'Européenne du Stationnement, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 194.461.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le deux février.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Bernard FELTEN, avocat, né à Schaerbeek (Belgique), le 18 septembre 1964, demeurant professionnellement

à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,

ici représenté par Madame Emmanuelle FRATTER, juriste, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2,

rue Jean-Pierre Brasseur, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 28 janvier 2015.

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

demeurera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va

constituer:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  La société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg et prend la dénomination de «L'Européenne du Stationnement» (la «Société»).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Il peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3. Le Conseil d'Administration de la Société (le «Conseil d'Administration») ou, le cas échéant, l'administrateur

unique, est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social.

2.4. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le
siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social à l'étranger, sera prise par le
Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique.

2.5. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société pourra acquérir, détenir, louer ou céder tout immeuble pour son compte propre, dont, notamment

mais non exclusivement, des parkings automobiles.

3.2. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés ou entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et
toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de
toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

3.3. La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou com-

merciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement.

3.4. La société pourra notamment employer ses fonds en vue de l'acquisition, la gestion pour son compte ou celui

d'autrui, la constitution, l'enregistrement et le dépôt, la valorisation, la vente, l'usage dans le cadre de son activité et la
concession de l'usage de tous noms de domaines et de tous droits de propriété intellectuelle, incluant notamment mais
non exclusivement tous droits d'auteur sur des logiciels informatiques, tous brevets, toutes marques de fabrique ou de
commerce, ainsi que tous dessins et tous modèles. La société aura également pour objet tous travaux de recherche et
de développement liés à la création et à l'exploitation de tous droits de propriété intellectuelle.

3.5. La société pourra également prêter son assistance en matière de gestion et d'organisation, à toutes filiales, de

façon rémunérée ou non.

3.6. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, y compris par voie d'offre publique. Elle peut procéder

par voie d'émission publique ou privée d'actions, d'obligations, de titres et instruments de toute nature. La Société peut
prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, ainsi qu'à des sociétés affiliées. La
Société peut également consentir des garanties et nantir, hypothéquer, céder, grever des charges ou autrement créer et

37279

L

U X E M B O U R G

accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre
société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.

3.7. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.8. Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

3.9. La société peut notamment réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, com-

merciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

3.10. D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

3.11. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer une activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu

l'autorisation requise.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000.- EUR) représenté par deux cent cinquante

mille (250.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.

5.2. Les actions peuvent être nominatives, au porteur, ou dématérialisées.
5.3. Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire désigné par le conseil d'ad-

ministration.  Le  conseil  d'administration  informera  les  actionnaires  de  toute  nomination  de  dépositaire  ou  de  tout
changement le concernant dans le délai de quinze (15) jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant
les dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l'article 11bis §1 

er

 , 3), d) de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation

précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l'action au porteur s'établie par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite

de  l'actionnaire  au  porteur,  un  certificat  peut  être  lui  délivré  par  le  dépositaire  constatant  toutes  les  inscriptions  le
concernant qui lui sera remis endéans huit (8) jours calendrier.

Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par

dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de
propriété entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard de
dépositaire, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété
reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n'étant pas valablement inscrites dans le registre des actions

au porteur, verront leurs droits suspendus.

5.4. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des

actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit ou par
e-mail, ou téléfax.

III. Administration - Surveillance

Art. 6. Administration.
6.1. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé au moins de trois (3) administrateurs, ac-

tionnaires ou non. Ils seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six (6)
ans et ils seront rééligibles.

6.2. Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il

est constaté que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique (l'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires cons-
tatant l'existence de plus d'un actionnaire.

6.3. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à tout moment, par une décision

adoptée par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

6.4. En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-

trateurs restants peuvent élire, à la majorité des votes, un administrateur pour remplir cette vacance jusqu'à la prochaine
assemblée générale des actionnaires de la Société.

6.5. Le mandat des administrateurs s'exercera à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

37280

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Pouvoirs du conseil d'administration.
7.1. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à

l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée des actionnaires
relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

7.2. Le Conseil d'Administration élit un président. En l'absence du président un autre administrateur peut présider la

réunion.

7.3. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier
électronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses col-
lègues.

7.4. L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

7.5. En cas de circonstances exceptionnelles, tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'adminis-

tration  par  conférence  téléphonique,  par  vidéo  conférence,  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  similaire
permettant leur identification. Ces moyens de télécommunication devront être géolocalisés dans le même pays que celui
où se déroule le conseil d'administration. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent
à la réunion et sera habilité à prendre part au vote.

7.6. Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Les écrits, télégram-
mes, télécopies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la
délibération.

7.7. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
7.8. Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de la réunion

ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les administrateurs présents ou représentés.

Art. 8. Délégation de pouvoir. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 9. Représentation de la société envers les tiers. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée,

en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'adminis-
trateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs au moins et si un administrateur-délégué est nommé, la
Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement la signature de l'ad-
ministrateur-délégué, ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a
été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.

Art. 10. Surveillance. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

IV. Année sociale - Assemblée générale

Art. 11. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même

année.

Art. 12. Assemblée générale.
12.1. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions

en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.

12.2. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

12.3. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.

12.4. Toute assemblée générale sera convoquée par le Conseil d'Administration par notification écrite envoyée à

chaque Actionnaire en conformité avec la Loi. L'assemblée sera convoquée à la demande des actionnaires représentant
au moins dix pour cent (10%) du capital de la Société. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils
déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de
convocation ou de publication. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital de la Société peuvent
demander l'ajout d'un ou de plusieurs points sur l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle
demande doit être adressée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date
de l'assemblée.

37281

L

U X E M B O U R G

12.5. Tout actionnaire peut voter au moyen d'un formulaire envoyé par poste ou par fax au siège social de la Société

ou à l'adresse mentionnée dans la convocation au moins trois (3) jours avant la date de l'assemblée.

12.6. Le formulaire de vote par correspondance reçu par la Société doit contenir les nom et prénom et le domicile

de l'actionnaire votant par correspondance; l'indication de la forme, nominative ou dématérialisée, sous laquelle sont
détenus les titres et du nombre de ces derniers; son vote pour chacun des points figurant à l'ordre du jour, ainsi que la
signature de l'actionnaire.

12.7. En cas de vote par correspondance d'un actionnaire détenant des titres dématérialisés, le formulaire visé au point

12.5. devra également être accompagné d'un extrait probant, émis dans les quinze (15) jours avant la tenue de l'assemblée,
de l'organisme où les titres sont détenus attestant du nombre d'actions de l'actionnaire.

12.8. Aucune cession ne sera valable et opposable à la Société si elle a été réalisée dans les quinze (15) jours avant la

tenue de l'assemblée.

12.9. Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire, actionnaire ou non et est par conséquent autorisé à voter par
procuration.

12.10. Les actionnaires sont autorisés à participer à une réunion par visioconférence ou par des moyens de télécom-

munications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de
majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'as-
semblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

12.11. Sauf dans les cas déterminés par la Loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée annuelle ou ordinaire

des Actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la Société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
12.12. Une assemblée générale extraordinaire convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra

valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présent ou représentée et que l'ordre du jour indique les
modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être
convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant
la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion
du  capital  représenté.  Dans  les  deux  assemblées,  les  résolutions,  pour  être  valables,  doivent  être  adoptées  par  une
majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

12.13. Néanmoins, en cas d'assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour le changement de nationalité

de la Société, ou l'augmentation des engagements des actionnaires, l'unanimité est toujours requise.

12.14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Art. 13. Réserves.
13.1. Chaque année cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social.

13.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des Actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

13.2. Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la Loi.

Art. 14. Date et lieu de l'assemblée annuelle. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit au siège social

ou tout autre lieu indiqué par la convocation, le 3 

ème

 mercredi du mois de juin à 11.00 heures, et si le 3 

ème

 mercredi

du mois de juin est un jour férié, le jour ouvrable suivant.

Art. 15. Dissolution.
15.1. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

15.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des Actionnaires.

15.3. Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux actionnaires

proportionnellement aux actions détenues par chacun d'eux.

Art. 16. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi"), ainsi que ses modifications

ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation, le premier exercice commencera à la date de signature des présents statuts, et se terminera au 31

décembre 2015.

37282

L

U X E M B O U R G

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2016.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, le comparant préqualifié déclare souscrire la totalité des actions, comme

suit:

Monsieur Bernard FELTEN, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme deux cent

cinquante mille euros (250.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à deux mille euros (2.000.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment

convoqué, a pris les résolutions suivantes:

1. Il est décidé de nommer un Administrateur Unique et un commissaire aux comptes.
2. Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Olivier LECLIPTEUR, administrateur de sociétés, né le 17 janvier 1969 à Rocourt (B), et demeurant pro-

fessionnellement à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
CD - SERVICES SARL, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au

RCSL sous le numéro B 50.564.

4. Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de l'an 2020.

5. Le siège social est fixé au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire par ses noms, prénoms

usuels, état et demeure, elle a signé avec nous notaire.

Signé: E. Fratter et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 février 2015. 2LAC/2015/2544. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025169/264.
(150028719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

IIL Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 188.200.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of December,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of IIL Investments S.A., SPF, société anonyme

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which registered office is located at 4, rue
Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under registration number B 188.200 (the “Company”), incorporated by a deed of Maître Carlo WERSANDT,
notary residing in Luxembourg on 18 June 2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2325 on 30 August 2014.

37283

L

U X E M B O U R G

The Meeting was opened with Mrs. Maria TKACHENKO, director, residing in Luxembourg, being in the chair (the

“Chairman”).

The  chairman  appointed  as  secretary  and  the  Meeting  elected  as  scrutineer  Mrs  Arlette  SIEBENALER,  employee

residing professionally in Luxembourg.

The Board of Meeting having been validly constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is as follows (the “Agenda”)

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by contribution in kind;
2. Issue of new shares - subscription to the new shares and related payment;
3. Amendment to Article 5.1.1. of the Company’s articles of association.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of

their shares are shown on an attendance list (the “Attendance List”). This Attendance List, which has been duly signed
by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the Board of the Meeting, will remain annexed
to the present deed in order to be filed with it at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, which have been initialled “ne varietur” by the proxyholders, shall also

remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital of the Company being present or represented at the present Meeting, and the sha-

reholders present or represented declaring that he has had due notice and due knowledge of the Agenda prior to this
Meeting, no convening notice was necessary.

IV. That, as a consequence of the entire share capital of the Company being present or represented, the present

Meeting is regularly constituted and may therefore validly deliberate on all of the items composing the Agenda,

After having duly considered the items set out in the Agenda, the Meeting unanimously adopted the following reso-

lutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by a total amount of nine hundred ninety nine

thousand one hundred thirty three Euro (EUR 999,133) in order to bring it from its current amount of thirty-one thousand
(31,000) euro represented by 31,000 (thirty one thousand) shares with a nominal value one (1.-) euro each up to a new
amount of one million thirty thousand one hundred thirty three Euro (EUR 1,030,133) consisting of one million thirty
thousand one hundred thirty three (1,030,133) shares with a nominal value one (1.-) euro each.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to issue nine hundred ninety nine thousand one hundred thirty three (999,133) new shares with

a nominal value of one (1.-) euro each, having the same rights and obligations of the existing shares.

<i>Subscription and payment

The Meeting resolves to accept the subscription by the existing shareholder, duly represented by Mrs Maria TKA-

CHENKO, by virtue of a proxy hereto attached, of all the nine hundred ninety nine thousand one hundred thirty three
(999,133) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, being issued for a total subscription price of nine
hundred ninety nine thousand one hundred thirty three Euro (EUR 999,133) paid as follows:

- a contribution in kind (the "Contribution in Kind") with an aggregate value of nine hundred and ninety nine thousand

one hundred and thirty three Euro (EUR 999,133) (i.e. a sum of USD 885,715 - eight hundred eighty five thousand seven
hundred fifteen US dollar - converted into EUR based on the exchange rate of 0.80715 Euro for 1 US dollar provided by
www.xe.com dated 11.12.2014 and two hundred eighty four thousand two hundred twenty eight Euro (EUR 284,228);
to the benefit of the Company, of the entire property of:

- Three hundred thirty four thousand (334,000) CHINA OIL AND 13 bonds (ISIN USG2115XAA66) and,
- Two hundred thousand (200,000) JBS IINVTS 14 bonds (ISIN USA29866AB53) and,
- One thousand seven hundred eighty four and eighty three hundredth (1,784.83) ROBECO CAP GR Funds H parts

in the fund (ISIN LU0823114243) and,

- One thousand two hundred fifty (1250) ROBECO CAP GR Funds FI parts in the fund (ISIN LU0622663093) and,
- Nine thousand five hundred (9500) CAPITAL INTL GLB HIG parts in the fund (ISIN LU0384427752) and,
- One hundred thousand (100,000) GENERAL SHOP 10 bonds (ISIN USG3812BAB65) and,
One hundred forty three thousand (143.000) Parts in financial structured product EFG PHOE GOLD SLV PA (ISIN

CH0201060495)

Altogether referred to as the “Contributed Assets”.
The proof of both the existence and the value of the contribution of the Contributed Assets, contributed to the

Company by the sole subscriber as consideration for his subscription for nine hundred ninety nine thousand one hundred

37284

L

U X E M B O U R G

thirty  three  (999,133)  new  shares  of  the  Company,  has  been  confirmed  according  to  the  terms  of  a  report  dated
29.12.2014, established by Artemis Audit &amp; Advisory represented by Someya Qalam in her capacity as independent auditor
(réviseur d'entreprises agréé) of the Company, which registered office is at 25 A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, in accordance with provisions of articles 26-1 and 32-1 of the Luxembourg law governing
commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

The conclusion of the report is as follows:
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 999,133 shares
with a nominal value of one euro each to be issued”.

A copy of the report, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder representing the sole subscriber and

by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon, nine hundred ninety nine thousand one hundred thirty three (999,133) new shares of the Company with

a nominal value one (1.-) euro each, fully paid-up, were allotted to the sole subscriber.

<i>Third resolution

In  order  to  reflect  the  capital  increase  here  above  resolved,  the  Meeting  resolves  to  amend  Article  5.1.1.  of  the

Company’s articles of association which reads as follows:

“ Art. 5.1.1. The Company’s issued share capital is set at one million thirty thousand one hundred thirty three Euro

(EUR 1,030,133) consisting of one million thirty thousand one hundred thirty three (1,030,133) shares with a nominal
value one (1.-) euro each”.

<i>Expenses - Valuation

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at EUR 3,000.-.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person duly represented by the proxyholder, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request
of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will
prevail.

The document having been read to the appearing person duly represented by the proxyholder, known to the notary

by his name, first name, civil status and residence, this person signed this deed with the notary.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf décembre,
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’"Assemblée") de IIL Investments S.A., SPF, une société ano-

nyme constituée et existante conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis 4, rue
Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.200 (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire Carlo
WERSANDT en date du 18 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2325 du 30
août 2014.

L’Assemblée a été ouverte sous la présidence de Madame Maria TKACHENKO, demeurant professionnellement à

Luxembourg (le «Président»).

Le Président a désigné comme secrétaire et l’Assemblée a désigné o comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler,

employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le Bureau valablement constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'établir:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant (l’ "Ordre du Jour"):

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la société par apport en nature;
2. Emission des actions - souscription et paiement;
3. Modification de l’article 5.1.1. des statuts de la Société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions

qu'ils détiennent sont répertoriés dans une feuille de présence (la "Feuille de Présence"). Cette Feuille de Présence,
dûment signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et le Bureau, sera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée concomitamment par les autorités compétentes.

37285

L

U X E M B O U R G

Les procurations des actionnaires représentés, paraphés "ne varietur" par les mandataires des actionnaires, représentés

seront également annexées au présent acte.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, et que les actionnaires

présents ou représentés ayant déclaré qu'ils avaient été dûment notifiés et qu'ils avaient pris connaissance de l’Ordre du
Jour préalablement à l’Assemblée, aucune convocation n'était nécessaire.

IV. Que du fait que l’intégralité du capital social de la Société soit représentée à la présente Assemblée, celle-ci, est

régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer sur tous les points de l’Ordre du Jour.

Après avoir dûment pris connaissance des points portés à l’Ordre du Jour, l’Assemblée a adopté à l’unanimité l’en-

semble des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille

cent trente-trois euros (EUR 999.133) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-),
représenté par trente et un mille (31.000) actions d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, au montant de
un million trente mille cent trente-trois euros (EUR 1.030.133) représenté par un million trente mille cent trente-trois
(1.030.133) actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée a décidé de l’émission par la Société de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-trois (999.133)

actions nouvelles d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.

<i>Souscription et paiement

L’Assemblée  a  décidé  d’accepter  la  souscription  par  l’actionnaire  existant,  dûment  représenté  par  Madame  Maria

TKACHENKO, prénommée, en vertu d’une procuration ci-annexée, de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-
trois (999.133) actions nouvelles d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, représentant un prix total de
souscription de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-trois euros (EUR 999.133) libéré comme suit:

- un apport en nature (l’«Apport en Nature») d’un montant global de neuf cent quatre-vingt-dix- neuf mille cent trente-

trois euros (EUR 999.133) (i.e. USD 885.715 - huit cent quatre- vingt cinq mille sept cent quinze US dollar - convertis en
EUR sur base du taux de change de 0,80715 EURO pour 1US dollar fournis par www.xe.com en date du 11/12/2014 et
deux cents quatre-vingt quatre mille deux cents vingt et huit Euros (EUR 284 228); au profit de la Société, de l’entière
propriété de:

- Trois cent trente-quatre mille (334 000) obligations émises par CHINA OIL 13 (ISIN USG2115XAA66) et,
- Deux cent mille (200 000) obligations émises par JBS IINVTS 14 (ISIN USA29866AB53) et,
- Mille sept cent quatre-vingt quatre virgule quatre-vingt trois (1.784,83) obligations émises par ROBECO CAP GR

Fonds H parts dans le fonds (ISIN LU0823114243) et,

-  Mille  deux  cent  cinquante  (1250)  obligations  émises  par  ROBECO  CAP  GR  Fonds  FI  dans  le  fonds  (ISIN

LU0622663093) et,

- Neuf mille cinq cents (9500) obligations émis par CAPITAL INTL GLB HIG dans le fonds (ISIN LU0384427752) et,
- Cent mille (100 000) obligations émises par 10 GENERAL BOUTIQUE (ISIN USG3812BAB65) et,
- Cent quarante et trois mille (143,000) parts dans le produit financier structuré EFG Phoebe GOLD SLV PA (ISIN

CH0201060495).

Au total, dénommés les «Actifs Apportés».
La preuve de l’existence ainsi que de la valeur du montant total des Actifs Apportés par le souscripteur unique à la

Société à l’effet du paiement du prix de souscription de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-trois (999.133)
actions de la Société a été confirmée aux termes d’un rapport en date du 29.12.2014 établi par Artemis Audit &amp; Advisory,
representé par Someya Qalam en sa qualité de réviseur d’entreprise agréé, dont le siège social est sis au 25A boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
“Basé sur le travail effectué et décrit ci-dessus, rien n’est venu à notre attention qui nous porterait à croire que la

valeur de l’apport en nature ne correspond pas au moins en nombre et valeur nominale aux 999.133 actions d'une valeur
nominale d'un euro chacune un à émettre.”

Une copie du rapport, après avoir été signé “ne varietur” par le mandataire du souscripteur unique et par le Notaire,

sera annexée au présent acte afin d'être enregistrée concomitamment par les autorités compétentes.

En conséquence, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-trois (999.133) nouvelles actions de la Société ayant

une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, intégralement libéré, ont été attribuées au souscripteur unique.

37286

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Afin de refléter l’augmentation du capital social de la Société ci-avant décidée, l’Assemblée a décidé de modifier l’article

5.1.1. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

« Art. 5.1.1. La Société a un capital social émis de un million trente mille cent trente-trois Euro (EUR 1.030.133)

représenté par un million trente mille cent trente-trois (1.030.133) actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR
1,-) chacune».

<i>Frais - évaluation

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à EUR 3.000.-.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante

dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie
comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. TKACHENKO, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/52. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025097/197.
(150028829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

UBS Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.851.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

THERE APPEARS:

Luxembourg Financial Group Holding S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with

registered office at 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B128323 (the Sole Shareholder),

represented by Annick Braquet, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under

private seal.

The powers of attorney of the Sole Shareholder, after having been initialled ne varietur by the attorney-in-fact and by

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration
authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all of the shares representing the entire issued share capital of UBS LUXEMBOURG

FINANCIAL GROUP ASSET MANAGEMENT S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme),
with registered office at 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B125851 (the Company). The Company was incorporated on 21 March 2007 pursuant
to a deed by the undersigned notary, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, dated 30 April 2007 number 745. The articles of association of the Company have been amended most recently
on 19 November 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has been published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations dated 8 December 2014 number 3761.

II. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(i) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 3,000,000 (three million euro), in order to bring

the share capital from its present amount to EUR 3,235,400 (three million two hundred and thirty five thousand four
hundred euro) by way of the issuance of 30,000 (thirty thousand) new Shares (the New Shares) with a nominal value of
EUR100 (one hundred euros) each;

(ii) Subscription to and payment in full, by the Sole Shareholder, of the New Shares by way of a contribution in cash;

and

(iii) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company (the Articles).

37287

L

U X E M B O U R G

III. The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of

EUR 3,000,000 (three million euro), in order to bring the share capital from its present amount to EUR 3,235,400 (three
million two hundred and thirty five thousand four hundred euro) by way of the issuance of the New Shares.

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder hereby declares to subscribe for the New Shares and to pay-up in full such New Shares by way

of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 3,000,000 (three million euro) (the Cash Contribution), which
is to be allocated to the share capital account of the Company.

Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary by means of a blocking

certificate confirming the availability of the amount of the Cash Contribution on the Company's bank account and the
notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above changes so that article

5 shall now read as follows:

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at EUR 3,235,400 (three million two hundred and thirty five

thousand four hundred euro) consisting of 32,354 (thirty-two thousand three hundred and fifty-four) ordinary shares in
registered form, fully paid in, with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 22."

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever arising as a result of the present deed shall

be borne by the Company and are estimated to be approximately EUR 3,500.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version, and that in case of discrepancies between the English and the French texts, the
English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The deed having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the attorney-in-fact of the Sole Shareholder

signs together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

COMPARAIT:

Luxembourg Financial Group Holding S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 33A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B128323 (l’Actionnaire Unique),

représentée par Annick Braquet, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé.

La procuration de l’Actionnaire Unique, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et par le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.

L’Actionnaire Unique, ainsi représenté, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L’Actionnaire Unique est le détenteur de toutes les Actions représentant l’intégralité du capital social émis de LU-

XEMBOURG FINANCIAL GROUP ASSET MANAGEMENT S.A., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,
ayant son siège social au 833A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B125851 (la Société). La Société a été constituée le 21 mars 2007
par un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, daté du 30 avril 2007
numéro  745.  Les  statuts  de  la  Société  ont  été  modifiés  dernièrement  le  19  novembre  2014  par  un  acte  du  notaire
instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, daté du 8 décembre 2014 numéro 3761.

II. L’Actionnaire Unique souhaite adopter les résolutions suivantes:
(i) augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 3.000.000 (trois millions d’euros) afin de porter

le capital social de son montant actuel à EUR 3.235.400 (trois millions deux cent trente-cinq mille quatre cents euros)
par l’émission de 30.000 (trente mille) nouvelles actions de la Société (les Nouvelles Actions) ayant une valeur nominale
de EUR 100 (cent euros);

37288

L

U X E M B O U R G

(ii) souscription et paiement intégral des Nouvelles Actions par l’Actionnaire Unique par un apport en numéraire; et
(iii) modification de l’article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter les modifications mentionnées ci-

dessus.

III. L’Actionnaire Unique adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant

de EUR 3.000.000 (trois millions d’euros) afin de porter le capital social de son montant actuel à EUR 3.235.400 (trois
millions deux cent trente-cinq mille quatre cents euros) par l’émission des Nouvelles Actions à l’Actionnaire Unique.

<i>Souscription - Libération

L’Actionnaire Unique déclare souscrire aux Nouvelles Actions et les libérer intégralement au moyen d'un apport en

numéraire d'un montant total de EUR 3.000.000 (trois millions d’euros) (l’Apport en Numéraire), qui sera alloué au capital
social de la Société.

Le paiement en vertu de l’Apport en Numéraire a été certifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat de

blocage qui confirme la disponibilité du montant payé en vertu de l’Apport en Numéraire sur le compte bancaire de la
Société et le notaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

<i>Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier l’article 5 des Statuts afin de refléter les changements intervenus ci-dessus,

de telle sorte que l’article 5 aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Capital. Le capital souscrit de la Société est établi à EUR 3.235.400 (trois millions deux cent trente-cinq mille

quatre cents euros) représenté par 32.354 (trente-deux mille trois cent cinquante-quatre) actions ordinaires nominatives,
entièrement libérées, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l’Assemblée Générale

statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l’article 22 ci-après."

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, coûts, rémunérations et charges quelle que soit leur forme survenant en conséquence du présent

acte seront supportés par la Société s'élève à approximativement EUR 3.500.-

Le notaire instrumentant, ayant personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l’Actionnaire Unique, ledit mandataire a signé avec le

notaire, l’original du présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/278. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015024672/125.
(150027410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

AIE EuroLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue John Fitzgerald Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.696.

RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle survenue dans la publication datée du 30 janvier 2015 et déposée au Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg le 2 février 2015, sous la référence L150020706:

Par résolutions prises en date du 30 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant B, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Michael Kidd, avec adresse professionnelle au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy,

L-1855 Luxembourg de son mandat de gérant B, avec effet au 31 décembre 2014;

37289

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025691/18.
(150029526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Aberdeen Indirect Property Partners Active Soparfi, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 124.153.

In the year two thousand and fifteen,
on the twenty-third day of the month of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“Aberdeen Management Services S.A.”, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office

at 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 119.541, acting in its capacity as management company of “Aberdeen
Dynamic  European  Property  Fund  of  Funds”,  a  sub-fund  of  ”Aberdeen  Umbrella  Property  Funds  of  Funds”,  a  fonds
commun de placement - fonds d'investissement spécialisé governed by the law of 13 February 2007 on specialised in-
vestment funds, as amended, (the “Shareholder”),

here represented by Mrs Martha ALEXAKI, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given to her in Luxembourg, on 19 January 2015.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of

“Aberdeen Indirect Property Partners Active Soparfi S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of
Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (12'500.- EUR), with its current registered office
at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed enacted
on 30 January 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 604 of
13 April 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124 153 (the
"Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial
deed enacted on 28 September 2012, published in the Mémorial on 30 October 2012, under number 2667 and page
127970.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To transfer its registered office from the municipality of Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg to Luxembourg

City;

2 To amend paragraph 2.1 of article 2 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the transfer

of the registered office;

3 To determine the new address of the registered office;
4 Miscellaneous;
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to transfer, with immediate effect, the registered office of the Company from the municipality

of Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg to Luxembourg City.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to amend paragraph 2.1 of article 2 of the articles of incorporation of the Company in order

to reflect the above resolution. Said paragraph will read henceforth as follows:

Art. 2. Registered office.
“2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.”

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to fix the new registered office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

37290

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such proxy holder signed together with Us the undersigned notary,
this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze,
le vingt-trois janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

«Aberdeen Management Services S.A.», une société régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2b, rue

Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119 541, agissant en sa capacité de société de gestion de «Aberdeen Dynamic
European Property Fund of Funds», un compartiment du fonds «Aberdeen Umbrella Property Fund of Funds», un fonds
commun de placement - fonds d'investissement spécialisé régi par la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement
spécialisés, telle que modifiée, (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Madame Martha ALEXAKI, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 19 janvier 2015.
La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire

soussignée, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de «Aberdeen Indirect

Property Partners Active Soparfi S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un
capital social de douze mille cinq cents euros (12'500.- EUR), dont le siège social actuel est au 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 30 janvier 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») sous le numéro 604 du 13 avril 2007 et
immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 124 153 (la «Société»). Les
statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu le 28 septembre 2012, lequel acte fut
publié au Mémorial, le 30 octobre 2012, sous le numéro 2667 et page 127970.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Transfert du siège social de la Société de la commune de Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg-

Ville;

2 Modification de l'alinéa 2.1 de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le transfert du siège social;
3 Déterminer la nouvelle adresse du siège social;
4 Divers;
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la commune de Hesperange, Grand-Duché de

Luxembourg à Luxembourg-Ville.

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa 2.1 de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter la précédente résolution.

Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 2. Siège social.
«2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé d'établir le nouveau siège social au 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie

comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la
même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

37291

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante connue du notaire

soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. ALEXAKI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 janvier 2015. Relation: EAC/2015/2108. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015024715/111.
(150028160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Asia III Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 36.000.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 184.949.

In the year two thousand and fifteen,
on the twenty-third day of the month of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“Aberdeen Management Services S.A.”, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office

at 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 119.541, acting in its capacity as management company of “Aberdeen
Asia III Property Fund of Funds” a fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé governed by the law
of 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended, (the “Shareholder”),

here represented by Mrs Martha ALEXAKI, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given to her in Luxembourg, on 19 January 2015.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of “Asia

III Soparfi S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of thirty-
six million Japanese Yen (36'000'000.- JPY), with its current registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed enacted on 13 February 2014, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 1168 of 08 May 2014 and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 184 949 (the "Company"). The articles of incor-
poration of the Company have never been amended since.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To transfer its registered office from the municipality of Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg to Luxembourg

City;

2 To amend paragraph 2.1 of article 2 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the transfer

of the registered office;

3 To determine the new address of the registered office;
4 Miscellaneous;
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to transfer, with immediate effect, the registered office of the Company from the municipality

of Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg to Luxembourg City.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to amend paragraph 2.1 of article 2 of the articles of incorporation of the Company in order

to reflect the above resolution. Said paragraph will read henceforth as follows:

Art. 2. Registered office.
“2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.”

37292

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to fix the new registered office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such proxy holder signed together with Us the undersigned notary,
this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze,
le vingt-trois janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

«Aberdeen Management Services S.A.», une société régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2b, rue

Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119 541, agissant en sa capacité de société de gestion de «Aberdeen Asia III
Property Fund of Funds» un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé régi par la loi du 13 février
2007 sur les fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée, (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Madame Martha ALEXAKI, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 19 janvier 2015.
La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire

soussignée, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de «Asia III Soparfi S.à

r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de trente-six millions de
yen japonais (36'000'000.- JPY), dont le siège social actuel est au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 13 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial») sous le numéro 1168 du 08 mai 2014 et immatriculée au Registre de Commerce
et des Société de Luxembourg sous le numéro B 184 949 (la «Société»). Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés
depuis lors.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Transfert du siège social de la Société de la commune de Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg-

Ville;

2 Modification de l'alinéa 2.1 de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le transfert du siège social;
3 Déterminer la nouvelle adresse du siège social;
4 Divers;
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la commune de Hesperange, Grand-Duché de

Luxembourg à Luxembourg-Ville.

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa 2.1 de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter la précédente résolution.

Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 2. Siège social.
«2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé d'établir le nouveau siège social au 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

37293

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie

comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la
même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante connue du notaire

soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. ALEXAKI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 janvier 2015. Relation: EAC/2015/2111. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015024731/106.
(150028219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

CCArchitectes s.a., Société Anonyme,

(anc. carloscorreiarchitecte s.a.).

Siège social: L-4204 Esch-sur-Alzette, 34, rue Large.

R.C.S. Luxembourg B 151.379.

L’an deux mil quinze, le vingt-neuvième jour du mois de janvier.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "carloscorreiarchitecte s.a.", établie et

ayant son siège social à L L-3230 Bettembourg, 29-31, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 151379 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WER-
SANDT, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations,  numéro  670  du  30  mars  2010,  et  que  les  statuts  ont  été  modifiés  suivant  acte  reçu  par  Maître  Carlo
WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 3050 du 3 décembre 2013.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlos Manuel CORREIA PIRES, architecte, demeurant à

B-6780 Longeau, 23, rue du Coin. Monsieur Carlos Manuel CORREIA PIRES occupe également la fonction de scrutateur.

L’assemblée choisit comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Dias, salarié, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de L-3230 Bettembourg, 29-31, route d'Esch, vers L-4204 Esch-sur-Alzette, 34, Rue Large

et modification subséquente de la première phrase de l’article 2 des statuts.

2. Changement de dénomination de carloscorreiarchitecte s.a. en CCArchitectes s.a. et modification subséquente de

l’article 1 

er

 des statuts.

3. Modification du nombre et de la valeur nominale des actions pour les porter à 1.000 actions de EUR 31,- chacune

et modification subséquente de l’article 5 des statuts.

4. Décision de fixer le nombre des administrateurs à trois et nomination de Madame Anne Sophie Mertz et de Madame

Carla Machado-Oliveira en tant qu’administrateurs de la Société et confirmation du mandat de Monsieur Carlos Manuel
Correia Pires en tant qu’administrateur de la Société. Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2020.

5. Prolongation du mandat du commissaire aux comptes à savoir Conseils Comptabilité Fiscalité S.A. jusqu’à l’assemblée

générale qui se tiendra en l’année 2020.

6. Modification du pouvoir de signature statutaire et modification subséquente de l’article 14 des statuts.
7. Pouvoir donné au conseil d’administration afin de nommer Monsieur Carlos Manuel Correia Pires administrateur-

délégué de la Société.

8. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Resteront annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne va-

rietur“ par les comparants.

III.- Que tous les actionnaires étant présents, les convocations d’usage n’ont pas été adressées aux actionnaires

37294

L

U X E M B O U R G

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’entièreté du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-3230 Bettembourg, 29-31, route d'Esch,

vers L-4204 Esch-sur-Alzette, 34, Rue Large et modification subséquente de la première phrase de l’article 2 des statuts
de la Société comme suit:

Art. 2. (première phrase). «Le siège social est établi dans la commune de Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-

bourg).»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de carloscorreiarchitecte s.a. en CCArchitectes

s.a. et modification subséquente de l’article 1 

er

 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "CCArchitectes s.a.".»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les trois cent dix (310) actions existantes d'une valeur nominale de cent euros

(EUR 100,-) chacune en mille (1.000) actions de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune et modification subséquente de
l’article 5 des statuts comme suit:

„ Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000)

actions de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune.“

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de procéder aux écritures qui s’imposent dans le registre des

actionnaires.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et nomination de Madame Anne Sophie

Mertz, architecte, née à Messancy le 02 janvier 1984, demeurant professionnellement au 34 Rue Large, L-4204 Esch/
Alzette et de Madame Carla Machado-Oliveira, comptable, née le 11 septembre 1975 à Fafe (P), demeurant profession-
nellement au 12, Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg en tant qu’administrateurs de la Société et confirmation du mandat
de Monsieur Carlos Manuel Correia Pires en tant qu’administrateur de la Société. Le mandat des administrateurs prendra
fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2020.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de prolonger le mandat du commissaire aux comptes de la Société à savoir Conseils

Comptabilité Fiscalité S.A. jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2020.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le pouvoir de signature statutaire et modification subséquente de l’article 14

des statuts comme suit:

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature individuelle de l’adminis-
trateur-délégué jusqu’à un montant de 10.000,-EUR, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
administrateur pour tout montant dépassant 10.000,- EUR.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale décide de donner pouvoir au conseil d’administration afin de nommer Monsieur Carlos Manuel

Correia Pires en qualité d’administrateur-délégué de la Société.

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l’Étude du notaire

soussigné, à l’effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.

37295

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Carlos Manuel Correia Pires, Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 3 février 2015. 1LAC / 2015 / 3314. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015024700/102.
(150028687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

MC GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 186.213.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de transfert de parts sociales exécutée en date du 29 décembre 2014 entre:
- VB (Joburg) Limited, une société à responsabilité limitée établie et existante sous les lois d'Angleterre et du Pays de

Galles, ayant son siège social au 10 Lower Grosvenor Place, SW1W OEN Londres, Royaume-Uni, et enregistrée auprès
du Registre des Sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles, sous le numéro 7990155,

Et,
- Monsieur Maurizio Bianco, né le 9 août 1961 à Turin, Italie, résidant à Via Pisacane 35, 20129 Milan, Italie,
que les quatre mille deux cent (4200) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, ont été

transférées par VB (Joburg) Limited, susnommée, à Monsieur Maurizio Bianco, prénommé,

Depuis lors, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

DUNE LUX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200 parts sociales

C ONE LUX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200 parts sociales

Monsieur Maurizio Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.600 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 février 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2015025270/30.
(150028233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Marowinia S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.484.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015025268/12.
(150028152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

37296


Document Outline

Aberdeen Indirect Property Partners Active Soparfi

AIE EuroLux S.à r.l.

Asia III Soparfi S.à r.l.

carloscorreiarchitecte s.a.

Carros Finance Luxembourg S.à r.l.

CCArchitectes s.a.

CO2 S.A.

Cordet Co-Investment SCSp

Creation Design International S.A.

Custom Sensors &amp; Technologies Luxembourg S.à r.l.

Digital Services XLIV (GP) S.à.r.l.

Digital Services XLV (GP) S.à.r.l.

Espirito Santo Industrial S.A.

Euro Road Services LTD

Groupe Renaissance S.A.

Horses One S.à r.l.

House for You S.à r.l.

IIL Investments S.A., SPF

Immobilière des Glacis S. à r.l.

Immochelle

IN4MATIX S.A.

Intellux Capital Management S.A., SPF

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.

Investissements Mobiliers Européens et Internationaux S.A.

Ire Hotel II Rad Blu Cologne

I &amp; S Coiffure S.à.r.l.

Jardin du Pain S.à r.l.

Jardin Populaire S.à r.l.

JCM Famille s.à r.l.

Köhl Maschinenbau

Legio Lux S.A.

L'Européenne du Stationnement

Luxluce S.P.F.

Marowinia S.A., SPF

MC GP S.à r.l.

MP B S.A.

Palan S.A.

Participating Monetary Organization

Participe S.A., SPF

Passiflora S.A.

Pasta Mano S.à.r.l.

Pasta Mano S.à.r.l.

Pasta Mano S.à.r.l.

Patron ES Holdings S.à r.l.

Pfaudler Midco S.à r.l.

PolyOne Luxembourg S.à r.l.

UBS Luxembourg Financial Group Asset Management S.A.