logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 776

20 mars 2015

SOMMAIRE

Acte II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37209

A.C.U. Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

37205

Adga Rhea Consultants S.A.  . . . . . . . . . . . .

37209

Ad-Lib Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37205

Ad-Lib Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37205

Ad-Lib Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37205

Agence Générale d'Assurances R. Stelmes

& Fils S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37209

AgFe Asset Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

37207

AgFe, SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37207

Agro Merchants LATAM Holdings S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37207

A&K S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37206

Algeco/Scotsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37206

Algeco/Scotsman Group S.à r.l.  . . . . . . . . .

37209

Algeco/Scotsman Management S.C.A.  . . .

37206

Algeco Scotsman PIK S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

37208

Allen & Overy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37206

Digital Services L (GP) S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

37210

Digital Services XLVII (GP) S.à r.l. . . . . . . .

37221

GSC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37240

Hailey Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37202

Innodis S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37202

Institut de beauté Selma S.à r.l.  . . . . . . . . .

37202

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . .

37202

Jujosygu S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37202

Kalchesbrück S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37203

La Main Verte S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37203

Likipi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37210

m.e.g.a. performance s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

37204

New-Connect S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37248

Noble Holding Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

37243

OOCL (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

37245

Thunderbird R S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37235

Tosca S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37208

UK Regional Portfolio II S.à r.l.  . . . . . . . . . .

37240

Ventech China  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37232

Vitarium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37203

Vivaro Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37204

VMF Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37204

Walgreen Asia Services S.à r.l.  . . . . . . . . . .

37237

White Bear S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37208

WHITE Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37205

WK Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37204

Xyzalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37204

Zarinvest S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37207

Zurich Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37208

37201

L

U X E M B O U R G

Institut de beauté Selma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4676 Niederkorn, 6A, rue Theis.

R.C.S. Luxembourg B 162.075.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025092/9.
(150028425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Hailey Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 41.407,60.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 182.192.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025069/10.
(150028774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.823.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 103.123.

Une liste de signatures autorisées de la société Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. en fonction au 12 février 2015 a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025094/14.
(150028918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Innodis S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 24.077.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 5 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015025108/12.
(150028097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Jujosygu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.700.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025145/9.
(150028550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37202

L

U X E M B O U R G

Kalchesbrück S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: Kalchesbrück, Zone Commerciale et Artisanale.

R.C.S. Luxembourg E 1.864.

<i>Dépôt rectifiant le dépôt numéro L130215755 effectué auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en date du 18 décembre

<i>2013

Répartition du capital social:
Suite au décès de Monsieur Jean Gustave WINANDY en date du 12 septembre 2012, le capital social de la Société est

désormais réparti comme suit:

Marie-Thérèse ENTRINGER
née le 14 décembre 1938 à Luxembourg
demeurant à L-2221 Luxembourg, 397, rue de Neudorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 parts sociales
Tom WINANDY
né le 17 février 1963 à Luxembourg
demeurant L-2112 Howald, 39, rue du 9 mai 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 parts sociales

Il résulte des résolutions prises par les associés en date du 13 décembre 2013 que:
- Les associés décident de modifier les dispositions de l'article 9 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur

suivante:

«La société est administrée par un conseil composé de un ou plusieurs membres».
- Les associés décident de modifier les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 des statuts de la Société afin de

lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de l'administrateur unique

ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures collectives de deux administrateur.»

- Les associés décident que, suite au décès de Monsieur Jean WINANDY en date du 14 septembre 2012, Monsieur

Tom WINANDY demeure seul membre de l'organe de gestion de la Société et est ainsi désigné Administrateur unique
de la Société pour une durée indéterminée.

La Société est désormais valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Tom WINANDY en tant

qu'Administrateur unique.

Tom WINANDY / Marie-Thérèse ENTRINGER
350 parts sociales / 350 parts sociales
<i>Les associés

Référence de publication: 2015025151/35.
(150028175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

La Main Verte S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4169 Esch-sur-Alzette, 32, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 82.580.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025171/9.
(150028418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Vitarium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 112.041.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015025617/10.
(150028122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37203

L

U X E M B O U R G

Vivaro Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 107.199.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 31 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025618/12.
(150028492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

VMF Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 183.455.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 31 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025619/12.
(150028128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

WK Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6181 Gonderange, 22, rue Stohlbour.

R.C.S. Luxembourg B 94.551.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025635/9.
(150028484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Xyzalux S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 55.399.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 31 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025644/12.
(150028127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

m.e.g.a. performance s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5213 Sandweiler, 28A, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 53.957.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025653/9.
(150029380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

37204

L

U X E M B O U R G

Ad-Lib Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 154.838.

Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour AD-LIB CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025657/12.
(150029622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Ad-Lib Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 154.838.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour AD-LIB CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025658/12.
(150029623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Ad-Lib Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 154.838.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour AD-LIB CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025659/12.
(150029624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

A.C.U. Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7225 Bereldange, 35, rue de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 80.156.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025654/9.
(150030041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

WHITE Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.826.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025633/9.
(150028561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37205

L

U X E M B O U R G

Algeco/Scotsman, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 158.703.

Suite aux modification d'adresse de gérant de la Société, il y a lieu de modifier les données les concernant comme suit:
- Gary May, gérant de classe A, a dorénavant son adresse professionnelle au 20, Bentinck street, GB - W1U 2EU

Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015025668/13.
(150029761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Allen &amp; Overy, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 178.291.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 22 décembre 2014

Les associés décident de nommer PricewaterhouseCoopers, société coopérative, ayant son siège social au 2, rue

Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477, à la fonction de réviseur d'entreprises agréé de la Société, avec
effet au 12 juin 2013, et pour une durée qui expirera lors de l'assemblée générale qui statuera sur l'approbation des
comptes annuels au 30.04.2015.

Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Allen &amp; Overy
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015025671/17.
(150029934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Algeco/Scotsman Management S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 35.914,83.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 160.307.

Suite aux modification d'adresse de commissaire de la Société, il y a lieu de modifier les données les concernant comme

suit:

- Blair Thompson, le commissaire, a dorénavant son adresse professionnelle au 20, Bentinck street, GB - W1U 2EU

Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015025670/14.
(150029759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

A&amp;K S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 39.766.

Le bilan arrêté au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015025655/10.
(150029443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

37206

L

U X E M B O U R G

AgFe Asset Company S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 174.956.

Monsieur Holger BEYER a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie A de la Société avec effet au 16

mai 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

AgFe Asset Company S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025665/13.
(150029484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Agro Merchants LATAM Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 192.972.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 12 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de Mme. Figen Eren avec effet du 31 janvier 2015
- De nommer M. Jabir Chakib, ne le 5 novembre 1967 a Casablanca, (Maroc) ayant sa résidence professionnelle au

26A boulevard Royal, L-2449 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 31 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Agro Merchants LATAM Holdings Sàrl

Référence de publication: 2015025664/14.
(150029410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

AgFe, SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad.

R.C.S. Luxembourg B 182.466.

Monsieur Holger BEYER a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 16 mai 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

AgFe, SICAV-SIF
Signature

Référence de publication: 2015025666/12.
(150029485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Zarinvest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 189.328.

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 11/02/2015:
Il est décidé nommer la société à responsabilité limité UNCOS, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,

immatriculée au RCSL sous le numéro B141298, en tant que dépositaire légal des actions au porteur de la société Zarinvest
S.A., SPF (B189328) et ceci en vertu de la loi du 28 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/02/2015.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015025645/15.
(150028364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37207

L

U X E M B O U R G

White Bear S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 73.475.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 9 février 2015 à 16.00

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2015025632/14.
(150028890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Zurich Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 133.394.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 31 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025647/12.
(150028126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Tosca S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 192.249.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 09 février 2015 à 15.00

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2015025571/14.
(150028076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Algeco Scotsman PIK S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 45.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 176.700.

Suite aux modification d'adresse d'administrateur de la Société, il y a lieu de modifier les données les concernant comme

suit:

- Gary May, administrateur de classe A, a dorénavant son adresse professionnelle au 20, Bentinck street, GB - W1U

2EU Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015025667/14.
(150029762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

37208

L

U X E M B O U R G

Algeco/Scotsman Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 867.725.416,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.029.

Suite aux modification d'adresse de gérant de la Société, il y a lieu de modifier les données les concernant comme suit:
- Gary May, gérant de classe A, a dorénavant son adresse professionnelle au 20, Bentinck street, GB - W1U 2EU

Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015025669/13.
(150029760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Agence Générale d'Assurances R. Stelmes &amp; Fils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 131, rue des Pommiers.

R.C.S. Luxembourg B 102.768.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Agence Générale d'Assurances R. STELMES &amp; FILS S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015025663/12.
(150029122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Acte II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 109.001.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La société
Signature

Référence de publication: 2015025683/11.
(150029671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Adga Rhea Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 102.264.

<i>Extrait de la résolution prise par l'administrateur unique en date du 21 janvier 2015

Suivant les dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la

tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière, a été désigné comme dépositaire des 2 titres au porteur représentant l'intégralité du capital social émis et payé
de la société ADGA RHEA CONSULTANTS S.A.:

Maître Stephan LE GOUEFF, c/o ETUDE D'AVOCATS LG@VOCATS, sis 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
Donald VENKATAPEN
<i>Administrateur Unique

Référence de publication: 2015025686/18.
(150029398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

37209

L

U X E M B O U R G

Likipi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 72.806.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 21 novembre 2014 au siège social

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg en date du 21 Novembre

2014 que l'Assemblée a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- Renouvellement, avec effet immédiat, des mandats des administrateurs suivants:
* M. Alain TIRCHER, né le 13 mars 1959 à Watermael-Boitsfort (Belgique) demeurant professionnellement à 7a, rue

Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, administrateur;

*M. Jean-Michel HAMELLE, né le 13 septembre 1962 à Reims (France) demeurant professionnellement à 7a, rue Tho-

mas Edison, L-1445 Luxembourg, administrateur;

* M. Massimo MAGNONI, demeurant professionnellement à Calle Muntaner 454, E-08006 Barcelona (Espagne), ad-

ministrateur;

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2015.
- Renouvellement, avec effet immédiat, du mandat du Commissaire aux Comptes suivant:
* Grant Thornton Weber &amp; Bontemps S.A., dont le siège social est au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, im-

matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.690.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l' assemblée qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015025209/24.
(150028398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Digital Services L (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.444.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services L S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law, having

its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being registered
with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 23 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services L (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 con-
cerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

37210

L

U X E M B O U R G

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

37211

L

U X E M B O U R G

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the  remaining  managers until  the  next meeting of shareholders  which shall  resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

37212

L

U X E M B O U R G

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

37213

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

37214

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services L S.àr.l., aforemen-

tioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services L S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem Recht

des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und deren
Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 23.

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services L (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

37215

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

37216

L

U X E M B O U R G

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

37217

L

U X E M B O U R G

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

37218

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

37219

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services L S.àr.l., vorbenannt, zum

Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg,

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

37220

L

U X E M B O U R G

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2446. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015024910/589.
(150028257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Digital Services XLVII (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.449.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XLVII S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law,

having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 23 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XLVII (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

37221

L

U X E M B O U R G

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,

37222

L

U X E M B O U R G

each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager  by the remaining  managers  until  the  next  meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager

37223

L

U X E M B O U R G

in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

37224

L

U X E M B O U R G

20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XLVII S.àr.l., afo-

rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

37225

L

U X E M B O U R G

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XLVII S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 23.

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XLVII (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

37226

L

U X E M B O U R G

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-

37227

L

U X E M B O U R G

stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

37228

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-

37229

L

U X E M B O U R G

fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

37230

L

U X E M B O U R G

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XLVII S.àr.l. vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800,- geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

37231

L

U X E M B O U R G

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2453. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015024918/589.
(150028349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Ventech China, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.619.

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of the month of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Ventech China (the “Extraordinary General Meeting” and the

“Company”, respectively), a société à responsabilité limitée having its registered office at 47, avenue J.F. Kennedy, regis-
tered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 161619, incorporated by deed of
Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 17 June 2011, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 1494 of 7 July 2011. The articles of
association of the Company (the “Articles”) have never been amended since its incorporation.

The Extraordinary General Meeting was presided by Mr Jean-Thomas Pradillon, jurist, professionally residing in 2, place

Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Me Michel Marques Pereira, avocat à la Cour, professionally

residing in 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by

the proxyholder(s), the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the
proxies, will remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all two thousand one hundred (2,100) shares in issue in the Company were

represented at the Extraordinary General Meeting so that the Extraordinary General Meeting was validly constituted and
able to validly decide on all the items of the agenda.

II. The agenda of the Extraordinary General Meeting was the following:

<i>Agenda

1. Waiver of convening formalities
2. Amendment of the first sentence of Article 7.1. of the Articles relating to the composition of the board of managers

of the Company in order to read as follows:

“ 7.1. The Company shall be managed by a board of managers composed of four (4) board members which shall always

be composed of two (2) managers of category A and two (2) managers of category B appointed by a resolution of the
general meeting of shareholders which sets the term of their office.”

After the foregoing was approved by the Extraordinary General Meeting, the following resolutions were adopted by

unanimous decision:

<i>First resolution

All shareholders represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the Extraordinary General

Meeting and waived their rights to any prior convening notice thereof.

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting resolved to amend the first sentence of Article 7.1. of the Articles in order to

read as follows:

37232

L

U X E M B O U R G

“ 7.1. The Company shall be managed by a board of managers composed of four (4) board members which shall always

be composed of two (2) managers of category A and two (2) managers of category B appointed by a resolution of the
general meeting of shareholders which sets the term of their office.”

There being no further item to be resolved upon, the Extraordinary General Meeting was closed.

<i>Ordinary general meeting of the shareholders

After the Extraordinary General Meeting was held an ordinary general meeting of the shareholders of the Company

(the “Meeting”).

The Meeting was presided by Mr Jean-Thomas Pradillon, prenamed.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Me Michel Marques Pereira, prenamed.
The chairman declared that:
I. It appears from an attendance list established and signed by the proxyholder(s), the chairman, the secretary and the

scrutineer that all the two thousand one hundred (2,100) shares in issue in the Company, are represented at this Meeting
so that the Meeting is validly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda below.

II. The attendance list shall remain attached together with the proxies to the present minutes.
III. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiver of convening formalities
2. Reclassification of Ms Jia Guo as manager of category B pursuant to Article 7.1. of the Articles of the Company so

that the board of managers of the Company shall be composed as follows:

<i>Category A managers:

- Mr Eric Huet; and
- Mr Alain Caffi

<i>Category B managers:

- Ms Jia Guo; and
- Ms Kathryn O’Sullivan.
After due consideration and deliberation of the items above, the Meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

All shareholders represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the Meeting and waived

their rights to any prior convening notice thereof.

<i>Second resolution

The Meeting resolved to reclassify Ms Jia Guo as manager of category B of the Company so that the board of managers

of the Company shall be composed as follows:

<i>Category A managers:

- Mr Eric Huet; and
- Mr Alain Caffi

<i>Category B managers:

- Ms Jia Guo; and
- Ms Kathryn O’Sullivan.
There being no further business, the Meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed, the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le vingt janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de Ventech China (respectivement l’«Assemblée Générale Ex-

traordinaire» et la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 47, avenue J.F. Kennedy,

37233

L

U X E M B O U R G

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161619, constituée
suivant acte reçu de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date
du 17 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1494 du 7 juillet
2011. Les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont jamais été modifiés depuis sa constitution.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a été présidée par M. Jean-Thomas Pradillon, juriste, demeurant professionnel-

lement au 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Me Michel Marques Pereira, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement au 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent figurent sur une liste de présences

signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procu-
rations resteront annexées au présent acte afin d’être soumises avec lui aux autorités de l’enregistrement.

Il ressort de ladite liste de présences que les deux mille cent (2.100) parts sociales émises par la Société étaient

représentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire de sorte que l’Assemblée Générale Extraordinaire était valablement
constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

II. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire était le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation aux formalités de convocation
2. Modification de la première phrase de l’Article 7.1. des Statuts relative à la composition du conseil de gérance de

la Société afin qu’elle ait la teneur suivante:

« 7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de quatre (4) membres dont deux (2) gérants de

catégorie A et deux (2) gérants de catégorie B nommés par une décision de l’assemblée générale des associés qui fixe la
durée de leurs mandats.»

Après avoir approuvé ce qui précède, l’Assemblée Générale Extraordinaire a adopté les résolutions suivantes à l’una-

nimité:

<i>Première résolution

Tous les associés représentés ont déclaré avoir été suffisamment et préalablement informés de l’ordre du jour de

l’Assemblée Générale Extraordinaire et ont renoncé à leur droit de convocation préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier la première phrase de l’Article 7.1. des Statuts de sorte

qu’il ait la teneur suivante:

« 7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de quatre (4) membres dont deux (2) gérants de

catégorie A et deux (2) gérants de catégorie B nommés par une décision de l’assemblée générale des associés qui fixe la
durée de leurs mandats.».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale Extraordinaire a été clôturée.

<i>Assemblée générale ordinaire des associés

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire, une assemblée générale ordinaire des associés de la Société a été tenue

(l’«Assemblée»).

L’Assemblée a été présidée par M. Jean-Thomas Pradillon, prénommé.
Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Me Michel Marques Pereira, prénommé.
Le président a déclaré que:
I. Il ressort d’une liste de présences signée par le mandataire, le président, le secrétaire et le scrutateur que les deux

mille cent (2.100) parts sociales émises par la Société sont représentées à l’Assemblée de sorte que l’Assemblée est
valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

II. La liste de présences ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte.
III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation aux formalités de convocation
2. Requalification de Mme Jia Guo en tant que gérant de catégorie B en vertu de l’Article 7.1. des Statuts de la Société

de sorte que le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

<i>Gérants de catégorie A:

- M. Eric Huet; et

37234

L

U X E M B O U R G

- M. Alain Caffi

<i>Gérants de catégorie B:

- Mme Jia Guo; et
- Mme Kathryn O’Sullivan.
Après avoir examiné et délibéré sur les points ci-dessus, l’Assemblée a adopté les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

Tous les associés représentés ont déclaré avoir été suffisamment et préalablement informés de l’ordre du jour de

l’Assemblée et ont renoncé à leur droit de convocation préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée a décidé de requalifier Mme Jia Guo en tant que gérant de catégorie B en vertu de l’Article 7.1. des Statuts

de la Société de sorte que le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

<i>Gérants de catégorie A:

- M. Eric Huet; et
- M. Alain Caffi

<i>Gérants de catégorie B:

- Mme Jia Guo; et
- Mme Kathryn O’Sullivan.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes parties, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Donc acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture du présent acte, les parties comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-T. PRADILLON, M. MARQUES PEREIRA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 28 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2576. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015025608/174.
(150028207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Thunderbird R S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 111.621.

In the year two thousand and fourteen, on the first of December.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Thunderbird R S.à r.l." (hereafter referred to as the

“Company”), a “Société à responsabilité limitée”, established at 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 111.621, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER,
notary, on November 08, 2005, published in the Luxembourg Memorial C number 283 on February 08, 2006 and whose
Articles of Incorporation were for the last time modified by deed enacted on November 21, 2006 published in the
Luxembourg Memorial C number 2392 on December 22, 2006.

There appeared

JER Thunderbird S.à r.l., a “Société à responsabilité limitée” with registered office at 7, rue Michel Rodange, L-2430

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the
number B 115.484 (“the Sole Shareholder”),

hereby represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

37235

L

U X E M B O U R G

The Sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II.- That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation),
2. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company with

registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator (the “Liquidator”);

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and
4. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder passes the following resolutions:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary

liquidation).

<i>Second resolution:

The  Sole  Shareholder  resolves  to  appoint  Alter  Domus  Liquidation  Services  S.à  r.l.,  prenamed,  as  liquidator  (the

“Liquidator”).

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended

Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations,

including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liqui-
dator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several
persons or entities.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole

signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document
which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois de décembre,
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de la Société à Responsabilité Limitée "Thunderbird R S.à

r.l." (la “Société”), ayant son siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 111.621, constituée suivant
acte reçu par le notaire Maître Jean-Joseph WAGNER en date du 08 Novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 283
du 08 février 2006 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 21 novembre 2006, publié
au Mémorial C numéro 2392 du 22 décembre 2006.

A comparu

JER  Thunderbird  S.à.r.l.,  une  Société  à  Responsabilité  Limitée  avec  siège  social  au  7,  rue  Michel  Rodange,  L-2430

Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 115.484 (l’Associé Unique),

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne variatur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

37236

L

U X E M B O U R G

I. que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital de la Société;
II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une Société à Responsabilité Limitée de droit luxembour-

geois ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Divers.
L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., précité, en tant que liquidateur (le

“Liquidateur”).

<i>Troisième résolution:

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du

10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).

L'Associé Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations,

en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées,
à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Associé Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule

signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des

avances sur le solde de liquidation à l’Associé Unique de la Société conformément à l’article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en

langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. Relation: LAC/2014/58776. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015025540/116.
(150029039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Walgreen Asia Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.222,13.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.159.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth of December,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Walgreen Asia Services S.à r.l., a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 46A, Avenue J.-F. Kennedy,

37237

L

U X E M B O U R G

L-1855 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 190159 (the Company). The Company was incorporated on 22 August 2014 pursuant to
a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C. n° 3123 dated 27 October 2014.

There appeared:

Walgreen Investments Luxembourg SCS a société en commandite simple registered in Luxembourg under number

B170149, having its registered seat at 2, rue Joseph Hackin in L-1746 Luxembourg, acting through its general partner
WBA Investments LLC (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Adrien Pastorelli, Attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 23 December 2014,
The proxy from the Sole Shareholder after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at

EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a
nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
(1) Waiver of the convening notice;
(2) Conversion of the currency of the share capital of the Company from Euro (EUR) to United States Dollars (USD)

with effect as of the incorporation of the Company;

(3) Subsequent amendment of article 5 of the Articles in order to reflect the change of share capital currency specified

under item 2. above;

(4) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes with power

and authority given to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen &amp; Overy, société en commandite
simple to proceed in the name and on behalf of the Company to any formalities in connection therewith;

(5) Miscellaneous.
III. that after due deliberation, the Meeting unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to convert the currency of the share capital of the Company from its current denomination in

Euro (EUR) to a new denomination in United States Dollars (USD), and as a consequence, to convert the share capital
of the Company of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to USD 15,222.13 (fifteen thousand two hundred
twenty-two United States Dollars and thirteen cents) (according to the foreign exchange rate applicable as at 29 December
2014 pursuant to which Euro 1 was equal to USD 1,21777 as determined using the FX platform http://www.oanda.com)
with effect as of the incorporation of the Company.

The Meeting acknowledges that, as a consequence of such currency conversion, the share capital of the Company is

now set at USD 15,222.13 (fifteen thousand two hundred twenty-two United States Dollars and thirteen cents), repre-
sented by 15,222 (fifteen thousand two hundred twenty-two) shares without a nominal value per share.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above redenomination of the share

capital of the Company so that it shall henceforth read as follows:

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 15,222.13 (fifteen thousand two hundred

twenty-two United States Dollars and thirteen cents), represented by 15,222 (fifteen thousand two hundred twenty-two)
Shares without a nominal value per share ".

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen &amp; Overy, société en com-
mandite simple to, each acting individually, under their sole signature, proceed in the name and on behalf of the Company,
to the registration in the share register of the Company (including for the avoidance of any doubt the signature of said
register) of the changes mentioned under the resolutions above, and to see to any formalities in connection therewith,
if any.

37238

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately one thousand two hundred (EUR
1,200).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente décembre,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Walgreen Asia Services S.à.r.l., une société

à responsabilité limitée ayant son siège social au 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ayant un capital social
de 12.500 euros et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
190159 (la Société). La Société a été constituée le 22 August 2014 par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. n° 3123
du 27 octobre 2014.

A comparu,

Walgreen Investments Luxembourg SCS une société en commandite simple enregistrée au Grand-Duché du Luxem-

bourg sous le numéro B170149, ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin in L-1746 Luxembourg, agissant par son
gérant commandité WBA Investments LLC (l'Associé Unique),

ici représenté par Monsieur Adrien Pastorelli, avocat à la Cour, résident professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 23 décembre 2014;
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte aux fins d'enregistrement auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté tel que mentionné ci-dessus, demande au notaire instrumentaire de prendre acte de ce

qui suit:

I. que l'Associé Unique représente la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à 12.500 euros

(douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ayant chacune une valeur
nominale de 1 euro (un euro).

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Conversion de la dénomination actuelle du capital social libellé en euro (EUR) en dollars des Etats-Unis d'Amérique

(USD) avec effet à la date de constitution de la Société;

3. Modification de l'article 5 des statuts afin d'y refléter la conversion de la dénomination du capital social de la Société

décidée au point 2. ci-dessus;

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et

autorité conféré à tout gérant de la Société ou à tout avocat ou employé d'Allen &amp; Overy, société en commandite simple
afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à toute formalité y afférente;

5. Divers.
III. Qu'après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, l'associé unique représenté s'estimant dûment convoqué et déclarant avoir pris connais-
sance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de convertir la devise du capital social de la Société actuellement en euro (EUR) en Dollars des

Etats-Unis d'Amérique (USD) avec, comme conséquence, la conversion du capital social de la Société d'un montant de
12.500 euros (douze mille cinq cents euros) à un montant de 15.222,13 USD (quinze mille deux cent vingt-deux Dollars
des Etats-Unis et treize cents) (conformément au taux de change applicable au 29 décembre 2014 selon lequel 1 euro

37239

L

U X E M B O U R G

équivalait  à  1,21777  USD  tel  que  déterminé  par  référence  à  la  plate-forme  de  conversion  de  devises  http://
www.oanda.com) avec effet à la date de la constitution de la Société.

L'Assemblée prend acte qu'en conséquence de la conversion de monnaie ci-dessus, le capital social de la Société est

maintenant fixé à 15,222.13 USD (quinze mille deux cent vingt-deux Dollars des Etats-Unis et treize cents) représenté
par 15,222 (quinze mille deux cent vingt-deux) parts sociales sans valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts de façon à y refléter l'augmentation de capital social de la Société

ci-dessus de sorte qu'il est désormais rédigé comme suit:

“ Art. 5. Capital social. Le montant des parts sociales de la Société souscrites est fixé à 15,222 USD (quinze mille deux

cent vingt-deux Dollars des Etats-Unis et treize cents), représenté par 15,222 (quinze mille deux cent vingt-deux) parts
sociales sans valeur nominale.".

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessous,

et confère pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy, société en
commandite simple, chacun agissant individuellement, sous sa propre signature, afin de procéder pour le compte de la
Société à l'inscription dans le registre de parts sociales de la Société des modifications mentionnées dans les résolutions
précédentes et afin d'effectuer toute formalité y afférente si nécessaire (incluant pour lever tout doute la signature dudit
registre).

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à mille deux cents euros (EUR
1.200).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante qui est connue du notaire instrumentaire par son nom,

prénom et état civil, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: A. Pastorelli, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 8 janvier 2015. GAC/2015/266. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015025620/154.
(150028294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

GSC S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. UK Regional Portfolio II S.à r.l.).

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 193.940.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of January.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, and

having its registered office at 43, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade Register under number B 193.947,

here represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal in Luxembourg on January 27 

th

 , 2015.

The beforesaid proxy, being initialled “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to enact the following:

37240

L

U X E M B O U R G

- That the société à responsabilité limitée "UK Regional Portfolio II S.à r.l.", has its registered office at 43, avenue J-F

Kennedy, L-1855 Luxembourg, is registered at the Commercial and Companies Register in Luxembourg under number
B 193.940, was incorporated by deed dated December 15 

th

 , 2014 and enacted by the undersigned notary, in course of

being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and which bylaws have not yet been amended
since (hereafter the “Company”).

- That the share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred points sterling (GBP 12,500) re-

presented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of one pound sterling (GBP 1) each.

- That the appearing party is the current sole shareholder of the Company.
- That the appearing party fixed the agenda as follows:

<i>Agenda

1. Waiver of convening notices;
2. Change of the name of the Company to GSC S.à r.l.;
3. Amendment of article 2 of the articles of incorporation to reflect such name change;
4. Acceptance of the resignation of Mr. Luke Hamill manager, as of 28 January 2015 and appointment of Mr. Alan

Botfield as of 28 January 2015, as manager of the Company;

5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the appearing party, it took the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital being represented at this shareholders resolution, the Sole Shareholder waives the convening

to the meeting.

The Sole Shareholder is considering itself as duly convened and declares having perfect knowledge of the agenda which

has been communicated to it beforehand.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to change the registered name of the Company, from "UK Regional Portfolio II S.à r.l."

into “GSC S.à r.l.".

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder decides to amend article 2 of the Articles of

Association to read as follows:

"Article two.- The Company’s name is "GSC S.à r.l.".”

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolve to accept the resignation of Mr Luke HAMILL, from his function as manager of the

Company as of January 28 

th

 , 2015 and resolves to give him discharge for his duty since his appointment until the date

of his resignation.

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Alan BOTFIELD, with professional address at 51, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg as manager of the Company as of January 28 

th

 , 2015 and for an undetermined period.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand three hundred
euro (EUR 1,300).

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la version en langue française.

L’an deux mil quinze, le vingt-huit janvier.
Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

37241

L

U X E M B O U R G

UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit de Luxembourg, et ayant

son siège social au 43, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.947,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 27 janvier 2015.

Lequel comparant, représenté comme indiqué, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée «UK Regional Portfolio II S. à r.l.», ayant son siège social au 43, avenue J-F

Kennedy, L-1855 Luxembourg, est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B
193.940, a été constituée suivant acte reçu en date du 15 décembre 2014 par le notaire instrumentaire, en cours de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n’ont pas encore été modifiés depuis
(ci-après la «Société»).

- Que le capital social de la Société s’élève à douze mille cinq cents livres sterling (12.500.- GBP) représenté par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un livre sterling (1.- GBP) chacune.

- Que le comparant est l’associé unique actuel de la Société.
- Que le comparant a fixé l’ordre du jour comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de la dénomination de la société en GSC S.à r.l.;
3. Modification de l’article 2 des statuts de la Société afin de refléter ce changement de dénomination;
4. Acceptation de la démission de Monsieur Luke Hamill gérant, avec effet au 28 janvier 2015 et nomination de Monsieur

Alan Botfield avec effet au 28 janvier 2015, en tant que gérant de la Société; et

5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par la partie comparante, cette dernière prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représentée à la présente résolution d’associé, l’Associé Unique renonce aux for-

malités de  convocation,  l’Associé  Unique  se  considérant  lui-même comme dûment  convoqué et  déclarant  avoir  une
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la société, de «UK Regional Portfolio II S.à r.l.» en «GSC S.à

r.l.».

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article

2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. La dénomination de la société sera "GSC S.à r.l.".»

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de d’accepter la résignation de Monsieur Luke HAMILL de sa fonction de gérant de la Société,

avec effet au 28 janvier 2015 et de lui accorder décharge de sa fonction depuis sa nomination jusqu’à la date de sa
résignation.

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Alan BOTFIELD, avec adresse professionnelle au 51, avenue J.F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg comme gérant de la Société, avec effet au 28 janvier 2015 et pour une durée indéterminée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de mille trois cents euros (1.300.- EUR).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 05 février 2015. 2LAC/2015/2668. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

37242

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025586/125.
(150029115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Noble Holding Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.398.200,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.910.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of the month of January;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Noble Holding Europe S.à r.l.”, a “société à responsabilité

limitée” having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and company register under number B 104.910 (the “Company”), incorporated by a notarial
deed enacted by Me Joseph ELVINGER, notary then residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 6 De-
cember 2004, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 253 and dated 21 March 2005
and lastly amended by a notarial deed enacted by the undersigned notary on 23 February 2012 and published in Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 979, dated 16 April 2012.

The meeting is presided by Mrs. Monique GOERES, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue

Jean Engling.

The chairperson appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Christian DOSTERT, employee, residing

professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

The chairperson requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder of the Company, Noble Drilling Holdings (Cyprus) Limited, a company organized under the

laws of Cyprus, having its registered office at 1 Lampousas, PC-1095 Nicosia, Cyprus (the “Sole Shareholder”) is duly
represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal dated 28 January 2015.

The above mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing persons and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
II.- That 53,982 (fifty three thousand nine hundred eighty two) shares of USD 5 (five United States Dollars) each,

representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states as having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of convening notice right;
2. Approval of the amendment of the signature power to bind the Company;
3. Subsequent amendment of the first and second paragraphs of article 13 of the articles of association of the Company

in order to reflect the new signature power described in resolution 2. above; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.

<i>Second resolution:

It is resolved to approve the amendment of the Company's signatory policy, so that the Company shall be bound by

the sole signature of any director of the Company.

37243

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution:

As a consequence of the second resolution above, it is resolved to amend accordingly the first and second paragraphs

of article 13 of the Company’s articles of association to read as follows:

Art. 13. 1 

st

 paragraph.  "The Company shall be represented through the sole signature of any member of the board

of directors.”

nd

 paragraph.  “The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his

absence, by the vice-chairman, or by two members of the board of directors. Copies or extracts of such minutes which
may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by any member of the board
of directors."

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the above resolutions, have been estimated at about EUR 1,050.- (one thousand and fifty
Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, acting as said before, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said appearing persons have signed with us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois de janvier;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de «Noble Holding Europe S.à r.l.», une société à respon-

sabilité  limitée  ayant  son  siège  social  au  25B,  Boulevard  Royal,  L-2449  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.910 (la «Société»),
constituée par acte notarié de Maître Joseph ELVINGER, notaire alors résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, le 6 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 253 en date du 21 mars
2005 et modifié pour la dernière fois par un acte notarié du notaire soussigné le 23 février 2012 et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 979 en date du 16 avril 2012.

L'assemblée est présidée par Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-

xembourg, 12, rue Jean Engling.

La  présidente  désigne  comme  secrétaire  et  l’assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Christian  DOSTERT,

employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- L’associé unique de la Société, Noble Drilling Holdings (Cyprus) Limited, une société de droit chypriote, ayant son

siège  social  au  1  Lampousas,  PC-1095  Nicosie,  Chypre  (l’«Associé  Unique»)  est  dûment  représentée  par  Monsieur
Christian DOSTERT, pré-qualifiée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 28 janvier 2015.

La procuration susmentionnée, signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée

au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités compétentes.

L’Associé Unique, représenté tel qu'évoqué plus haut, a demandé au notaire d’acter comme suit:
II.- Que les 53.982 (cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-deux) parts sociales d’une valeur nominale de 5 USD

(cinq Dollars américains) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’Associé Unique confirme
avoir été valablement informé à l’avance.

III.- L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la modification du pouvoir de signature pour engager la Société;

37244

L

U X E M B O U R G

3. Modification en conséquence du premier et deuxième paragraphe de l’article 13 des statuts de la Société, afin de

refléter le nouveau pouvoir de signature, tel que décrit dans la résolution 2. ci-dessus; et

4. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit à une convocation préalable à la présente assemblée; l’Associé

Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère être valablement convoqué et est donc
d’accord pour délibérer et voter sur tous les points de l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation
produite à l’assemblée a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un délai suffisant pour lui permettre d’examiner
attentivement chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d’approuver la modification du pouvoir de signature dans la Société, de sorte que la Société sera désormais

engagée par la seule signature d’un de ses gérants.

<i>Troisième résolution:

En conséquence de la deuxième résolution ci-dessus, il est décidé de modifier les premier et second paragraphes de

l’article 13 de la Société pour leur donner la teneur suivante:

Art. 13. 1 

er

 paragraphe.  «La Société sera représentée par la seule signature de tout membre du conseil de gérance.»

e

 paragraphe.  «Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou,

en son absence, par le vice-président, ou par deux membres du conseil de gérance. Les copies ou extraits des procès-
verbaux destinés être produits en justice ou ailleurs devront être signés par le président ou par tout membre du conseil
de gérance.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet Acte, ont été évaluées à environ EUR 1.050,- (mille cinquante euros).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-

parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par nom, prénom, état

civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 février 2015. 2LAC/2015/2379. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015025299/138.
(150029071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

OOCL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.690.

In the year two thousand and fifteen, on the third of February.
Before Maître Martine SCHAEFFER, cicil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersi-

gned.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "OOCL (Luxembourg) S.A." (hereafter referred to as

the “Company”), a “Société Anonyme”, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, established
at Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 123690, incorporated by deed of Maître Paul Bettingen, notary

37245

L

U X E M B O U R G

residing at Senningerberg, on January 8, 2007, published in the Luxembourg Memorial C number 419 on March 21, 2007.
The articles of incorporation have not been amended since.

There appeared

Gold Talent Holding Limited, a British Virgin Islands Limited Company, with registered office at Trident Chambers,

P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Companies of British Virgin
Islands under the number 319338 (the “Sole Shareholder”), hereby represented by Mister Gianpiero SADDI, private
employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Luxem-
bourg on January 30, 2015, which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of
the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The Sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. that the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of the Sole Shareholder as liquidator (the “Liquidator”);
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the directors of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
5. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder passes the following resolutions:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary

liquidation).

<i>Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to be appointed himself as liquidator of the Company (the “Liquidator”).

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended

Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations,

including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liqui-
dator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several
persons or entities.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole

signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document
which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

<i>Fourth resolution:

The Sole Shareholder decides to grant full and total discharge to the board of directors for the accomplishment of

their respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil quinze le trois février.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

Se réunit

l'Assemblée Générale Extraordinaire de actionnaire unique de la société anonyme "OOCL (Luxembourg) S.A." (la

“Société”), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et

37246

L

U X E M B O U R G

des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B123690 constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul
Bettingen, notaire de résidence à Senningerberg en date du 8 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro 419 du 21 mars
2007. Les statuts de la société n'ont pas été changés depuis.

A comparu

Gold Talent Holding Limited, (société à responsabilité limitée des Iles Vierges Britanniques) avec siège social au Trident

Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Tortola sous le numéro 319338 (l'Actionnaire Unique),

Ici représenté par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, de résidence professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 30 janvier 2015. Ladite procuration, après
signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Actionnaire Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que l'Actionnaire Unique détient toutes les actions du capital de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de l'Actionnaire unique aux fonctions de liquidateur (le “Liquidateur”);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;
5. Divers.
III. L'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Deuxième résolution:

L'Actionnaire Unique décide d'être nommé lui-même aux fonctions de liquidateur de la Société (le “Liquidateur”).

<i>Troisième résolution:

L'Actionnaire Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi

du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).

L'Actionnaire Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opéra-

tions, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Actionnaire Unique. Le
Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement
déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Actionnaire Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule

signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Actionnaire Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des

avances sur le solde de liquidation à l'Actionnaire Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

<i>Quatrième résolution:

L'Actionnaire Unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat

jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en

langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 février 2015. 2LAC/2015/2676. Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

37247

L

U X E M B O U R G

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025342/120.
(150028879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

New-Connect S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: New-Kebab.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincaré.

R.C.S. Luxembourg B 181.041.

L'an deux mille quinze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Madame Ouarda EL FEKRE, gérante de société, née à Mazouja (Maroc) le 20 décembre 1980, demeurant à L-4744

Lamadelaine, 7, rue Jean-Pierre Kirchen,

détentrice de cent (100) parts sociales.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée "NEW-CONNECT

s. à r.l." (numéro d'identité 2013 24 46 726), avec siège social à L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincaré, inscrite
au R.C.S.L. sous le numéro B 181.041, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 octobre
2013, publié au Mémorial C, numéro 3100 du 6 décembre 2013,

a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'insérer à l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social, un deuxième alinéa ayant la teneur

suivante:

"La société a également pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, d'un établisse-

ment de restauration et d'un établissement d'hébergement."

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société prend la dénomination de "NEW-CONNECT s.à r.l.". Elle pourra exercer son activité commerciale

telle que définie au deuxième alinéa de l'article 2 des statuts sous l'enseigne NEWKEBAB ".

<i>Troisième résolution

L'associée unique constate que l'adresse de l'associée unique, respectivement de la gérante unique Madame Ouarda

EL FEKRE est désormais fixée à L-4744 Lamadelaine, 7, rue Jean-Pierre Kirchen.

La comparante déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que la société ne se
livre pas et ne s'est pas livrée pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à environ neuf cents euros (€ 900.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: EL FEKRE, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2700. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015022922/47.
(150026867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

37248


Document Outline

Acte II S.A.

A.C.U. Immobilière S.A.

Adga Rhea Consultants S.A.

Ad-Lib Consulting S.A.

Ad-Lib Consulting S.A.

Ad-Lib Consulting S.A.

Agence Générale d'Assurances R. Stelmes &amp; Fils S.à r.l.

AgFe Asset Company S.A.

AgFe, SICAV-SIF

Agro Merchants LATAM Holdings S.à.r.l.

A&amp;K S.à r.l.

Algeco/Scotsman

Algeco/Scotsman Group S.à r.l.

Algeco/Scotsman Management S.C.A.

Algeco Scotsman PIK S.A.

Allen &amp; Overy

Digital Services L (GP) S.à.r.l.

Digital Services XLVII (GP) S.à r.l.

GSC S.à r.l.

Hailey Holdings S.à r.l.

Innodis S.A., SPF

Institut de beauté Selma S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Jujosygu S.à r.l.

Kalchesbrück S.C.I.

La Main Verte S.à.r.l.

Likipi Holding S.A.

m.e.g.a. performance s.àr.l.

New-Connect S.à r.l.

Noble Holding Europe S.à r.l.

OOCL (Luxembourg) S.A.

Thunderbird R S.à r.l.

Tosca S.A. SPF

UK Regional Portfolio II S.à r.l.

Ventech China

Vitarium S.A.

Vivaro Holdings S.A.

VMF Solutions S.A.

Walgreen Asia Services S.à r.l.

White Bear S.A.

WHITE Investments

WK Investment S.A.

Xyzalux S.A.

Zarinvest S.A., SPF

Zurich Real Estate S.A.