This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2471
12 septembre 2014
SOMMAIRE
AAD Fiduciaire S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118562
Absolut Investissement, S.à r.l. . . . . . . . . . .
118563
A Capital Louvre Hotels Investments . . . .
118603
Adolfo Dominguez (Luxembourg) S.A. . . .
118563
Adomex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118563
Advent Kai Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118564
Advent Kai Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
118564
AES Structured Finance Holdings (Lux) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118565
Agihold Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118565
AIV SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118566
Allandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118564
Altercorp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118563
AMP Capital Investors (IDF II SBT N°2) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118567
AMP Capital Investors (IDF II USD N°1)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118573
AMP Capital Investors (IDF No. 2) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118569
AMP Capital Investors (Luxembourg No.
5) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118571
AMP Capital Investors (Luxembourg No.
6) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118572
Ande Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
118564
Anquith S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118564
Arenamex Invest 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
118563
Ataraxie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118565
Atelier d'Architecture et de Design Jim
Clemes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118569
Aurio SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118562
Autoparts Holdings (Luxembourg) I S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118562
Barret S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118569
Base Investments Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .
118566
BCD Technology S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118570
BCW Trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118567
Bell Equipment International S.A. . . . . . . .
118565
Best Clean Services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
118568
BIOCARDEL Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
118562
BlackGold-Société Privée d'Investisse-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118569
Braas Monier Building Group S.A. . . . . . . .
118572
Brasseur Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
118568
Bruehl Leipzig Arcaden Luxco S.àr.l. . . . .
118565
Bruehl Leipzig Arcaden S.àr.l. . . . . . . . . . . .
118587
Build Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118608
Cadami Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118571
Canto Ecological Ports S.A. . . . . . . . . . . . . .
118568
Caredor SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118572
Caymus Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
118570
CBP Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118571
Celgene Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118570
CFG Holdings S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
118573
C.K. Business Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
118570
Cresos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118572
C.T. - A & A S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118571
Digital Services XXVI (GP) S.à r.l. . . . . . . .
118592
FFI S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118573
Generali North American Holding 1 S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118567
Glacier Re Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
118567
Guardian Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
118566
Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118578
Horefi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118588
Hypatia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118574
JN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118592
ZAM Ventures Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
118562
118561
L
U X E M B O U R G
BIOCARDEL Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 131.849.
Par la présente, je vous informe de ma démission de mon poste d'administrateur de Biocardel Europe S.A. B131849
en date du 31 mars 2014.
Longuyon, le 31/03/2014.
Sandrine RENAUDIN WATRIN.
Référence de publication: 2014096697/10.
(140115513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
AAD Fiduciaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 89.237.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07. Juillet 2014.
Référence de publication: 2014096764/10.
(140115091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
ZAM Ventures Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 130.489.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ZAM Ventures Luxembourg S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014096670/11.
(140114936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Autoparts Holdings (Luxembourg) I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 158.909.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2014096757/11.
(140115415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Aurio SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 136.482.
Les comptes annuels au 31. Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
<i>Administration centrale de l'OPC
i>Signatures
Référence de publication: 2014096755/12.
(140115767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118562
L
U X E M B O U R G
Absolut Investissement, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 139.851.
Le Bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/4/2014.
Signature.
Référence de publication: 2014096765/10.
(140116394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Adolfo Dominguez (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 36, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 63.919.
Les comptes annuels au 28 février 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096768/10.
(140115347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Adomex, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 121.385.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014096769/11.
(140116349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Altercorp S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 150.353.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M. Jadot / J. Adriaens
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014096781/11.
(140115968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Arenamex Invest 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.075.
- Modification de l'adresse de la société ARENA Invest S.à r.l, Associé unique:
ARENA INVEST S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B.156722 est sis au 9a, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2014096750/12.
(140116374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118563
L
U X E M B O U R G
Advent Kai Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 130.792.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 juillet 2014.
Référence de publication: 2014096770/10.
(140116120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Advent Kai Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 130.655.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2014.
Référence de publication: 2014096771/10.
(140116121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Ande Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 167.002.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ande Management S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2014096797/11.
(140115981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Anquith S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 78.215.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. VIGNERON / F. LANNERS
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014096799/11.
(140116278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Allandis, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 148.191.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014096778/12.
(140116279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118564
L
U X E M B O U R G
AES Structured Finance Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.391.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2014.
Référence de publication: 2014096773/10.
(140116262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Agihold Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 134.545.
Le bilan abrégé au 31 janvier 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2014096775/10.
(140115530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Ataraxie S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 78.217.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. DUMONT / S. BOUREKBA
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014096808/11.
(140116019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Bell Equipment International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 16.748.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2014.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2014096828/11.
(140116409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Bruehl Leipzig Arcaden Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.429.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 juillet 2014.
Jean-Jacques Josset
<i>Manageri>
Référence de publication: 2014096845/12.
(140115255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118565
L
U X E M B O U R G
AIV SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 127.762.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096776/10.
(140115653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Guardian Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.428.327,16.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R.C.S. Luxembourg B 23.829.
EXTRAIT
Par décision de l'assemblée générale des associés de la Société en date du 30 juin 2014 les associés ont révoqué le
mandat de M. Scott V Thomsen en tant que gérant de la Société avec prise d'effet au 13 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2014099972/15.
(140119756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Base Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 82.127.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 3 juillet 2014:i>
L'Assemblée Générale Ordinaire décide:
- le renouvellement des mandats, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2015, des administrateurs suivants:
* Monsieur Massimo Paolo GENTILI, Président et Administrateur
* Monsieur Stefano ROGNA, Administrateur
* Monsieur Beat Viktor MEIER, Administrateur
* Monsieur Pietro SCIBONA, Administrateur
- le renouvellement du mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS, en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé, pour
une nouvelle période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.
A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Massimo Paolo GENTILI, 11 rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg
- Monsieur Stefano ROGNA, 5 Via P. Peri, CH-6900 Lugano Suisse
- Monsieur Beat Viktor MEIER, 3rd George Street, 8159 George House, Nassau, Bahamas
- Monsieur Pietro SCIBONA, 5 Via P. Peri, CH-6900 Lugano Suisse
<i>Réviseur d'Entreprises Agréé:i>
PRICEWATERHOUSECOOPERS, ayant son siège social à L -1014 Luxembourg, 400, Route d'Esch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014096858/26.
(140116065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118566
L
U X E M B O U R G
Generali North American Holding 1 S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 1.369.679,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.422.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014099957/9.
(140119869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
BCW Trading, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 173.309.
Par décision prise le 16 mai 2014, l'associé unique de la société BCW Trading a accepté avec effet immédiat la démission
présentée par Monsieur Bert Wilden, demeurant à Hundsumkehr 5, 93047 Regensburg, Allemagne de son mandant de
gérant de la société.
Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Référence de publication: 2014096869/11.
(140116177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
AMP Capital Investors (IDF II SBT N°2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 180.498.
EXTRAIT
En date du 7 juillet 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Emma Haight, avec adresse professionnelle au niveau 4, Berkeley Square, Berkeley Square House, Londres, W1J6
BX, Royaume-Uni, est élue nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014096791/13.
(140115699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Glacier Re Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 283.936.128,00.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 104.275.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue en date du 10 juillet 2014i>
Les associés de la Société:
- approuvent le rapport du commissaire à la liquidation;
- donnent décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation de la société;
- prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 10
juillet 2014;
- décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à
l'adresse suivante: 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2014.
Glacier Re Holdings S.à r.l., en liquidation volontaire
Signatures
Référence de publication: 2014099959/21.
(140119480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
118567
L
U X E M B O U R G
Brasseur Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 118.886.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014096881/9.
(140115422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Canto Ecological Ports S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 119.015.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014096887/9.
(140115616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Best Clean Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 13, rue Kalchesbruck.
R.C.S. Luxembourg B 180.804.
L'an deux mille quatorze, le vingt-six juin.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
- Mimouna MIMOUN, employée, demeurant à L-4716 Pétange, 22A, rue Bommert,
- Naziha ABAJJA, employée, demeurant à B-6791 Athus (Belgique), 93, Grand-Rue,
associées de la société "BEST CLEAN SERVICES Sàrl", établie et ayant son siège à L-4716 Pétange, 22A, rue Bommert,
constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 30 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Numéro 2938 du 21 novembre 2013, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B180.804.
Les comparantes prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Elles décident de transférer le siège social de Pétange à Luxembourg, et par conséquent de modifier l'article 2 des
statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:
" Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg."
<i>Deuxième résolutioni>
Elles fixent l'adresse de la société à L-1852 Luxembourg, 13, rue Kalchesbruck.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leur nom, prénom
usuel, état et demeure, elles ont toutes signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: MIMOUN, ABAJJA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 juin 2014. Relation: LAC / 2014 / 29676. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Référence de publication: 2014096873/33.
(140115351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118568
L
U X E M B O U R G
Atelier d'Architecture et de Design Jim Clemes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 74.511.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/07/2014.
Référence de publication: 2014096809/10.
(140116276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
BlackGold-Société Privée d'Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 168.568.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BlackGold-Société Privée d'Investissements S.A.
Référence de publication: 2014096835/10.
(140115823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
AMP Capital Investors (IDF No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 156.083.
EXTRAIT
En date du 7 juillet 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Emma Haight, avec adresse professionnelle au niveau 4, Berkeley Square, Berkeley Square House, Londres, W1J6
BX, Royaume-Uni, est élue nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014096793/13.
(140115744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Barret S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 25.808.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 juillet 2014 que:
Les Administrateurs et Commissaire aux comptes suivants ont démissionnés:
- Monsieur Paul LAPLUME, en qualité d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration
- Madame Martine STIEVEN, en qualité d'Administrateur
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, en qualité d'Administrateur
- Madame Mireille GEHLEN, en qualité de Commissaire aux comptes
De plus, sont nommés en leurs remplacement et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2017:
- Monsieur Frans KRAUCH, né le 21 mars 1960 à Aalst (Belgique), demeurant Bellestraat 56, B-1790 Hekelgem-Affligem
(Belgique), en qualité d'Administrateur, avec un pouvoir de signature individuel
- Monsieur Paul LAPLUME, né le 22 mars 1958 à Dudelange, demeurant au 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, en
qualité de Commissaire aux comptes
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014096856/21.
(140116354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118569
L
U X E M B O U R G
C.K. Business Center S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 55, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 77.613.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014096885/9.
(140115865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Caymus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 180.704.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Caymus Holding S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014096899/11.
(140115414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Celgene Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.000.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 165.350.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 30 juin 2014i>
Le 30 juin 2014, l'associé unique de Celgene Luxembourg a pris la résolution suivante:
- Le siège social de la Société est transféré au 21-25 Allée Scheffer, L2520 Luxembourg avec effet au 1
er
juin 2014.
Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2014096901/14.
(140115522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
BCD Technology S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 62.558.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 2014i>
1. Mme Virginie DECONINCK, administrateur de sociétés, née à Rocourt (Belgique), le 11 octobre 1976 demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale statutaire de 2019.
2. M. Jonathan MIGNON, a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. Le siège social de la société a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à
L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de M. Franck BETH et de Mme Ingrid CERNICCHI se trouve désormais
au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BCD TECHNOLOGY S.A.
Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014096863/20.
(140115670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118570
L
U X E M B O U R G
C.T. - A & A S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 49-51, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 74.654.
<i>Extrait de résolution du Liquidateur du 07.07.2014i>
Le liquidateur de la société C.T.-A&A S.A. a décidé ce qui suit:
1. Transfert du siège social au 49-51, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 07.07.2014.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2014096886/13.
(140115734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
AMP Capital Investors (Luxembourg No. 5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.992.
EXTRAIT
En date du 7 juillet 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Emma Haight, avec adresse professionnelle au niveau 4, Berkeley Square, Berkeley Square House, Londres, W1J6
BX, Royaume-Uni, est élue nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014096794/13.
(140115757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Cadami Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.452.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 8 mai 2014i>
<i>à 10.00 heuresi>
L'assemblée générale constate le changement d'adresse des personnes suivantes:
Pierre FORT, administrateur, demeurant à F - 93210 La Plaine Saint Denis, 10, Rue Federico Fellini
Bernard CALVIGNAC, commissaire aux comptes, demeurant à F - 46100 Figeac, 35, Chemin des Bruyères
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2014096915/14.
(140115133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
CBP Lux S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 110.345.
La société P. & I. S.C.I., n° R.C. E 4192, avec siège social à L-4037 ESCH-SUR-ALZETTE, 13, Rue Bolivar, représentée
par son gérant actuellement en fonction, Monsieur Philippe MONET, dénonce par la présente le siège social de la société
à responsabilité limitée CBP LUX S.A., avec siège à L-4210 Esch-sur-Alzette, 40, rue de la Libération, n° R.C.S. B 110345
avec effet date de la présente.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 1
er
juillet 2014.
P. & I. S.C.I.
Philippe MONET
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2014096926/14.
(140115535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118571
L
U X E M B O U R G
Braas Monier Building Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.558.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 juillet 2014.
Référence de publication: 2014096840/10.
(140115345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Caredor SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 123.157.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Cette mention remplace la précédente du 13/06/2014 n° L140098063
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096920/11.
(140115393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
AMP Capital Investors (Luxembourg No. 6) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.993.
EXTRAIT
En date du 7 juillet 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Emma Haight, avec adresse professionnelle au niveau 4, Berkeley Square, Berkeley Square House, Londres, W1J6
BX, Royaume-Uni, est élue nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014096795/13.
(140115765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Cresos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 97.950.
EXTRAIT
Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 juillet 2014 que:
L'assemblée reconduit les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Geert DE NEEF, né le 3 avril 1963 à Aalst (Belgique), demeurant à B-9300 Aalst, 39, Achtermaal,
- Monsieur Raf VLEUGELS, né le 3 octobre 1968 à Mol (Belgique), demeurant à B-3920 Lommel, 35, Hans Memlingdreef,
- Monsieur Jean Nicolas WEBER, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg,
36, avenue Marie-Thérèse.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2019.
L'assemblée décide de reconduire le mandat de commissaire aux comptes détenu par la société:
- FIDU-CONCEPT SARL, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B.38.136.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2019.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2014096972/20.
(140116145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118572
L
U X E M B O U R G
AMP Capital Investors (IDF II USD N°1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 176.617.
EXTRAIT
En date du 7 juillet 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Emma Haight, avec adresse professionnelle au niveau 4, Berkeley Square, Berkeley Square House, Londres, W1J6
BX, Royaume-Uni, est élue nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014096792/13.
(140115718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
CFG Holdings S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 171.086.
EXTRAIT
L'Actionnaire Unique de la Société a pris en date du 17 juin 2014 les résolutions suivantes:
- L'Actionnaire Unique de la Société accepte la démission avec effet immédiat de Mr. Marc Alexander SMIT de son
poste d'Administrateur de la Société.
- L'Actionnaire Unique de la Société nomme en remplacement et avec effet immédiat Mr. Jean-Philippe KAMM, né le
4 septembre 1982 à Harfleur (France) et résident à 28, rue de la Chapelle, L - 5213 Sandweiler (Luxembourg), en qualité
d'Administrateur de la Société.
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2014.
Référence de publication: 2014099798/17.
(140119945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
FFI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.068.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 5 juin 2014 que le mandat de M. Allen
Foley en tant que gérant de classe B de la Société a pris fin avec effet au 5 juin 2014 et que M. Hakim Bendriss, né le 27
août 1974 à Gien, France, résidant professionnellement au 5, rue Goethe L-1637 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg a été nommé en tant que gérant de classe B du conseil de gérance de la Société avec effet au 5 juin 2014 et pour
une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Nancy Gail Zimmerman, gérant de classe A;
- John Spinney, gérant de classe A;
- Hakim Bendriss, gérant de classe B;
- Frits Carlsen, gérant de classe B
- Natisha Nicole Ramroop, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 juillet 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2014096706/24.
(140114623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
118573
L
U X E M B O U R G
Hypatia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 188.627.
In the year two thousand fourteen, on the fourteenth day of July.
Before us Me Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Aristotle S.A., a public limited company, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B,
duly represented by Mr Luc HANSEN, “licencié en administration des affaires”, residing professionally at 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy.
Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw up the following
articles of a limited liability company to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is Hypatia S.à r.l..
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all immobililiar and mobiliar transactions the last of which
pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the
administration, the management, the control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into
twelve thousand five hundred (12,500) corporate units with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial
Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may
only be done in accordance with the law on Commercial Companies.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to
pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company is managed by several managers of which at least one manager of category A and one manager
of category B. The managers are appointed and dismissed by the members.
Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one manager of category
A and one manager of category B.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on
Commercial Companies.
118574
L
U X E M B O U R G
Art. 15. The business year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
of each year.
Art. 16. Every year on December 31
st
, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-
bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be
members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,
pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant
legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2014.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) corporate units have been entirely subscribed by the sole member Aristotle
S.A., predesignated.
All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on Commercial Companies
have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
EUR 1,100.-.
<i>Resolutions of the sole memberi>
The sole member, prenamed, represented as mentioned above, representing the whole of the corporate capital, passed
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Are appointed managers of the company, for an undetermined period and with the powers indicated in article 11 of
the articles of incorporation:
<i>Category Ai>
1. Mrs Natacha ONAWELHO-LOREN, lawyer, born on 7 January 1971 in Kampala, Uganda, residing at 3, rue Chausse
Coq, CH-1204 Geneva,
<i>Category Bi>
2. Mr Luc HANSEN, “licencié en administration des affaires”, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing profes-
sionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
3. Mr Philippe PONSARD, “ingénieur commercial”, born on 16 March 1967 in Arlon, Belgium, residing professionally
at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
<i>Second resolutioni>
The company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
118575
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing person, known
to the notary by his surname, first name, civil status and residence, signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Folgt die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, den vierzehnten Juli.
Vor uns Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz zu Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Aristotle S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, noch nicht im Han-
dels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingetragen,
hier vertreten durch Herrn Luc HANSEN, „licencié en administration des affaires“, mit beruflicher Anschrift in L-1653
Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar "ne
varietur" gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründ-
enden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der ihr die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung Hypatia S.à r.l..
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Sitz kann durch Beschluss den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle immobiliaren und mobiliare Operationen, welch letztere direkt oder
indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die
Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung,
Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, Die Ge-
sellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an alle
Gesellschaften der Gruppe oder an Gesellschafter, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien
gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile zu je ein Euro (EUR 1).
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen an
Dritte unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-
tums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mehreren Geschäftsführer verwaltet, von denen mindestens ein Geschäftsführer
der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B zugehört. Die Gesellschafter nominieren und entlassen die
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem
Geschäftsführer der Kategorie B nach außen hin verpflichtet.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
118576
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über die Handelsgesellschaften sind für die Beschlüsse der
Generalversammlung zu beachten.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung gilt solange bis die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Wenn und so lange ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2014.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die zweitausendfünfhundert (12.500) Anteile wurden durch die alleinige Gesellschafterin, Aristotle S.A., vorgenannt,
gezeichnet.
Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
EUR 1.100,-.
<i>Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterini>
Die vorgenannte alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital dar-
stellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Zu Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer und mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen
werden ernannt:
<i>Kategorie A:i>
1. Frau Natacha ONAWELHO-LOREN, Anwältin, geboren am 7.
Januar 1971 in Kampala, Uganda, wohnhaft in 3, rue Chausse Coq, CH-1204 Genf,
<i>Kategorie B:i>
2. Herr Luc HANSEN, „licencié en administration des affaires“, geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, mit beruflicher
Anschrift in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle,
3. Herr Philippe PONSARD, „ingénieur commercial“, geboren am 16. März 1967 in Arlon, Belgien, mit beruflicher
Anschrift in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
118577
L
U X E M B O U R G
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der Komparentin
die vorliegende Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben Komparentin
und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung rechtsgültig.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, dem instrumen-
tierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: L. HANSEN, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 15 juillet 2014. Relation: RED/2014/1535. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. ELS.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, den 15. Juli 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2014102199/221.
(140122580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
HPF 1 Feeder, Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 188.659.
STATUTES
In the year two thousand fourteen on the twenty-seventh day of June.
Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) Foyer Vie S.A. with registered office at 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange and registered with the Luxembourg
trade registry under the number B 34233, being duly represented by Mr. Benoît Lejeune residing professionally in Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 13 June 2014;
2) Cardif Lux Vie S.A. with registered office at 23-25 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg and registered
with the Luxembourg trade registry under the number B 47240, being duly represented by Mr. Benoît Lejeune residing
professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 10 June 2014;
3) P&V Assurances Scrl with registered office at rue Royale 151-153, B-1210 Saint-Josse-ten-Ode (Brussels) and re-
gistered with the Registre des Personnes Morales Bruxelles under the number 0402.236.531, being duly represented by
Mr. Benoît Lejeune residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 19 June 2014;
4) Aviabel RE S.A. with registered office at 534 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg registry under the number B 48216, being duly represented by Mr. Benoît Lejeune residing professionally in
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 11 June 2014.
The proxies given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to
the present deed and will be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act have requested the undersigned notary to state as follows the
Articles of Incorporation (the "Articles") of a company which they declare organised by itself.
Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers, and all those who may become owners of shares
hereafter issued, a public limited company (société anonyme or S.A.) qualifying as an investment company with variable
share capital established as a specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investisse-
ment spécialisé) governed by the law of February 13, 2007 on specialised investment funds, as such law has been and will
be amended from time to time, under the name of “Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF” or, in abbreviated
form, “HPF 1 Feeder SA SICAV-SIF” (hereinafter the “Company”).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of
Luxembourg. The registered office of the Company may be transferred within the same municipality by resolution of the
board of directors of the Company (the “Board”).
118578
L
U X E M B O U R G
In the event that the Board determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent
which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Duration. The Company is established for a period of ten (10) years.
The Company may however be dissolved earlier if the Master Fund (as defined in article 4 below) is terminated before
such ten (10) year term. The Company would then be dissolved on the date of termination of the Master Fund as such
date is determined pursuant to the constitutive documents of the Master Fund.
In addition, the Company may at any time be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for the amendments of the present articles of association as further set out in article 27 therein.
Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest directly or indirectly through its wholly owned
subsidiary(ies) all or substantially all of its the funds available to it in Health Property Fund 1, a French law, simplified,
leveraged variable capital investment company investing primarily in real estate (société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier or “SPPICAV”) with registered office
at 167 quai de la Bataille de Stalingrad 92867 Issy les Moulineaux Cedex, France (the "Master Fund"), in accordance with
the law of February 13, 2007 on specialized investment funds, as such law has been or may be amended from time to
time (the “SIF Law”). The Company and or its wholly owned subsidiary(ies) may further hold cash or cash equivalents,
and such other assets as disclosed in the latest information memorandum issued by the Company (the “Information
Memorandum”).
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted under the SIF Law.
Title II. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The share capital of the Company shall be represented by fully paid up shares
without par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company.
The minimum share capital shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-), as specified
in the SIF Law or the equivalent thereof in any other currency. The minimum share capital of the Company must be
achieved within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment
fund under the SIF Law.
The shares to be issued pursuant to article 7 hereof are of different classes (each a “Class”, and together the “Classes”).
There are distribution shares (“Distribution shares”) and capitalisation shares (“Capitalisation shares”). Distribution sha-
res entitle the holders thereof to the portion of the Company's available net income attributable during the lifetime of
the Company. Capitalisation shares entitle the holders thereof to the portion of the Company's available net income,
which portion will be reinvested by the Company and distributed to such holders as at closing of the Company's liqui-
dation.
The Company may, as the Board shall determine, in the future, issue shares of further Classes so as to correspond to
(i) a specific sales and redemption charge structure and/or (ii) a specific management or advisory fee structure and/or (iii)
different distribution, shareholders servicing or other fees and/or (iv) different types of targeted investors and/or (v) such
other features as may be determined by the Board from time to time.
For the purpose of determining the total assets of the Company, the net assets attributable to each Class of shares
shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro.
Art. 6. Form of Shares.
(1) The Company shall only issue shares in registered form.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by
the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name
of each owner of record of registered shares, residence or elected domicile of the owner as indicated to the Company,
the number of registered shares held by the owner of record and the amount paid up on each share.
The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences the shareholder's right of ownership on
such registered shares.
(2) Shareholders entitled to receive shares shall provide the Company with an address to which all notices and an-
nouncements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
118579
L
U X E M B O U R G
(3) The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to
represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise
of all rights attached to such share(s).
(4) The Company may decide to issue fractional shares, up to three decimals. Such fractional shares shall not be entitled
to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable such class of shares on a pro rata basis.
(5) Each share grants the right to one vote at every meeting of shareholders and as the case may be at separate Class
meetings of the holders of shares of each of the Classes issued.
Art. 7. Subscription of Shares. In accordance with article 1 of the SIF Law, shares of the Company may only be
subscribed by well-informed investors, which, in accordance with article 2 of the SIF Law, are (i) institutional investors,
(ii) professional investors, or (iii) any other investors having declared in writing their adherence to the status of a well-
informed investor and either having a minimum commitment to the Company of at least one hundred and twenty-five
thousand Euros (EUR 125,000.-) (or an equivalent amount in another currency) or having been the subject of an assess-
ment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment firm within the meaning
of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of Directive 2001/107/EC certifying his ex-
pertise, his experience and his knowledge in adequately appraising an investment in a specialised investment fund (“Well-
Informed Investors”)
Except where dealings in shares have been suspended (as specified in article 12), shares may be subscribed by investors
at such date or during period(s) and in the manner specified in the Information Memorandum at the subscription price.
Applications for shares should be made in writing and in the manner specified in the Information Memorandum or such
other method as the Board in its discretion may accept.
The subscription price to be paid by Investors subscribing for Capitalisation shares and/or Distribution Shares upon
the Initial Closing Date (as defined in the Information Memorandum) shall be EUR 10,000.
Except for subscription made on the Initial Closing Date, subscriptions are made at unknown Net Asset Value (as
defined in article 11) and the number of shares to be received is determined upon the Net Asset Value calculated at the
Valuation Day (as defined in article 12) following the subscription.
The vesting date is the first calendar date after the Valuation Day.
Investors will be required (in their application form) to enter into a commitment to subscribe for an amount of shares.
Art. 8. Redemption of Shares. No shares will be redeemed until 31 December 2015 (the “Lock-in Period”). After the
end of the lock-In Period, shareholders may request the redemption of all or part of their shares by submitting a written
notice to the Administrator (as defined in the Information Memorandum) stating the value of shares to be redeemed (a
"Redemption Form"). A Redemption Form must include or be accompanied by such evidence of the shareholder's identity
and such other documents as the Board may require, failing which payment of redemption proceeds may be delayed.
The redemption requests are to be received by the Board before 5 p.m. (CET) ten (10) business days before the
relevant Valuation Day.
After the end of the Lock-in Period, when a shareholder requests the redemption of a number of shares higher than
0.01% of the shares it holds in the Company, the portion of shares for which redemption is requested exceeding such
percentage might not be carried out by the Company. The portion of the redemption order not carried out is carried
over to the next Valuation Day.
The redemption price shall be the Net Asset Value as determined on the first Valuation Day after the Board's receipt
of the Redemption Form in due time before the relevant Valuation Day, as described above.
In that case, the Board will inform the shareholder by registered letter with request for receipt of the partial execution
of his order as well as the justification and conditions of execution above.
In the event that the shareholder's redemption request must be carried out over more than sixteen (16) Valuation
Days, the redemption request shall be carried out entirely on the sixteenth (16
th
) Valuation Day, being at the end of
four (4) years.
The standard redemption settlement time shall be up zero (0) to nine (9) months, depending on the redemption
settlement date organized by the Master Fund.
As a consequence when redemption is requested, the Company will have a maximum four (4) years and nine (9)
months to satisfy such redemption request.
Payments will be made in EUR, normally by transfer to an account specified in the Redemption Form. Pending re-
demption of the shareholder's shares, the shares will remain in issue and he will continue to be entitled to participate in
the income of the Company as if the Redemption Form had not been given. Shares which have been redeemed will be
cancelled.
Art. 9. Compulsory Sale or Redemption of Shares. A shareholder who is, or who holds shares on behalf of, a person
whose interest in such shares (whether alone or in conjunction with other persons in the same position) is:
i. such as to cause the Company to be in breach of any law or regulation of any country or governmental authority;
or
118580
L
U X E M B O U R G
ii. in the Board's reasonable opinion, likely to give rise to any fiscal, tax or other pecuniary disadvantage to the Company
or to other shareholders or to increase the cost of administering the Company,
shall be considered a “Disqualified Investor”.
Any shareholder who to his knowledge becomes a Disqualified Investor is required to notify the Board accordingly
and to offer all its shares for sale. The Board may call upon the holder of any shares to establish to its satisfaction that
the holder is not a Disqualified Investor, failing which the Board may require him to sell his shares. If the shareholder fails
to sell his shares the Board may do so as the Disqualified Investor's agent or compulsorily redeem those shares (at the
discretion of the Board). Such shares will be sold or compulsorily redeemed at 75 % of the then current Net Asset Value
per share of the Company reduced by any cost, expenses, interests and penalties borne by the Company and related to
such compulsory redemption.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares and Transfer of Shares.
1. Restrictions on Ownership of Shares
The shares will only be issued to shareholders qualifying as Well-Informed Investors and having provided specified
identification documentation and information to comply with various “know your client” and anti-money laundering
regulations and as required by the Board or any relevant agent of the Company at the time of subscription and at any
other time as notified to the relevant shareholders.
The Board may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body,
if in the opinion of the Board such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or
regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disad-
vantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred, as further described in the Information
Memorandum.
2. Restrictions on Transfer of Shares
Shares will be freely transferable among shareholders. Any transfer of shares by a shareholder to a third party shall
be subject to the prior written approval of the Board, not to be unreasonably withheld. The Board shall inter alia be
satisfied that the proposed transferee is a Well-Informed Investor and is not a Disqualified Investor and has satisfied KYC
obligations.
Notification of any transfer of shares is to be provided to the Company and to the Administrator by the transferor
no later than 10 business days before the expected date of transfer. Such notification shall state the name and address of
the proposed transferee, the number of shares to be transferred and provide the anti-money laundering documents
regarding the transferee. Registration of a transfer will take effect only on a Valuation Day. It will be the responsibility of
the transferor and transferee to deal with any taxes, duties, imposts or levies payable on or in consequence of a transfer
of Shares.
Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share shall be determined by dividing the
net assets of the Company (being the portion of assets less the portion of liabilities attributable to the Company, on any
such Valuation Day) (the “Net Asset Value”), by the number of shares then in issue, in accordance with the valuation
rules set out below. Net Asset Value per share will include any income which has been allocated, but not yet distributed,
by the Master Fund to the subsidiary.
If following the determination of the Net Asset Value of the shares there is a material change in relation to a substantial
part of the assets or property rights of the Company, the Board may, in order to safeguard the interests of the share-
holders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
I. The value of the assets of the Company shall be determined as follows:
The value of the Master Fund shares held indirectly by the Company will be calculated by taking the aggregate net
asset value of the Master Fund shares (the “Master NAV”) held indirectly by the Company, valued in accordance with
the valuation policy of the Master Fund.
The assets of the Company will be valued in accordance with Luxembourg GAAP standards.
The value of any shares, loans, cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the
full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof
shall be determined after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true
value thereof.
The Company is authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the Company if the
aforesaid valuation methods appear impossible or inappropriate due to extraordinary circumstances or events in order
to reflect better the probable realisation value established with prudence and good faith.
II. The liabilities of the Company shall be determined as follows:
The liabilities of the Company will be valued in accordance with Luxembourg GAAP standards.
The liabilities of the Company shall include:
(a) all loans and other indebtedness for borrowed money (including convertible debts), bills and accounts payable net
of the unamortised portion of discounts and/or premiums and financing costs;
118581
L
U X E M B O U R G
(b) all accrued interest on such loans and other indebtedness for borrowed money (including accrued fees for com-
mitment for such loans and other indebtedness);
(c) all accrued or payable expenses (including fees payable to agents);
(d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money, in-
cluding the amount of any unpaid distributions declared by the Company, where the Valuation Day falls on the record
date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
(e) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Board, as well as such amount (if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in
respect of any contingent liabilities of the Company (i.e. liabilities for past events which are definite as to their nature and
are certain or probable to occur and can be measured with reasonable accuracy, which might arise during the life of the
Company and may include potential liabilities arising from any disputes); and
(f) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law.
In determining the amount of such liabilities the Board shall take into account all expenses payable by the Company. The
Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount
rateably for yearly or other periods.
III. For the purpose of this article:
a) shares to be redeemed (if any) shall be treated as existing and taken into account until the date on which the shares
are redeemed, and from such time and until paid by the Company the price therefor shall be deemed to be a liability of
the Company;
b) shares to be issued shall be treated as being in issue as from the date of issue and from such time and until received
by the Company the price therefor shall be deemed to be a debt due to the Company;
c) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of de-
nomination of the shares shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the
date and time for determination of the Net Asset Value per share of the Company; and
d) the assets and liabilities of the Company shall be deemed to include the assets and liabilities of its wholly owned
subsidiary(ies), unless such assets and liabilities are already explicitly included by way of the provisions set out above.
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of the Net Asset Value per Share. The Net Asset Value
per share of the Company will be calculated as at 31 March, 30 June, 30 September and 31 December (each a "Valuation
Day"). Additionally the Net Asset Value per share of the Company will be calculated on 10 December 2014 and 10
December 2015.
The Board may appoint additional or alternative days to be Valuation Days and will notify Shareholders accordingly.
The Board may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value per Share and if applicable, the issue
of its shares:
a) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Board as a result
of which disposals or valuation of assets owned by the Company would be impracticable;
b) during any period when, as a result of the political, economic, military or monetary events or any circumstance
outside the control, responsibility and power of the Board, or the existence of any state of affairs in the real estate market,
disposal of the assets of the Company is not reasonably practicable without materially and adversely affecting and preju-
dicing the interests of shareholders or if, in the opinion of the Board, a fair price cannot be determined for the assets of
the Company;
c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of the
assets of the Company;
d) when for any other reason the prices of the assets owned by the Company cannot promptly or accurately be
ascertained;
e) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of the shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of the assets of
the Company or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal rates
of exchange;
f) during any period when the value of the net assets of the underlying investment vehicles in which the Company has
invested, may not be determined accurately, or if the calculation of the net asset value of the underlying investment
vehicles is suspended; or
g) upon publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of resolving the winding
up of the Company.
Any such suspension shall be published, if appropriate, by the Administrator and may be notified to shareholders having
made an application for subscription of shares for which the calculation of the Net Asset Value per share has been
suspended.
118582
L
U X E M B O U R G
Title III. Administration and supervision
Art. 13. The Board. The Company shall be managed by the Board composed of at least three (3) members, who need
not be shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders which shall determine their
remuneration and term of office.
Each director shall remain in function until his or her successor is elected, provided, however, that any director may
be removed with or without cause and/or replaced at any time by a resolution adopted by the general meeting. Upon
the expiry of their term, directors may be reappointed by the general meeting.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 14. Meetings of the Board. The Board may choose from amongst its members a chairman, and may choose from
among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall
be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside over all meetings of shareholders and the Board, but in his absence the shareholders or
the Board may appoint another director, and in respect of shareholders meetings any other person, as chairman pro
tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Board may from time to time appoint the officers of
the Company, including general managers and any assistant general managers or other officers considered necessary for
the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers
need not be directors or shareholder of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these
Articles, shall have the powers and duties given them by the Board.
Notice of any meeting of the Board shall be given by the chairman to all directors at least twenty-four (24) hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax
or e-mailed PDF scan of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call or similar means of communications equip-
ment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means
shall constitute presence in person at such meeting.
Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or e-mailed PDF scan another
director as his proxy. The Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or
represented at a meeting of the Board. If the quorum is not satisfied, another meeting shall be convened.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the
event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting
vote.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing and may consist of one or
several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall
be the date of the latest signature.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro
tempore who presided over such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 15. Powers of the Board. The Board possesses the widest powers to manage the business of the Company and
to take all actions of disposal and administration which are in line with the objects of the Company, and anything which
is not a matter for the general meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its
competence.
The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management
and business affairs of the Company.
The Board may delegate under its overall responsibility and control its powers to conduct the daily management and
affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to directors
or officers of the Company.
Art. 16. Corporate Signature. Towards third parties, the Company will be bound by the joint signature of any two (2)
directors or, by the joint or sole signature of any director or officer to whom authority has been specially delegated by
the Company.
Art. 17. Delegation of Power. The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the
Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in fur-
therance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not
118583
L
U X E M B O U R G
be members of the board, who shall have the powers determined by the Board and who may, if the Board so authorises,
sub-delegate their powers.
The Board may enter into an investment management agreement with one or several investment managers which may
undertake certain management and investment advisory functions under the control and responsibility of the directors
of the Company.
The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. Investment Policies. The Board, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine (i)
the investment policy of the Company (ii) the hedging strategy to be applied to the shares and (iii) the course of conduct
of the management and business affairs of the Company, all in compliance with the provisions of these Articles, the
Information Memorandum and with applicable laws and regulations.
Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company has in any transaction of the Company an interest opposite
to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the Board such opposite interest and shall
not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall
be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be
determined by the Board in its discretion.
Art. 20. Indemnification of Directors. Subject to Luxembourg law, the Company shall indemnify any member of the
Board or any of its employees, directors, officers or partners, against any claims asserted in connection with the operations
of the Company involving a person's status as a member of the Board or any of its employees, directors, officers or
partners, unless it is determined that any such person's action was due to (i) an act or omission material to the matter
giving rise to the proceedings that either was committed with negligence, wilful misconduct or fraud, in bad faith or was
the result of a material breach of any duty under the Information Memorandum, or these Articles; (ii) the actual receipt
of an improper personal benefit in money, property or services; or (iii) in the case of any proceedings, a belief, based on
reasonable cause, that the act or omission was unlawful.
Art. 21. Auditors. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor
(réviseur d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.
The auditor shall fulfil all duties prescribed by the SIF Law.
Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company
shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders.
It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board.
It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth (1/10
th
) of the share capital.
The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Company in Luxembourg, on the second Tuesday of May of each year at 2:30 p.m. Luxembourg time. If such day
is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
Shareholders shall meet upon call by the Board pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least ten (10)
Business Days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of share-
holders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be
prepared by the Board except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in
which instance the Board may prepare a supplementary agenda.
If all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered
mail only. If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed
of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting
of shareholders.
Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing
their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
118584
L
U X E M B O U R G
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each share of any Class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles. A shareholder
may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder and
who may be a director of the Company. Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed
resolution, nor an abstention, are void.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the
votes of the shareholders validly cast.
Art. 23. General Meetings of Shareholders in a Class of Share. General meetings of shareholders shall be held, at any
time, to decide on any matters which relates exclusively to such Class.
The provisions of article 22, paragraphs 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 shall apply to such general meetings.
Art. 24. Financial Year. The financial years of the Company shall commence on 1 January of each year and shall terminate
on 31 December of the same year.
Art. 25. Distributions. The general meeting of shareholders of the Company shall, upon proposal from the Board and
within the limits provided by law, determine how the results of the Company shall be disposed of, and may from time to
time declare, or authorise the Board to declare, distributions.
For any Classes of shares entitled to distributions, the Board may decide to pay interim dividends in compliance with
the conditions set forth by law.
Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the
register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board shall
determine from time to time. The Board may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such
terms and conditions as may be set forth by the Board.
Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to the
issued shares.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. Final provisions
Art. 26. Depositary. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking
or saving institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the
“Depositary”).
The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the SIF Law.
If the Depositary desires to retire, the Board shall use its best endeavours to find a successor depositary within two
months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Depositary but shall
not remove the Depositary unless and until a successor depositary has been appointed to act in the place thereof.
Art. 27. Alternative investment fund manager. In accordance with the provisions of the law dated 12 July 2013 on
alternative investment fund managers, as may be amended from time to time (the “AIFM Law”), the Company qualifies
as an alternative investment fund (“AIF”) and has designated an external alternative investment fund manager (“AIFM”)
The AIFM is responsible for the portfolio management and the risk management functions in accordance with the
AIFM Law.
The AIFM has been duly authorized to act as AIFM by the the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the
"CSSF").
Art. 27. Dissolution of the Company. Notwithstanding the provisions of article 3 hereabove, the Company may at any
time be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements
referred to in article 30 hereof.
Whenever the share capital falls below two-thirds (2/3
rd
) of the minimum capital indicated in article 5 hereof, the
question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board. The general meeting,
for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the
meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share
capital falls below one-fourth (1/4
th
) of the minimum capital set by article 5 hereof; in such an event, the general meeting
shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth
(1/4
th
) of the votes of the shares represented at the meeting.
118585
L
U X E M B O U R G
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net
assets of the Company have fallen below two-thirds (2/3
rd
) or one-fourth (1/4
th
) of the legal minimum, as the case
may be.
Art. 29. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or
legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compen-
sation.
Art. 30. Amendments to the Articles. These Articles may be amended by a general meeting of shareholders subject
to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 31. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organised group of persons whether
incorporated or not.
Capitalised terms within these Articles shall have the same meaning as in the Information Memorandum, unless other-
wise defined herein.
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies and the SIF Law as such laws have been or may be amended from time to
time.
<i>Transitional Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of its incorporation and end on 31 December 2014.
The first annual general meeting shall be held in 2015.
<i>Initial Capital - Subscription and Paymenti>
The initial capital is fixed at thirty six million two hundred and six thousand four hundred and thirty- six euros and
forty cents (EUR 36,206,436.40) represented by three thousand six hundred and twenty point six hundred and forty-
three (3,620.643) Distribution shares without par value.
The entire share capital is subscribed as follows by the pre-named appearing parties, as follows:
Foyer Vie S.A. for two hundred and ninety-seven point nine hundred and twenty-eight Distribution shares of the
Company
Cardif Lux Vie S.A. for one thousand eight hundred and forty-three point three hundred and eighteen (1,843.318)
Distribution shares of the Company
Aviabel RE S.A. for one hundred and ninety-seven point nine hundred and seventy- four (197.974) Distribution shares
of the Company
P&V Assurances Scrl for one thousand two hundred and eighty one point four hundred and twenty-three (1,281.423)
Distribution shares of the Company
The above shareholders declare to subscribe for the Distribution shares and to have them fully paid up by the con-
tribution of:
Thirty two thousand seven hundred and forty-six point five thousand seven hundred and twenty- nine (32,746.5729)
shares of the Master Fund, prenamed, contributed by Foyer Vie S.A. for a value of two million nine hundred and seventy-
nine thousand two hundred and eighty-three euros and twenty cents (EUR 2,979,283.20)
Two hundred and two thousand six hundred and six point nine thousand four hundred and thirty-five (202,606.9435)
shares of the Master Fund, prenamed, contributed by Cardif Lux Vie S.A. for a value of eighteen million four hundred and
thirty-three thousand one hundred and seventy-nine euros and seventy-two cents (EUR 18,433,179.72).
Twenty one thousand seven hundred and sixty point one thousand six hundred and ninety-seven (21,760.1697) shares
of the Master Fund, prenamed, contributed by Aviabel RE S.A. for a value of one million nine hundred and seventy-nine
thousand seven hundred and forty euros and twenty-four cents (EUR 1,979,740.24)
One hundred and forty thousand eight hundred and forty-six point seven thousand eighty seven (140,846.7087) shares
of the Master Fund, prenamed, contributed by P&V Assurances Scrl for a value of twelve million eight hundred and
fourteen thousand two hundred and thirty-three euros and fifty-six cents (EUR 12,814,233.56).
That is to say a total of three hundred and ninety-seven thousand nine hundred and sixty point three thousand nine
hundred thirteen (397,960.3913) shares of the Master Fund, prenamed, for a total value of thirty-six millions two hundred
and six thousand four hundred and thirty-six euros and forty cents (EUR 36,206,436.40) which have been allocated to
the share capital of the Company.
Pursuant to articles 26-1 and 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915 as amended,
the shares of the Master Fund being contributed to the Company have been the subject of a report prepared by Price-
waterhouseCoopers, independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) dated 18 June 2014, which concludes as follows:
118586
L
U X E M B O U R G
“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the con-
tribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value of the shares to be issued in
counterpart”.
The said auditor's report, after having been signed ne varietur by the representatives of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the
Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses which shall be borne by the Company as a result of its creation are estimated at approximately EUR
8,500.-.
<i>General Meeting of Shareholdersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as validly convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders which resolved as follows:
I. The following are elected as directors for a term to expire at the close of the annual general meeting of shareholders
which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 31 December 2014.
<i>Members:i>
- Sven REIN, born on 3 November 1967 in Wiesbaden, Germany, residing professionally at 44, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg;
- Jacqueline FAISANT, born on 28 August 1955 in Tain l'Hermitage, France, residing professionally at 167 quai de la
Bataille de Stalingrad, F-92867 Issy-les-Moulineaux Cedex, whose appointment is, as of the date of today, still subject to
approval by Commission de Surveillance du Secteur Financier;
- Dominique MOERENHOUT, born on 23 May 1974 in Etterbeek, Belgium, residing professionally at 44, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
II. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative with registered office at 400 Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, is
appointed as auditor of the Company for a term to expire at the close of the annual general meeting of shareholders
which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 31 December 2014.
III. The registered office of the Company is set at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this deed.
This deed having been given for reading to the parties, they signed together with us, the notary, this original deed.
Signé: B. LEJEUNE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2014. Relation: LAC/2014/31214. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Référence de publication: 2014102191/525.
(140123612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
Bruehl Leipzig Arcaden S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.146.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 juillet 2014.
Jean-Jacques Josset
<i>Manageri>
Référence de publication: 2014096846/12.
(140115254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
118587
L
U X E M B O U R G
Horefi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 89.469.
L'an deux mille quatorze, le trente juin,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société «HOREFI S.à r.l.», une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.469, constituée suivant acte notarié en date du 21 octobre
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 novembre 2002, numéro 1684 (ci-après la «So-
ciété»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 20 décembre
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 11 mars 2013, numéro 589.
L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Carla LOURO, employée privée, résidant
professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Martine ZELLINGER, employée privée, ré-
sidant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maxime TOQUE, corporate officer, résidant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Refonte intégrale des statuts de la Société visant notamment à créer deux catégories de gérants sans pour autant
modifier le montant du capital social de la Société, la date de clôture de l'exercice ou l'objet social;
2. Nomination en tant que gérants de la Société, pour une durée indéterminée de:
- Monsieur Raphaël SAXOD, actuel gérant unique de la Société, né à Annecy (France), le 17 janvier 1971, demeurant
à Victory Heights, Estella Drive, Villa 42, Dubaï Sports City (Émirats Arabes Unis), en qualité de «Gérant de catégorie A»
de la Société;
- Monsieur Yves SAXOD, né à Grenoble (France), le 27 avril 1962, demeurant au 7, Clos des Barattes, F-74290 Veyrier-
du-Lac, en qualité de «Gérant de catégorie A» de la Société;
- Monsieur Jean-Luc SAXOD, né à Grenoble (France), le 14 mai 1959, demeurant au 219, Route du Président Lavy,
F-74370 Argonay, en qualité de «Gérant de catégorie A» de la Société;
- Madame Marie-Laure MOUCHET, né à Grenoble (France), le 21 novembre 1957, demeurant au 73, Les Coudrets,
F-74350 Cruseilles, en qualité de «Gérante de catégorie A» de la Société;
- Monsieur Thierry JACOB, né à Thionville (France), le 7 juillet 1967, résidant professionnellement au 412F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, en qualité de «Gérant de catégorie B» de la Société;
- Madame Chantal MATHU, né à Aye (Belgique), le 8 mai 1968, résidant professionnellement au 412F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, en qualité de «Gérante de catégorie B» de la Société;
3. Divers.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de la refonte complète des statuts de la Société afin de leur donner désormais la teneur
suivante:
118588
L
U X E M B O U R G
«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «HOREFI S.à r.l.» (la
Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, indus-
trielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création,
la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute
activité, sous quelque forme que ce soit, principalement liée au secteur de l'immobilier, ainsi que la gestion et la mise en
valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée
selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».
3.2 La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à quatre millions huit cent soixante-quinze mille cent soixante-quinze euros (EUR
4.875.175,-), représenté par cent quatre-vingt-quinze mille sept (195.007) parts sociales sous forme nominative d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de part sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
118589
L
U X E M B O U R G
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
7.2 Les membres du conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de
catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si la majorité des
Gérants de catégorie A et la majorité des Gérants de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil
de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de
catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par la majorité des voix
des gérants de catégorie A présents ou représentés et la majorité des voix des gérants de catégorie B présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),
la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie
B.
10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
118590
L
U X E M B O U R G
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par téléfax ou courrier
électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaî-
tront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente-et-un septembre de
chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires
aux associés avant la fin de l'exercice social sur la base d’un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par
les associés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide, en outre, de nommer en tant que gérants de la Société, pour une durée indéterminée,
les personnes suivantes:
- Monsieur Raphaël SAXOD, actuel gérant unique de la Société, né à Annecy (France), le 17 janvier 1971, demeurant
à Victory Heights, Estella Drive, Villa 42, Dubaï Sports City (Émirats Arabes Unis), en qualité de «Gérant de catégorie A»
de la Société;
- Monsieur Yves SAXOD, né à Grenoble (France), le 27 avril 1962, demeurant au 7, Clos des Barattes, F-74290 Veyrier-
du-Lac, en qualité de «Gérant de catégorie A» de la Société;
- Monsieur Jean-Luc SAXOD, né à Grenoble (France), le 14 mai 1959, demeurant au 219, Route du Président Lavy,
F-74370 Argonay, en qualité de «Gérant de catégorie A» de la Société;
118591
L
U X E M B O U R G
- Madame Marie-Laure MOUCHET, né à Grenoble (France), le 21 novembre 1957, demeurant au 73, Les Coudrets,
F-74350 Cruseilles, en qualité de «Gérante de catégorie A» de la Société;
- Monsieur Thierry JACOB, né à Thionville (France), le 7 juillet 1967, résidant professionnellement au 412F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, en qualité de «Gérant de catégorie B» de la Société;
- Madame Chantal MATHU, né à Aye (Belgique), le 8 mai 1968, résidant professionnellement au 412F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, en qualité de «Gérante de catégorie B» de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. LOURO, M. ZELLINGER, M. TOQUE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
juillet 2014. LAC / 2014 / 30230. Reçu soixante quinze euros.. 75,-
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Référence de publication: 2014102205/232.
(140122822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
JN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 95.074.
<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration daté du 2 juillet 2014i>
En date du 23 mai 2014, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.
Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse professionnelle de tous les Ad-
ministrateurs, à savoir Richard BREKELMANS, Elizabeth TIMMER et Michael VERHULST au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, et ce avec effet immédiat ainsi que le transfert du siège social du Commissaire aux Comptes ALTER AUDIT
S.à r.l. au 163, Rue du Kiem, L-8030 Strassen et ce avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2014.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014099219/18.
(140118084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.
Digital Services XXVI (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.499.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of June.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Digital Services XXVI S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
the registration of which with the Luxembourg Trade and Companies’ Register is pending,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, residing in Luxembourg,, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, on 18. June 2014, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18. June 2014.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
118592
L
U X E M B O U R G
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services XXVI (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any
Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
118593
L
U X E M B O U R G
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
118594
L
U X E M B O U R G
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
118595
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
118596
L
U X E M B O U R G
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XXVI S.à r.l., afo-
rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR
1,000.-).
<i>Resolution of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendvierzehn, am achtzehnten Juni.
Vor uns, Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Digital Services XXVI S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groß-
herzogtum Luxemburg, deren Eintragung im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister noch aussteht,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer
Vollmacht ausgestellt in Berlin, Deutschland, am 18. Juni 2014 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 18.
Juni 2014.
Besagte Vollmacht, welche vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne vari-
etur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
118597
L
U X E M B O U R G
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services XXVI (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vorneh-
men, sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen, und die
ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus
zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
118598
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in oder
jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und
übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich
innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welche in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
118599
L
U X E M B O U R G
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, EMail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
118600
L
U X E M B O U R G
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den) oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter) oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen
eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseur(s) d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
118601
L
U X E M B O U R G
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23 Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24 Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden von Digital Services XXVI S.à r.l., vorbenannt,
zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf eintausend Euro (EUR 1.000) geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstraße
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
118602
L
U X E M B O U R G
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Signé: L. AGUERRE ENRÍQUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2014. LAC/2014/28988. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Référence de publication: 2014100941/577.
(140120299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
A Capital Louvre Hotels Investments, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 188.652.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le trois juin.
Par-devant, Maître Martine SCHAEFFER notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
A COMPARU:
A CAPITAL ALLIANCE, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social
au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg,
ici représentée par Emmanuelle FRATTER, juriste, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-
Pierre Brasseur,
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
demeurera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va
constituer:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. La société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg et prend la dénomination de «A CAPITAL LOUVRE HOTELS INVESTMENTS» (la «Société»).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg au Grand-Duché du Luxembourg.
2.2. Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.
2.3. Le Conseil d'Administration de la Société (le "Conseil d'Administration") ou, le cas échéant, l'administrateur unique,
est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social.
2.4. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le
siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social à l'étranger, sera prise par le
Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique.
2.5. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
118603
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés ou entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et
toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de
toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
3.2. La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou com-
merciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement.
3.3. La société pourra notamment employer ses fonds en vue de l'acquisition, la gestion pour son compte ou celui
d'autrui, la constitution, l'enregistrement et le dépôt, la valorisation, la vente, l'usage dans le cadre de son activité et la
concession de l'usage de tous noms de domaines et de tous droits de propriété intellectuelle, incluant notamment mais
non exclusivement tous droits d'auteur sur des logiciels informatiques, tous brevets, toutes marques de fabrique ou de
commerce, ainsi que tous dessins et tous modèles. La société aura également pour objet tous travaux de recherche et
de développement liés à la création et à l'exploitation de tous droits de propriété intellectuelle.
3.4. La société pourra également prêter son assistance en matière de gestion et d'organisation, à toutes filiales, de
façon rémunérée ou non.
3.5. La Société pourra acquérir, détenir, louer ou céder tout immeuble pour son compte propre.
3.6. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, y compris par voie d'offre publique. Elle peut procéder
par voie d'émission publique ou privée d'actions, d'obligations, de titres et instruments de toute nature. La Société peut
prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, ainsi qu'à des sociétés affiliées. La
Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever des charges ou autrement créer et accorder des
sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de
manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
3.7. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.8. Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
3.9. La société peut notamment réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, com-
merciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
3.10. D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.
3.11. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer une activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
II. Capital - Actions
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR) représenté par cents (100) actions d'une valeur
nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
5.2. Les actions peuvent être nominatives, au porteur, ou dématérialisées.
5.3. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des
actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit ou par
e-mail, ou téléfax.
Art. 6. Droit de préemption.
6.1. Toute cession d'actions de la Société est subordonnée à l'exercice, dans les conditions ci-après, du droit de
préemption suivant.
6.2. L'actionnaire cédant doit notifier son projet de cession aux actionnaires non cédants (ci-après les «Bénéficiaires»)
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il doit indiquer le nom et le domicile ou la dénomination
sociale et le siège du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales
conditions de la cession. Cette notification vaut offre de cession au profit de tous les Bénéficiaires. Le projet de cession
doit également être accompagné d'un courrier d'engagement irrévocable d'achat des actions signé par le cessionnaire
initial comportant le nombre de titres et le prix par action.
6.3. Tous les actionnaires bénéficient d'un droit de préemption sur les actions au prix convenu entre l'actionnaire
cédant et le cessionnaire.
6.4. Les Bénéficiaires qui désirent exercer leur droit de préemption, doivent le notifier à l'actionnaire cédant par fax
ou par e-mail, confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze (15) jours ouvrés de
la notification visée au point 2 du présent article, en indiquant le nombre d'actions de la Société qu'ils souhaitent acquérir.
118604
L
U X E M B O U R G
6.5. A défaut, ils sont réputés y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.
6.6. Si les droits de préemption sont exercés pour la totalité des actions offertes, l'actionnaire cédant établit une liste
des actionnaires avec l'indication du nombre d'actions préemptées pour chacun d'eux (étant précisé qu'au cas où les
demandes de préemption dépasseraient le nombre d'actions proposées, celles-ci seraient réparties entre les Actionnaires
pré-empteurs au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent respectivement et dans la limite de leur demande) qu'il
notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, sans délai, à tous les Bénéficiaires.
6.7. Dans les trente (30) jours suivant cette notification, les conventions portant sur la cession des actions préemptées
devront être établies et signées par l'actionnaire cédant.
6.8. De leur côté, chacun des Bénéficiaires ayant exercé son droit de préemption devra également signer la convention
de cession le concernant.
6.9. Le prix de cession devra être acquitté par les Bénéficiaires ayant exercé leur droit de préemption, par virement
bancaire sur le compte de l'actionnaire cédant, le jour de la signature de la convention de cession.
6.10. Le transfert de la propriété des actions de la Société s'opère au jour de la signature des conventions de cession.
6.11. A défaut d'exercice de leur droit de préemption sur la totalité des actions proposées, la proportion non pré-
emptée de la cession pourra être réalisée au bénéfice du cessionnaire initial et suivant le courrier d'engagement décrit
au point 2 du présent article.
6.12. Le droit de préemption prévu au présent article s'applique à toute cession ou mutation à un tiers, à titre onéreux
ou gratuit, alors même que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision judiciaire. Ces
dispositions sont également applicables en cas d'apport en numéraire, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.
6.13. Elles s'appliquent également, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits d'attribution ou de sou-
scription, comme aux renonciations de droits de souscription en faveur de tiers bénéficiaires dénommés.
6.14. Toute cession effectuée en violation des procédures de préemption prévues au présent article est nulle.
6.15. En cas d'exercice du droit de préemption par les Bénéficiaires, le prix d'achat des actions sera le prix initialement
convenu entre l'actionnaire cédant et le cessionnaire en cas de vente des actions cédées.
6.16. Dans les autres cas et, notamment en cas de donation, d'échange, d'apport, de fusion ou de scission ou d'une
forme combinée de ces modes de transfert de propriété, le prix d'achat sera le prix offert de bonne foi par l'actionnaire
cédant, ou en cas de désaccord, fixé par un expert désigné à la demande de la ou des Parties contestataires par ordonnance
du Président du Tribunal de commerce, statuant en la forme des référés et sans recours possible.
6.17. Toute contestation aura pour effet de rendre caduc tout exercice du droit de préemption qui aurait été notifié
par un autre actionnaire, préalablement à la notification du rapport d'expert aux Actionnaires.
6.18. Les Bénéficiaires pourront alors exercer leur droit de préemption au prix fixé par l'expert dans les quinze (15)
jours de la notification de son rapport.
6.19. En cas d'accord unanime des actionnaires, ceux-ci peuvent renoncer à toute ou partie des clauses prévues à
l'article 7 des présents statuts.
III. Administration - Surveillance
Art. 7. Administration.
7.1. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé au moins de trois administrateurs, action-
naires ou non. Ils seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et ils
seront rééligibles.
7.2. Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique (l'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires cons-
tatant l'existence de plus d'un actionnaire.
7.3. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à tout moment, par une décision
adoptée par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.
7.4. En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-
trateurs restants peuvent élire, à la majorité des votes, un administrateur pour remplir cette vacance jusqu'à la prochaine
assemblée générale des actionnaires de la Société.
7.5. Le mandant des administrateurs s'exercera à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Art. 8. Pouvoirs du conseil d'administration.
8.1. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à
l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée des actionnaires
relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.
8.2. Le Conseil d'Administration élit un président. En l'absence du président un autre administrateur peut présider la
réunion.
8.3. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier
118605
L
U X E M B O U R G
électronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses col-
lègues.
8.4. L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique.
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.
8.5. En cas de circonstances exceptionnelles, tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'adminis-
tration par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de communication similaire
permettant leur identification. Ces moyens de télécommunication devront être géolocalisés dans le même pays que celui
où se déroule le conseil d'administration. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent
à la réunion et sera habilité à prendre part au vote.
8.6. Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Les écrits, télégram-
mes, télécopies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la
délibération.
8.7. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
8.8. Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de la réunion
ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les administrateurs présents ou représentés.
Art. 9. Délégation de pouvoir. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Art. 10. Représentation de la société envers les tiers. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée,
en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'adminis-
trateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs au moins et si un administrateur-délégué est nommé, la
Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement la signature de l'ad-
ministrateur-délégué, ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a
été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.
Art. 11. Surveillance. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
IV. Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même
année.
Art. 13. Assemblée générale.
13.1. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions
en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.
13.2. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des actionnaires et prend les décisions par écrit.
13.3. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.
13.4. Toute assemblée générale sera convoquée par le Conseil d'Administration par notification écrite envoyée à
chaque Actionnaire en conformité avec la Loi. L'assemblée sera convoquée à la demande des actionnaires représentant
au moins dix pour cent (10%) du capital de la Société. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils
déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de
convocation ou de publication. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital de la Société peuvent
demander l'ajout d'un ou de plusieurs points sur l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle
demande doit être adressée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date
de l'assemblée.
13.5. Tout actionnaire peut voter au moyen d'un formulaire envoyé par poste ou par fax au siège social de la Société
ou à l'adresse mentionnée dans la convocation au moins trois (3) jours avant la date de l'assemblée.
13.6. Le formulaire de vote par correspondance reçu par la Société doit contenir les nom et prénom et le domicile
de l'actionnaire votant par correspondance; l'indication de la forme, nominative ou dématérialisée, sous laquelle sont
détenus les titres et du nombre de ces derniers; son vote pour chacun des points figurant à l'ordre du jour, ainsi que la
signature de l'actionnaire.
118606
L
U X E M B O U R G
13.7. En cas de vote par correspondance d'un actionnaire détenant des titres dématérialisés, le formulaire visé au point
13.5. devra également être accompagné d'un extrait probant, émis dans les quinze (15) jours avant la tenue de l'assemblée,
de l'organisme où les titres sont détenus attestant du nombre d'actions de l'actionnaire.
13.8. Aucune cession ne sera valable et opposable à la Société si elle a été réalisée dans les quinze (15) jours avant la
tenue de l'assemblée.
13.9. Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax
ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire, actionnaire ou non et est par conséquent autorisé à voter par
procuration.
13.10. Les actionnaires sont autorisés à participer à une réunion par visioconférence ou par des moyens de télécom-
munications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de
majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'as-
semblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
13.11. Sauf dans les cas déterminés par la Loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée annuelle ou ordinaire
des Actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
Lorsque la Société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
13.12. Une assemblée générale extraordinaire convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra
valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présent ou représentée et que l'ordre du jour indique les
modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être
convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant
la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion
du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une
majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.
13.13. Néanmoins, en cas d'assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour le changement de nationalité
de la Société, ou l'augmentation des engagements des actionnaires, l'unanimité est toujours requise.
13.14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Art. 14. Réserves.
14.1. Chaque année cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social.
14.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des Actionnaires décide de la répartition et de la distri-
bution du solde des bénéfices nets.
14.2. Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la Loi.
Art. 15. Date et lieu de l'assemblée annuelle. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit au siège social
ou tout autre lieu indiqué par la convocation, le 3
e
mercredi du mois de juin à 11.00 heures, et si le 3
e
mercredi du mois
de juin est un jour férié, le jour ouvrable suivant.
Art. 16. Dissolution.
16.1. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires, délibérant dans les mêmes
conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
16.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l'assemblée générale des Actionnaires.
16.3. Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux actionnaires
proportionnellement aux actions détenues par chacun d'eux.
Art. 17. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi"), ainsi que ses modifications
ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation, le premier exercice commencera à la date de signature des présents statuts, et se terminera au 31
décembre 2014.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2015.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, la société à responsabilité limitée A CAPITAL ALLIANCE, susmen-
tionnée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire la totalité des actions, comme suit:
118607
L
U X E M B O U R G
A CAPITAL ALLIANCE, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions
Les actions ont été libérées à hauteur de 25,16 % par un versement en numéraire, de sorte que la somme de sept
mille huit cents Euros (7.800,-EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment
convoqué, a pris les résolutions suivantes:
1.- Il est décidé de nommer un administrateur unique et un commissaire aux comptes.
2.- Est appelés aux fonctions d'administrateur unique:
La société anonyme de droit luxembourgeois A Capital Management S.A., établie et ayant son siège social à L-1653
Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 167.989, ayant pour représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission Monsieur André LO-
SEKRUG, dirigeant de sociétés, né le 12 novembre 1972 à Berlin, Allemagne, résidant au 11bis rue Lauriston, 75116 Paris,
France,
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme de droit luxembourgeoise ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social
à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 88.019.
4.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de l'an deux mille dix-neuf (2019).
5.- Le siège social est fixé au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire par ses noms, prénoms
usuels, état et demeure, elle a signé avec nous notaire.
Signé: E. Fratter et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juin 2014. LAC/2014/26294. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2014.
Référence de publication: 2014101811/299.
(140123493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
Build Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 155.129.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2014.
Build Finance S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014096847/12.
(140115582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
118608
AAD Fiduciaire S.à r.l.
Absolut Investissement, S.à r.l.
A Capital Louvre Hotels Investments
Adolfo Dominguez (Luxembourg) S.A.
Adomex
Advent Kai Luxembourg Holding S.à r.l.
Advent Kai Luxembourg S.à r.l.
AES Structured Finance Holdings (Lux) S.à r.l.
Agihold Europe
AIV SA
Allandis
Altercorp S.A.
AMP Capital Investors (IDF II SBT N°2) S.à r.l.
AMP Capital Investors (IDF II USD N°1) S.à r.l.
AMP Capital Investors (IDF No. 2) S.à r.l.
AMP Capital Investors (Luxembourg No. 5) S.à r.l.
AMP Capital Investors (Luxembourg No. 6) S.à r.l.
Ande Management S.à r.l.
Anquith S.A.
Arenamex Invest 2 S.à r.l.
Ataraxie S.A.
Atelier d'Architecture et de Design Jim Clemes S.A.
Aurio SICAV-FIS
Autoparts Holdings (Luxembourg) I S.à r.l.
Barret S.A.
Base Investments Sicav
BCD Technology S.A.
BCW Trading
Bell Equipment International S.A.
Best Clean Services Sàrl
BIOCARDEL Europe S.A.
BlackGold-Société Privée d'Investissements S.A.
Braas Monier Building Group S.A.
Brasseur Investments Sàrl
Bruehl Leipzig Arcaden Luxco S.àr.l.
Bruehl Leipzig Arcaden S.àr.l.
Build Finance S.à r.l.
Cadami Finance S.A.
Canto Ecological Ports S.A.
Caredor SA
Caymus Holding S.à r.l.
CBP Lux S.A.
Celgene Luxembourg
CFG Holdings S.A. SPF
C.K. Business Center S.A.
Cresos S.A.
C.T. - A & A S.A.
Digital Services XXVI (GP) S.à r.l.
FFI S.àr.l.
Generali North American Holding 1 S.A.
Glacier Re Holdings S.à r.l.
Guardian Europe S.à r.l.
Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF
Horefi S.à r.l.
Hypatia S.à r.l.
JN S.A.
ZAM Ventures Luxembourg S.à r.l.