This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2810
9 novembre 2013
SOMMAIRE
Brighton Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
134878
Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l. . .
134834
Bruisend S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134865
Cable TV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134865
Cable & Wireless Global Businesses Inter-
national Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134878
CAIVS S.C.A. SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134871
Capfields s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134859
Capital R.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134878
Cardea International Fund S.C.A., SICAV-
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134859
Carlista S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134879
Catwalk Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134858
C.B.R. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134861
Cemag S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134859
Centre G.R. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134859
Ceres Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
134860
Chambre de Commerce d'Espagne au Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134860
Charon Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
134860
Chasselas Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134871
CHEN-JI s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134861
Climmolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134877
CMC Card and Management Consult S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134877
Coconsult s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134878
Coface Services Luxembourg . . . . . . . . . . .
134858
Coiffure Eliane S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134861
Colinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134858
Communauté d'Exploitation agricole
SCHMIT-SCHUMANN . . . . . . . . . . . . . . . .
134857
Compagnie Financière pour la Gestion
Collective S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134857
Costantini Promotions s.à r.l. . . . . . . . . . . .
134878
Cozen s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134878
CP Machinery Limited S.à r.l. . . . . . . . . . . .
134862
CPPIB Credit Investments European Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134873
Craft Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134877
Creation Design International S.A. . . . . . .
134877
CRV Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
134877
Crynolis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134879
CVC Services Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . .
134865
Datofin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134873
D Chateau VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134862
Debt Resolution Corp S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
134871
Demas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134873
Deuxcouleurs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134862
DH M Beta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134873
DIF Participations 1 Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134879
DIF Participations 2 Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134879
DIF Participations 3 Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134879
Double Jhang S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134871
Elite Wealth Management S.à r.l. . . . . . . . .
134879
EuroPRISA Luxembourg Holding Compa-
ny F S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134880
Lux Mara S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134880
Manema S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134880
Manema S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134880
MECS International Holding Sàrl . . . . . . . .
134880
Sufren Private S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
134834
Talentia Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
134856
Tarnold Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
134856
Taro S.A., Société de Gestion de Patrimoi-
ne Familial, (SPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134856
Tawban S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134856
TCP Publishing Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . .
134857
Tecoh Investissements S.à r.l. . . . . . . . . . . .
134857
THBIREF Management Company S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134856
134833
L
U X E M B O U R G
Sufren Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 154.156.
Les comptes annuels au 30.06.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03.10.13.
<i>Pour: SUFREN PRIVATE S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2013139337/15.
(130169437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 100.461.
COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER
as agreed by the management boards of
BROOKFIELD FINANCE LUXEMBOURG S.À R.L.
and
NORMA INVESTMENTS SP. Z O.O.
The management boards of:
1. Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., a company organized and existing under the laws of Luxembourg (a société
à responsabilité limitée), having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
having a share capital of five hundred and eighteen million thirty-nine thousand and forty United States dollars (USD
518,039,040.-) and registered with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under the number B 100.461
(the “Acquiring Company”); and
2. Norma Investments sp. z o.o., a limited liability company organized and existing under the laws of Poland, having its
registered office at AI. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa, registered with the National Court Register (Krajowy
Rejestr Sadowy) held by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12
th
Commercial Division - KRS under the
number 0000268119 (the “Company Ceasing to Exist” and together with the Acquiring Company, the “Merging Com-
panies”);
Whereas:
(i) the Acquiring Company is the holder of the entire issued and paid up share capital of the Company Ceasing to Exist,
as the Acquiring Company is the holder of all of the shares in the share capital of the Company Ceasing to Exist;
(ii) none of the Merging Companies has a supervisory board;
(iii) the Merging Companies have not been dissolved or declared bankrupt, nor has a suspension of payment been
declared with respect to the Merging Companies;
(iv) none of the Merging Companies has a works council or a trade union that has amongst its members employees
of one of the Merging Companies or any of their subsidiaries;
(v) the Company Ceasing to Exist does not employ any employees;
(vi) the shareholder of the Acquiring Company intends, on or around the date hereof, to convert 9,193,525 ordinary
shares having a par value of thirty United States dollars (USD 30) each into 9,193,525 mandatory redeemable preference
shares having a par value of thirty United States dollars (USD 30) each;
(vii) the Company Ceasing to Exist intends to cease conducting any business activity in Poland;
(viii) the shareholder of the Acquiring Company intends to simplify the corporate structure by merging the Company
Ceasing to Exist into the Acquiring Company.
The Merging Companies propose a cross-border merger within the meaning of Directive 2005/56/EC of the European
Parliament and of the Council of the European Union of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability
companies and the relevant local Polish and Luxembourg laws applicable to the Merging Companies as a result of which:
- the Company Ceasing to Exist will cease to exist without going into liquidation; and
134834
L
U X E M B O U R G
- the Acquiring Company will acquire the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist under a universal title
of succession;
it being understood that these draft terms of merger are drawn up in English, Polish and in French and that in case of
any discrepancy between the English version and the other versions, the English version will prevail.
The specifics to be mentioned pursuant to Article 516
3
of the Polish Commercial Companies' Code (the “CCC”) and
Article 261 et seq of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Luxembourg
Law”), are as follows:
a. Type of legal entity, name, registered office/official seat, name of the official register and entry number of the Merging
Companies and the merger type (Art. 516
3
pt 1 of the CCC and Art. 261 (2) a) of the Luxembourg Law)
(i) Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized
and existing under Luxembourg law, having its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered
with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under the number B 100.461.
(ii) Norma Investments Sp z o.o., a limited liability company (spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia) organized and
existing under the laws of the Republic of Poland, having its registered seat in AI. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa,
Poland registered with the National Court Register (Krajowy Rejestr Sadowy) held by the District Court for the Capital
City of Warsaw, 12
th
Commercial Division - KRS under the number 0000268119.
The merger will be effected through the transfer of all assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to the
Acquiring Company (the merger through the acquisition), in line with Article 492 § 1 pt 1 of the CCC, art. 491 § 1
1
of
the CCC and Art. 274 (1) a) of the Luxembourg Law.
b. Articles of association of the Acquiring Company (Art. 516
3
pt 15 of the CCC and Art. 261 (4) a) of the Luxembourg
Law)
The articles of association of the Acquiring Company shall not be amended in connection with the merger.
The articles of association of the Acquiring Company were drawn up by deed of incorporation executed on 21 April
2004 before Maître Joseph ELVINGER, a notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 18 June 2004 number 630. The articles of association have been
amended for the last time pursuant to a notarial deed drawn up by Maître Henri Hellinckx on 22 May 2013. The text of
the articles of association of the Acquiring Company is attached to these draft terms of merger as Annex A.
c. Ratio of exchange of other securities of the Company Ceasing to Exist for securities of the Acquiring Company and
the amount of additional payments (Art. 516
3
pt 3 of the CCC)
There are no other securities of the Company Ceasing to Exist than the shares. Therefore, the information on the
ratio of exchange referred to in Art. 516
3
pt 3 of the CCC is not applicable.
d. Rights conferred by the Acquiring Company on the holders of shares to which special rights are attached and the
holders of securities other than shares, or the measures proposed concerning them
As there are neither shares to which special rights are attached, nor persons who, in any other capacity than as
shareholders, have special rights against the Company Ceasing to Exist, no special rights and no compensations will be
granted at the expense of the Acquiring Company to anyone.
e. The date as of which other securities give the right to participate in the profits of the Acquiring Company, as well
as other terms concerning the acquisition or exercise of that right if such terms have been stipulated (Art. 516
3
pt 7 of
the CCC). The date as of which the shares entitle to participate in the profit of the Acquiring Company and other terms
of exercising of this right (Art. 516
3
pt 6 of the CCC)
There will be no other securities issued by the Acquiring Company. Therefore, the information on the date referred
to in Art. 516
3
pt 7 is not applicable.
There will be no shares issued by the Acquiring Company. Therefore, the information on the date referred to in Art.
516
3
pt 6 is not applicable.
f. Special advantage granted to experts or members of the administrative, management, supervisory or controlling
bodies of the Merging Companies (Art. 516
3
pt 8 of the CCC and Art. 261 (2) g) of the Luxembourg Law)
None.
g. Intentions with regard to the composition of the management board of the Acquiring Company after the cross-
border merger
There is no intention to change the composition of the management board after the cross-border merger.
The present composition of the management board of the Acquiring Company is as follows:
<i>Management board:i>
- Andrew O'SHEA;
- Gregor DALRYMPLE; and
- Damian WARDE.
134835
L
U X E M B O U R G
h. Date from which the transactions of the Company Ceasing to Exist shall be treated for accounting purposes as being
those of the Acquiring Company (Art. 516
3
pt 12 of the CCC and Art. 261 (2) e) of the Luxembourg Law)
The transactions of the Company Ceasing to Exist shall be treated for accounting purposes as being those of the
Acquiring Company starting on the moment this merger shall be effective being the publication date in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations of the Acquiring Company's shareholder resolution approving the cross-border
merger (the “Effective Date”).
The financial data of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of the Acquiring
Company as per Effective Date. The aforesaid takes into account the regulations governed by the Polish Accounting Act
of 29 September 1994.
i. Ratio of exchange of shares of the Company Ceasing to Exist for shares of the Acquiring Company (Art. 516
3
pt 2
of the CCC and Art 261 (2) b) of the Luxembourg Law). Other rights granted by the Acquiring Company to the share-
holders or holders of other securities than shares in the Acquiring Company (Art. 516
3
pt 4 of the CCC). Other terms
of shares or other securities issuance in the Acquiring Company (Art. 516
3
pt 5 of the CCC)
As this is a cross-border merger of a parent company with its 100% subsidiary, there is no allotment of shares in the
Acquiring Company.
There are no other rights granted by the Acquiring Company to the shareholders or holders of securities other than
shares in the Acquiring Company.
There are no other terms of issuance of shares or other securities in the Acquiring Company.
j. Contemplated continuation or termination of activities
The activities of the Company Ceasing to Exist will be continued by the Acquiring Company. No business activity will
be conducted in Poland.
k. Information on the valuation of assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring
Company as of September 30, 2013 (Art. 516
3
pt 13 of the CCC and Art. 261 (4) d) of the Luxembourg Law)
The valuation of the relevant assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring
Company was last made on September 30, 2013 on the basis of their book value.
The valuation of assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be Acquired by the Acquiring Company is
as follows:
ASSETS
Fixed assets - PLN 158,231,720.05
Current assets - PLN 816,856,499.27
TOTAL ASSETS - PLN 975,088,219.32
LIABILITIES
Equity - PLN 975,014,483.50
Payables and reserves for payables - PLN 73,735.82
TOTAL LIABILITIES - PLN 975,088,219.32
I. Likely repercussions on employment (Art. 516
3
pt 11 of the CCC and Art. 261 (4) b) of the Luxembourg Law)
The cross-border merger will not have any negative effect on employment.
m. Procedures for employee participation (Art. 516
3
pt 10 of the CCC and Art. 261 (4) c) of the Luxembourg Law)
As none of the Merging Companies is operating under an employee participation system within the meaning of Directive
2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union of 26 October 2005 on cross-border
mergers of limited liability companies, and the Company Ceasing to Exist does not employ any employees, no procedure
by which arrangements for the involvement of employees in the participation in the company resulting from the cross-
border merger is legally prescribed and, therefore, no employee participation arrangements have to be made.
n. Proposal for the level of compensation of shareholders
No compensation for shareholders that vote against the proposal to effectuate the cross-border merger is proposed,
as it is not expected that votes will be cast against this proposal.
o. Terms of exercising of creditors' and minority shareholders' rights and indication of the address at which any person
free of any charge may receive full information on these terms (Art. 516
3
pt 9 of the CCC, Art. 262 (2) C) and Art. 268
(1) of the Luxembourg Law)
The creditors of the Company Ceasing to Exist shall be entitled to raise their claims against the proposed merger
within a month from the publication of this merger proposal in the Official Court and Business Gazette (Monitor Sadowy
i Gospodarczy) in accordance with article 516
10
of the Polish Commercial Companies' Code. Further information about
the creditors' rights in that respect shall be made available free of charge at the registered office of the Company Ceasing
to Exist at AI. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa.
134836
L
U X E M B O U R G
The creditors of the Acquiring Company shall be entitled to raise their claims against the proposed merger within two
months from the publication of this merger proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations in accordance
with article 268 (1) and article 262 (2) c) of the Luxembourg Law. Further information about the creditors' rights in that
respect shall be made available free of charge at the registered office of the Acquiring Company at 67, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
As there are no minority shareholders in the Merging Companies no specific terms are provided by the merger proposal
in that respect.
p. The date for closing the books in the Merging Companies (Art. 516
3
pt 14 of the CCC)
The date for closing the books in the Company Ceasing to Exist for the purpose of the Cross Border Merger shall be
the Effective Date. The aforesaid takes into account the regulations governed by the Polish Accounting Act of 29 Sep-
tember 1994.
The applicable regulations of the law of Luxembourg do not require to have the Acquiring Company's books closed
following the merger.
q. The date of the most recently adopted annual accounts or interim financial statements, used to establish the con-
ditions of the cross-border merger
The date of the most recently adopted annual accounts / interim financial statements of the Merging Companies'
accounts used to establish the conditions of the cross-border merger is:
Acquiring Company: 30 September 2013
Company Ceasing to Exist: 30 September 2013
r. Annexes
Annexes to these draft terms form an integral part of this proposal.
Signed in Luxembourg / Warsaw on 25 October 2013.
Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l.
Andrew O'SHEA / Gregor DALRYMPLE, represented by Andrew O'SHEA / Damian WARDE
<i>Manageri> / <i>Manageri> / <i>Manager
i>Norma Investments Sp. z o.o.
Alwyn Jacobus DE LANGE
<i>Chairman of the Management Boardi>
Annex A: Current articles of association of the Acquiring Company
Annex B: Draft resolutions approving the merger
Annex C: Determination of the value of assets for the Company Ceasing to Exist - balance sheet and profit and loss
account as of September 30, 2013
Annex D: Statement regarding the book values of assets for the Company Ceasing to Exist
PLAN POŁACZENIA TRANSGRANICZNEGO
uzgodniony przez zarzady spółek
BROOKFIELD FINANCE LUXEMBOURG S.À R.L
oraz
NORMA INVESTMENTS SP. Z O.O.
Zarzady:
1. Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., spółki utworzonej i działajacej wedlug prawa luksemburskiego (société à
responsabilité limitée), z siedziba przy 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, o kapitale zakła-
dowym w wysokosci pieciuset osiemnastu milionów trzydziestu dziewieciu tysiecy czterdziestu dolarów amerykanskich
(518.039.040,- USD), wpisanej do Rejestru Handlu i Spółek (Register of Commerce and Companies) w Luksemburgu pod
numerem В 100.461 („Spółka Przejmujaca“); oraz
2. Norma Investments sp. z o.o., spółki z ograniczona odpowiedzialnoscia utworzonej wedlug prawa polskiego, z
siedziba w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 56C, 00-803 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sadu Rejestrowego pod
numerem KRS 0000268119 („Spółka Przejmowana“, a wraz ze Spółka Przejmujaca „Spółki Łaczace Sie“);
Majac na wzgledzie, ze:
(i) na Spółke Przejmujaca przypada cały zarejestrowany oraz pokryty kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej, jak tez
Spółce Przejmujacej przypadaja wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
(ii) zadna ze Spółek Łaczacych Sie nie posiada rady nadzorczej;
(iii) Spółki Łaczace Sie nie uległy rozwiazaniu ani nie ogłoszono ich upadłosci, ani tez nie ogłoszono zawieszenia spłat
zobowiazan wobec którejkolwiek ze Spółek Łaczacych Sie;
134837
L
U X E M B O U R G
(iv) w zadnej ze Spółek Łaczacych Sie nie funkcjonuje rada pracownicza ani zwiazek zawodowy, do których nalezeliby
pracownicy którejkolwiek ze Spółek Łaczacych Sie lub jakiejkolwiek ich spółki zaleznej;
(v) Spółka Przejmowana nie zatrudnia pracowników;
(vi) wspólnik Spółki Przejmujacej zamierza w dniu lub około dnia podpisania niniejszego planu połaczenia dokonac
konwersji 9.193.525 zwykłych udzialów o wartosci nominalnej trzydziestu dolarów amerykanskich (30 USD) kazdy na
9.193.525 udziałów uprzywilejowanych, których umorzenie jest obowiazkowe, o wartosci nominalnej trzydziestu dolarów
amerykanskich (30 USD) kazdy;
(vii) Spółka Przejmowana zamierza zaprzestac prowadzenia działalnosci gospodarczej w Polsce;
(viii) wspólnik Spółki Przejmujacej zamierza uproscic strukture korporacyjna poprzez połaczenie Spółki Przejmowanej
ze Spółka Przejmujaca;
Spółki Łaczace Sie proponuja połaczenie transgraniczne w rozumieniu Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejs-
kiego В Rady z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego łaczenia sie spółek kapitałowych oraz własciwych
przepisów krajowych polskich í luksemburskich majacych zastosowanie wobec Spółek Łaczacych Sie, w wyniku czego:
- Spółka Przejmowana przestanie istniec bez koniecznosci postawienia jej w stan likwidacji, oraz
- Spółka Przejmujaca przejmie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej,
przy czym rozumie sie, ze niniejszy plan połaczenia zostaje sporzadzony w jezyku angielskim, polskim i francuskim oraz
ze w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy jego angielska wersja jezykowa i pozostałymi wersjami jezykowymi,
angielska wersja jezykowa jest rozstrzygajaca.
Szczegółowe informacje, które nalezy okreslic zgodnie z art. 516
3
polskiego Kodeksu Spółek Handlowych („KSH“)
oraz art. 261 i n, ustawy luksemburskiej z dnia 10 sierpnia 1915 roku w sprawie spółek handlowych, ze zm. („Ustawa
Luksemburska“), obejmuja:
a. Typ, firme i siedzibe statutowa Spółek Łaczacych Sie, oznaczenie rejestru i numer wpisu do rejestru kazdej ze Spółek
Łaczacych Sie, a takze sposób łaczenia (art. 516
3
pkt 1 KSH oraz art. 261 (2) a) Ustawy Luksemburskiej)
(i) Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., prywatna spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia (société à responsabilité
limitée) utworzona В działajaca według prawa luksemburskiego, z siedziba w Luksemburgu, Wielkie Ksiestwo Luksem-
burga, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Luksemburgu pod numerem В 100.461.
(ii) Norma Investments Sp. z o.o., spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia utworzona i działajaca według prawa pols-
kiego, z siedziba przy Al. Jerozolimskich nr 56C, 00-803 Warszawa, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sadu Rejestrowego pod
numerem KRS 0000268119.
Połaczenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie wszystkich aktywów oraz pasywów Spółki Przejmowanej na
Spółke Przejmujaca (łaczenie sie przez przejecie) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 491 § 1
1
KSH oraz art. 274
(1) a) Ustawy Luksemburskiej.
b. Umowe Spółki Przejmujacej (art. 516
3
pkt 15 KSH oraz art. 261 (4) a) Ustawy Luksemburskiej)
Umowa Spółki Przejmujacej nie ulegnie zmianie w zwiazku z łaczeniem.
Umowa Spółki Przejmujacej została sporzadzona w drodze aktu załozycielskiego podpisanego w dniu 21 kwietnia 2004
r. przed Maître Joseph ELVINGER, notariuszem zamieszkałym w Luksemburgu, Wielkie Ksiestwo Luksemburga, obubli-
kowanego w Mémorial В, Recueil des Sociétés et Associations z dnia 18 czerwca 2004 r. numer 630. Przedmiotowa umowa
spółki została zmieniona po raz ostatni na podstawie aktu notarialnego sporzadzonego przez Maître Henri Hellinckx w
dniu 22 maja 2013 r. Tresc umowy Spółki Przejmujacej jest załaczona do niniejszego planu połaczenia jako Załacznik A.
c. Stosunek wymiany innych papierów wartosciowych Spółki Przejmowanej na papiery wartosciowe Spółki Przejmujacej
oraz wysokosc dopłat pienieznych (art. 516
3
pkt 3 KSH)
Brak jest jakichkolwiek innych papierów wartosciowych Spółki Przejmowanej poza udziałami. W zwiazku z tym, in-
formacje na temat stosunku wymiany, o którym mowa w art. 516
3
pkt 3 KSH, nie dotycza planowanego połaczenia.
d. Prawa przyznane przez Spółke Przejmujaca wspólnikom posiadajacym udziały ze szczególnymi prawami z nich wy-
nikajacymi i uprawnionym z innych papierów wartosciowych, lub proponowane srodki ich dotyczace
Z uwagi na fakt, ze brak jest udziałów ze szczególnymi prawami z nich wynikajacymi lub tez osób, którym - z tytułu
innego niz posiadanie statusu wspólnika - przysługuja szczególne prawa wobec Spółki Przejmowanej, nie zostana nikomu
przyznane na koszt Spółki Przejmujacej jakiekolwiek szezególne prawa ani wynagrodzenia.
e. Dzien, od którego inne papiery wartosciowe uprawniaja do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmujacej, a takze inne
warunki dotyczace nabycia lub wykonywania tego prawa, jezeli takie warunki zostały ustanowione (art. 516
3
pkt 7 KSH).
Dzien, od którego udziały uprawniaja do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmujacej oraz inne warunki wykonywania tego
prawa (art. 516
3
pkt 6 KSH)
Spółka Przejmujaca nie wyemituje zadnych innych papierów wartosciowych, a zatem informacje na temat terminu, o
którym mowa w art. 516
3
pkt 7 KSH, nie dotycza planowanego połaczenia.
134838
L
U X E M B O U R G
Spółka Przejmujaca nie wyemituje zadnych udziałów, a zatem informacje na temat terminu, o którym mowa w art. 516
3
pkt 6 KSH, nie dotycza planowanego połaczenia.
f. Szczególne korzysci przyznane biegłym badajacym plan połaczenia lub członkom organów zarzadzajacych lub nadzo-
rujacych Spółek Łaczacych Sie (art, 516
3
pkt 8 KSH oraz art. 261 (2) g) Ustawy Luksemburskiej)
Brak.
g. Zamiary dotyczace składu zarzadu Spółki Przejmujacej po dokonaniu łaczenia transgranicznego
Brak zamiaru dokonania zmiany w składzie zarzadu po zakonczeniu łaczenia transgranicznego.
Obecny skład zarzadu Spółki Przejmujacej jest nastepujacy:
<i>Zarzad:i>
- Andrew O'SHEA,
- Gregor DALRYMPLE, oraz
- Damian WARDE.
В. Dzien, od którego czynnosci Spółki Przejmowanej beda uwazane, dla celów rachunkowosci, za czynnosci dokonywane
przez Spółke Przejmujaca (art. 516
3
pkt 12 KSH oraz art. 261 (2) e) Ustawy Luksemburskiej)
Czynnosci Spółki Przejmowanej beda uwazane, dla celów rachunkowosci, za czynnosci dokonywane przez Spółke
Przejmujaca od dnia połaczenia, którym jest dzien opublikowania w Mémorial В, Recueil des Sociétés et Associations
uchwały wspólnika Spółki Przejmujacej zatwierdzajacej planowane połaczenie transgraniczne („Dzien Połaczenia“).
Dane finansowe Spółki Przejmowanej zostana uwzglednione w rocznych sprawozdaniach Spółki Przejmujacej od Dnia
Połaczenia. Powyzsze uwzglednia regulacje zawarte w polskiej ustawie o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
i. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmujacej (art. 516
3
pkt 2 KSH oraz art. 261
(2) b) Ustawy Luksemburskiej), inne prawa przyznane przez Spółke Przejmujaca wspólnikom lub uprawnionym z innych
papierów wartosciowych w Spółce Przejmowanej (art. 516
3
pkt 4 KSH). Inne warunki dotyczace przyznania udziałów
lub innych papierów wartosciowych w Spółce Przejmujacej (art. 516
3
pkt 5 KSH)
Z uwagi na fakt, ze Spółka Przejmujaca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, nie przydziela sie nikomu
udziałów w Spółce Przejmujacej.
Nie przyznaje sie wspólnikom lub uprawnionym z innych papierów wartosciowych w Spółce Przejmowanej zadnych
innych praw.
Nie przewiduje sie zadnych innych warunków dotyczacych przyznania udziałów lub innych papierów wartosciowych
w Spółce Przejmujacej.
j. Przewidziana kontynuacja lub rozwiazanie działalnosci
Działalnosc Spółki Przejmowanej bedzie nadal prowadzona przez Spółke Przejmujaca. Działalnosc gospodarcza w Pols-
ce zostanie zaprzestana.
k. Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przenoszonych nВ Spółke Przejmujaca na
dzien 30 wrzesnia 2013 roku (art. 516
3
pkt 13 KSH oraz art. 261 (4) d Ustawy Luksemburskiej)
Wycena odnosnych aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przenoszonych na Spółke Przejmujaca była ostatnio
przeprowadzona w dniu 30 wrzesnia 2013 r. na podstawie wartosci ksiegowych.
Wycena aktywów ì pasywów Spółki Przejmowanej Przenoszonych na Spółke Przejmujaca jest nastepujaca:
AKTYWA
Aktywa trwałe - 158.231.720,05 PLN
Aktywa obrotowe - 816.856.499,27 PLN
AKTYWA RAZEM - 975.088.219,32 PLN
PASYWA
Kapitał własny - 975.014.483,50 PLN
Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania - 73.735,82 PLN
PASYWA RAZEM - 975.088.219,32 PLN
I. Prawdopodobny wpływ połaczenia na stan zatrudnienia (art. 516
3
pkt 11 KSH oraz art. 261 (4) b) Ustawy Luksem-
burskiej)
Planowane połaczenie transgraniczne nie wpłynie niekorzystnie na stan zatrudnienia.
m. Procedury okreslajace zasady udziału pracowników (art. 516
3
pkt 10 KSH oraz art. 261 (4) c) Ustawy Luksem-
burskiej)
Z uwagi na fakt, ze zadna ze Spółek Łaczacych Sie nie podlega zasadom uczestnictwa pracowników w rozumieniu
Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego
łaczenia sie spółek kapitałowych, a Spółka Przejmowana nie zatrudnia pracowników, brak jest prawnie przewidzianej
134839
L
U X E M B O U R G
procedury, która okreslałaby zasady zaangazowania pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połac-
zenia, w zwiazku z czym nie ma potrzeby okreslania procedury uczestnictwa pracowników.
n. Proponowany poziom wynagrodzenia wspólników
Nie proponuje sie zadnego wynagrodzenia dla wspólników głosujacych przeciwko planowi połaczenia transgranicznego,
poniewaz nie oczekuje sie, aby jakiekolwiek głosy zostały oddane przeciwko temu planowi.
o. Warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszosciowych i wskazanie adresu, pod którym mozna
bezpłatnie uzyskac pełne informacje na temat tych warunków (art. 516
3
pkt 9 KSH oraz art. 262 (2) В) В art. 268 (1)
Ustawy Luksemburskiej)
Wierzyciele Spółki Przejmowanej beda uprawnieni do zgłoszenia swych roszczen wobec planowanego połaczenia w
ciagu miesiaca od publikacji niniejszego planu połaczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym zgodnie z art. 516
10
polskiego Kodeksu Spółek Handlowych. Informacje na temat warunków wykonywania praw wierzycieli w tym zakresie
zostana udostepnione nieodpłatnie w siedzibie Spółki Przejmowanej przy Al. Jerozolimskich nr 56C, 00-803 Warszawa
Wierzyciele Spółki Przejmujacej sa uprawnieni do zgłoszenia swych roszczen wobec planowanego połaczenia w ciagu
dwóch miesiecy od publikacji niniejszego planu łaczenia w Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations zgodnie z art.
268 (1) oraz art. 262 (2) В) Ustawy luksemburskiej. Dalsze informacje na temat praw wierzycieli w tym zakresie zostana
udostepnione nieodpłatnie w siedzibie Spółki Przejmujacej pod adresem: 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg.
Z uwagi na brak jakichkolwiek wspólników mniejszosciowych w Spółkach Łaczacych Sie, w niniejszym planie połaczenie
nie przewiduje sie zadnych szczególnych warunków w tym zakresie.
p. Dzien zamkniecia ksiag rachunkowych w Spółkach Łaczacych Sie (art. 516
3
pkt 14 KSH)
Dniem zamkniecia ksiag w Spółce Przejmowanej dla celów niniejszego Połaczenia Transgranicznego jest Dzien Połac-
zenia. Powyzsze uwzglednia przepisy potskiej ustawy В rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
Obowiazujace regulacje prawa luksemburskiego nie wymagaja zamkniecia ksiag Spółki Przejmujacej po dokonaniu łac-
zenia.
q. Dzien, w którym przyjeto ostatnie roczne sprawozdanie finansowe lub wstepne sprawozdanie finansowe wykor-
zystane do ustalenia warunków transgranicznego połaczenia
Dniem, w którym przyjeto ostatnie roczne sprawozdania finansowe lub wstepne sprawozdania finansowe Spółek Łac-
zacych Sie, wykorzystane do ustalenia warunków transgranicznego połaczenia, jest:
Spółka Przejmujaca: 30 wrzesnia 2013
Spółka Przejmowana: 30 wrzesnia 2013
r. Załaczniki
Załaczniki do niniejszego planu stanowia jego integralna czesc.
Podpisano w Luksemburgu / Warszawie w dniu 25 pazdziernika 2013 r.
Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l.
Andrew O'SHEA / Gregor DALRYMPLE, reprezentowany przez Andrew O'SHEA / Damian WARDE
<i>Członek Zarzadui> / <i>Członek Zarzadui> / <i>Członek Zarzadu
i>Norma Investments Sp. z o.o.
Alwyn Jacobus DE LANGE
<i>Prezes Zarzadui>
Załacznik A: Aktualna wersja umowy Spółki Przejmujacej
Załacznik B: Projekty uchwał zatwierdzajacych połaczenie
Załacznik C: Ustalenie wartosci aktywów Spółki Przejmowanej - bilans i rachunek zysków i strat na dzien 30 wrzesnia
2013 roku
Załacznik D: Oswiadczenie zawierajace informacje o stanie ksiegowym Spółki Przejmowanej sporzadzona dla celów
polaczenia
PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE
tel qu'approuvé par les conseils de gérance de
BROOKFIELD FINANCE LUXEMBOURG S.À R.L.
et
NORMA INVESTMENTS SP. Z O.O.
Les conseils de gérance de:
1. Brookfield Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi
au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, disposant d'un capital social de cinq cent dix-huit
134840
L
U X E M B O U R G
millions trente-neuf mille quarante dollars américains (USD 518.039.040,-) and immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.461 (la «Société Absorbante»); et
2. Norma Investments Sp.z.o.o., une société de droit polonais (a spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia), dont le
siège social est établi au AI. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa, immatriculée auprès du Registre de la Cour Nationale
(Krajowy Rejestr Sadowy) tenu par la cour du district de la ville de Varsovie, 12
ème
chambre commerciale - KRS sous
le numéro 0000268119 (la «Société Absorbée» et avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnant»),
Attendu que:
(i) la Société Absorbante détient la totalité du capital émis (et libéré) de la Société Absorbée comme la Société Ab-
sorbante est propriétaire de l'ensemble des parts sociales dans le capital de la Société Absorbée;
(ii) aucune des Sociétés Fusionnant n'a de conseil de surveillance;
(iii) les Sociétés Fusionnant ne sont pas dissoutes ou déclarées en faillite, ni ne sont en cessation de paiement;
(iv) aucune des Sociétés Fusionnant n'a de conseil d'entreprise ni de syndicat dont les membres seraient des employés
des Sociétés Fusionnant ou de leurs filiales;
(v) la Société Absorbée n'emploie aucun salarié;
(vi) l'associé de la Société Absorbante a l'intention à la date des présentes ou aux environs de cette date de convertir
9.193.525 parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune en 9.193.525
de parts sociales privilégiées obligatoirement convertibles ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD
30) chacune;
(vii) la Société Absorbée a l'intention de cesser toute activité en Pologne;
(viii) l'associé de la Société Absorbante a l'intention de simplifier la structure sociale en fusionnant la Société Absorbée
et la Société Absorbante.
Les Sociétés Fusionnant suggèrent d'effectuer une fusion transfrontalière selon le sens défini dans la Directive 2005/56/
CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés â responsabilité
limitée et dans les différentes lois nationales applicables aux Sociétés Fusionnant, à la suite de ladite fusion:
- la Société Absorbée cessera d'exister sans liquidation; et
- la Société Absorbante acquerra le passif et l'actif de la Société Absorbée selon un titre de succession universel;
étant entendu que le présent projet de fusion est rédigé en anglais, en polonais et en français et qu'en cas de divergence
entre la version anglaise et les autres versions, la version anglaise fera foi.
Les mentions spécifiques devant figurer dans le projet de fusion conformément aux Articles 516 du Code des Sociétés
Commerciales Polonais (le «CSC») et aux Articles 261 et suivants de la loi luxembourgeoise de 1915 sur les Sociétés
Commerciales, telle que modifiée (la «Loi Luxembourgeoise») sont les suivantes:
a. Type de sociétés, nom, siège social/adresse, nom du registre officiel et numéro d'immatriculation des Sociétés
Fusionnant et le type de fusion (article 516 pt 1 du CSC et article 261 (2) a) de la Loi Luxembourgeoise)
(i) Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège
social est établi au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.461.
(i) Norma Investments Sp.z.o.o., une société à responsabilité limitée (a spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) selon
les droits de la République de Pologne, dont le siège social est établi à Al. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa, Pologne
immatriculée auprès du Registre de la Cour Nationale (Krajowy Rejestr Sadowy) tenu par la cour du district de la ville
de Varsovie, 12
ème
chambre commerciale - KRS sous le numéro 0000268119.
La fusion entraînera de plein droit la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société
Absorbée à la Société Absorbante, conformément à l'Article 492 § 1 pt 1 du CSC, art. 491 § 1
1
du CSC et Art. 274 (1)
a) de la Loi Luxembourgeoise.
b. Statuts de la Société Absorbante (Article 516 pt 15 du CSC et article 261 (4) a) de la Loi Luxembourgeoise)
Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés du fait de la fusion.
Les statuts de la Société Absorbante ont été rédigés suivant l'acte de constitution adopté le 21 avril 2004 par devant
Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations le 18 juin 2004 numéro 630. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant
un acte de Maître Hellinckx le 22 mai 2013. Les statuts de la Société Absorbante sont joints au présent projet de fusion
en Annexe A.
c. Ratio d'échange des autres titres de la Société Absorbée pour des titres de la Société Absorbante (article 516 pt 3
du CSC)
il n'y a pas d'autres titres de la Société Absorbée autre que les parts sociales. Par conséquent, l'information sur le ratio
d'échange prévu par l'article 516 pt 3 du CSC n'est pas applicable.
d. Droits assurés par la Société Absorbante aux propriétaires des part sociales ayant des droits spéciaux et aux porteurs
de titres autres que des parts sociales ou les mesures proposées à leur égard
134841
L
U X E M B O U R G
Puisqu'il n'y a pas de parts sociales auxquelles sont liés des droits spéciaux, ni de personne, autre que les associés,
ayant des droits spécifiques envers la Société Absorbée, aucun droit particulier ni compensation ne sera accordé à qui-
conque par la Société Absorbante.
e. Date à partir de laquelle les autres titres confèrent le droit de participer aux profits de la Société Absorbante, ainsi
que les autres termes relatif à l'acquisition ou à l'exercice dudit droit si ces termes ont été stipulés (article 516 pt 7 du
CSC). Date à partir de laquelle les parts sociales donne le droit de participer aux profits dans la Société Absorbante et
autres termes relatifs à l'exercice de ce droit (article 516 pt 6 du CSC)
Il n'y aura pas d'autres titres émis par la Société Absorbante. Par conséquent, l'information relative à la date prévue
par l'article 516 pt 7 n'est pas applicable.
Il n'y aura pas de parts sociales émises par la Société Absorbante. Par conséquent, l'information relative à la date prévue
par l'article 516 pt 6 n'est pas applicable.
f. Avantages particuliers attribués aux experts de la fusion et aux membres des organes d'administration, de gérance
ou de contrôle des Sociétés Fusionnant (article 516 pt 8 du CSC et article 261 (2) g) de la Loi Luxembourgeoise)
Aucun.
g. Modification de la composition du directoire de la Société Absorbante après la fusion transfrontalière
Aucune modification de la composition du directoire n'est prévue après la fusion transfrontalière.
La composition actuelle du directoire de la Société Absorbante est la suivante:
<i>Conseil de gérance:i>
- Andrew O'SHEA;
- Gregor DALRYMPLE; et
- Damian WARDE.
h. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme ayant été effectuées par
la Société Absorbante d'un point de vue comptable (article 516 pt 12 du CSC et article 261 (2) e) de la Loi Luxembour-
geoise)
Les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme étant celles de la
Société Absorbante à partir du moment où cette fusion sera effective, c'est-à-dire du jour de la publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations des résolutions des associés de la Société Absorbante approuvant la fusion trans-
frontalière (la «Date d'Effet de la Fusion»).
Les données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absor-
bante à compter de la Date d'Effet de la Fusion. Le susdit prend en compte les réglementations régies par la Loi sur la
Comptabilité Polonaise du 29 septembre 1994.
i. Ratio d'échange des parts sociales de la Société Absorbée avec les parts sociales de la Société Absorbante (article
516 pt 2 du CSC et article 261 (2) b) de la Loi Luxembourgeoise). Autres droits conférrés par la Société Absorbante aux
associés ou détenteurs d'autres titres que les parts sociales de la Société Absorbante (article 516 pt 4 du CSC). Autres
termes de l'émission des parts sociales ou d'autres titres de la Société Absorbante (article 516 pt 5 du CSC)
Dans le cadre de la présente fusion d'une société mère avec sa filiale qu'elle détient à 100%, il n'y aura aucune affectation
de parts sociales de la Société Absorbante.
Il n'y a aucun autre droit conféré par la Société Absorbante aux associés ou détenteurs de titres autres que les parts
sociales de la Société Absorbante.
Il n'y a aucun autre terme relatif à l'émission de parts sociales ou d'autres titres de la Société Absorbante.
j. Continuation ou cessation des activités
La Société Absorbante continuera les activités de la Société Absorbée. Aucune activité ne sera effectuée en Pologne.
k. Informations sur la valeur des actifs et passifs de la Société Absorbée devant être acquises par la Société Absorbante
en date du 30 septembre 2013 (article 516 pt 13 du CSC et article 261 (4) d) de la Loi Luxembourgeoise)
L'évaluation des actifs et passifs de la Société Absorbée devant être acquise par la Société Absorbante a été faite
dernièrement le 30 septembre 2013 sur ta base de la valeur comptable.
L'évaluation des actifs et passifs de la Société Absorbée devant être acquise par la Société Absorbante est la suivante:
ACTIF
Actifs immobilisés - PLN 158.231.720,05
Actifs à court terme - PLN 816.856.499,27
ACTIF TOTAL - PLN 975.088.219,32
PASSIF
Titres de capitaux - PLN 975.014.483,50
Charges à payer et provisions pour charges - PLN 73.735,82
PASSIF TOTAL - PLN 975,088,219.32
134842
L
U X E M B O U R G
I. Probables répercussions sur l'emploi (article 516 pt 11 du CSC et article 261 (4) b) de la Loi Luxembourgeoise)
La fusion transfrontalière n'aura aucune répercussion sur l'emploi.
m. Procédures relatives à l'implication des travailleurs (article 516 pt 10 du CSC et article 261 (4) c) de (a Loi Lu-
xembourgeoise)
Puisqu'aucune des Sociétés Fusionnant n'est soumise à un régime de participation des employés au sens de la Directive
2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés à
responsabilité limitée, aucune procédure selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des salariés dans la défi-
nition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière est prévue par la loi et, par
conséquent, aucun arrangement de participation des travailleurs ne doit être fait.
n. Proposition relative au niveau de compensation des associés
Aucune compensation n'est prévue pour les associés qui voteraient contre le projet de fusion transfrontalière puis-
qu'aucun vote contre n'est attendu.
o. Les droits des créanciers et des associés minoritaires et informations sur les modalités relatives à l'exercice des
droits des créanciers (article 516 pt 9 du CSC, Art. 262 (2) c) et article 268 (1) de la Loi Luxembourgeoise)
Les créanciers de la Société Absorbée sont en droit de revendiquer la fusion un mois à partir de la publication du
Projet de Fusion à la Cour Officielle et la Gazette des Affaires (Monitor Sadowy i Gospodarczy) conformément à l'article
516 du Code des Sociétés Commerciales Polonais. Plus d'informations sur les droits des créanciers à cet égard doivent
être mis à disposition gratuitement au siège social de la Société Absorbée au Al. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa.
Les créanciers de la Société sont en droit de revendiquer la fusion dans les deux mois à partir de la publication du
projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations conformément à l'article 268 (1) et 262 (2) c) de la
Loi Luxembourgeoise. Plus d'informations sur les droits des créanciers à cet égard doivent être mis à disposition gratui-
tement au siège social de la Société Absorbante au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Comme il n'y a pas d'associé minoritaire dans les Sociétés Fusionnant pas de droits spécifiques sont prévus par le
projet de fusion à cet égard.
p. La date de clôture des livres des Sociétés Fusionnant (article 516 pt 14 du CSC)
La date de clôture des livres de la Société Absorbée dans le cadre de la Fusion Transfrontalière sera la Date d'Effet
de la Fusion. Le susdit prend en compte les réglementations régis par la Loi sur la Comptabilité Polonaise du 29 septembre
1994.
Les dispositions applicables de la loi luxembourgeoise n'exigent pas d'avoir les livres de la Société Absorbante fermées
suite à la fusion.
q. Date des derniers comptes annuels adoptés ou du bilan intermédiaire, utilisés pour définir les conditions de la fusion
transfrontalière
La date des derniers comptes annuels adoptés / du bilan intermédiaire des Sociétés Fusionnant utilisés pour définir les
conditions de la fusion transfrontalière est la suivante:
Société Absorbante: 30 septembre 2013
Société Absorbée: 30 septembre 2013
q. Annexes
Les annexes au présent projet de fusion forme une partie intégrale de ce projet.
Signé à Luxembourg / Varsovie, le 25 octobre 2013.
Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l.
Andrew O'SHEA / Gregor DALRYMPLE, représenté par Andrew O'SHEA / Damian WARDE
<i>Géranti> / <i>Géranti> / <i>Gérant
i>Norma Investments Sp. z o.o.
Alwyn Jacobus DE LANGE
<i>Président du Conseil de Gérancei>
Annexe A: Statuts à jour de la Société Absorbante
Annexe B: Projets de résolutions approuvant la fusion
Annexe C: Détermination de la valeur des actifs de la Société Absorbée
Annexe D: Déclaration relative à la valeur comptable des actifs de la Société Absorbée
134843
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
Annexe B au Projet de Fusion
<i>Résolutions de l'Assemblée Extraordinaire des Associés tenue le [*] novembre 2013 d'une société sous la dénominationi>
<i>Norma Investments, une société de droit polonais (a spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia)i>
dont le siège social est établi à Varsovie, au Al. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa, immatriculée auprès du
Registre de la Cour Nationale tenu par la cour du district de la ville de Varsovie, 12
ème
chambre commerciale - KRS
sous le numéro 0000268119 portant sur la fusion avec Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité
limitée luxembourgeoise dont le siège social est établi à Luxembourg, sur les termes mentionnés dans le projet de fusion
(le «Projet de Fusion») signé par les conseils de gérance des sociétés qui fusionnent le [*] 2013, publié à la cour et dans
le journal commercial (Monitor Sadowy В Gospodarczy) no [*] le [*] 2013, point [*].
L'Assemblée Extraordinaire des Associés de la Société approuve le Projet de Fusion et statue sur la fusion de la Société
et Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise organisée et existante
selon les lois du Luxembourg, dont le siège social est établi au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.461 (la «Société
Absorbante») par l'acquisition des actifs et passifs de la Société par la Société Absorbante sur la base de l'article 492 § 1
point 1 en association avec l'art. 491 § 1 du code des sociétés commerciales, conformément aux termes du Projet de
Fusion en date du [*] 2013.
Załacznik B do Planu Polaczenia
<i>Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnikówi>
<i>z dnia [•] listopada 2013 rokui>
<i>spółki pod firmai>
<i>Norma Investments spółka z ograniczna odpowiedzialnosciai>
z siedziba w Warszawie („Spółka“) przy Al. Jerozolimskich nr 56C, 00-803 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sadu Rejes-
trowego pod numerem KRS 0000268119, w sprawie połaczenia ze spółka Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l.,
luksemburska prywatna spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia (société à responsabilité limitée) z siedziba w Luksem-
burgu, na warunkach okreslonych w planie połaczenia („Plan Połaczenia“) podpisanym przez zarzady podlegajacych
łaczeniu sie spółek w dniu [•] 2013 roku i ogłoszonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr [•] z dnia [•] 2013 roku,
poz. [•].
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym wyraza zgode na Plan Połaczenia i postanawia o połac-
zeniu Spółki ze spółka Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., luksemburska prywatna spółka z ograniczona odpowied-
zialnoscia (société à responsabilité limitée), utworzona według prawa luksemburskiego, z siedziba przy 67, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek (Register of Commerce and
Companies) w Luksemburgu pod numerem B 100.461 (dalej jako: „Spółka Przejmujaca“), poprzez przeniesienie całego
majatku Spółki na Spółke Przejmujaca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 491 § 1
1
Kodeksu spółek handlowych na
warunkach okreslonych w Planie Połaczenia z dnia [•] 2013 roku.
Annex B to the Merger Plan
<i>Resolution of the Extraordinary Meeting of the Shareholdersi>
<i>held on [•] November 2013i>
<i>of a company under the namei>
<i>Norma Investments spółka z ograniczna odpowiedzialnosciai>
with its registered office in Warsaw, at Al. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa, registered with the National Court
Register (Krajowy Rejestr Sadowy) held by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12
th
Commercial Division
- KRS under the number 0000268119, on the merger with Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) with its registered office in Luxembourg, on the terms deter-
mined in the merger plan (the “Merger Plan”) signed by the management boards of the merging companies on [•] 2013,
announced in the Court and Commercial Gazette (Monitor Sadowy i Gospodarczy) no [•] of [•] 2013, item [•].
The Extraordinary Shareholders Meeting of the Company hereby approves the Merger Plan and resolves on the merger
of the Company and Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à
responsabilité limitée), organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 67, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies in Luxem-
bourg under the number B 100.461 (the “Acquiring Company”) by means of a transfer of assets and liabilities of the
Company to the Acquiring Company pursuant to Art. 492 § 1 point 1 in conjunction with Art. 491 § 1
1
of the Commercial
Companies Code on the terms as determined in the Merger Plan as of [•] 2013.
134844
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
Annexe C
NORMA INVESTMENTS SP. Z.O.O.
<i>Bilani>
<i>(Tous les montants sont exprimés en PLN)i>
ACTIFS
30.09.2013
Actifs non-courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.231.720,05
Créances à long terme
Des parties liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.228.798.45
Investissements à long terme
Actifs financiers à long terme
Dans les parties liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312,27
Acomptes et dépenses différées
Actif d'impôt différé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2609,33
Actifs circulants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816.856.499,27
Créances à court terme
Créances d'autres entités
Fiscalité et débiteurs (sécurité sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.228,00
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.586,51
41.814,51
Investissements à court terme
Actifs financiers à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816.814.684,76
TOTAL ACTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975.088.219,32
FONDS PROPRES ET PASSIFS
30.09.2013
Fonds Propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975.014.483,50
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.433.000,00
Réserve en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797.188.082,00
Réserve de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.551.770,82
Bénéfices accumulés des exercices précédents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.407.949,94
Bénéfice net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.433.680,74
975.014.483,50
Passifs et provisions pour passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.735,82
Passifs à court terme
Passifs attribuables à d'autres parties
Autres créanciers, échéance maximale jusqu'à 12 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.192,44
Fiscalité, droits de douane et securité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.008,57
65.201,01
Règlements inter périodiques
Autres règlements inter périodiques
A court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.534,81
TOTAL ACTIFS ET PASSIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975.088.219,32
Du 01.01.2013
au 30.09.2013
Recettes nettes de la vente et équivalents en recettes de la vente, notamment:
- des parties liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.914.375,14
5.914.375,74
Dépenses d'exploitation
Services externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
549.323,86
Fiscalité et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398,52
Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.331,36
Sécurité sociale et autres avantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.016,76
Autres dépenses en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711,29
134845
L
U X E M B O U R G
626.781,79
Bénéfice brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.287.593,95
Recette financière
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,84
Charges financières
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.450,23
Bénéfices avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.248.172,56
Impôt sur les sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(185.508,18)
Bénéfice net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.433.680,74
NORMA INVESTMENTS SP. Z O.O.
<i>Bilansi>
<i>(wszystkic danc liczbowe przcdstawiono w zlotych polskich)i>
AKTYWA
30.09.2013
Aktywa trwale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 231 720,05
Naleznosci długoterminowe
Od jednostek powiazanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 228 798,45
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiazanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312,27
Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 609,33
Aktywa obrotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 856 499,27
Naleznosci krótkoterminowe
Naleznosci od jednostek pozostałych
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczen i innych swiadczen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 228,00
inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 586,51
41 814,51
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 814 684,76
AKTYWA RAZEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 088 219,32
PASYWA
30.09.2013
Kapitał własny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 014 483,50
Kapitał podstawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 433 000,00
Kapital zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 188 082,00
Kapitał z aktualizacji wyceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 551 770,82
Zysk z lat ubiegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 407 949,94
Zysk netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 433 680,74
975 014 483,50
Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 735,82
Zobowiazania krótkoterminowe
Wobec pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnosci do 12 miesiecy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 192,44
z tytułu podatków, cci, ubezpieczen i innych swiadczen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 008,57
65 201,01
Rozliczenia miedzyokresowe
Inne rozliczenia miedzyokresowe
krótkoterminowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 534,81
PASYWA RAZEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 088 219,32
01.01.2013 -
30.09.2013
Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 914 375,74
- od jednostek powiazanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 914 375,74
Koszty działalnosci operacyjnej
134846
L
U X E M B O U R G
Usługi obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
549 323,86
Podatki i opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398,52
Wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 331,36
Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 016,76
Pozoscałe koszty rodzajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711,29
626 781,79
Zysk ze sprzedazy
5 287 593,95
Przychody finansowe
Odsetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,84
Koszty finansowe
Inne koszty finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 450,23
Zysk brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 248 172,56
Podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(185 508,18)
Zysk netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 433 680,74
Warszawa, 18.10.2013 r.
Podpisów.
Annexe D au Projet de Fusion
Suit la traduction française du texte qui précède:
<i>Déclaration au regard de la situation comptable de Norma Investments,i>
<i>une société de droit polonais (a spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia) établie pour le besoin de la fusioni>
Le Conseil de Gérance de Norma Investments, une société de droit polonais (a spółka z ograniczona odpowiedzial-
noscia) dont le siège social est établi en Varsovie (la «Société») au Al. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa,
immatriculée auprès du Registre de la Cour Nationale tenu par la cour du district de la ville de Varsovie, 12
ème
chambre
commerciale - KRS sous le numéro 0000268119, déclare qu'à compter du 30 septembre 2013, la situation comptable de
la Société est comme suit:
ACTIFS
Actifs immobilisés - PLN 158.231.720,05
Actifs circulants - PLN 816.856.499,27
TOTAL ACTIFS - PLN 975.088.219,32
PASSIFS
Fonds propres - PLN 975.014.483,50
Dettes et provisions pour dettes - PLN 73.735,82
TOTAL PASSIFS - PLN 975.088.219,32
Les informations mentionnées dans le statut comptable de la Société préparé pour la fusion reprennent les mêmes
méthodes et le même format que ceux utilisés pour le dernier bilan annuel qui constitue l'annexe 1 de la présente
déclaration et fait partie intégrante à cette déclaration.
Le Conseil de Gérance de Norma Investments Sp. Z.o.o.
Alwyn Jacobus DE LANGE / Thomas Neville RAVENSDALE
<i>Président du Conseil de Gérancei> / <i>Membre du Conseil de Gérancei>
Zalacznik D do Planu Polaczenia
Dnia 25 pazdziernika 2013 roku
<i>Oswiadczenie zawierajace informacje o stanie ksiegowymi>
<i>Norma Investments spółka z ogranicznai>
<i>odpowiedzialnoscia sporzadzona dla celów połaczeniai>
Zarzad Norma Investments spółki z ograniczona odpowiedzialnoscia, z siedziba w Warszawie („Spółka“) przy Al.
Jerozolimskich nr 56C, 00-803 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejo-
nowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sadu Rejestrowego pod numerem KRS 0000268119,
niniejszym oswiadcza, ze na dzien 30 wrzesnia 2013 r., stan ksiegowy spółki przedstawia sie nastepujaco:
AKTYWA
Aktywa trwałe - 158.231.720,05 PLN
Aktywa obrotowe - 816.856.499,27 PLN
AKTYWA RAZEM - 975.088.219,32 PLN
134847
L
U X E M B O U R G
PASYWA
Kapitał własny - 975.014.483,50 PLN
Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania - 73.735,82 PLN
PASYWA RAZEM - 975.088.219,32 PLN
Szczegółowa informacja o stanie ksiegowym Spółki sporzadzona dla celów połaczenia na dzien 30 wrzesnia 2013 r.,
przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, stanowi Załacznik nr 1 do
niniejszego oswiadczenia i jest jego integralna czescia.
Zarzad Norma investments Sp. z o.o.
Alwyn Jacobus DE LANGE / Thomas Neville RAVENSDALE
<i>Prezes Zarzadui> / <i>Członek Zarzadui>
Annex D to the Merger Plan
October 25, 2013.
<i>Statement regarding the accounting situationi>
<i>of Norma Investments spółka z ograniczna odpowiedzialnosciai>
<i>prepared for the purposes of the mergeri>
The Management Board of Norma Investments spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, with its registered office in
Warsaw (the “Company”), at Al. Jerozolimskie nr 56C, 00-803 Warszawa, registered with the National Court Register
held by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division - KRS under the number
0000268119, hereby declares that as of September 30, 2013, the accounting status of the Company is as follows:
ASSETS
Fixed assets - PLN 158,231,720.05
Current assets - PLN 816,856,499.27
TOTAL ASSETS - PLN 975,088,219.32
LIABILITIES
Equity - PLN 975,014,483.50
Payables and reserves for payables - PLN 73,735.82
TOTAL LIABILITIES - PLN 975,088,219.32
The detailed information on the accounting status of the Company prepared for the purposes of the merger, with the
use of the same methods and layout as the last annual balance sheet, constitutes Annex 1 to this statement and constitutes
an integral part hereof.
The Management Board of Norma Investments Sp. z o.o.
Alwyn Jacobus DE LANGE / Thomas Neville RAVENSDALE
<i>Chairman of the Management Boardi> / <i>Member of the Management Boardi>
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, of September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on “sociétés à responsabilité limitée”, as amended,
and the present articles of incorporation.
Art. 2. The Company's name is Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l.
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31
st
, 1929, on Holding
Companies.
134848
L
U X E M B O U R G
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to
require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.
II. Capital - Shares
Art. 8. The share capital is set at five hundred eighteen million thirty-nine thousand and forty US dollars (USD
518,039,040), represented by nine million one hundred ninety-four thousand three hundred and fifty-nine (9,194,359)
ordinary shares (the Ordinary Shares), having a par value of thirty US dollars (USD 30) each and eight million seventy-
three thousand six hundred and nine (8,073,609) mandatory redeemable preferred shares (the MRPS), having a par value
of thirty US dollars (USD 30) each, all in registered form, all subscribed and fully paid-up. The MRPS and the Ordinary
Shares are hereinafter referred to individually as a “Share” and collectively as the “Shares”. The Ordinary Shares and the
MRPS shall constitute separate classes of shares in the Company. The MRPS shall have preferred dividend and preferred
liquidation rights vis-a-vis the Ordinary Shares subject to the terms and conditions described hereafter.
The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the partners, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The partners may decide to create reserves
and/or share premium accounts which may be connected to classes of Shares as set out above.
The holders of the Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if
any) paid for the subscription of Ordinary Shares. The holders of MRPS will be exclusively entitled to any and all rights
attached to the share premium (if any) paid for the subscription of MRPS.
All MRPS are issued in the form of redeemable shares and the redemption of the MRPS can only be made by means
of sums available for distribution pursuant to Article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary
reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or proceeds of a new issue made for the
redemption purpose and through extraordinary general meeting of partners. The MRPS will be redeemed pursuant to
the following terms and conditions:
(i) in any circumstances whatsoever, the Company shall redeem all of the MRPS then in issue upon expiry of a thirteen
(13) years period from the date on which the MRPS are issued (the “Final Mandatory Redemption Date”);
(ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the holders of MRPS may
request by prior written notice to redeem all or part of the MRPS through and subject to the approval by the extraordinary
general meeting of partners; and
(iii) the redemption price of the MRPS to be redeemed will be equal to the par value of the redeemed MRPS increased
by the share premium (if any) attached to the MRPS and that is attributable to the MRPS so redeemed plus any accrued
and undeclared dividends (if any).
Redeemed MRPS will be cancelled forthwith after redemption and through the extraordinary general meeting of
partners resolving on such redemption.
All MRPS are issued in the form of convertible Shares into Ordinary Shares. MRPS may be converted pursuant to the
following terms and conditions:
(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of MRPS may at any time before such date,
request (in one or several occasions) in writing to convert into Ordinary Shares all or part of the MRPS to the fair market
value equivalent of the Ordinary Shares equal to the relevant MRPS par value, attached share premium and any declared
and unpaid dividends (if any), subject to the approval by the extraordinary general meeting of partners; and
134849
L
U X E M B O U R G
(ii) the number of Shares to be issued through extraordinary general meeting of shareholders upon such conversion
of MRPS into Ordinary Shares will be equal to the number of Shares converted in the relevant MRPS. The share premium
(if any) attached to the converted MRPS and that is attributable to the MRPS so converted will be allocated to the share
premium of the Ordinary Shares or to the share premium of the relevant MRPS.
The MRPS shall confer upon the holder(s) thereof as a class the right, in priority to the payment of dividends to the
holder(s) of Ordinary Shares to receive out of the profits of the Company available for distribution by way of dividend a
fixed cumulative preferential cash dividend (hereinafter called the MRPS Preferred Dividend), of 0.01% of the subscription
price paid by the relevant holder per MRPS (being the par value of each MRPS increased by the MRPS share premium
paid for each MRPS) (the MRPS Subscription Price), which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year.
The holder(s) of the MRPS shall not be entitled to participate in the distribution of dividends (if any) paid in excess of the
MRPS Preferred Dividend. [No dividend, whether in cash or kind, shall be paid or declared, nor shall any other distribution
be made (i) on the Ordinary Shares until any accrued MRPS Preferred Dividend shall have been declared and paid in full].
In case of dissolution of the Company, the holder of MRPS will rank junior to all debts incurred by the Company but
will rank senior to the holder of Ordinary Shares as set forth in article 20 below.
Art. 9. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.
Shares are freely transferable among the partners.
Where the Company has a sole partner, Shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one partner, the transfer of Shares (inter vivos) to third parties is subject to the
prior approval of the partners representing at feast three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
A register of partners is kept at the registered office and may be examined by each partner upon request.
The Company may redeem its own Shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that
purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management
Art. 10. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
Ali powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by
- the signature of any two managers for any transactions or dealings up to an amount of USD 20,000.- (twenty thousand
US Dollars)
- the signature of all the managers for any transactions of dealings above to an amount of USD 20,000.- (twenty thousand
US Dollars).
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that ail managers be present or
represented. In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the unanimous vote of the managers
present or represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 12. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
134850
L
U X E M B O U R G
IV. Partners decisions
Art. 13. Partner's decisions are taken by partner's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partner's number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions
to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 14. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of partners
representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second
meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be
represented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
As a consequence thereof, ail decisions which exceed the powers of the managers are taken by the partners.
V. Financial year - Balance sheet
Art. 15. The Company's financial Year begins on July 1
st
and closes on June 30
th
.
Art. 16. Each year, as of the 30
th
of June, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of ail its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of partners together with the balance sheet.
Art. 17. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
The partners determine how the balance of the annual net profits is allocated. They may allocate such balance to the
payment of a dividend and in particular the dividend referred to in article 8 above, transfer such balance to a reserve
account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.
Interim dividends may be distributed, at any time, subject to article 8 and under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the managers;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the partners within two (2) months from the date
of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the partners must
refund the excess to the Company.
VI. Winding-up - Liquidation
Art. 19. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the partners, adopted with the consent of a
majority (in number) of partners owning at least three-quarters of the share capital. The partners appoint one or several
liquidators, who need not be partners, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the partners, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the
liabilities of the Company.
The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities will be paid as follows:
(i) firstly, in repayment to the holder(s) of the MRPS (if any such shares are then outstanding) of the MRPS Preferential
Liquidation Right (as defined hereafter), such payment to be made on an equal per share basis, and
134851
L
U X E M B O U R G
(ii) secondly, after payment in full of the MRPS Preferential Liquidation Right, the holder(s) of the Ordinary Shares (if
any such shares are then outstanding) shall be entitled to be paid the remainder of the surplus, such payment to be made
on an equal per share basis among the Ordinary Shares.
If the surplus available for distribution among the shareholders is insufficient to make payment of the MRPS Preferential
Liquidation Right in full to all holders of the MRPS, then such a surplus shall be distributed among the holder(s) of the
MRPS, ratably in proportion to the full amounts to which they would otherwise be respectively entitled.
VII. Applicable law
Art. 20. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of incorporation do not
provide for the contrary.
Traduction française du texte qui précède:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est ici constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les
lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du
18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la Société est Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l.
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généra-
lement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger. Au cas où la gérance estimerait
que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale
au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents,
il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la
connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
II. Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à cinq cent dix-huit millions trente-neuf mille quarante dollars américains (USD
518.039.040,-) divisé en neuf millions cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent cinquante-neuf (9.194.359) parts sociales
ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune et
huit millions soixante-treize mille six cent neuf (8.073.609) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les
«PSPOR»), ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune, toutes sous forme nominative,
toutes souscrites et entièrement libérées. Les PSPOR et les Parts Sociales Ordinaires sont ci-après désignées individuel-
134852
L
U X E M B O U R G
lement comme une «Part Sociale» et collectivement comme les «Parts Sociales». Les Parts Sociales Ordinaires et les
PSPOR constitueront des catégories séparées de parts sociales dans la Société. Les PSPOR auront des dividendes pré-
férentiels et des droits de liquidation préférentiels vis-à-vis des Parts Sociales Ordinaires, conformément aux termes et
conditions décrits ci-après.
Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Les associés peuvent décider de créer des réserves et/ou des comptes de prime d'émission qui seront rattachés aux
classes des Parts Sociales définies ci-dessus.
Les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront exclusivement tous les droits quels qu'ils soient rattachés à la
prime d'émission (le cas échéant) payée pour la souscription des Parts Sociales Ordinaires. Les détenteurs des PSPOR
auront exclusivement tous les droits quels qu'ils soient rattachés à la prime d'émission (le cas échéant) payée pour la
souscription des PSPOR.
Toutes les PSPOR sont émises sous forme de parts sociales rachetables et le rachat des PSPOR pourra uniquement
se faire au moyen de sommes disponibles à la distribution en vertu de l'Article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, en ce
compris la réserve extraordinaire établie avec les fonds reçus par ta Société comme prime d'émission) ou le produit d'une
nouvelle émission effectuée pour les fins de rachat et par assemblée générale extraordinaire des associés. Les PSPOR
seront rachetées selon les modalités suivantes:
(i) quelques soient les circonstances, la Société rachètera toutes les PSPOR alors en circulation à l'expiration d'une
période de treize (13) ans à compter de la date à laquelle les PSPOR ont été émises (la «Date Ultime de Rachat Obliga-
toire»);
(ii) nonobstant la Date Ultime de Rachat Obligatoire et à tout moment avant cette Date, les détenteurs de PSPOR
peuvent demander par avis écrit préalable à racheter toutes ou une partie des PSPOR en et sous réserve de l'approbation
de l'assemblée générale extraordinaire; et
(iii) le prix de rachat des PSPOR sera égal à la valeur nominale des PSPOR rachetées augmenté de la prime d'émission
(s'il y en a) rattachée aux PSPOR et attribuable aux PSPOR ainsi rachetées plus tous dividendes cumulés mais non déclarés
(le cas échéant).
Les PSPOR rachetées seront immédiatement annulée après le rachat par l'assemblée générale extraordinaire des
associés qui a décidé ce rachat.
Toutes les PSPOR sont émises sous la forme de parts sociales convertibles en Parts Sociales Ordinaires. Les PSPOR
peuvent être converties selon les modalités suivantes:
(i) nonobstant la Date Ultime de Rachat Obligatoire, le détenteur de PSPOR peut à tout moment avant cette date,
demander (en une ou plusieurs occasions) par écrit de convertir en Parts Sociales Ordinaires toutes ou une partie des
PSPOR à la valeur marchande équivalente des Parts Sociales Ordinaires égale à la valeur nominale des PSPOR en question,
la prime d'émission rattachée et les dividendes déclarés mais non payés (le cas échéant) sous réserve de l'approbation
par l'assemblée générale extraordinaire des associés; et
(ii) le nombre de Parts Sociales à émettre par assemblée générale extraordinaire des associés pour cette conversion
de PSPOR en Parts Sociales Ordinaires sera égaie au nombre de Parts Sociales converties en PSPOR. La prime d'émission
(le cas échéant) rattachée aux PSPOR converties et qui est attribuable aux PSPOR ainsi converties sera affectée à la prime
d'émission des Parts Sociales Ordinaires ou à la prime d'émission des PSPOR concernées.
Les PSPOR conféreront sur leur(s) détenteur(s) comme une catégorie le droit, prioritairement au paiement de divi-
dendes au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires, de recevoir hors des bénéfices de la Société disponibles pour
distribution, par dividende en numéraire préférentiel cumulatif fixe (ci-après dénommé les Dividendes Préférentiels
PSPOR), de 0,01% du prix de souscription payé by le détenteur concerné par PSPOR (étant la valeur nominale et chaque
PSPOR augmentée par la prime d'émission PSPOR payé pour chaque PSPOR) (le Prix de Souscription PSPOR), qui sera
journalièrement cumulé et calculé sur 365 jours par an. Le(s) détenteur(s) des PSPOR n'auront pas droit de participer à
la distribution de dividendes (s'il y en a) payés en supplément des Dividendes Préférentiels PSPOR. [Aucun dividende,
qu'il soit en numéraire ou en nature, ne sera payé ou déclaré, et aucune autre distribution ne sera faite (i) sur les Parts
Sociales Ordinaires jusqu'à ce que tous les dividendes Préférentiels PSPOR aient été déclarés et entièrement payé.
En cas de dissolution de la Société, les détenteurs de PSPOR auront un rang inférieur à toutes les dettes de la Société
mais auront un rang supérieur aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires tel que défini à l'article 20 ci-dessous.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
134853
L
U X E M B O U R G
La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes
à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gérance
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par:
- la signature conjointe de deux gérants pour toutes transactions d'un montant inférieur ou égal à USD 20.000 (vingt
mille dollars américains);
- la signature de tous les gérants pour toutes transactions d'un montant supérieur à USD 20.000 (vingt mille dollars
américains).
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si tous les gérants sont
présents ou représentés.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées par le vote unanime des gérants présents ou repré-
sentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 12. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
IV. Décisions des associés
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 14. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par les associés.
V. Exercice social - Comptes annuels
Art. 15. L'exercice social commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin.
134854
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Chaque année, avec effet au 30 juin, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la
Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes de(s) gérant(s) envers la société. Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui
sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.
Art. 17. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les
gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuâmes mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d'une obligation légale ou statutaire. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions
suivantes:
a. des comptes intérimaires sont établis par les gérants;
b. ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants
sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la
réserve légale;
c. la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
d. les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
e. si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excédent à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 19. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en
nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liqui-
dateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et
rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les actifs et payer les dettes de la Société. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes
est distribué comme suit:
(i) premièrement, en repaiement au(x) détenteur(s) des PSPOR (si de telles parts sociales existent toujours) de leur
Droit de Boni Préférentiel PSPOR (tel que défini ci-après), un tel paiement devant être fait sur une base proportionnelle
par part sociale; et
(ii) deuxièmement, après paiement entier du Droit de Boni Préférentiel PSPOR, le(s) détenteur(s) des Parts Sociales
Ordinaires (si de telles parts sociales existent toujours) auront le droit d'être payé avec l'excédent restant, un tel paiement
devant être fait sur une base proportionnelle par part sociale parmi les Parts Sociales Ordinaires.
VII. Loi applicable
Art. 20. Les lois mentionnées à l'article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Luxembourg, le 17 juillet 2013.
POUR STATUTS COORDONNES
Henri HELLINCKX
<i>Notaire à Luxembourgi>
Référence de publication: 2013153275/1181.
(130187935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.
134855
L
U X E M B O U R G
Talentia Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 59.972.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013139349/10.
(130169500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Tarnold Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.224.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 01/10/2013.
Tarnold Holding S. à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2013139350/12.
(130169335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Taro S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 41.933.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139351/11.
(130169750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
THBIREF Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 167.784.
La société a décidé de procéder au transfert du siège social de la société de son adresse actuelle au 205, route d’Arlon,
L-1150 Luxembourg.
Cette décision a pris effet à compter du 1
er
octobre 2013.
Luxembourg, le 3 octobre 2013.
Pour extrait analytique conforme
Référence de publication: 2013139357/13.
(130169460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Tawban S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8561 Schwebach, 3, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 152.228.
EXTRAIT
La société informe le public que Monsieur Arab Abdelaziz né le 23.06.1976 à Metz (FR), occupant le mandat de gérant
de la société Tawban SARL, a changé son domicile qui est actuellement à
L - 8561 Schwebach 3, Haaptstrooss
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
134856
L
U X E M B O U R G
Schwebach, le 03 février 2013.
Pour extrait
Signature
Référence de publication: 2013139353/15.
(130169405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
TCP Publishing Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 155.441.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139354/10.
(130169395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Tecoh Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 111.560.
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clémency, le 03/10/2013.
Référence de publication: 2013139355/10.
(130169629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
COFIGECO, Compagnie Financière pour la Gestion Collective S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R.C.S. Luxembourg B 114.997.
<i>Extrait du procès verbal du conseil d'administration de la Compagnie Financière pour la Gestion Collective en abrégé COFIGECOi>
<i>du 22 mai 2013.i>
<i>Dépôt rectificatif du le dépôt initial numéro L130121361.i>
Est nommé à l'unanimité Président du Conseil d'Administration pour une durée d'un an:
Monsieur René Charles Gicquel
Ont démissionnés de leur poste d'Administrateurs Délégués:
Monsieur Alex De Jésus, le 15 avril 2013;
Monsieur Jean-Jacques Pire, le 22 mai 2013 avec effet au 30 juin 2013.
Est nommé à l'unanimité du Conseil d'Administration comme Directeur Mr Stéphane Vomscheid, domicilié à Rue de
la Montée 10 L-3362 Leudelange, pour y exercer la gestion journalière et entre autres les activités telles que décrites
dans le Règlement CSSF 10-4 et la Circulaire CSSF 12/546.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2013139589/19.
(130170331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Communauté d'Exploitation agricole SCHMIT-SCHUMANN, Société Civile.
Siège social: L-4975 Bettange-sur-Mess, Leftgermillen.
R.C.S. Luxembourg E 1.270.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le trente avril.
Ont comparu:
1) Monsieur SCHMIT Roger, associé-gérant, né le 11 mai 1946 au LUXEMBOURG, demeurant à L-4975 BETTANGE-
SUR MESS, Leftgermillen
2) Madame WELLONG Léa, associée-gérante, née 03 juin 1948 au LUXEMBOURG, demeurant à L-4975 BETTANGE-
SUR-MESS, Leftgermillen
134857
L
U X E M B O U R G
Les comparants se sont requis eux-mêmes pour documenter comme suit leurs déclarations:
a. Que la société civile «Communauté d'Exploitation agricole SCHMIT-SCHUMANN», avec siège social à L-4975
BETTANGE-SUR-MESS, Leftgermillen, (R.C.S. Luxembourg section E numéro 1270), a été constituée suivant acte du 25
avril 1990.
b. Que les comparants, représentés comme dit ci avant, ont décidé de dissoudre la société civile «Communauté
d'Exploitation agricole SCHMIT-SCHUMANN» aux droits des parties, par reprise par les associés-gérants de l'intégralité
de l'actif et du passif de la société civile.
c. Qu'il s'ensuit que ladite société civile «Communauté d'Exploitation agricole SCHMIT-SCHUMANN» est et restera
dissoute avec effet en date de ce jour.
d. Que tout l'actif et le passif de la société civile dissoute seront transmis aux associés-gérants proportionnellement à
leurs participations dans la société civile.
Fait et passé à Bettange-sur-Mess, en date du 30 avril 2006.
Référence de publication: 2013139588/26.
(130170719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Coface Services Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 129.767.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013139586/10.
(130170499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Colinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 74, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 158.333.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est
tenue le 2 octobre 2013 que:
- La démission de Mme Nadia Rodriguez de son poste d'administrateur est acceptée.
- Monsieur Marc Engelmann, directeur, né le 10 juillet 1974 à Ettelbruck, demeurant 24, Merschterwee L-9376 Ho-
scheid est nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013139611/18.
(130170306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Catwalk Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6670 Mertert, 52A, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 167.087.
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29. September 2013i>
1. Der Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds Herrn Knut Klinnert mit Wirkung zum 8. September 2013 wird ange-
nommen.
2. Der Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds Herrn Leif-Erik Klinnert mit sofortiger Wirkung wird angenommen.
<i>Für die Gesellschaft
Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2013139602/13.
(130170616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
134858
L
U X E M B O U R G
Cardea International Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 155.710.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’actionnaire unique de la Société prises en date du 31 mai 2013 les décisions suivantes:
- Révocation d’Ernst & Young S.A. en tant que commissaire aux comptes avec effet immédiat
- Nomination de Grant Thornton Lux Audit S.A. avec adresse professionnelle au 89A Parc d’Activités Capellen, L-8308
Capellen, en tant que réviseur d’entreprises agrée avec effet immédiat et ce pour une période de 3 ans
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 03 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139598/15.
(130170245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Centre G.R. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 21.134.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139579/9.
(130170688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Cemag S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 90.751.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 08 juillet 2013, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1) L'assemblée décide de prononcer la clôture de la liquidation et constater que la société a définitivement cessé
d'exister
2) L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une durée minimum de cinq ans
au domicile du liquidateur Grand rue, 78 à 9530 Wiltz.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 juillet 2013.
<i>L'associéi>
Référence de publication: 2013139603/17.
(130170990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Capfields s.a., Société Anonyme.
Siège social: L-8228 Mamer, 42, rue Nicolas Flener.
R.C.S. Luxembourg B 136.696.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 juin 2013i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale reconduit le mandat des administrateurs:
- Monsieur Frank Sikora, Monsieur Louis de Laromiguière et Monsieur Yves de Laromiguière pour une durée de trois
ans. Leurs mandats viendront à expiration à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice social de l'an
2015.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale reconduit le mandat du commissaire aux comptes:
134859
L
U X E M B O U R G
- L'AUXILIAIRE DES P.M.E. S.A., anciennement AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., pour une durée de
trois ans. Son mandat viendra à expiration à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice de l'an 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>POUR CAPFIELDS s.a.
i>Signature
Référence de publication: 2013139596/20.
(130169998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Charon Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.855.
EXTRAIT
Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 3 octobre 2013 que la société BRE/Management
6 S.A. a démissionné en tant que gérant unique de la Société avec effet au 4 octobre 2013.
L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BREDS Management S.A., société anonyme de droit
Luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B180.408, en tant que gérant unique de la Société, avec effet au
4 octobre 2013 pour une durée indéterminée.
La Société est désormais gérée par la société BREDS Management S.A. en qualité de gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013139583/20.
(130170374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Chambre de Commerce d'Espagne au Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg F 328.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Les membres de l'association sans but lucratif Chambre de Commerce d'Espagne au Luxembourg, réunis en assemblée
générale extraordinaire en date du 4 octobre 2013, ont a approuvé à l'unanimité la dissolution de l'association, sans
liquidation du fait de l'absence d'actif et de passif.
L'actif net étant inexistant, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque affectation.
Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139582/14.
(130171156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Ceres Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 175.196.
EXTRAIT
Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 3 octobre 2013 que la société BRE/Management
6 S.A. a démissionné en tant que gérant unique de la Société avec effet au 4 octobre 2013.
L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BREDS Management S.A., société anonyme de droit
Luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B180.408, en tant que gérant unique de la Société, avec effet au
4 octobre 2013 pour une durée indéterminée.
La Société est désormais gérée par la société BREDS Management S.A. en qualité de gérant unique.
134860
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013139580/20.
(130170375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
C.B.R. Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 17.657.
En date du 30 août 2013 et avec effet au 2 septembre 2013, Christian Leclercq, avec adresse au 47, avenue de la
Fauconnerie, 1170 Bruxelles, Belgique, a démissionné de son mandat d’administrateur de la société C.B.R. Finance S.A.,
avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 17657.
Alter Domus Luxembourg S.à r.l., mandaté par le démissionnaire
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139571/14.
(130170332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
CHEN-JI s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 174, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 78.713.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 septembre 2013
que:
- Les associés ont accepté la démission de Monsieur CHEN Zhiguang de son poste de gérant technique.
- Les associés on décidé de nommer en remplacement en qualité de gérant technique:
- Monsieur CHEN Xin, né le 5 avril 1982 à Zhejiang, demeurant à L-8010 STRASSEN, 174 route d'Arlon, en qualité
de gérant technique.
- Les associés ont demandé que soit modifié le pouvoir de signature de la société selon les termes suivants:
«Chaque gérant peut engager la société par sa signature individuelle. Pour les activités de la société soumises à une
autorisation d'établissement délivrée par les Classe Moyennes, la co-signature du gérant titulaire de cette autorisation
d'établissement est obligatoire.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Signatures.
Référence de publication: 2013139606/20.
(130170915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Coiffure Eliane S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1243 Luxembourg, 25, rue Félix de Blochausen.
R.C.S. Luxembourg B 83.210.
En date du 1
er
octobre 2013, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:
Madame Eliane MOINY, gérante, née le 4 décembre 1956 à Hatrival (B), demeurant à L-3899 FOETZ, 87, rue Théodore
de Wacquant, a cédé les cent vingt-quatre (124) parts sociales sur les cent vingt-quatre (124) parts sociales qu'elle détenait,
à Madame Eva Margarida FERNANDES DE SOUSA, maître-coiffeuse, née le 4 octobre 1977 à Abrunheira (P), demeurant
à L-1145 Luxembourg, 4, rue de Aubépines.
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s'établit comme suit:
Madame Eva Margarida FERNANDES DE SOUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 parts
TOTAL: CENT VINGT-QUATRE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 parts
Madame Eliane MOINY a démissioné de son poste de gérante unique.
Madame Eva Margarida FERNANDES DE SOUSA est nommée gérante unique de la société.
134861
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013139610/19.
(130170862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
CP Machinery Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 3.610.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 169.537.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 26 août 2013i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de Ching Nar Cindy Chan avec effet au 10 juillet 2013;
- D'accepter la démission de Changqing Ye avec effet au 10 juillet 2013;
- De nommer les gérants suivants avec effet au 10 juillet 2013:
* Bart Decroos, né le 24 octobre 1964 à Oostende, Belgium, demeurant professionnellement au Sany-Allee 1, 50181
Bedburg, Allemagne, aux fonctions de gérant de classe A pour une durée illimitée;
* Xiangyang Jiang, né le 17 juin 1963 à Guangxi, Chine, demeurant professionnellement au Max-Eyth-Strasse 10, 72631
Aichtal, Allemagne, aux fonctions de gérant de classe A pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Petra Diederich.
Référence de publication: 2013139614/18.
(130170740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Deuxcouleurs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 114.049.
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession sous seing privé signé en date du 1
er
octobre 2013 que Monsieur Juan GASSO NA-
VARRO, né le 10 août 1958 à Barcelona (Espagne), demeurant à Pablo Alcober no 50 3° 2A, E-08017 Barcelona (Espagne)
a cédé en date de ce jour à Monsieur Antonio GASSO NAVARRO, né le 9 février 1968 à Barcelona (Espagne), demeurant
à Migjorn no 54 B, E-08329 Teia Barcelona (Espagne) 62 parts sociales.
Partant, les 124 parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société sont réparties comme suit:
Antonio GASSO NAVARRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139626/17.
(130169968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
D Chateau VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 122.955.
In the year two thousand thirteen on the twenty-sixth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
VII CI Strandbrook, LLC, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Delaware, having its
address at 160 Greentree Drive, Suite 101, 19904 City of Dover, Delaware, U.S.A., company number 4373595,
duly represented by Mr Vincent BOUFFIOUX, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney, given under private seal in New York on 23 September 2013 (hereafter the Sole Shareholder).
Said proxy, initialed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
134862
L
U X E M B O U R G
Such appearing party is the Sole Shareholders of D Chateau VII S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered
office in L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 122.955, (the Company) incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHT-
GEN, notary then residing in Luxembourg, dated December 15
th
, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 241 dated February 23
rd
, 2007, successively and for the last time modified by deed of the
undersigned notary, dated November 25
th
, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 2978 dated December 17
th
, 2008.
The five hundred (500) shares of the Company with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, representing
the entire subscribed capital of the Company amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) are duly
present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of
the agenda. The Sole Shareholder present or represented declares that it has had due notice of, and has been duly informed
of the agenda prior to the Meeting.
The agenda of the meeting is the following:
1) Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
2) Discharge of the managers of the Company for the exercise of their respective mandates.
3) Appointment of one liquidator (the Liquidator).
4) Determination of the powers of the Liquidator and decision to instruct the Liquidator to execute at the best of its
abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.
5) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken by the Sole Shareholder:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides, in compliance with the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended,
to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder decides to give full discharge to the managers of the Company for the exercise of their respective
mandates until the date hereof.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder decides to appoint as liquidator Mr Vincenzo ARNÒ, private employee, born on May 20
th
,
1963 in Luxembourg, residing professionally in L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey, in relation to the voluntary
liquidation of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder decides that the Liquidator shall receive the powers as follows:
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.
The Liquidator is required to prepare an inventory of all assets and liabilities of the Company,
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the
general meeting in the cases in which it is requested.
The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
part of its powers it determines and for the period it will fix.
The Liquidator may distribute the Company's assets to the Shareholders in cash or in kind and will be empowered to
make an interim dividend distribution to the Shareholders, which interim dividend may be effected by way of endorsement
of any promissory notes in the possession of the Company's Shareholders.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-
ments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article
148 of the Law.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall prevail.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all known to the notary by their names, surnames and
residence, all signed together with Us the notary the present original deed.
134863
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil treize, le vingt-six septembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
VII CI Strandbrook, LLC, une limited liability company, constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social à c/o National Registered Agents, 160 Greentree Drive, Suite 101, 19904 City of Dover, Delaware, U.S.A.,
enregistrée à la Division of Corporation de l'Etat du Delaware, sous le numéro 4373595,
dûment représentée par un de ses gérants, Monsieur Vincent BOUFFIOUX, employé privé, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York le 23 septembre 2013 (ci-après
l'Associé Unique).
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de D Château VII S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 33,
avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 122.955 (la Société), constituée
suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du
15 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 241 du 23 février 2007, succes-
sivement et en dernier lieu modifié suivant acte reçu par le notaire soussignée, en date du 25 novembre 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1468 du 17 décembre 2008.
Toutes les cinq cents (500) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune,
représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR)
sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les
points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre
du jour.
Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société.
2) Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs.
3) Nomination d'un liquidateur (le Liquidateur).
4) Définition des responsabilités du Liquidateur et décision de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard
aux circonstances, tous les actifs de la société, et de payer toutes les dettes de la Société.
5) Divers.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'Associé Unique:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide, en conformité à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de dissoudre
la Société et de la mettre volontairement en liquidation (liquidation volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants de la Société en ce qui concerne l'exercice
de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique désigne comme liquidateur Monsieur Vincenzo ARNÒ, employé privé, né à Luxembourg le 20 mai
1963, ayant son adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey, en relation avec la liquidation
volontaire de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide que le Liquidateur recevra les pouvoirs comme déterminés ci-après.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la Loi.
Le Liquidateur doit dresser l'inventaire de l'actif et du passif de la Société.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du Liquidateur.
Le Liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans demander l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où cette autorisation serait requise.
Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.
Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux Associés en numéraire ou en espèces et pourra faire des
distributions d'avances sur le produit de la liquidation aux Associés, lesquelles distributions d'avances pourront être
réalisées par l'endossement de billets à ordre détenue par la Société au profit de ses actionnaires.
134864
L
U X E M B O U R G
L'assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux Associés, conformément à l'article 148 de la Loi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,
tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. BOUFFIOUX et M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2013. LAC/2013/44196. Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveuri>
(signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139621/137.
(130170943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
CVC Services Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 148.924.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139620/10.
(130170893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Bruisend S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 83.787.
<i>Extrait de la résolution de l'actionnaire unique en date du 30 novembre 2012i>
L'actionnaire unique de Bruisend S.A., décide de mettre un terme aux mandats d'administrateurs d'Yves Huart et
Gérard Witters et de commissaire aux comptes de la société Jawer Consulting S.A. avec effet immédiat. Christian Van
Brussel, avec adresse professionnelle au 34/303 avenue du 10
ème
de Ligne B-6700 Arlon est nommé administrateur
unique de la société et Jacques Lemoine, avec adresse professionnelle au 36/202 Haapstrooss L-8530 Ell, est nommé
commissaire aux comptes de la société. Les deux mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2018.
Luxembourg, le 30 novembre 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013139568/15.
(130170865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Cable TV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 119.896.
In the year two thousand and thirteen, on the fifth of September.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, under-
signed.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Cable TV S.A., a public limited liability company ("société
anonyme") incorporated and organized under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46,
Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ('Registre
de Commerce et des Sociétés") under number B 119.896 and incorporated pursuant to a deed drawn up by Maître Joseph
134865
L
U X E M B O U R G
Elvinger, notary residing in Luxembourg in place of Maître Henri Hellinckx, notary residing then in Mersch on 24 August
2006 and published on 15 November 2006 in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 2134, page
102413 (hereafter referred to as the "Company").
The articles of association of the Company (the "Articles") have been modified several times and for the last time
pursuant to a deed drawn up by Maître Francis Kesseler, pre-named, on 24 May 2013 and published on 6 August 2013
in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 1893, page 90825.
The meeting was chaired by Mr. David Remy, employee, residing professionally in Luxembourg, who appointed Mrs
Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, residing professionally in Esch/Alzette as secretary, residing professio-
nally in Luxembourg. The meeting designated Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, residing professionally
in Esch/Alzette as scrutineer.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The Company's share capital is set at USD 45,714.- (forty-five thousand seven hundred and fourteen United States
Dollars) divided into 22,857 (twenty-two thousand eight hundred and fifty-seven) ordinary shares all with a par value of
USD 2.- (two United States Dollars) per share.
II. The shareholders of the Company, holding together the whole share capital of the Company, are represented at
the meeting. The proxy of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list,
which after having been controlled by the proxy of the represented shareholders and by the members of the bureau of
the general meeting, has been signed by the proxies and the members of the bureau.
III. This attendance list, as well as the proxies of the represented shareholders, after having been signed "ne varietur"
by the parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes and shall be registered together
with these minutes.
IV. The agenda of the meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 64,519,292.- (sixty-four million five hundred and
nineteen thousand two hundred and ninety-two United States Dollars) in order to raise it from its current amount of
USD 45,714.- (forty-five thousand seven hundred and fourteen United States Dollars) to USD 64,565,006.- (sixty-four
million five hundred and sixty-five thousand and six United States Dollars) by creating and issuing 32,259,646 (thirty-two
million two hundred and fifty-nine thousand six hundred and forty-six) new shares (the "New Shares"), each with a par
value of USD 2.- (two United States Dollars);
2. Subscription to the New Shares by APTT Holdings 1 Limited, a company incorporated under the laws of Bermuda,
with registered office at Penboss Building, 50 Parliament Street, Hamilton HM12, Bermuda, registered with the Companies
Register of Bermuda under number EC-41702 (the "Subscriber 1") and by APTT Holdings 2 Limited, a company incor-
porated under the laws of Bermuda, with registered office at Penboss Building, 50 Parliament Street, Hamilton HM12,
Bermuda, registered with the Companies Register of Bermuda under number 40353 (the "Subscriber 2", together with
Subscriber 1, the "Subscribers" or the "Shareholders") in the equivalent proportion as their current respective partici-
pation in the Company by way of conversion of some of the Company's share premium;
3. Subsequent amendment of Article 5.1.1 of the Articles which shall henceforth read as follows: "The subscribed
capital of the Company is set at sixty-four million five hundred and sixty-five thousand and six United States Dollars (USD
64,565,006.-) divided into thirty-two million two hundred and eighty-two thousand five hundred and three (32,282,503)
shares (the "Ordinary Shares') all with a par value of two United States Dollars (USD 2.-) per Ordinary Share, all fully
subscribed and entirely paid-up.";
4. Immediately after the capital increase, decrease of the share capital of the Company by an amount of USD
64,519,292.- (sixty-four million five hundred and nineteen thousand two hundred and ninety-two) in order to reach its
previous amount equal to USD 45,714.- (forty-five thousand seven hundred and fourteen United States Dollars) by way
of absorption of some of the losses of the Company as of USD 64,519,292.- (sixty-four million five hundred and nineteen
thousand two hundred and ninety-two United States Dollars);
5. Subsequent amendment of Article 5.1.1 of the Articles which shall henceforth read as follows: "The subscribed
capital of the Company is set at forty-five thousand seven hundred and fourteen United States Dollars (USD 45,714.-)
divided into twenty-two thousand eight hundred and fifty-seven (22,857) shares (the "Ordinary Shares") all with a par
value of two United States Dollars (USD 2.-) per Ordinary Share, all fully subscribed and entirely paid-up.";
6. Appointment of a manager to implement the whole resolutions; and
7. Miscellaneous.
The Shareholders unanimously decide to adopt the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to INCREASE the share capital of the Company by an amount of USD 64,519,292.- (sixty-
four million five hundred and nineteen thousand two hundred and ninety-two United States Dollars) in order to raise it
from its current amount of USD 45,714.- (forty-five thousand seven hundred and fourteen United States Dollars) to USD
64,565,006.- (sixty-four million five hundred and sixty-five thousand and six United States Dollars) by creating and issuing
the New Shares.
134866
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to SUBSCRIBE to the New Shares in the equivalent proportion as their current respective
participation in the Company and to have the New Shares fully paid up by way of conversion of some of the share premium
of the Company, as follows:
Current
participation
(%)
Number of
New Shares
Nominal Value
of New Shares
(USD)
Subscriber 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.50 16,936,314
33,872,628.00
Subscriber 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.50 15,323,332
30,646,664.00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.00 32,259,646
64,519,292.00
As the Company's share premium amounting to USD 85,001,819.55 (eighty-five million one thousand eight hundred
and nineteen United States Dollars fifty-five Cents) before such capital increase, the Shareholders ACKNOWLEDGES
that, after such capital increase, the Company's share premium is set at USD 20,482,527.55 (twenty million four hundred
and eighty-two thousand five hundred and twenty-seven United States Dollars fifty-five Cents) and the share capital is
split as follows:
Participation
after
increase (%)
Participation
after increase
(Number
of shares)
Participation
after increase
(USD)
APTT Holdings 1 Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.50
16,948,314
33,896,628.00
APTT Holdings 2 Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.50
15,334,189
30,668,378.00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.00
32,282,503
64,565,006.00
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the previous resolutions, the Shareholders RESOLVE to AMEND Article 5.1.1. of the Articles
which shall henceforth read as follows:
"The subscribed capital of the Company is set at sixty-four million five hundred and sixty-five thousand and six United
States Dollars (USD 64,565,006.-) divided into thirty-two million two hundred and eighty-two thousand five hundred and
three (32,282,503) shares (the "Ordinary Shares") all with a par value of two United States Dollars (USD 2.-) per Ordinary
Share, all fully subscribed and entirely paid-up.".
<i>Fourth resolutioni>
Immediately after the implementation of such capital increase, the Shareholders, after having reviewed the interim
financial statements as of 15 August 2013, showing a carried forward loss of USD 42,154,512.04 (forty-two million one
hundred and fifty-four thousand five hundred and twelve United States Dollars four Cents), RESOLVE to DECREASE the
share capital of the Company by an amount of USD 64,519,292.- (sixty-four million five hundred and nineteen thousand
two hundred and ninety-two United States Dollars) in order to bring it from USD 64,565,006.- (sixty-four million five
hundred and sixty-five thousand and six United States Dollars) to USD 45,714.- (forty-five thousand seven hundred and
fourteen United States Dollars) by way of absorption of some of the losses for an amount of USD 64,519,292.- (sixty-
four million five hundred and nineteen thousand two hundred and ninety-two United States Dollars) in order to offset
some of the incurred losses for an amount of USD 64,519,292.- (sixty-four million five hundred and nineteen thousand
two hundred and ninety-two United States Dollars).
As a result of the foregoing share capital decrease, the share capital is split as follows:
Participation
after
decrease
(%)
Participation
after
decrease
(Number
of shares)
Participation
after
decrease
(USD)
APTT Holdings 1 Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.50
12,000
24,000.00
APTT Holdings 2 Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.50
10,857
21,714.00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.00
22,857
45,714.00
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the previous resolutions, the Shareholders RESOLVE to AMEND Article 5.1.1. of the Articles
which shall henceforth read as follows:
"The subscribed capital of the Company is set at forty-five thousand seven hundred and fourteen United States Dollars
(USD 45,714.-) divided into twenty-two thousand eight hundred and fifty-seven (22,857) shares (the "Ordinary Shares")
all with a par value of two United States Dollars (USD 2.-) per Ordinary Share, all fully subscribed and entirely paid-up.".
134867
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to GRANT any manager ("gerant") of the Company each acting individually, the power
to proceed to all such acts and matters directly or indirectly necessary or useful to the capital increase referred to under
the first resolution and the capital decrease referred to under the fourth resolution, including but not limited to the
update of the shareholders' register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company are
estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1.500,-).
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
There being no further business the Chairman declared the meeting closed.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, the latter signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le cinq septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cable TV S.A., une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B. 119.896 et constituée en vertu d'un acte reçu par Me Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en remplacement de Me Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch
le 24 août 2006 et publié le 15 novembre 2006 au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro
2134, page 102413 (dénommée ci-après la «Société»).
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire Maître Francis Kesseler, précité, le 24 mai 2013 et publié le 6 août 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 1893, page 90825.
L'assemblée est présidée par Mr. David Remy, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, lequel dé-
signe comme secrétaire Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, ayant son adresse professionnelle à
Esch/Alzette. L'assemblée choisit également comme scrutateur, Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée,
ayant son adresse professionnelle à Esch/Alzette.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le capital social de la Société est fixé à 45.714 USD (quarante-cinq mille sept cent quatorze Dollars américains)
représenté par 22.857 (vingt - deux mille huit cent cinquante - sept) actions ordinaires toutes d'une valeur nominale de
2 USD (deux Dollars américains) par action.
II. Les actionnaires de la Société, représentant ensemble l'entièreté du capital de la Société, sont représentés à l'as-
semblée. Le mandataire des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence, laquelle, après avoir été contrôlée par le mandataire des actionnaires représentés et par les membres du
bureau de l'assemblée générale, a été signée par les mandataires et les membres du bureau.
III. Cette liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur»
par les parties et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
IV. La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de 64.519.292 USD (soixante-quatre millions cinq
cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-douze Dollars américains) pour le porter de son montant actuel de 45.714
USD (quarante - cinq mille sept cent quatorze Dollars américains) à 64.565.006 USD (soixante-quatre millions cinq cent
soixante-cinq mille six Dollars américains) par l'émission de 32.259.646 (trente-deux millions deux cent cinquante-neuf
mille six cent quarante-six) nouvelles actions (les «Nouvelles Actions»), chacune d'une valeur nominale de 2 USD (deux
Dollars américains);
2. Souscription des Nouvelles Actions par APTT Holdings 1 Limited, une société de droit des Bermudes, ayant son
siège social à Penboss Building, 50 Parliament Street, Hamilton HM12, Bermudes, inscrite auprès du Registre des Sociétés
des Bermudes sous le numéro EC-41702 (le «Souscripteur 1») et par APTT Holdings 2 Limited, une société de droit des
134868
L
U X E M B O U R G
Bermudes, ayant son siège social à Penboss Building, 50 Parliament Street, Hamilton HM12, Bermudes, inscrite auprès
du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 40353 (le «Souscripteur 2», ensemble avec le Souscripteur 1, les
«Souscripteurs» ou les «Actionnaires») dans une proportion équivalente à leur actuelle respective participation dans la
Société par voie de conversion d'une partie de la prime d'émission de la Société;
3. Modification subséquente de l'article 5.1.1 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit: «Le capital souscrit
de la Société est fixé à soixante-quatre millions cinq cent soixante-cinq mille six Dollars américains (64.565.006 USD)
divisé en trente-deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent trois (32.282.503) actions ordinaires (les «Ac-
tions Ordinaires»), avec une valeur nominale de deux Dollars américains (2 USD) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.»;
4. Immédiatement après l'augmentation de capital, baisse du capital de la Société d'un montant de 64.519.292 USD
(soixante-quatre millions cinq cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-douze de Dollars américains) dans le but d'at-
teindre son précédent montant de 45.714 USD (quarante-cinq mille sept cent quatorze Dollars américain) par voie
d'absorption d'une partie des pertes de la Société pour un montant de 64.519.292 USD (soixante-quatre millions cinq
cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-douze de Dollars américains);
5. Modification subséquente de l'article 5.1.1 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit: «Le capital souscrit
de la Société est fixé à quarante - cinq mille sept cent quatorze Dollars américains (45.714 USD) divisé en vingt deux
mille huit cent cinquante - sept (22.857) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»), avec une valeur nominale de deux
Dollars américains (2 USD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»;
6. Nomination d'un gérant pour mettre en oeuvre l'ensemble des résolutions; et
7. Divers.
Les Actionnaires décident à l'unanimité d'adopter les résolutions qui suivent:
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT d'AUGMENTER le capital souscrit de la Société à concurrence de 64.519.292 USD
(soixante-quatre millions cinq cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-douze Dollars américains) pour le porter de son
montant actuel de 45.714 USD (quarante - cinq mille sept cent quatorze Dollars américains) à 64.565.006 USD (soixante-
quatre millions cinq cent soixante-cinq mille six Dollars américains) par l'émission des Nouvelles Actions.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT de SOUSCRIRE les Nouvelles Actions dans une proportion équivalente à leur actuelle
respective participation dans la Société et de libérer entièrement les Nouvelles Actions par voie de conversion d'une
partie de la prime d'émission de la Société, comme suit:
Participation
actuelle (%)
Nombre de
Nouvelles
Actions
Valeur
Nominale
des
Nouvelles
Actions
(USD)
Souscripteur 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52,50 16.936.314 33.872.628
Souscripteur 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,50 15.323.332 30.646.664
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00 32.259.646 64.519.292
Comme la prime d'émission de la Société s'élève à 85.001.819,55 USD (quatre-vingt-cinq millions mille huit cent dix-
neuf Dollars américains et cinquante-cinq cents) avant cette augmentation de capital, les Actionnaires CONSTATENT
que, après cette augmentation de capital, la prime d'émission de la Société s'élève à 20.482.527,55 USD (vingt millions
quatre-cent-quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-sept Dollars américains et cinquante-cinq cents) et que le capital social
est réparti comme suit:
Participation
après
augmentation
(%)
Participation
après
augmentation
(Nombre
d'actions)
Participation
après
augmentation
(USD)
APTT Holdings 1 Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52,50
16.948.314
33.896.628
APTT Holdings 2 Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,50
15.334.189
30.668.378
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00
32.282.503
64.565.006
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des décisions prises ci-avant, les Actionnaires DECIDENT de MODIFIER l'article 5.1.1 des Statuts,
lequel sera dorénavant libellé comme suit:
134869
L
U X E M B O U R G
«Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante-quatre millions cinq cent soixante-cinq mille six Dollars américains
(64.565.006 USD) divisé en trente-deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent trois (32.282.503) actions
ordinaires (les «Actions Ordinaires»), avec une valeur nominale de deux Dollars américains (2 USD) chacune, toutes
entièrement souscrites et libérées.».
<i>Quatrième résolutioni>
Immédiatement après la réalisation de ladite augmentation de capital, les Actionnaires, après avoir revu les comptes
intérimaires arrêtés au 15 août 2013, faisant apparaître une perte reportée de 42.154.512,04 USD (quarante-deux million
cent cinquante-quatre mille cinq cent douze mille Dollars américains et quatre Cents), DECIDE de REDUIRE le capital
social de la Société d'un montant de 64.519.292 USD (soixante-quatre millions cinq cent dix-neuf mille deux cent quatre-
vingt-douze Dollars américains) pour le porter de son montant précédent de 64.565.006 USD (soixante-quatre millions
cinq cent soixante-cinq mille six Dollars américains) à 45.714 USD (quarante-cinq mille sept cent quatorze Dollars amé-
ricains) par voie d'absorption d'une partie des pertes de la Société pour un montant de 64.519.292 USD (soixante-quatre
millions cinq cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-douze Dollars américains) de manière à compenser les pertes
encourues pour un montant de 64.519.292 USD (soixante-quatre millions cinq cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-
douze Dollars américains).
En conséquence de la réduction de capital décidée ci-dessus, le capital social est réparti comme suit:
Participation
après
réduction
(%)
Participation
après
réduction
(Nombre
d'actions)
Participation
après
réduction
(USD)
APTT Holdings 1 Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52,50
12.000
24.000
APTT Holdings 2 Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,50
10.857
21.714
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00
22.857
45.714
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des précédentes résolutions, les Actionnaires DECIDENT de MODIFIER l'article 5.1.1 des Statuts,
lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à quarante - cinq mille sept cent quatorze Dollars américains (45.714 USD)
divisé en vingt deux mille huit cent cinquante - sept (22.857) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»), avec une valeur
nominale de deux Dollars américains (2 USD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.».
<i>Sixième résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT d'ACCORDER à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, le pouvoir
de procéder à tout acte et toutes choses directement ou indirectement nécessaires ou utiles à l'augmentation de capital
reprise à la première résolution et à la réduction de capital reprise à la quatrième résolution, incluant sans y être limité
la mise à jour du registre d'actionnaires de la Société.
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés
à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en
constate expressément l'accomplissement.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président déclare la séance levée.
DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des personnes comparantes, ce dernier a signé le
présent acte avec, Nous, le notaire.
Signé: Remy, Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11649. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
134870
L
U X E M B O U R G
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139573/290.
(130170833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
CAIVS S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 139.632.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CAIVS S.C.A. Sicar
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2013139594/12.
(130170757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Debt Resolution Corp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 173.049.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 octobre 2013.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2013139623/11.
(130170776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Chasselas Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 157.893.
Le Rapport Annuel Révisé au 31 mars 2013 et la distribution des dividendes relative aux Résolutions de l’Actionnaire
unique du 27 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139605/11.
(130170748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Double Jhang S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5417 Ehnen, 8, rue Isidore Comes.
R.C.S. Luxembourg E 5.169.
STATUTES
L'an deux mille.
Le trois février.
ENTRE LES SOUSSIGNES:
1.- Monsieur Jean LINDEN, vigneron, né à Ehnen, le 9 octobre 1948, demeurant à L-5417 Ehnen, 8, rue Isidore Comes;
2.- Monsieur Jean SECKLER, notaire, né à Luxembourg, le 3 janvier 1947, demeurant à L-6133 Junglinster, 11, Cité
Kremerich;
une société civile immobilière a été constitutée avec les statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu'elle
a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil.
Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la construction et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles à l'exclusion
de toute activité commerciale.
Art. 3. La dénomination de la société est "DOUBLE JHANG S.C.I.".
134871
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Le siège social est établi à Ehnen.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l'assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000.- Frs.), divisé en CENT (100) parts de
MILLE FRANCS (1.000.- Frs.) chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué:
1.- Monsieur Jean LINDEN, vigneron, né à Ehnen, le 9 octobre 1948,
demeurant à L-5417 Ehnen, 8, rue Isidore Comes, cinquante parts; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Jean SECKLER, notaire, né à Luxembourg, le 3 janvier 1947,
demeurant à L-6133 Junglinster, 11, Cité Kremerich, cinquante parts; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL: cent parts; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L'intégralité de l'apport devra être libérée
sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l'appel des fonds ou apports.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de
mort à des tiers non associés sans l'accord des associés représentant 75% du capital en cas entre cession entre vifs
respectivement sans l'accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.
En cas de transfert par l'un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption
sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l'unanimité d'année en année lors de l'assemblée générale statuant
sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement
à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux
autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.
Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants
n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé
décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à
régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes
intéressant la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l'unanimité de tous les associés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour
compte de la société.
La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle des gérants tant pour les actes
d'administration que de disposition.
Art. 11. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 12. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du
code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.
Art. 13. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du
gérant ou sur convocation d'un des associés. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'assemblée.
L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que
l'assemblée n'en décide autrement.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparantes, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé aux fonctions de gérant:
Monsieur Jean LINDEN, préqualifié.
2.- Le siège social est établi à L-5417 Ehnen, 8, rue Isidore Comes.
Fait en autant d'exemplaires que de parties à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Signé: J. LINDEN - J. SECKLER.
134872
L
U X E M B O U R G
Enregistré deux rôles sans renvoi à Grevenmacher, le 4 février 2000, volume 167, folio 28, case 2. Reçu mille francs.
1% = 1.000.-
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013139642/76.
(130170892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Demas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 60.439.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2013.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2013139633/12.
(130170770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
DH M Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.000.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 162.697.
Les comptes annuels pour la période du 4 août 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2012 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139634/11.
(130170627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Datofin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 40.472.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139632/9.
(130170294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
CPPIB Credit Investments European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 8.758.808,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 151.453.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of September,
before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), acting as replacement of
Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain
the depositary of the present deed,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of CPPIB Credit Investments European
Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
151.453 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger on February 9, 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on March 31, 2010 under number 684.The articles of association of the
Company have been amended and for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach,
dated August 14, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
THERE APPEARED:
134873
L
U X E M B O U R G
CII, Luxembourg Branch, having its registered office at 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163.285, being
the Luxembourg branch of CPPIB Credit Investments Inc., a corporation organised under the laws of Canada, having its
registered office at One Queen Street East, Suite 2600, Toronto, ON M5C 2W5, Canada, and registered with the Industry
Canada under number 707726-2 (the Sole Shareholder),
duly represented by Peggy Simon, private employee, with professional address in Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of eighty thousand United States Dollars (USD 80,000.-)
so as to bring it from its current amount of eight million six hundred seventy-eight thousand eight hundred and eight
United States Dollars (USD 8,678,808.-) to the amount of eight million seven hundred fifty-eight thousand eight hundred
and eight United States Dollars (USD 8,758,808.-) by way of the issuance of eighty thousand (80,000) new mandatory
redeemable preferred shares (MRPS) having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each;
2. Subscription and payment of the share capital increase by way of a contribution in cash;
3. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the share
capital increase adopted under item 1 above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, to proceed for and on behalf of the Company with the registration of
such changes; and
5. Miscellaneous.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eighty thousand United
States Dollars (USD 80,000.-) so as to bring it from its current amount of eight million six hundred seventy-eight thousand
eight hundred and eight United States Dollars (USD 8,678,808.-) to the amount of eight million seven hundred fifty-eight
thousand eight hundred and eight United States Dollars (USD 8,758,808.-) by way of the issuance of eighty thousand
(80,000) MRPS, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital
increase as follows:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to eighty thousand
(80,000) new MRPS, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of
a contribution in cash in an amount of eight million United States Dollars (USD 8,000,000.-).
Such contribution in cash shall be allocated as follows:
(i) eighty thousand United States Dollars (USD 80,000.-) to the share capital account of the Company; and
(ii) seven million nine hundred twenty thousand United States Dollars (USD 7,920,000) to the premium reserve account
attached to the MRPS of the Company.
Therefore, the amount of eight million United States Dollars (USD 8,000,000.-) is now at the disposal of the Company
and proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, so
that it shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at eight million seven hundred fifty-eight thousand eight hundred and eight United States
Dollars (USD 8,758,808.-), represented by twenty-five thousand (25,000) ordinary shares (the Ordinary Shares) having
a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and eight million seven hundred thirty-three thousand eight
hundred and eight (8,733,808) mandatory redeemable preferred shares (the MRPS) having a nominal value of one United
States Dollar (USD 1.-) each, all in registered form, all subscribed and fully paid-up. The MRPS and the Ordinary Shares
are hereinafter referred to individually as a Share and collectively as the Shares."
134874
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed for and on
behalf of the Company with the registration of such changes.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately three thousand four hundred Euro (EUR 3.400.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed
together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-septième jour du mois de septembre,
par devant Maître Jean SECKLER, notaire, résidant à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg), agissant en rempla-
cement de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, ce dernier
restant le dépositaire de l'acte présent,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de CPPIB Credit Investments European
Holdings S.àr.l, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont
le siège social se situe 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.453 (la Société), constituée suivant un acte
de Maître Joseph Elvinger le 9 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association le 31 mars 2010,
numéro 684. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Beck, notaire
de résidence à Echternach, daté du 14 août 2013, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
A COMPARU
CII, Luxembourg Branch, dont le siège social se situe 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.285, qui est
la succursale luxembourgeoise de CPPIB Credit Investments Inc., une société régie par le droit canadien, dont le siège
social se situe One Queen Street East, Suite 2600, Toronto, Ontario, M5C 2W5, Canada, immatriculée auprès de Canada
Industrie sous le numéro 707726-2 (l'Associé Unique),
représentée par Peggy Simon, employée privée, de résidence professionnelle à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire de la partie com-
parante, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt mille dollars américains (USD 80.000,-)
afin de le porter de son montant actuel de huit millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent huit dollars américains
(USD 8.678.808,-) au montant de huit millions sept cent cinquante-huit mille huit cent huit dollars américains (USD
8.758.808,-) par l'émission de quatre-vingt mille (80,000) nouvelles parts sociales préférentielles obligatoirement rache-
tables (PSPOR) ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune;
2. Souscription et libération de l'augmentation de capital social par un apport en numéraire;
3. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du capital social
adoptée au point 1. ci-dessus;
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société pour procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription de ces modifi-
cations; et
5. Divers.
III. l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:
134875
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt mille dollars américains
(USD 80.000,-) afin de le porter de son montant actuel de huit millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent huit
dollars américains (USD 8.678.808,-) au montant de huit millions sept cent cinquante-huit mille huit cent huit dollars
américains (USD 8.758.808,-) par l'émission de quatre-vingt mille (80,000) nouvelles PSPOR ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation
de capital comme suit:
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Dès lors, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux quatre-vingt mille
(80,000) nouvelles PSPOR ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libérer intégralement
par un apport en numéraire d'un montant de huit millions de dollars américains (USD 8.000.000,-).
L'apport en numéraire sera affecté de la manière suivante:
(i) quatre-vingt mille dollars américains (USD 80.000,-) au compte capital social de la Société; et
(ii) sept millions neuf cent vingt mille dollars américains (USD 7.920.000,-) seront affectés au compte de réserve de
prime d'émission rattaché aux PSPOR de la Société.
Ainsi, la somme de huit millions de dollars américains (USD 8.000.000,-) est désormais à la disposition de la Société
dont la preuve a été dûment apportée au notaire instrumentant qui le reconnait expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier l'article 5.1. des Statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social est fixé à huit millions sept cent cinquante-huit mille huit cent huit dollars américains (USD
8.758.808,-), représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune et huit millions sept cent trente-trois mille huit cent huit
(8.733.808) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les PSPOR) ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1,-) chacune, toutes sous forme nominative, toutes souscrites et entièrement libérées. Les PSPOR et les
Parts Sociales Ordinaires sont individuellement appelées une Part Sociale et collectivement appelées les Parts Sociales."
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société pour procéder pour le compte et au nom de la Société à l'inscription
de ces modifications.
<i>Évaluation des fraisi>
Les dépenses coûts, honoraires et charges de toute sorte qui incombent à la société du fait du présent acte s'élèvent
approximativement à trois mille quatre cents Euros (EUR 3.400.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte original.
Signé: P. SIMON, Jean SECKLER.
Enregistré à Echternach, le 01 octobre 2013. Relation: ECH/2013/1791. Reçu soixante-douze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 04 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139615/174.
(130170481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
134876
L
U X E M B O U R G
Craft Air S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 93.626.
Le Bilan du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139616/10.
(130170450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Creation Design International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.
R.C.S. Luxembourg B 105.361.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2013139617/12.
(130170267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
CRV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9016 Ettelbruck, 3-5, rue de l'Ecole Agricole.
R.C.S. Luxembourg B 114.162.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 octobre 2013.
Référence de publication: 2013139618/10.
(130170205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Climmolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 49.225.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013139607/10.
(130170671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
CMC Card and Management Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5534 Remich, 17, rue Foascht.
R.C.S. Luxembourg B 106.420.
Le bilan arrêté au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 octobre 2013.
<i>Pour CMC CARD AND MANAGEMENT CONSULT SARL
i>Fiduciaire Roger Linster Sàrl
Référence de publication: 2013139608/12.
(130170825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
134877
L
U X E M B O U R G
Coconsult s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.
R.C.S. Luxembourg B 37.017.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139609/9.
(130170713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Costantini Promotions s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.
R.C.S. Luxembourg B 144.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139612/9.
(130170910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Cozen s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 2B, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 143.054.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139613/9.
(130170931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Brighton Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 97.323.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 26 aout 2013:i>
<i>Administrateur:i>
- Cristina Fileno a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 26 aout 2013.
- Robert Quinn ayant pour adresse professionnelle le 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a été nommée
administrateur de la société avec effet au 26 aout 2013 jusqu’à la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013139567/15.
(130170849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Capital R.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1870 Luxembourg, 199, Kohlenberg.
R.C.S. Luxembourg B 153.388.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139597/9.
(130170576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Cable & Wireless Global Businesses International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 63.922.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
134878
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139572/9.
(130170724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Carlista S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 40.469.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139599/9.
(130170656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Crynolis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 72.190.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139619/9.
(130170540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
DIF Participations 1 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 170.316.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139638/9.
(130170781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
DIF Participations 2 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 170.355.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139639/9.
(130170783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
DIF Participations 3 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 170.357.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139640/9.
(130170782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Elite Wealth Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 167.889.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139652/9.
(130170433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
134879
L
U X E M B O U R G
Lux Mara S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9377 Hoscheid, 27, Lisseneck.
R.C.S. Luxembourg B 150.884.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139912/9.
(130170864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Manema S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 134.477.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139937/9.
(130170151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Manema S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 134.477.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139938/9.
(130170152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
MECS International Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, rue Général Patton.
R.C.S. Luxembourg B 109.677.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013139943/9.
(130170240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
EuroPRISA Luxembourg Holding Company F S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 113.413.
Il résulte d’une résolution prise par l’organe de gérance de la Société et datée du 26 septembre 2013 que le siège social
de la Société a été transféré du 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
avec prise d’effet à dater du 1
er
septembre 2013.
L’adresse professionnelle du gérant Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.àr.l.a été transféré du 15 bou-
levard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.
L’adresse professionnelle du gérant Enrico Baldan a été transféré du 57 rue de Beggen, L-1221 Luxembourg au 2
boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2013.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013139664/18.
(130170144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
134880
Brighton Investments S.A.
Brookfield Finance Luxembourg S.à r.l.
Bruisend S.A.
Cable TV S.A.
Cable & Wireless Global Businesses International Sàrl
CAIVS S.C.A. SICAR
Capfields s.a.
Capital R.L. S.A.
Cardea International Fund S.C.A., SICAV-SIF
Carlista S.A.
Catwalk Europe S.A.
C.B.R. Finance S.A.
Cemag S.A.
Centre G.R. s.à r.l.
Ceres Investment S.à r.l.
Chambre de Commerce d'Espagne au Luxembourg
Charon Investment S.à r.l.
Chasselas Fund
CHEN-JI s.à.r.l.
Climmolux S.A.
CMC Card and Management Consult S.à r.l.
Coconsult s.à r.l.
Coface Services Luxembourg
Coiffure Eliane S.à.r.l.
Colinvest S.A.
Communauté d'Exploitation agricole SCHMIT-SCHUMANN
Compagnie Financière pour la Gestion Collective S.A.
Costantini Promotions s.à r.l.
Cozen s.à r.l.
CP Machinery Limited S.à r.l.
CPPIB Credit Investments European Holdings S.à r.l.
Craft Air S.A.
Creation Design International S.A.
CRV Luxembourg S.à r.l.
Crynolis S.à r.l.
CVC Services Holdings S.àr.l.
Datofin S.A.
D Chateau VII S.à r.l.
Debt Resolution Corp S.à r.l.
Demas S.A.
Deuxcouleurs S.à r.l.
DH M Beta S.à r.l.
DIF Participations 1 Luxembourg S.à r.l.
DIF Participations 2 Luxembourg S.à r.l.
DIF Participations 3 Luxembourg S.à r.l.
Double Jhang S.C.I.
Elite Wealth Management S.à r.l.
EuroPRISA Luxembourg Holding Company F S.à r.l.
Lux Mara S.à r.l.
Manema S.A.
Manema S.A.
MECS International Holding Sàrl
Sufren Private S.A. SPF
Talentia Luxembourg S.A.
Tarnold Holding S. à r.l.
Taro S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, (SPF)
Tawban S.à r.l.
TCP Publishing Holdco S.à r.l.
Tecoh Investissements S.à r.l.
THBIREF Management Company S.à r.l.