This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2675
31 octobre 2012
SOMMAIRE
Avolon Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
128393
BlackRock Global Funds . . . . . . . . . . . . . . . .
128397
Clearness Investment Fund S.C.A., SICAV-
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128379
Data Center Infrastructure S.à r.l. . . . . . . .
128354
DataEurope Co-Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . .
128354
FFH Financial Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
128362
Five Arrows Nautilus Co-Invest Feeder
SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128366
Fosbele Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
128399
Fotex Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128398
Henrik Andersen Sportpromotion AG . . .
128357
Immoconsulting Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
128377
Industeam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128390
ING (L) Liquid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128361
International Trading and Investments
Holdings S.A. Luxembourg . . . . . . . . . . . .
128356
Lainal S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128354
Langwies II sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128356
LCE Allemagne 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128358
LCE Allemagne 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128361
LCE Allemagne 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128361
LCE Allemagne 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128362
LCE Allemagne 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128362
Litsea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128362
Lux-Vitrerie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128366
Maxalice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128376
MEIF 3 Luxembourg B Holdings, S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128379
MGM 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128379
Monier Investissement S.C.A. . . . . . . . . . . .
128366
Mountain Aviation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128376
Nesah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128392
New Equities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128393
North REOF Cuza S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128389
North REOF Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
128390
Nova Metrix (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
128392
Nova Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128392
Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS . . . . . . . . . . .
128393
Pandore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128394
PEF Turkey MENA III S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
128395
PEF Turkey MENA II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
128390
PEF Turkey MENA Nisantasi Commercial
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128396
PEF Turkey MENA Nisantasi Office S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128398
Phoenix Finance & Immo Luxembourg
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128395
Q.I.M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128400
Royalty Opportunities Feeder S.A. . . . . . .
128358
Stonehage Corporate Services Luxem-
bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128394
TCI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128396
TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., Indus-
trie per le Telecomunicazioni . . . . . . . . . .
128396
Trade Crédit Re Carré S.A. . . . . . . . . . . . . .
128397
Transalliance Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128397
Traveling S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128396
Triplewell S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128397
Vigicore Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128399
Vigroup Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128399
Vigroup Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128400
Vigroup Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128400
Virovest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128398
128353
L
U X E M B O U R G
Lainal S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4959 Bascharage, 18, Zone Artisanale Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg E 2.695.
<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 1 i>
<i>eri>
<i> août 2012i>
L'an deux douze, le premier août, les associés détenant toutes les parts de la société civile immobilière LAINAL S.C.I.,
dont le siège est à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris
la résolution suivante:
Transfert du siège social
Le siège de la société est transféré à L-4959 Bascharage, 18, Zone Artisanale Op Zaemer, à compter du 1
er
août 2012.
Bertrange, le 01.08.2012.
<i>Les associési>
Référence de publication: 2012131463/15.
(120173675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Data Center Infrastructure S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DataEurope Co-Invest S.à r.l.).
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 170.137.
<i>Rectificatif d'erreurs matérielles relatif à l'assemblée générale extraordinaire du notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg,i>
<i>du 26 juillet 2012 déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 24 août 2012 sous la référence L120148494i>
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la société Data Center Infrastructure S.à r.l., dressé par le notaire
Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 26 juillet 2012, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1
er
août 2012, Relation LAC/2012/36733,
qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'ordre du jour de l'Assemblée (sous le point 3) du texte français:
Augmentation du capital de la Société d'un montant de 858.245,40 EUR (huit cent cinquante huit mille deux cent
quarante-cinq euros et quarante centimes) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 12.600
EUR (douze mille six cent euros) à un montant de 870.845,40 EUR (huit cent soixante-dix mille huit cent quarante-cinq
euros et quarante centimes) par le biais de l'émission de 87.084.540 (quatre-vingt sept millions quatre-vingt quatre mille
cinq cent quarante) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) chacune dans le capital social de
la Société (les Nouvelles Parts Sociales);
or il fallait lire:
Augmentation du capital de la Société d'un montant de 858.245,40 EUR (huit cent cinquante huit mille deux cent
quarante-cinq euros et quarante centimes) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 12.600
EUR (douze mille six cent euros) à un montant de 870.845,40 EUR (huit cent soixante-dix mille huit cent quarante-cinq
euros et quarante centimes) par le biais de l'émission de 85.824.540 (quatre-vingt cinq millions huit cent vingt quatre mille
cinq cent quarante) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) chacune dans le capital social de
la Société (les Nouvelles Parts Sociales);
qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la PREMIERE RESOLUTION du texte français:
<i>«Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 858.245,40 EUR (huit cent cinquante
huit mille deux cent quarante-cinq euros et quarante centimes) afin de porter le capital social de la Société de son montant
actuel de 12.600 EUR (douze mille six cent euros) représenté par 1.260.000 (un million deux cent soixante mille) parts
sociales ayant une valeur nominale de 0.01 EUR (un centime) chacune, à un montant de 870.845,40 EUR (huit cent
soixante-dix mille huit cent quarante-cinq euros et quarante centimes) par l'émission de 87.084.540 (quatre-vingt sept
millions quatre-vingt quatre mille cinq cent quarante) parts sociales ayant une valeur de 0,01 EUR (un centime) chacune,
et l'Assemblée émet ces nouvelles parts sociales (les Nouvelles Parts Sociales)."
or il fallait lire:
<i>"Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 858.245,40 EUR (huit cent cinquante
huit mille deux cent quarante-cinq euros et quarante centimes) afin de porter le capital social de la Société de son montant
actuel de 12.600 EUR (douze mille six cent euros) représenté par 1.260.000 (un million deux cent soixante mille) parts
sociales ayant une valeur nominale de 0.01 EUR (un centime) chacune, à un montant de 870.845,40 EUR (huit cent
soixante-dix mille huit cent quarante-cinq euros et quarante centimes) par l'émission de 85.824.540 (quatre-vingt cinq
128354
L
U X E M B O U R G
millions huit cent vingt quatre mille cinq cent quarante) parts sociales ayant une valeur de 0,01 EUR (un centime) chacune,
et l'Assemblée émet ces nouvelles parts sociales (les Nouvelles Parts Sociales)."
qu'une première erreur matérielle s'est glissée dans la QUATRIEME RESOLUTION du texte français:
<i>«Quatrième résolutioni>
(i) souscrire à toutes les 87.084.540 (quatre-vingt sept millions quatre-vingt quatre mille cinq cent quarante) Nouvelles
Parts sociales ayant une valeur nominale de 0.01 EUR (un centime) chacune, pour un prix de souscription total de
113,982,699.79 EUR (cent treize millions neuf cent quatre vingt-deux mille six cent quatre-vingt dix-neuf Euro et soixante-
dix-neuf centimes), chacune ayant le même prix de souscription, et.
(ii) payer les 87.084.540 (quatre-vingt sept millions quatre-vingt quatre mille cinq cent quarante) Nouvelles Parts
sociales au moyen d'un apport en nature comme suit:»
or il fallait lire:
<i>«Quatrième résolutioni>
(i) souscrire à toutes les 85.824.540 (quatre-vingt cinq millions huit cent vingt quatre mille cinq cent quarante) Nouvelles
Parts sociales ayant une valeur nominale de 0.01 EUR (un centime) chacune, pour un prix de souscription total de
113,982,699.79 EUR (cent treize millions neuf cent quatre vingt-deux mille six cent quatre-vingt dix-neuf Euro et soixante-
dix-neuf centimes), chacune ayant le même prix de souscription, et
(ii) payer les 85.824.540 (quatre-vingt cinq millions huit cent vingt quatre mille cinq cent quarante) Nouvelles Parts
sociales au moyen d'un apport en nature comme suit:»
qu'une seconde erreur matérielle s'est glissée dans la QUATRIEME RESOLUTION du texte français:
<i>«Quatrième résolutioni>
L'apport des Actions et des Créances décrit ci-dessus d'un montant total de 113,982,699.79 EUR (cent treize millions
neuf cent quatre-vingt deux mille six cent quatre-vingt dix-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) sera alloué comme
suit:
- 858.245,40 EUR (huit cent cinquante huit mille deux cent quarante-cinq euros et quarante centimes) au compte de
capital social de la Société;
- 85.824.54 EUR (quatre-vingt cinq mille huit cent vingt quatre euros et cinquante-quatre centimes) à la réserve légale
de la Société (cette affectation à la réserve légale résultant de la conversion de la prime d'émission du même montant);
et
- 870.845, 40 EUR (huit cent soixante-dix mille huit cent quarante-cinq euros et quarante centimes) à la prime d'émis-
sion de la Société.
or il fallait lire:
<i>«Quatrième résolutioni>
L'apport des Actions et des Créances décrit ci-dessus d'un montant total de 113,982,699.79 EUR (cent treize millions
neuf cent quatre-vingt deux mille six cent quatre-vingt dix-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) sera alloué comme
suit:
- 858.245,40 EUR (huit cent cinquante huit mille deux cent quarante-cinq euros et quarante centimes) au compte de
capital social de la Société;
- 85.824.54 EUR (quatre-vingt cinq mille huit cent vingt quatre euros et cinquante-quatre centimes) à la réserve légale
de la Société (cette affectation à la réserve légale résultant de la conversion de la prime d'émission du même montant);
et
- 113.038.629,85 EUR (cent treize mille trente-huit mille six cent vingt-neuf euros et quatre-vingt cinq centimes) à la
prime d'émission de la Société.
Luxembourg, le 18 septembre 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la société Data Center Infrastructure S.à r.l.i>
suit signature
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 octobre 2012. Relation: LAC/2012/46149. Reçu douze euros (EUR 12,-)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131896/93.
(120173828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
128355
L
U X E M B O U R G
Langwies II sa, Société Anonyme.
Siège social: L-6131 Junglinster, 6, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 27.340.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131464/9.
(120173610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 29.742.
(I) Changement Président du Conseil d'Administration:
Monsieur Mariusz Walter n'est plus président du conseil d'administration (tout en restant administrateur de classe A)
à partir du 4 janvier 2011 et Monsieur Bruno Valsangiacomo est devenu président du conseil d'administration à partir de
cette date et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014; par conséquent, Monsieur Bruno Valsangiacomo est
Administrateur de classe A et Président du Conseil d'Administration.
(II) Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 25 mai 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
<i>Conseil d'Administrationi>
1. Nomination des administrateurs suivants:
- Carmen Behles, avec adresse professionnelle au 20, Werdmüllerweg, 8645 Jona, Suisse, en tant que administrateur
de classe A,
- Friedrich Rather, avec adresse professionnelle au 9/73, ul. Czerniowiecka, 02 705 Warszawa, Pologne, en tant que
administrateur de classe A,
- Gabriel Wujek, avec adresse professionnelle au 184, ul. Inflancka 19 m., 00 189 Warszawa, Pologne, en tant que
administrateur de classe B.
avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les comptes de
l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017 et qui se tiendra en 2018.
2. Modification du mandat d'Aldona Wejchert, avec adresse professionnelle au 18, Via Veglia, 7500 Saint-Moritz, Suisse,
d'administrateur de classe B en administrateur de classe A avec effet immédiat et pour une période venant à échéance
lors de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017 et qui se
tiendra en 2018.
3. Non renouvellement du mandat d'administrateur de classe A de Christian Benz, avec adresse professionnelle au
33e, Flühgasse, 8008 Zurich, Suisse.
Il résulte de ce qui précède que le conseil d'administration est composé comme suit:
Mariusz Walter, Administrateur de classe A
Bruno Valsangiacomo, Administrateur de classe A et Président du Conseil d'Administration
Aldona Wejchert, Administrateur de classe A
Carmen Behles, Administrateur de classe A
Piotr Nowak, Administrateur de classe A
Toinon Hoss, Administrateur de classe A
Friedrich Rather, Administrateur de classe A
Wojciech Kostrzewa, Administrateur de classe B
Marek Janicki, Administrateur de classe B
Markus Sieger, Administrateur de classe B
Gabriel Wujek, Administrateur de classe B
Réviseur d'entreprises agrée/Commissaire aux comptes
4. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400,
Route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
5. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400,
Route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
128356
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131422/51.
(120173702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Henrik Andersen Sportpromotion AG, Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Dinklange.
R.C.S. Luxembourg B 97.525.
Im Jahre zweitausendzwölf, am vierundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbrück,
versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "HENRIK ANDER-
SEN SPORTPROMOTION A.G." (Matrikel 2001 2229 004), mit Sitz in L-9710 Clerf, 35, Grand'rue,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Sektion B unter Nummer 97.525,
gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Urbain Tholl, mit dem Amtssitz in Mersch, am 16. November
2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 553 vom 10. April 2002.
Die Versammlung wurde eröffnet um 13,30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herr Henrik ANDERSEN,
Spielervermittler, wohnhaft in B-4837 Baelen, Nereth 12F, geboren zu Kopenhagen (Dänemark) am 7. Mai 1965 (Matrikel
1965 05 07 757).
Die Gesellschafterversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktien-gesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen
Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
II. aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 1000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital
darstellen, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung
somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.
III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
2. Verschiedenes.
Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, wurden folgende Beschlüsse einstimmig
gefasst:
<i>Einziger Beschluss:i>
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Sitz der Gesellschaft nach L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drin-
klange zu verlegen.
Demzufolge wird Absatz 2 des ersten Artikels der Satzungen wie folgt abgeändert:
Art. 1. (Absatz 2). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Ulflingen."
Da die Tagesordnung erschöpft ist wird die Versammlung aufgehoben.
<i>Kosten.i>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen,
werden geschätzt auf EUR 650,-.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesenden, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Henrik ANDERSEN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2012. Relation: DIE/2012/11495. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012132003/48.
(120173937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
128357
L
U X E M B O U R G
LCE Allemagne 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 119.731.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l’Associé unique en date du 28 août 2012:
- Les démissions de Wim Rits et Ivo Hemelraad en tant que gérants A de la Société sont acceptées avec effet immédiat;
- Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling (Grande-Bretagne) et Claire Théobald, née le 28 février 1982 à
Thionville (France), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, ont été élus nouveaux
gérants A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012131469/15.
(120173708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Royalty Opportunities Feeder S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.775.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of August.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mrs. Ingrid Cernicchi, employee of Intertrust (Luxembourg) S.A., with professional address in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors (the Board) of ROYALTY OPPORTUNITIES FEEDER S.A., a
public limited company (société anonyme), incorporated and organized under the laws of Luxembourg, with registered
office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 160775 (the Company),
pursuant to resolutions taken by the Board on August 2, 2012 (the Resolutions).
A copy of the Resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The appearing person, representing the Board pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the fol-
lowing statements:
I.- The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg,
dated April 27, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1713 dated July 28, 2011.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated November 16, 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 37 dated January 5, 2012.
II.- The Company has an issued share capital of four hundred and twenty three thousand eight hundred and seventy-
eight United States dollars (USD 423,878) represented by fourty two million three hundred eighty seven thousand and
eight hundred (42,387,800) Shares in registered form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each.
III.- Article 5.3 of the Articles provides as follows:
"The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication of the deed of incorporation,
to:
(i) increase the current share capital in one or several times up to four million six hundred and forty-five thousand
three hundred and ninety-three United States dollars (USD 4,645,393.06), by the issue of four hundred sixty-four million
five hundred and thirty nine thousand three hundred and six (464,539,306) new shares, having the same rights as the
existing shares;
(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons
authorized to subscribe to the new shares; and
(iii) record by way of a notarial deed each share capital increase and amend the share register accordingly."
IV.- The Board pursuant to the Resolutions resolved to inter alia:
(i) increase the share capital of the Company from its current amount of four hundred and twenty three thousand
eight hundred and seventy-eight United States dollars (USD 423,878) to six hundred and twenty eight thousand eight
hundred and thirty United States dollars (USD 628,830) by way of the creation and issue of twenty million four hundred
and ninety five thousand two hundred (20,495,200) new ordinary shares having a par value of one United States cent
128358
L
U X E M B O U R G
(USD 0.01) each (the New Shares), within the limits set forth in the authorisation given to the Board under article 5.3 of
the Articles to increase the share capital in one or several times;
(ii) amendment of article 5.1 and 5.3 (i) of the Articles as a result of the foregoing resolutions; and
(iii) to appoint any employee of Intertrust (Luxembourg) S.A., acting under his sole signature, to execute and sign on
behalf of the Company any acts, deeds, declarations, certificates, notices, documents or statements as may be necessary
to formalise the share capital increase in front of a notary public in Luxembourg. This delegation of signatory powers shall
cover but shall not be limited to any corporate action necessary to amend and restate the articles of association, certify
any excerpt or extract of the above Resolutions or part thereof and pay any taxes and duties which may become payable
as a result of the present share capital increase.
The New Shares have been fully subscribed and fully paid up by a contribution in cash of two hundred and four thousand
nine hundred and fifty two United States dollars (USD 204,952) fully allocated to the share capital account of the Company,
as approved by the Resolutions, evidence of which has been given to the undersigned notary.
V.- As a result of the above, the Board has resolved to amend articles 5.1. and 5.3 (i) of the Articles which should now
be read as follows:
" 5.1. The share capital is set at six hundred and twenty eight thousand eight hundred and thirty United States dollars
(USD 628,830), represented by sixty two million eight hundred and eighty three thousand (62,883,000) shares in regis-
tered form, having a par value of one United States cent (USD $0.01) each, all subscribed and fully paid-up."
" 5.3. [...] (i) increase the current share capital in one or several times up to four million four hundred and forty thousand
four hundred and forty one United States dollars and six cents (USD 4,440,441.06), by the issue of four hundred forty
four million and forty four thousand one hundred six (444,044,106) new shares, having the same rights as the existing
shares.
<i>Estimate of costsi>
The appearing party declares that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid
by the Company as a result of this deed amount approximately to one thousand two hundred and fifty Euro.
The amount of the capital increase is valued at EUR 165,740.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the person appearing, he/she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-troisième jour d'août.
Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Madame Ingrid Cernicchi, employée d'Intertrust (Luxembourg) S.A., résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en qualité de représentante du conseil d'administration (le Conseil) de ROYALTY OPPORTUNITIES FEEDER
S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe
au65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160775 (la Société),
conformément aux décisions prises par le Conseil le 2 août 2012 (les Décisions).
Une copie des Décisions, signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentant le Conseil conformément aux Décisions, a prié le notaire instrumentant d'acter
ce qui suit:
I. La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 27 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1713 du 28 juillet 2011. Les
statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 37 du 5 janvier 2012.
II. La Société a un capital social souscrit de quatre cent vingt-trois mille huit cent et soixante-dix-huit dollars des Etats-
Unis (USD 423.878) représenté par quarante-deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent (42.387.800)
actions sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un centime de dollar des Etats-Unis (USD 0,01) chacune.
III. L'article 5.3 des Statuts prévoit ce qui suit:
128359
L
U X E M B O U R G
"Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'acte constitutif,
à:
(i) augmenter le capital social existant en une ou plusieurs fois, à hauteur de quatre millions six cent quarante-cinq
mille trois cent quatre-vingt-treize dollars des Etats-Unis et six centimes (USD 4.645.393,06), par l'émission de quatre
cent soixante-quatre millions cinq cent trente-neuf mille trois cent six (464.539.306) de nouvelles actions, ayant les mêmes
droits que les actions existantes;
(ii) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer
les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et
(iii) faire constater chaque augmentation de capital social par acte notarié et modifier le registre des actions en con-
séquence."
IV. Le Conseil, conformément aux Décisions, a décidé inter alia:
(i) d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de quatre cent vingt-trois mille huit cent soixante-
dix-huit dollars des Etats-Unis (USD 423.878,00) à six cent vingt-huit mille huit cent trente dollars des Etats-Unis (USD
628.830) par la création et l'émission de vingt millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille deux cent (20.495.200)
nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale d'un centime de dollar des Etats-Unis (USD 0,01) chacune (les Nou-
velles Actions), dans les limites prévues par l'autorisation donné au Conseil en vertu de l'article 5.3 des Statuts pour
augmenter le capital social en une ou plusieurs fois;
(ii) de modifier l'article 5.1 et 5.3 (i) des Statuts, suite aux Décisions précédentes; et
(iii) de nommer tout employé d'Intertrust (Luxembourg) S.A., agissant sous sa seule signature, pour exécuter et signer
pour le compte de la Société tous les documents, actes, déclarations, certificats, mentions, documents ou déclarations
jugés nécessaires afin de formaliser la présente augmentation de capital social en présence d'un notaire de Luxembourg.
Cette délégation de pouvoir de signature couvre, mais n'est pas limitée à, toute action de la Société nécessaire à la
modification de statuts, la certification de tout extrait des Décisions ou partie de ces dernières et le paiement de toutes
les taxes et droits exigibles consécutifs à la présente augmentation de capital.
Les Nouvelles Actions ont été entièrement souscrites et entièrement libérées par un apport en numéraire de deux
cent quatre mille neuf cent cinquante-deux dollars des Etats-Unis (USD 204.952) entièrement affecté au compte de capital
social de la Société tel qu'approuvé lors des Décisions, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.
V. En conséquence de ce qui précède, le Conseil a décidé de modifier les articles 5.1. et 5.3 (i) des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social est fixé à six cent vingt-huit mille huit cent trente dollars des Etats-Unis (USD 628.830), représenté
par soixante-deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille (62.883.000) actions sous forme nominative, ayant une valeur
nominale d'un centime de dollar des Etats-Unis (USD 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."
" 5.3. [...] (i) augmenter le capital social existant à une ou plusieurs reprises, à hauteur de quatre millions quatre cent
quarante mille quatre cent quarante-et-un dollars des Etats-Unis et six centimes (USD 4.440.441,06), par l'émission de
quatre cent quarante-quatre millions quarante-quatre mille cent six (444.044.106) nouvelles actions, ayant les mêmes
droits que les actions existantes."
<i>Estimation des coûtsi>
La partie comparante déclare que les dépenses, coûts et frais ou charges de toute nature qui seront à régler par la
Société puisque découlant de cet acte, atteindront le montant approximatif de mille deux cent cinquante euros.
Le montant de l'augmentation du capital social est évalué à EUR 165.740.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare, par la présente, qu'à la demande de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même personne
comparante, en cas de divergences entre le texte en anglais et celui en français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ingrid Cernicchi, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2012. Relation GRE/2012/3175. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 10 octobre 2012.
Référence de publication: 2012132206/147.
(120174094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
128360
L
U X E M B O U R G
LCE Allemagne 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.306.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'Associé unique en date du 28 août 2012:
- Les démissions de Wim Rits et Ivo Hemelraad en tant que gérants A de la Société sont acceptées avec effet immédiat;
- Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling (Grande-Bretagne) et Claire Théobald, née le 28 février 1982 à
Thionville (France), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, ont été élus nouveaux
gérants A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012131470/15.
(120173594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
LCE Allemagne 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.306.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131471/9.
(120173627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
ING (L) Liquid, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 86.762.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 09 octobre 2012i>
<i>Conseil d’Administrationi>
- Démission de Monsieur Michel van Elk en date du 1
er
novembre 2011
- Démission de Monsieur Jan Straatman en date du 1
er
décembre 2011
- Démission de Monsieur David Suetens en date du 29 mars 2012
- Ratification de la cooptation avec effet au 1
er
novembre 2011 de Monsieur André van den Heuvel, 65 Schenkkade,
2595 AS, The Hague, The Netherlands
- Nomination de Monsieur André van den Heuvel
- Ratification de la cooptation avec effet au 1
er
septembre 2012 de Monsieur Mark den Hollander, 65 Schenkkade,
2595 AS, The Hague, The Netherlands
- Nomination de Monsieur Mark den Hollander
Confirmation du mandat des administrateurs suivants:
- Madame Maaike van Meer, 81/F, International Commerce Centre, Austin Road West 1, Kowloon, Hong Kong
- Monsieur Dirk Buggenhout, 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
<i>Réviseuri>
Reconduction de mandat de la société Ernst & Young, 7 rue Gabriel Lippmann à L-5365 Munsbach, pour une période
d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 octobre 2012.
ING Investment Management Luxembourg S.A.
Par délégation
Elise Valentin / Kathleen Carnevali
Référence de publication: 2012132026/30.
(120173750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
128361
L
U X E M B O U R G
LCE Allemagne 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.307.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131472/9.
(120173672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
LCE Allemagne 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.307.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l’Associé unique en date du 28 août 2012:
- Les démissions de Wim Rits et Ivo Hemelraad en tant que gérants A de la Société sont acceptées avec effet immédiat;
- Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling (Grande-Bretagne) et Claire Théobald, née le 28 février 1982 à
Thionville (France), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, ont été élus nouveaux
gérants A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012131473/15.
(120173690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Litsea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 154.374.
Il résulte des résolutions prises par le gérant unique de la société en date du 9 octobre 2012 que le siège social de la
société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
avec effet au 1
er
octobre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131478/12.
(120173637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
FFH Financial Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 61.605.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of September
Before Maître Gérard LECUIT, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the Under-
signed, acting instead and place of Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, temporarily unavailable, who will hold the present deed.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of "FFH Financial Holding S.A." a company limited by shares
(société anonyme) established under the laws of Luxembourg having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, incorporated on 10 November 1997
following a deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 95 of 13 February 1998 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 61.605 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have last been
amended following a deed of 1 December 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
160 of 19 January 2012.
The meeting was declared open by Ms Sara Lecomte, private employee, with professional address in Luxembourg, in
the chair, who appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Flora Gibert, private employee, with
professional address in Luxembourg.
128362
L
U X E M B O U R G
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(I) That the agenda of the meeting was the following.
1 Waiver of the convening notices
2 Increase of the share capital of the Company by an amount of seventy-four million four hundred ninety-nine thousand
nine hundred ninety-nine point seventy-one dollars of the United States of America (USD 74,499,999.71) in order to
bring it from its present amount of two hundred six thousand six hundred fourteen point twenty-nine dollars of the
United States of America (USD 206,614.29) to an amount of seventy-four million seven hundred six thousand six hundred
fourteen dollars of the United States of America (USD 74,706,614.-) and issue of forty-nine million nine hundred thirty-
nine thousand six hundred seventy (49,939,670) new ordinary shares, without nominal value.
3 Subscription by the sole shareholder of the Company of the new ordinary shares for a total subscription price of
seventy-four million four hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine point seventy-one dollars of the United
States of America (USD 74,499,999.71).
4 Amendments to Article 3 of the articles of association of the Company to reflect the share capital increase.
(II) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list, this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed.
(III) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(IV) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(V) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(VI) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to waive the convening notices, all shareholders having full knowledge
of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of seventy-
four million four hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine point seventy-one dollars of the United States
of America (USD 74,499,999.71) in order to bring it from its present amount of two hundred six thousand six hundred
fourteen point twenty-nine dollars of the United States of America (USD 206,614.29) to an amount of seventy-four million
seven hundred six thousand six hundred fourteen dollars of the United States of America (USD 74,706,614.-) and further
resolved to issue forty-nine million nine hundred thirty-nine thousand six hundred seventy (49,939,670) new ordinary
shares, without nominal value.
Third resolution
Subscription and Payment
FFHL Group Ltd., a company existing under the laws of Canada, having its registered office at 95 Wellington Street
West, suite 800, Toronto, Ontario M5J2N7, Canada, registered under the corporation file number 344134-2 (the "Sub-
scriber"), represented by Ms Sara Lecomte, prenamed, by virtue of a proxy, declares
(i) to subscribe for the forty-nine million nine hundred thirty-nine thousand six hundred seventy (49,939,670) new
ordinary shares, without nominal value and
(ii) to fully pay them up by payment in cash of seventy-four million four hundred ninety-nine thousand nine hundred
ninety-nine point seventy-one dollars of the United States of America (USD 74,499,999.71), so that from now on the
Company has at its free and entire disposal the amount of seventy-four million four hundred ninety-nine thousand nine
hundred ninety-nine point seventy-one dollars of the United States of America (USD 74,499,999.71), as was certified to
the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting of shareholders accepts the subscription of the forty-nine million nine hundred thirty-
nine thousand six hundred seventy (49,939,670) new ordinary shares by the Subscriber.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph
of Article 3 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows.
" Art. 3. The Company's capital is set at seventy-four million seven hundred six thousand six hundred fourteen dollars
of the United States of America (USD 74,706,614.-), represented by fifty- million nine thousand six hundred seventy
128363
L
U X E M B O U R G
(50,009,670) ordinary shares (the "Ordinary Shares") thirty thousand (30,000) Class A mandatory redeemable preferred
shares ("Class A MRPS"), thirty-eight thousand five hundred (38,500) Class B mandatory redeemable preferred shares
(the "Class B MRPS"), the Class A MRPS and the Class B MRPS being individually and collectively referred to as the "MRPS"
and the Ordinary Shares and the MRPS being individually referred to as a share and collectively to as the shares."
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately seven thousand euros (EUR 7,000.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the appearing parties, the said proxy signed together with the notary
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-cinq septembre,
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, soussigné,
agissant en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêché,
qui restera dépositaire des présentes.
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FFH Financial Holding S.A., une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, constituée suivant acte de Maitre Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch en date du 10
novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 95 du 13 février 1998,
immaculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 61.605 (la «Société»). Les statuts
ont été modifies la dernière fois par un acte du 1 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numéro 160 du 19 janvier 2012.
L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire et l'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Flora
Gibert, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitue, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit
(I) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant
1 Renonciation aux formalités de convocation
2 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-
dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf virgule soixante-onze dollars des États-Unis d' Amérique (USD
74.499.999,71) afin de la porter de son montant actuel de deux cents six mille six cents quatorze virgule vingt-neuf dollars
des États-Unis d'Amérique (USD 206.614,29) à un montant de soixante-quatorze millions sept cent six mille six cent
quatorze dollars des États-Unis d'Amérique (USD 74.706.614,-) et émission de quarante-neuf millions neuf cent trente-
neuf mille six cent soixante-dix (49.939.670) nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale.
3 Souscription par le seul actionnaire de la Société des nouvelles actions ordinaires pour un prix de souscription total
de soixante-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf virgule soixante-
onze dollars des États-Unis d' Amérique (USD 74.499.999,71).
4 Modification de l'article 3 des statuts de la Société afin de rendre compte de l'augmentation de capital.
(II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte
(III) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau
et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte
(IV) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(V) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portes à l'ordre du jour
(VI) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes
128364
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de renoncer aux formalités de convocation, tous les actionnaires ayant
complète connaissance de l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante-
quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf virgule soixante-onze dollars des
États-Unis d' Amérique (USD 74.499.999,71) afin de la porter de son montant actuel de deux cent six mille six cent
quatorze virgule vingt-neuf dollars des États-Unis d'Amérique (USD 206.614,29) à un montant de soixante-quatorze
millions sept cent six mille six cent quatorze dollars des États-Unis d'Amérique (USD 74.706.614,-) et d'émettre quarante-
neuf millions neuf cent trente-neuf mille six cent soixante-dix (49.939.670) nouvelles actions ordinaires sans valeur
nominale.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription et Paiementi>
L'actionnaire unique, FFHL Group Ltd, une société de droit canadien, ayant son siège social à 95 Wellington Street
West, suite 800, Toronto, Ontario M5J2N7, Canada, inscrite sous le numéro 344134-2 (le «Souscripteur») représentée
par Madame Sara Lecomte, prénommée, en vertu d'une procuration, déclare
(i) souscrire les cinquante-six millions neuf cent soixante-dix-huit mille cent quarante-huit (56.978.148) nouvelles ac-
tions ordinaires sans valeur nominale et
(ii) les libérer intégralement en numéraire d'un montant total de soixante-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-
dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf virgule soixante-onze dollars des États-Unis d' Amérique (USD
74.499.999,71), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de soixante-quatorze
millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf virgule soixante-onze dollars des États-
Unis d' Amérique (USD 74.499.999,71) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
Ensuite a comparu l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter la souscription des quarante-neuf millions
neuf cent trente-neuf mille six cent soixante-dix (49.939.670) nouvelles actions ordinaires par le Souscripteur.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le premier
alinéa de l'Article 3 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante.
« Art. 3. Le capital social de la Société est fixé à soixante-quatorze millions sept cent six mille six cent quatorze dollars
des États-Unis d'Amérique (USD 74.706.614,-), représenté par cinquante millions neuf mille six cent soixante-dix
(50.009.670) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»), trente mille (30.000) actions préférentielles à rachat obliga-
toire de catégorie A («MRPS de Catégorie A»), trente-huit mille cinq cents (38.500) actions préférentielles à rachat
obligatoire de catégorie B («MRPS de Catégorie B»), les MRPS de Catégorie A et les MRPS de Catégorie B étant indivi-
duellement et collectivement définies comme des «MRPS» et les Actions Ordinaires et les MRPS étant individuellement
définies comme une action et collectivement les Actions.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimes à sept mille euros (EUR 7.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussignée présent acte
Signé: S. LECOMTE, F. GIBERT, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 28 septembre 2012. Relation: LAC/2012/45246. Reçu soixante quinze euros
(EUR 75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2012131962/180.
(120174010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
128365
L
U X E M B O U R G
Lux-Vitrerie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7355 Helmdange, 20, rue Fautelfiels.
R.C.S. Luxembourg B 119.689.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUX–VITRERIE S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012131481/11.
(120173819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Monier Investissement S.C.A., Société en Commandite par Actions (en liquidation).
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 136.625.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2012.
Référence de publication: 2012131491/10.
(120173641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Five Arrows Nautilus Co-Invest Feeder SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 171.852.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the third day of the month of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
(i) Five Arrows Co-Investments Feeder V SCA SICAR, a company qualifying as a société d'investissement en capital à
risque pursuant to the Luxembourg law of 15 June 2004 on investment companies in risk capital, as amended, having its
registered office at 3 rue Goethe, L-1637 Luxembourg, incorporated under the form of a société en commandite par
actions by a deed of Maître Patrick Serres, notary residing in Remich on 9 April 2010 and registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 152399, acting through its general partner Five Arrows
Managers, appearing and named under (ii) below, and
(ii) Five Arrows Managers, a société anonyme, having its registered office at 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, initially
incorporated under the form of a société à responsabilité limitée by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in
Junglinster on 12 December 2008 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under
number B 143757;
each represented by Cheikh Ndiaye, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to proxies both dated 27 September
2012. The proxies given, shall remain annexed to this document to be filed with it with the registration authorities which
shall be registered together with the present deed.
Such appearing parties, in their respective capacities, have requested the notary to state as follows the Articles of
Incorporation of a société en commandite par actions "FIVE ARROWS NAUTILUS CO-INVEST FEEDER SCA" which
they form between themselves:
Art. 1. Denomination. There exists between all persons that are shareholders on this day and all those who will become
owners of the Shares mentioned hereafter a Luxembourg société en commandite par actions under the name of "FIVE
ARROWS NAUTILUS CO-INVEST FEEDER SCA" (the "Company") governed by the laws of Luxembourg and these
articles of incorporation (the "Articles" or the "Articles of Incorporation").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the Manager. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution
of the Manager.
In the event that the Manager determines that extraordinary political, economical, and/or military events have occurred
or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
128366
L
U X E M B O U R G
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an indefinite period of time. The Company may be dissolved at any
time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.
The Company shall not be dissolved in case the Manager resigns, is liquidated, is declared bankrupt or is unable to
continue its business. In such circumstances Article 17 shall apply.
Art. 4. Object. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and
any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments
of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise
and may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out
its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private or public placement to the issue of bonds, notes and
debentures or any kind of debt or any other type of securities.
The Company may lend funds in any form including without limitation resulting from any borrowings of the Company
or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company,
entity or person as it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities for its own obligations and undertakings as well as for the
obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part of the group
of companies to which the Company belongs or any other company, entity or person as it deems fit.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies, enterprises or persons in which the Company
has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company,
entity or person as it deems fit, take any controlling, supervisory or other measures and carry out any operation which
it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 5. Share Capital.
5.1. The issued share capital of the Company shall be represented by two categories of shares (each, a Category),
namely management share(s) held by the Manager as unlimited liability shareholder (actionnaire commandité) ("Manage-
ment Shares") and ordinary shares held by the limited liability shareholders (actionnaires commanditaires) ("Ordinary
Shares") of the Company. Ordinary Shares and Management Shares shall be referred to as a "Share" and collectively as
the "Shares", whenever the reference to a specific category or class of shares is not justified or required.
5.2. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000) represented by (one) (1) fully
paid Management Share and thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) fully paid Ordinary Shares with nominal
value of one Euro (€1) each.
5.3. The Management Share shall be held by Five Arrows Managers, a société anonyme, initially incorporated under
the form of a société à responsabilité limitée by a deed of Maître Jean Seckler on 12 December 2008 with registered
office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as unlimited liability shareholder (actionnaire commandité) and as
Manager of the Company.
5.4. The issued share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the
General Meeting of Shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of
Incorporation or, as the case may be, by law for any amendment of these Articles of Incorporation.
5.5. The Company may not issue fractional Shares. The Manager shall be authorised at its discretion to provide for
the payment of cash in lieu of any fraction of a Share.
5.6. The Company or its subsidiaries may proceed to the purchase or repurchase of its own Shares and may hold
Shares in treasury, each time within the limits laid down by law.
5.7. Any Share premium shall be freely distributable in accordance with the provision of these Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Shares of the Company are in registered form only.
6.2. A register of Shares will be kept at the registered office of the Company. Ownership of registered Shares will be
established by inscription in the said register.
6.3. The Shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognise only one holder per Share. In case a Share
is held by more than one person, the persons claiming ownership of the Share will be required to name a single proxy
to represent the Share vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
128367
L
U X E M B O U R G
to such Share until one person has been so appointed. The same rule shall apply in the case of a conflict between an
usufructuary and a bare owner or between a pledgor and a pledgee.
6.4. The Company may consider the person in whose name the registered Shares are registered in the register of
Shareholders as the full owner of such registered Shares. The Company shall be completely free from any responsibility
in dealing with such registered Shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claims
of such third parties in or upon such registered shares to be nonexistent, subject, however, to any right which such third
party might have to demand the registration or change in registration of registered Shares. In the event that a holder of
registered shares does not provide an address to which all notices or announcements from the Company may be sent,
the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register(s) of Shareholders and such holder's
address will be deemed to be at the registered office of the Company or such other address as may be so entered by the
Company from time to time, until a different address shall be provided to the Company by such holder. The holder may,
at any time, change his address as entered in the register(s) of Shareholders by means of written notification to the
Company.
6.5. All communications and notices to be given to a registered Shareholder shall be deemed validly made to the latest
address communicated by the Shareholder to the Company.
6.6. Upon the written request of a Shareholder, registered nominative Share certificate(s) recording the entry of such
Shareholder in the register of Shareholders may be issued in such denominations as the Manager shall prescribe. The
certificates so issued shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be
determined by the Manager. Such certificates shall be signed manually or by facsimile by two authorized representatives
of the Manager. Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings
and indemnities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated Share certificates shall be deli-
vered before new certificates are remitted.
Art. 7. Transfer of Shares.
7.1. A transfer of Ordinary Shares made in accordance with the provisions of the present Articles shall be carried out
by means of a declaration of transfer entered in the relevant register, dated and signed by the transferor and the transferee
or by their duly authorised representatives. The Company may accept and enter in the relevant register a transfer on
the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee
satisfactory to the Company.
7.2. The Management Share held by the Manager is exclusively transferable to a successor or additional manager with
unlimited liability for the Company's financial obligations.
Art. 8. Voting Right. Subject as set forth in these Articles, each Share shall be entitled to one vote at all general meetings
of shareholders.
Art. 9. Management.
9.1. The Company shall be managed by one manager who shall be the unlimited liability shareholder (commandité)
(the "Manager"). Five Arrows Managers, prenamed, is appointed as the Manager of the Company.
9.2. The Manager may not be removed without its approval expect in the case of legal incapacity, liquidation or other
permanent situation preventing the Manager from acting as Manager of the Company, in which case the Manager may be
removed by a decision of the General Meeting of Shareholders holding the Ordinary Shares adopted under the conditions
required to amend the Articles of Incorporation of the Company.
9.3. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as
Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board
appoints an administrator, who needs not be a shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general
meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At
such general meeting, the Shareholders holding Ordinary Shares may appoint, in accordance with the quorum and majority
requirements for amendment of the Articles of Incorporation, a successor Manager. Any such appointment of a successor
manager shall not be subject to the approval of the Manager.
Art. 10. Management Powers.
10.1. The Manager is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/
or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers
not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the General Meeting of Shareholders or to the
Supervisory Board are within the powers of the Manager.
10.2. The Manager shall have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and all of the
purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that
it may deem necessary, advisable or useful or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the Manager
has, and shall have full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and
powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.
128368
L
U X E M B O U R G
10.3. The Manager may, from time to time, appoint officers or agents of the Company considered necessary for the
operation and management of the Company. The officers and/or agents appointed shall have the powers and duties given
to them by the Manager.
Art. 11. Binding Signatures. The Company will be bound towards third parties by the signature of the Manager, acting
through one or more of its duly authorised signatories as designated by the Manager at its sole discretion, or such person
(s) to which such power has been delegated by the Manager. Any litigation involving the Company either as plaintiff or
as defendant will be handled in the name of the Company by the above mentioned Manager.
Art. 12. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or
entity shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one more of shareholder, managers or officers
of the Manager is interested in, or is a shareholder, director, officer or employee of such other company or entity with
which the Company shall contract or otherwise engage in business. The Manager or such officers shall not by reasons of
such affiliation with such other company or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters
with respect to such contract or other business.
Art. 13. Supervisory Board.
13.1. The Company is supervised by a board of a minimum of three supervisors (the "Supervisory Board") appointed
by the General Meeting of Shareholders which fixes their remuneration as well as the term of their office.
13.2. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and
shall authorise any actions of the Manager that may, pursuant to applicable law, exceed the powers of the Manager.
13.3. The members of the Supervisory Board may be re-elected.
13.4. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.
13.5. The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. Written notice of any meeting of
the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight (8) days prior to the date set
for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the
notice of meeting. Notice may be waived by consent in writing, by electronic message or by telefax or any other means
of transmission capable of evidencing such waiver. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places fixed in a resolution adopted by the Supervisory Board. Any member may act at any meeting by appointing in
writing or by telefax or any other means of transmission capable of evidencing such waiver another member as his proxy.
A member may represent several of his colleagues.
13.6. The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or
represented. Resolutions are taken by a simple majority vote of the members present or represented. Resolutions of the
Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the Supervisory Board, the chairman of the
meeting, any two members or as may be resolved at the relevant meeting or any subsequent meeting. Copies or extracts
may be signed by the chairman of the Supervisory Board, the chairman of the meeting, any two members or as may be
resolved at the relevant meeting or any subsequent meeting.
13.7. Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same
effect as resolutions passed at a meeting of the Supervisory Board, each member shall approve such resolution in writing,
by telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing
and all documents shall form the record that proves that such resolution has been taken.
13.8. Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
A meeting may also be held by way of conference call or similar means only. The participation in a meeting or the holding
of a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 14. General Meetings.
14.1. The General Meeting of Shareholders represents all the Shareholders of the Company. It shall have the powers
to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise expressly
provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager.
14.2. General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice given by a Manager setting forth the
agenda and sent, unless otherwise provided for by law, by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to
each Shareholder at the shareholder's address recorded in the register of registered shares.
14.3. The annual general meeting shall be held on the third day of the month of December at 11.00 a.m. (CET) at the
registered office or at a place in Luxembourg specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
14.4. Other Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective
convening notice of meeting.
14.5. If the entire issued Share capital is represented at a General Meeting of Shareholders, the General Meeting may
be validly held without any convening notice.
128369
L
U X E M B O U R G
14.6. Resolutions at a General Meeting of Shareholders will, unless otherwise provided for by law or in these Articles
of Incorporation, be passed at simple majority of the votes validly cast. Resolutions on the amendment of the Articles of
Incorporation or on issues for which these Articles of Incorporation or applicable refers to the conditions required for
an amendment of the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one half of the issued share capital. If the
quorum requirement is not met at the first general meeting of Shareholders, a second meeting may be convened in
accordance with applicable law. The second Meeting shall validly deliberate regardless of quorum. At both meetings,
decisions must be passed by at least two thirds of the votes validly cast.
14.7. Any General Meeting of Shareholders may only be validly constituted if the Management Share is duly represented
and no decision may be taken at any General Meeting of Shareholders if not approved by the vote attaching to the
Management Share, unless expressly otherwise provided in these Articles of Incorporation.
Art. 15. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the first of November of each year and
shall terminate on the thirty-first of October of the next year save for the first accounting year which shall commence
on the day of incorporation and end on 31 October 2012.
Art. 16. Allocation of Profits, Distributions.
16.1. Out of the net profits of each year, an amount equal to five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve
account. This allocation ceases to be compulsory when such reserve is equal to ten percent (10%) of the issued share
capital of the Company.
16.2. The balance shall be allocated as determined by decision of the General Meeting of Shareholders.
16.3. Interim dividends may be declared and paid by the Manager in accordance with applicable law.
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or whatever time, the liquidation will be
performed by liquidators or by the Manager then in office who will be endowed with the powers provided by Articles
144 et seq. of the Law of 1915.
17.2. Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the Ordinary
Shareholders.
Art. 18. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Incorporation are to be determined in accordance
with the law of 10th August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31
st
October
2012.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2012.
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties
subscribed and entirely paid up the thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (€ 1) each as
follows.
Evidence of the payment in cash of the subscription price of thirty-one thousand Euro (€ 31,000) has been given to
the undersigned notary.
The capital has been subscribed as follows:
Name of Ordinary Subscriber (Commanditaire)
Number of subscribed Ordinary Shares
Five Arrows Co-Investments Feeder V SCA SICAR . . . . . . . . . .
30,899
Five Arrows Managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Name of Management Share Subscriber (Commandité)
Number of subscribed Management Shares
Five Arrows Managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,999 Ordinary Shares and 1 Management Share
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the
Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the extraordinary general meeting of the shareholders has re-
solved that:
128370
L
U X E M B O U R G
(A) The following persons have been appointed as members of the Supervisory Board for a period of six years as of
the day stated at the beginning of this document:
(i) Mireille Klitting, employee, born on 23 October 1959 in Bron, France, with professional address at 23 bis avenue
Messine, F-75008 Paris;
(ii) Antoine Bougnoux, employee, born on 23 July 1976 in Paris, France, with professional address at 23 bis avenue
Messine, F-75008 Paris; and
(iii) Audrey Coppede, employee, born on 4 May 1980 in Thionville, France, with professional address at 3, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg.
(B) The registered office of the Company is fixed at 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le troisième jour du mois d' octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
(i) Five Arrows Co-Investments Feeder V SCA SICAR, une société qualifiée
de société d'investissement en capital à risque en vertu de la loi luxembourgeoise du 15 juin 2004 relatives aux sociétés
d'investissement en capital à risque, telle qu'elle a été modifiée, ayant son siège social au 3 rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg, constituée sous la forme d'une société en commandite par actions suivant acte de Maître Patrick Serres, notaire
de résidence à Remich en date du 9 avril 2010 et en immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 152399, par l'intermédiaire de son associé gérant commandité Five Arrows Managers,
comparant et nommée sous (ii) ci-dessous, et
(ii) Five Arrows Managers, une société anonyme, ayant son siège social au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, initia-
lement constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de
résidence à Junglinster en date du 12 décembre 2008 et en immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 143757; chacune représentée par Cheikh Ndiaye, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de procurations toutes deux datées du 27 septembre 2012. Les procurations prémentionnées resteront anne-
xées à ce document pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement et devront être enregistrées avec le
présent acte.
Les parties comparantes, agissant ès-qualités, ont requis le notaire de dresser les Statuts d'une société en commandite
par actions sous la dénomination de «FIVE ARROWS NAUTILUS CO-INVEST FEEDER SCA» qu'elles déclarent consti-
tuer entre elles:
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe entre toutes les personnes qui sont actionnaires en ce jour et tous ceux qui
deviendront propriétaires des Actions ci-après mentionnées une société en commandite par actions de droit luxem-
bourgeois sous la dénomination de «FIVE ARROWS NAUTILUS CO-INVEST FEEDER SCA» (la "Société") régie par les
lois du Luxembourg et les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Sur décision du Gérant, des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis tant au Grand-Duché de Lu-
xembourg qu'à l'étranger. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même municipalité par simple décision du
Gérant.
Dans l'hypothèse où le Gérant estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique et/ou
militaire, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication avec ce siège
ou de ce siège avec des personnes situées à l'étranger, se présentent ou sont imminents, il pourra transférer provisoi-
rement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires
n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société
luxembourgeoise.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société peut à tout moment être dissoute
par une résolution des actionnaires statuant de la manière requise en matière de modification des présents Statuts.
La Société ne sera pas dissoute du fait de la démission du Gérant, de sa liquidation, de sa mise en faillite ou de son
incapacité à poursuivre ses affaires. Dans de telles circonstances, l'Article 17 s'appliquera.
128371
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la prise de participations et de tous
intérêts, de quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou toute autres entité com-
merciale, entreprise ou investissement, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière de même que
le transfert par la vente, échange ou autrement d'actions, obligations, certificats de créances, notes, certificats de dépôt
et toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers de toute espèce, et la détention, l'administration, le déve-
loppement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de toute manière et dans tout type d'avoirs. La Société peut également détenir des intérêts dans des
sociétés de personnes et exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement public ou privé à l'émission d'obliga-
tions, de notes et de certificats de créances ou de toute sorte d'instruments représentatifs de dettes ou tout autre type
de valeurs mobilières.
La Société peut prêter des fonds sous toute forme, y compris sans limitation, ceux résultant de tout emprunt de la
Société ou de l'émission de tout titre représentatif de capital ou de dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées
ou toute autre société, entité ou personne qu'elle juge appropriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés pour ses propres obligations et engagements de même
que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du
groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société, entité ou personne qu'elle juge appropriée.
D'une manière générale, elle peut prêter assistante de quelque manière que ce soit à toutes sociétés, entreprises ou
personnes dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou
toute autre société, entité ou personne qu'elle juge appropriée, prendre toutes mesures de contrôle, de supervision ou
toutes autres mesures et effectuer toute opération qu'elle juge utile à l'accomplissement et au développement de son
objet.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social émis de la Société sera représenté par deux classes d'actions (chacune, une «Classe»), à savoir
des actions de commandité détenues par le Gérant en sa qualité d'actionnaire commandité («Actions de Commandité»)
et des actions ordinaires de commanditaire détenues par les actionnaires commanditaires («Actions de Commanditaire»)
de la Société. Les Actions de Commanditaire et les Actions de Commandité sont désignées en tant qu'«Action» et
collectivement en tant qu' «Actions» chaque fois que la référence à une catégorie ou classe particulière n'est pas justifiée
ni requise.
5.2. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille Euros (€ 31 000) représenté par une (1) Action de
Commandité entièrement libérée et trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30 999) Actions de Commanditaire
entièrement libérées avec une valeur nominale de un Euro (€ 1) chacune.
5.3. L'Action de Commandité est détenue par Five Arrows Managers, une société anonyme, initialement constituée
sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster
en date du 12 décembre 2008, ayant son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité d'actionnaire
commandité et en qualité de Gérant de la Société.
5.4. Le capital social émis de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois sur décision de l'Assemblée
Générale des Actionnaires adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité fixées par les Statuts ou, le cas
échéant, par la loi en ce qui concerne la modification des présents Statuts.
5.5. La Société ne peut pas émettre de fractions d'Actions. Le Gérant est autorisé, à sa discrétion, à prévoir le paiement
en numéraire en remplacement d'une fraction d'Action.
5.6. La Société ou ses filiales peuvent procéder à l'acquisition ou au rachat de leurs propres Actions et peuvent détenir
des Actions en trésorerie, à chaque fois dans les limites prévues par la loi.
5.7. Toute prime d'Emission est librement distribuable conformément aux dispositions des présents Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1. Les Actions de la Société sont uniquement sous forme nominative.
6.2. Un registre des Actionnaires sera tenu au siège social de la Société. La détention d'Actions nominatives sera établie
par une inscription dans ledit registre.
6.3. Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul détenteur par Action. En cas de
co-détention d'Actions, les personnes qui prétendent un droit sur cette Actions devront nommer une seule personne
pour représenter l'Action à l'égard de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés
à cette Action jusqu'à ce qu'un seul représentant ait été nommé. La même règle s'applique en cas de conflit entre un
usufruitier et un nu-propriétaire et un créancier et créancier-gagiste.
6.4. La Société peut considérer la personne au nom de laquelle les Actions nominatives sont inscrites dans le registre
des Actionnaires comme étant le seul propriétaire desdites Actions nominatives. Vis-à-vis des tiers, la Société sera libérée
128372
L
U X E M B O U R G
de toute responsabilité en traitant lesdites Actions nominatives, et pourra considérer tout droit, intérêt ou prétention
d'un tiers sur les Actions ou les concernant comme non-existant, sous condition, toutefois, des droits d'un tiers à de-
mander l'inscription dans le registre des Actions nominatives d'un changement ou d'une inscription. Dans le cas où un
détenteur d'Actions nominatives ne fournit pas une adresse à laquelle pourront être envoyées toutes les notifications ou
annonces de la Société, la Société pourra porter une inscription à cet effet dans le(s) registre(s) des Actionnaires et
l'adresse de ce détenteur sera censée être le siège social de la Société ou toute autre adresse fournie par ce détenteur
à la Société. Le détenteur peut, à tout moment, changer son adresse telle qu'indiquée dans le(s) registre(s) des Action-
naires au moyen d'une notification écrite à la Société.
6.5. Toutes les communications et notifications devant être envoyées à un Actionnaire nominatif seront censées être
valablement effectuées à la dernière adresse communiquée par l'Actionnaire à la Société.
6.6. Sur demande écrite d'un Actionnaire, un(des) certificat(s) d'Actions nominatives attestant l'inscription de cet
Actionnaire dans le registre des Actionnaires pourra/pourront être émis dans les dénominations que le Gérant prescrira.
Les certificats ainsi émis auront la forme et porteront les légendes et numéros d'identifications que le Gérant déterminera.
Ces certificats seront signés manuellement ou par télécopie par deux représentants autorisés du Gérant. Les certificats,
perdus, volés ou endommagés seront remplacés par la Société sur présentation d'une preuve, engagement ou indemnité
jugés satisfaisants pour le Gérant, et les certificats d'Actions endommagés devront être remis avant que de nouveaux
certificats ne soient émis.
Art. 7. Transfert d'Actions.
7.1. Un transfert d'Actions de Commanditaire effectué conformément aux dispositions des présents Statuts sera ef-
fectué au moyen d'une déclaration de transfert inscrite dans le registre concerné, daté et signé par le cédant et le
cessionnaire ou par leurs représentants dûment autorisés. La Société peut accepter et inscrire dans le registre concerné
un transfert sur la base d'une correspondance ou autres documents faisant foi de l'accord intervenu entre le cédant et
le cessionnaire jugés satisfaisants pour la Société.
7.2. L'Action de Commandité détenue par le Gérant est exclusivement transférable à un successeur ou un gérant
supplémentaire ayant une responsabilité illimitée en ce qui concerne les obligations de la Société.
Art. 8. Droits de vote. Sous réserve des présents Statuts, chaque Action donne droit à une voix à toutes les assemblées
générale des actionnaires.
Art. 9. Gérance.
9.1. La Société sera gérée par un gérant qui sera l'actionnaire commandité (le «Gérant»). Five Arrows Managers,
prénommée, est nommée Gérant de la Société.
9.2. Le Gérant ne peut pas être révoqué sans son approbation sauf dans le cas d'incapacité légale, liquidation ou autre
situation permanente empêchant le Gérant d'agir en sa capacité de Gérant de la Société, auquel cas le Gérant peut être
révoqué sur décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires détenant les Actionnaires de Commanditaire adoptée
de la manière requise pour la modification des présents Statuts.
9.3. En cas d'incapacité légale, de liquidation ou de toute autre situation permanente empêchant le Gérant d'agir en
tant que Gérant de la Société, la Société ne sera pas immédiatement dissoute ou liquidée, à condition que le Conseil de
Surveillance nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être un actionnaire, pour effectuer les actes d'urgence ou
purement administratifs jusqu'à ce qu'une assemblée des actionnaires soit tenue, laquelle devra être convoquée par
l'administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale. Les Actionnaires détenant
des Actions Commanditaires pourront nommer, conformément aux règles de quorum et de majorité requises en cas de
modification des Statuts, un nouveau Gérant. La nomination de ce nouveau gérant ne sera pas soumise à l'approbation
du Gérant.
Art. 10. Pouvoirs de Gestion.
10.1. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser t/ou
accomplir tous les actes d'administration, de disposition, et de gestion en conformité avec l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale des
Actionnaires ou au Conseil de Surveillance appartiennent au Gérant.
10.2. Le Gérant aura le pouvoir, pour le compte et au nom de la Société, de réaliser tous les objectifs de la Société et
d'effectuer tous les actes et de conclure et de délivrer tous les contrats et tous autres engagements qui lui semblent
nécessaires, avisés, utiles ou accessoires à de ce dernier. A moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement, le
Gérant a et aura pleine autorité à sa discrétion pour exercer pour le compte et au nom de la Société tous droits et
pouvoirs nécessaires ou utiles en vue de réaliser les objectifs de la Société.
10.3. Le Gérant peut de temps à autre, s'il le juge nécessaire pour les opérations et la gestion de la Société, nommer
des fondés de pouvoir ou agents de la Société. Les fondés de pouvoir et/ou les agents désignés auront les pouvoirs et
obligations qui leur seront attribués par le Gérant.
128373
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Signatures ayant force obligatoire. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature du Gérant, agissant
par une ou plusieurs personnes habilitées à signer et désignées par le Gérant de manière discrétionnaire, ou telle(s)
personne(s) à qui ce pouvoir a été délégué par le Gérant.
Tout contentieux dans laquelle la Société serait plaignante ou défenderesse sera réglé au nom de la Société par le
Gérant mentionné ci-dessus.
Art. 12. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ni aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés
ou entités ne pourront être affectés ou invalidés par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs actionnaires, directeurs ou
fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans une telle autre société ou entités, ou par le fait qu'il
serait associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou firme avec laquelle la Société contracte
ou est autrement en relation d'affaires. Le Gérant ou ses fondés de pouvoir ne sera pas, par là même, privé du droit de
délibérer, de voter et d'agir s'agissant des matières en relation avec ce contrat ou autres affaires.
Art. 13. Conseil de Surveillance.
13.1 La Société est surveillée par un conseil composé de trois membres au moins (le «Conseil de Surveillance») désignés
par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui fixe leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.
13.2. Le Conseil de Surveillance sera consulté par le Gérant sur toutes les affaires que le Gérant pourra déterminer
et autorisera toutes les actions du Gérant qui pourraient, selon la loi, excéder les pouvoirs du Gérant.
13.3. Les membres du Conseil de Surveillance sont rééligibles.
13.4. Le Conseil de Surveillance peut choisir un président parmi ses membres.
13.5. Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant. Un avis de convocation à toute
réunion du Conseil de Surveillance sera envoyé à tous les membres du Conseil de Surveillance huit (8) jours au moins
avant la date prévue pour cette réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
exposés dans l'avis de convocation à la réunion. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par
écrit, par message électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication permettant d'attester de
l'authenticité d'une telle renonciation. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des assemblées se tenant aux
heures et endroits déterminés dans une résolution adoptée par le Conseil de Surveillance. Tout membre pourra agir lors
de toute réunion du Conseil de Surveillance en désignant par écrit ou par télécopie ou par tout autre moyen de com-
munication attestant de l'authenticité d'une telle renonciation un autre membre comme son représentant. Un membre
peut représenter plusieurs de ses collègues.
13.6. Le Conseil de Surveillance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres
sont présents ou représentés.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. Les résolutions du
Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président du Conseil de Surveillance, le
président de la réunion ou deux membres ou tel que décidé à la réunion concernée ou toute réunion subséquente. Des
copies ou extraits peuvent être signés par le président du Conseil de Surveillance, le président de la réunion, par deux
membres ou tel que décidé à la réunion concernée ou toute réunion subséquente.
13.7. Les résolutions approuvées et signées par voie écrite par tous les membres du Conseil de Surveillance prendront
effet au même titre que les résolutions passées lors d'une réunion du Conseil de Surveillance; chaque membre doit
approuver une telle résolution par écrit, télégramme, télétex, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. Une telle approbation doit être confirmée par écrit et tous les documents constitueront le procès-verbal faisant foi
de la résolution intervenue.
13.8. Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence
téléphonique ou par tous autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à
cette réunion de communiquer entre elles. Une réunion peut également être tenue par voie de conférence téléphonique
uniquement ou tout autre moyen de communication similaire. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à
une présence en personne à une telle réunion.
Art. 14. Assemblées générales.
14.1 L'Assemblée Générale des Actionnaires représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs d'or-
donner, d'exécuter ou de ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf disposition contraire
dans les présents Statuts, aucune résolution ne pourra être valablement prise à moins d'avoir été approuvée par le Gérant.
14.2 Les Assemblées Générales des Actionnaires sont convoquées au moyen d'un avis du Gérant indiquant l'ordre du
jour et envoyé, sauf disposition contraire de la loi, par lettre recommandée huit (8) jours au moins avant la date de
l'assemblée à chaque Actionnaire à l'adresse inscrite dans le registre des actions nominatives.
14.3. L'assemblée générale annuelle se tiendra le troisième jour du mois de décembre à onze heures (CET) au siège
social ou à tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg,
l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
14.4. Les autres Assemblées des Actionnaires se tiendront aux lieux et heures indiqués dans les avis de convocation
respectifs des assemblées.
128374
L
U X E M B O U R G
14.5. Si l'entièreté du capital social émis est représentée à une Assemblée Générale des Actionnaires, l'Assemblée
Générale peut valablement être tenue sans convocation préalable.
14.6. Lors d'une Assemblée Générale, les résolutions sont prises, sauf indication contraire de la loi ou dans les présents
Statuts, à la majorité simple des votes valablement exprimés. Les résolutions concernant une modification des Statuts ou
les matières pour lesquelles les présents Statuts ou lois applicables renvoient aux conditions requises pour une modifi-
cation des statuts, le quorum sera d'au moins la moitié du capital social émis. Si le quorum n'est pas réuni lors de la
première assemblée générale des Actionnaires, une seconde assemblée sera convoquée conformément à la loi applicable.
La seconde assemblée pourra valablement délibérer sans condition de quorum. Lors des deux assemblées, les décisions
doivent être adoptées aux deux-tiers des votes valablement exprimés au moins.
14.7. Toute Assemblée Générale des Actionnaires n'est valablement constituée que si l'Action de Commandité est
valablement représentée et aucune décision ne peut, sauf disposition contraire expresse dans les présents Statuts, être
prise lors d'une Assemblée Générale des Actionnaires si elle n'est pas approuvée par la voix attachée à l'Action de
Commandité.
Art. 15. Exercice comptable. L'exercice comptable de la Société débutera le premier jour du mois de novembre de
chaque année et prendra fin le trentième et unième jour du mois d'octobre de l'année suivante excepté pour le premier
exercice comptable lequel commence le jour de la constitution et prend fin le 31 octobre 2012.
Art. 16. Affectation des Bénéfices, Distribution.
16.1. Il sera prélevé sur les bénéfices nets annuels de la Société un montant égal à cinq pour cent (5%) qui sera affecté
à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve sera égale à dix pour cent
(10%) du capital émis de la Société.
16.2. Le solde pourra être alloué tel que déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
16.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et payés par le Gérant conformément à la loi applicable.
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation
sera effectuée par les soins de liquidateurs ou du Gérant alors en fonction qui auront les pouvoirs conférés par les Articles
144 et suivants de la Loi de 1915.
17.2. Une fois toutes les dettes, charges et dépenses de liquidation réglées, tout solde en résultant sera payé aux
Actionnaires Commanditaires.
Art. 18. Droit applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront déterminées
conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice de la société commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 octobre
2012.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2012.
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, les parties comparantes ont souscrit et
entièrement libéré les trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de un Euro (€ 1) chacune comme suit.
Preuve du paiement en numéraire du prix de souscription de trente-et-un mille Euro (€ 31.000) a été donnée au
notaire soussigné.
Le capital a été souscrit comme suit:
Nom des Souscripteurs Ordinaires (Commanditaire)
Nombre d'Actions Ordinaires souscrites
Five Arrows Co-Investments Feeder V SCA . . . . . . . . . . . . . .
30.899
Five Arrows Managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Nom du Souscripteur de l'Action Commandité
Nombre d'Actions Commandités souscrites
Five Arrows Managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.999 Actions Ordinaires et 1 Action Commandité
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société
suite à sa constitution sont estimés à environ EUR 1,200,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé que:
128375
L
U X E M B O U R G
(A) Les personnes suivantes ont été nommées membres du Conseil de Surveillance pour une durée de six ans à partir
du jour mentionné au début de ce document:
(i) Mireille Klitting, employée, né le 23 octobre 1959 à Bron, France, avec une adresse professionnelle au 23 bis avenue
Messine, F-75008 Paris;
(ii) Antoine Bougnoux, employé, né le 23 juillet 1976 à Paris, France, avec une adresse professionnelle au 23 bis avenue
Messine, F-75008 Paris; et
(iii) Audrey Coppede, employée, né le 4 mai 1980 à Thionville, France, avec une adresse professionnelle au 3, rue
Goethe, L-1637 Luxembourg.
(B) Le siège social de la Société est fixé au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une traduction en français. En cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite aux comparants, connu du notaire de son nom, prénom usuel, état civil et demeure, comparants
à signer avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. NDIAYE - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civil, le 5 octobre 2012. Relation: LAC/2012/46730. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le neuf octobre de l'an deux mille douze.
Référence de publication: 2012131970/558.
(120173797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Mountain Aviation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 116.707.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration de la société en date du 9 octobre 2012 que:
Le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012;
Monsieur Alberto Morandini est désormais domicilié professionnellement au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg avec effet au 1
er
octobre 2012 et est nommé président du conseil d’administration avec effet immédiat et ce pour
une durée de six ans;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131496/15.
(120173636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Maxalice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 128.954.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131503/10.
(120173700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
128376
L
U X E M B O U R G
Immoconsulting Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 26-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 171.872.
STATUTS
L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE QUATRE OCTOBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Andrea MURGIA, de nationalité italienne, demeurant à 18, rue Raoul Follereau, L-8027 Strassen.
Lequel comparant a déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et
par les présents statuts:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre
les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, la promotion immobilière ainsi que l'achat, la
vente, la mise en valeur, l'échange, la promotion, la négociation, l'expertise, la location d'immeubles et de tous droits
immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de bien meubles et immeubles, la gérance, respectivement la
gestion d'immeubles ou patrimoine mobiliers et immobilières.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de «Immoconsulting Lux S.à r.l.»
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres
localités du pays et à l'étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par six mille
deux cent cinquante (6.250) parts sociales d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) chacune.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 8. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou
par les associés.
En cas de pluralité de gérants, la société est, vis-à-vis des tiers, valablement engagée par les signatures conjointes de
deux gérants.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
128377
L
U X E M B O U R G
Art. 12. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. L'associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et
du bilan.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, savoir M. Andrea Murgia, précité, lequel les a
intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément, au moyen d'un certificat bancaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.000.-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
1. La société est gérée par un gérant.
2. Est nommée gérant unique de la société:
M. Andrea MURGIA, prénommé, né le 20 septembre 1988 à Luxembourg et demeurant à 18, rue Raoul Follereau,
L-8027 Strassen.
Le gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous sa seule
signature.
3. La société a son siège social à 26-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg et son siège administratif au 18, rue Raoul
Follereau, L-8027 Strassen.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant
par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: A. MURGIA, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 8 octobre 2012. Relation: RED/2012/1316. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 10 octobre 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012132012/98.
(120174076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
128378
L
U X E M B O U R G
MEIF 3 Luxembourg B Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 142.750.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2012.
Référence de publication: 2012131508/11.
(120173643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
MGM 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 117.549.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131514/11.
(120173621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Clearness Investment Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 171.857.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of August.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Clearness Investment S.à r.l., a Luxembourg company, having its registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to be registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Me Vincent LINARI-PIERRON, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a “société en
commandite par actions” which such party declares to incorporate.
Title I - Form and Name - Registered office - Duration - Corporate Object
Art. 1. Form and Name. There exists among the general manager and unlimited shareholder, “actionnaire gérant
commandité” (the “General Manager”) and the limited shareholders, “actionnaires commanditaires” (the “Limited Sha-
reholders” and together with the General Manager the “Shareholders”), a “société en commandite par actions” organized
as a “société d'investissement à capital variable” qualifying as a “fonds d'investissement spécialisé” under the name of
Clearness Investment Fund S.C.A., SICAV-SIF (hereafter the “Company”), governed by the Luxembourg law of 10 August
1915 relating to commercial companies, as amended (the “1915 Law”), the Luxembourg law of 13 February 2007 relating
to specialized investment Companies, as amended (the “2007 Law”) and the present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the General Manager. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the General Manager. Where the General Manager determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
128379
L
U X E M B O U R G
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several of the Shareholders.
The Company shall not come to an end in the event of the resignation, removal, dissolution or bankruptcy or insolvency
of the General Manager.
Art. 4. Corporate object. The purpose of the Company is to invest the funds available to it in any kind of assets eligible
under the 2007 Law with the aim of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the mana-
gement of such assets.
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted under the 2007 Law.
Title II - Share Capital - Shares - Compartments
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any
time be equal to the total net assets of the Company and its Compartments (as defined below), if any. The initial share
capital of the Company upon incorporation amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided into 100 (one
hundred) management shares (the “Management Shares”) and 3,000 (three thousand) ordinary shares (the “Ordinary
Shares”) (the Management Shares, the Ordinary Shares and any other Class of shares created and issued in accordance
with these Articles are hereinafter collectively referred to as the “Shares”) fully paid-up and of no par value.
The Management Shares are exclusively reserved to the General Manager. The Shares are offered to well-informed
investors within the meaning of article 2 of the 2007 Law (each a “Well-Informed Investor”).
The minimum capital of the Company shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000), which
must be reached within twelve months after the date on which the Company has been authorized in accordance with
the 2007 Law.
Art. 6. Compartments. The Company is composed of one or more compartments (collectively the “Compartments”
and individually a “Compartment”), in accordance with article 71 of the 2007 Law, each of them constituting a distinct
pool of assets, managed in the exclusive benefit of the Limited Shareholders of the relevant Compartment. The name of
each Compartment shall comprise the first part of the name of the Company, followed by the denomination determined
at the discretion of the General Manager.
The General Manager may, at any time, establish additional Compartment(s) and determine the name and specific
features thereof (including, but not limited to investment objectives, policy, strategy and/or restrictions, specific fee
structure, reference currency) as further set out in the private placement memorandum of the Company, as amended
and updated from time to time (the “PPM”) and which shall be fully described in the relevant annex of the PPM (the
“Compartment Specifications”), which forms an integral part of the PPM for purposes of the relevant Compartment.
The Company is one single legal entity. However, by way of derogation to article 2093 of the Luxembourg Civil Code
and in accordance with the provisions of the 2007 Law, the assets of any given Compartment are only available for the
satisfaction of the debts, obligations and liabilities, which are attributable to such Compartment. Amongst Shareholders,
each Compartment is treated as a separate entity.
Art. 7. Classes of Shares. The General Manager may, at any time, issue different classes of Shares (collectively the
“Classes” and individually a “Class”) in respect of each Compartment, which may carry different rights and obligations
inter alia with regards to Well-Informed Investors, income and profit entitlements, redemption features, reporting obli-
gations and/or fee and cost features as described in the Compartment Specifications.
Art. 8. Form of Shares. The Company shall issue Shares in registered form only.
All issued Shares of the Company shall be registered in the Share register which shall be kept at the registered office
of the Company and such register shall contain the name of each owner of registered Shares, his residence or elected
domicile as indicated to the Company, the number of registered Shares held by him and the amount paid up on each
fractional Share.
The inscription of the Shareholder's name in the Share register evidences his right of ownership on such registered
Shares. The Company shall normally not issue certificates for such inscription, but each Shareholder shall receive a written
confirmation of his share holding upon request.
Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which all notices and
announcements may be sent. Such address will also be entered in the Share register.
In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the Share register and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be
128380
L
U X E M B O U R G
provided to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as entered in the
Share register by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may
be set by the General Manager from time to time.
The Company recognizes only one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of
such Shares(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) must appoint a sole attorney to represent such
share holding in dealings with the Company. The General Manager has the right to suspend the exercise of all rights
attached to such Shares(s) until such attorney has been duly appointed. In the event that a Share is registered in the name
of more than one person, the first-named holder in the register shall be deemed to be the representative of all joint
holders and shall alone be entitled to be treated as a holder of such Share for all purposes, including without limitation,
to receive notices from the Company.
The Company may decide to issue fractional Shares, up to two decimal places. Such fractional Shares shall not be
entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class of Shares on a pro
rata basis.
Payments of dividends, if any, will be made to Shareholders by bank transfer unless otherwise decided by the General
Manager.
Art. 9. Issue and subscription of Shares. The Shares may only be subscribed for by investors who comply with the
status of Well-Informed Investor. The compliance of each subscriber with the status of Well-Informed Investor will be
verified by the General Manager or any agent to which such function has been delegated by the General Manager.
The General Manager or any agent to which such function has been delegated by the General Manager, may at its
discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares until such time as the Company has received
sufficient evidence that the applicant qualifies as an Well-Informed Investor.
In addition to any liability under applicable law, each Shareholder who does not qualify as an Well-Informed Investor
and who holds Shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the General Manager, the other
shareholders and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding
in circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made mis-
leading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Well-Informed Investor or has failed to notify
the Company of its loss of such status.
Investors wishing to subscribe for Shares in a Compartment shall execute a subscription agreement (the “Subscription
Agreement”), which upon acceptance will be signed by the General Manager. Investors thus commit themselves to sub-
scribing and accepting Shares in accordance with the Articles as well as the terms and conditions set forth in the PPM.
The General Manager is authorized to issue, at any time, an unlimited number of additional Shares in any Class and in
any Compartment, without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to be
issued. Each newly issued Share in one specific Class of one specific Compartment entitles its holder to the same rights
and obligations of the holders of existing Shares in the same Class of the same Compartment.
No additional Management Share may be issued.
Shares may be designated in series (each a Series), each corresponding to a specific period of issuance, as determined
for each Class in the relevant Compartment Specifications. The Shares of each Series within a specific Class will have the
same characteristics as the Shares of each other Series of that Class, differing only in respect of their issue date and thus
in respect of any right or obligation based on such issue date.
The General Manager may impose conditions on the issue of Shares (including without limitation the execution of such
subscription documents and the provision of such information as the General Manager may determine to be appropriate)
and may fix a minimum subscription level. The General Manager may also, in respect of a particular Compartment, levy
a subscription charge and has the right to waive partly or entirely this subscription charge. Any conditions to which the
issue of Shares may be submitted shall be detailed in the PPM and, specifically, the relevant Compartment Specifications.
The issue price of Shares is determined by the General Manager on a Class by Class basis as fully described in the
relevant Compartment Specifications.
Shares shall be allotted only upon acceptance of the subscription and payment of the issue price. The issue price must
be received before the issue of Shares. The payment will be made under the conditions and within the time limits as
determined by the General Manager and fully described in the relevant Compartment Specifications.
The General Manager may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind, in compliance with the
conditions set forth by Luxembourg law.
If an Investor does not meet the payment requirements as fully described in the relevant Compartment Specifications,
it will be in default and potentially suffer the consequences as provided for in respect of each Compartment and set forth
in the relevant Compartment Specifications.
The General Manager may delegate to any duly authorized director, manager, officer or to any other duly authorized
agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the issue price of any Shares and to deliver the Shares.
Art. 10. Transfer of Shares.. Shares are generally freely transferable between Well-Informed Investors but may be
subject to such transfer conditions as set forth in the relevant Compartment Specifications.
128381
L
U X E M B O U R G
Any transfer of registered Shares shall be given effect by a written declaration of transfer to be inscribed in the Share
register, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act
therefore. Subject to the provisions of the paragraph above, any transfer of registered Shares shall be entered into the
register of Shareholders; such inscription shall be signed by the General Manager or any officer of the Company or by
any other person duly authorized thereto by the General Manager.
The Management Shares are exclusively and mandatorily transferable upon replacement of the General Manager.
Art. 11. Restriction on ownership. The General Manager shall have power to impose such restrictions as it may think
necessary for the purpose of ensuring that no Shares in the Company are acquired or held by (a) any person not qualifying
as a Well-Informed Investor, (b) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental authority
or (c) any person in circumstances which in the opinion of the General Manager might result in the Company incurring
any liability or taxation or suffering any pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred
or suffered. More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any
person, firm or corporate body, and without limitation, by any "U.S. Person", as defined hereafter.
For such purposes the Company may:
1) decline to issue any share or to register any transfer of any Share where it appears to it that such registering would
or might result in such Share being directly or beneficially owned by a person who is precluded from holding such Shares;
2) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported
by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such
shareholder's Share rests or will rest in a person who is precluded from holding Shares;
3) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares at any meeting of Shareholders of
the Company; and
4) where it appears to the Company that any person who is precluded from holding Shares or a certain proportion
of the Shares in the Company or whom the Company reasonably believes to be precluded from holding Shares in the
Company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of Shares, (i) direct such shareholder
to (a) transfer his Shares to a person qualified to own such Shares, or (b) request the Company to redeem his Shares,
or (ii) compulsorily redeem from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following manner:
a) The Company shall serve a notice (hereinafter called the “Redemption Notice”) upon the shareholder holding such
Shares or appearing in the Register as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be redeemed as
aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the redemption price in respect of such share is
payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope
addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said share-
holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if issued)
representing the Shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date specified
in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the Shares previously held or owned by
him shall be cancelled;
b) The price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the “Redemption
Price”) shall be an amount equal to the Net Asset Value per share of Shares in the Company of the relevant Class,
determined in accordance with Article 15 hereof less any service charge (if any). Where it appears that, due to the situation
of the shareholder, payment of the Redemption Price by the Company, any of its agents and/or any other intermediary
may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary to be liable to a foreign authority for
the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further withhold or retain, or allow any of its
agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the Redemption Price an amount sufficient to cover such
potential liability until such time that the shareholder provide the Company, any of its agents and/or any other intermediary
with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being understood (i) that in some cases the amount so
withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which case such amount may no longer be
claimed by the shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage that the Company,
any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by confidentiality rules;
c) Payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination for the relevant Class of Shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or
elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to such person but only, if a share certificate shall have
been issued, upon surrender of the share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. Upon
deposit of such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any
further interest in such Shares or any of them, or any claim against in the Company or its assets in respect thereof, except
the right of the shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without interest) from
such bank as aforesaid.
d) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such
case said powers were exercised by the Company in good faith.
128382
L
U X E M B O U R G
Whenever used in these Articles, the term «U.S. Person» shall have the same meaning as in Regulation S, as amended
from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended (the «1933 Act») or as in any other regulation
or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulation
S of the 1933 Act.
The General Manager may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.
Art. 12. Redemption of Shares. The redemption of certain Classes of Shares in certain Compartments may be autho-
rized on a Class by Class basis as set forth in the relevant Compartment Specifications.
The General Manager may, upon serving a Redemption Notice, decide to redeem the Shares of any Shareholder and
such Shareholder shall be obliged to sell its Shares to the Company at the conditions determined in accordance with the
contents of the PPM and, specifically, the relevant Compartment Specifications.
In the event that redemption requests on any given Valuation Date exceed 10% of the Net Asset Value of the Sub-
Fund from which Shares are to be redeemed, the General Manager may decide that the portion of the redemption requests
exceeding 10% of the Net Asset Value of such Sub-Fund be deferred to the following Valuation Date and any subsequent
Valuation Date for as long as redemption requests exceed 10% of the Net Asset Value of such Sub-Fund. In the case of
deferrals all pending redemption requests will be reduced proportionally and, for any subsequent Valuation Date, outs-
tanding deferred redemption requests will be dealt with prior to new redemption requests. The redemption will be settled
at the Valuation Date on which the relevant Shares are redeemed. Any deferred redemption request will have priority
over the redemption requests received on the following Valuation Date without prejudice of the 10% threshold mentioned
hereabove.
Art. 13. Conversion of Shares. The conversion of Shares in a given Compartment into Shares of another Compartment
or the conversion (or switching) of Shares of one Class into another Class within the same Compartment or of another
Compartment may be authorized on a Compartment by Compartment basis as well as on a Class by Class basis as set
forth in the relevant Compartment Specifications.
The Management Share is not convertible.
Title III - Net Asset Value
Art. 14. Valuation Date / Frequency of calculation of the Net Asset Value per share. The net asset value (the “Net
Asset Value” or “NAV”) of shares shall be determined by the General Manager or, under its responsibility, by an agent
designated by the General Manager in accordance with the requirements of Luxembourg law and the International Fi-
nancial Reporting Standards, as amended from time (“IFRS”).
The Net Asset Value of the Company shall be determined in Euros, from time to time, but in no instance less than
twice per year, as the General Manager by regulation may direct (every such day or time for determination of Net Asset
Value being referred to herein as a “Valuation Date”).
Art. 15. Determination of Net Asset Value per share. The Net Asset Value of share of each Class shall be expressed
in the reference currency of the relevant Class (and/or in such other currencies as the General Manager shall from time
to time determine) as a per share figure and shall be determined as of any Valuation Date by dividing the net assets of
the Company attributable to the relevant Class, being the value of the assets of the Company attributable to such Class
less the liabilities attributable to such Class, on any such Valuation Date, by the number of shares of the relevant Class
then outstanding, in accordance with the rules set forth below.
The Net Asset Value per share shall be calculated up to two decimal places.
The Net Asset Value per share will be calculated and available not later than 40 days following the Valuation Date.
If, since the time of determination of the Net Asset Value on the relevant Valuation Date, there has been a material
change in the valuations of the investments, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders
and of the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
I. The assets of the Company shall include (without limitation):
a) properties or property rights registered owned by the Company;
b) shareholdings in convertible and other debt securities of real estate companies as well as all securities, shares, bonds,
debentures, options or subscription rights and any other investments and securities belonging to the Company;
c) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
d) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of properties, property rights, se-
curities or any other assets sold but not delivered);
e) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-
rants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company;
f) all stock dividends, cash dividends and cash payments receivable by the Company to the extent information thereon
is reasonably available to the Company, the General Manager or the Custodian;
g) all rentals accrued on any real estate properties or interest accrued on any interest-bearing assets owned by the
Company except to the extent that the same is included or reflected in the value attributed to such asset;
128383
L
U X E M B O U R G
h) the formation expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing Shares of the Company, insofar
as the same have not been written off;
i) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
For the purpose of the determination of the Net Asset Value, the value of the Company's assets shall be determined
as follows:
a) Property assets will be valued by one or more independent appraisers annually and on such other days as the General
Manager may determine in accordance with the methodology to be determined from time to time by the General Manager.
b) The securities which are listed on a stock exchange or dealt in on another regulated market will be valued on the
basis of the last available publicised stock exchange or market value.
c) The securities of real estate companies which are neither listed on a stock exchange nor dealt in on another regulated
market will be valued on the basis of the probable net realisation value (excluding any deferred taxation) estimated with
prudence and in good faith by the General Manager.
d) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
e) All other securities and other assets, including debt securities and securities for which no market quotation is
available, are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by a pricing service approved by the General Manager
or, to the extent such prices are not deemed to be representative of market values, such securities and other assets shall
be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the General Manager. Money
market instruments held by the Company with a remaining maturity of ninety days or less will be valued by the amortised
cost method, which approximates market value.
f) The General Manager may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation
better reflects the fair value of any asset of the Company.
II. The liabilities of the Company shall include (without limitation):
a) all loans and other indebtedness for borrowed money (including convertible debt), bills and accounts payable;
b) all accrued interest on such loans and other indebtedness for borrowed money (including accrued fees for com-
mitment for such loans and other indebtedness);
c) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, advisory fees, custodian fees, and central admi-
nistration fees);
d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid distributions declared by the Company, where the Valuation Date falls on
the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto; and
e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law
and Luxembourg generally accepted accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall
take into account all expenses payable by the Company and may accrue administrative and other expenses of a regular
or recurring nature based on an estimated amount rateably for yearly or other periods.
III. The value of all assets and liabilities not expressed in Euro will be converted into Euro at the relevant rates of
exchange prevailing on the relevant Valuation Date. If such quotations are not available, the rate of exchange will be
determined with prudence and in good faith by or under procedures established by the General Manager.
IV. In the determination of the Net Asset Value of Shares:
a) Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the General
Manager on the Valuation Date on which such valuation is made and from such time and until received by the Company
the price therefore shall be deemed to be an asset of the Company;
b) Shares of the Company to be redeemed (if any) shall be treated as existing and taken into account until the date
fixed for redemption, and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a
liability of the Company; and
c) where on any Valuation Date the Company has contracted to:
i. purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
ii. sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered by the Company shall not be included in the assets of the Company;
provided, however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Date, then its value shall be estimated by the General Manager.
128384
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Temporary suspension of calculation of Net Asset Value per share and of issue of Shares. The Company may
suspend the calculation of the Net Asset Value of one or more Classes and, as the case may be, the issue, conversion
and redemption of Shares of such Class(es):
a) during any period when one or more stock exchanges or markets which provide the basis for valuing a substantial
portion of the assets of the Company are closed other than for, or during, holidays or if dealings are restricted or
suspended or where trading is restricted or suspended; or
b) during any period if, in the reasonable opinion of the General Manager, a fair valuation of the assets of the Company
is not practical for reasons of force majeure or act of nature beyond the control of the General Manager; or
c) during the existence of any state of affairs as a result of which the valuation of assets of the Company would be
impracticable; or
d) during any breakdown in excess of one week in the means of communication normally employed in determining
the value of the assets of the Company; or
e) when the central administration agent advises that the Net Asset Value of any subsidiary of the Company may not
be determined accurately; or
f) on publication of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose of resolving
the liquidation of the Company; or
g) when for any reason the independent property valuer advises that the prices of any investments cannot be promptly
or accurately determined.
Notice of the beginning and of the end of any period of suspension shall be given by the Company to all the shareholders
affected, i.e. having made an application for subscription, conversion or redemption of Shares for which the calculation
of the Net Asset Value has been suspended.
Any application for subscription, conversion or redemption of Shares is irrevocable except in case of suspension of
the calculation of the Net Asset Value of the relevant Class, in which case shareholders may give notice that they wish
to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, such application will be dealt with on the
first applicable Valuation Date following the end of the period of suspension.
Suspended subscription, redemption and conversion applications, may be withdrawn by means of a written notice,
provided the Central Administration receives such notice before a suspension is lifted.
Suspended subscription, redemption and conversion applications that have not been withdrawn shall be processed on
the first Valuation Date after a suspension is lifted.Notice of the beginning and of the end of any period of suspension
shall be given by the Company to all the shareholders affected, i.e. having made an application for subscription, conversion
or redemption of Shares for which the calculation of the Net Asset Value has been suspended.
Any application for subscription, conversion or redemption of Shares is irrevocable except in case of suspension of
the calculation of the Net Asset Value of the relevant Class, in which case shareholders may give notice that they wish
to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, such application will be dealt with on the
first applicable Valuation Date following the end of the period of suspension.
Art. 17. Custodian Agreement. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank, which shall satisfy
the requirements of the Luxembourg laws and the 2007 Law (the “Custodian”). All assets of the Company are to be held
by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities
provided by the law.
In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the Custodian, the Custodian will remain in place until the
appointment of another eligible credit institution as successor Custodian, such appointment to take place not more than
two months following the withdrawal of the original Custodian.
Title IV - Administration
Art. 18. General Manager. The Company shall be managed by Clearness Investment S.à r.l. in its capacity as General
Manager.
The General Manager may be dismissed by the general meeting of shareholders, in accordance with the rules applicable
to the amendment of these Articles.
Art. 19. Powers of the General Manager. The General Manager is invested with the broadest power to perform all
acts of administration and disposition in compliance with the Company's corporate objects. All powers not expressly
reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the General
Manager.
The General Manager shall, based upon the principle of spreading of risks, determine the corporate and investment
policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.
The General Manager shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the invest-
ments of the Company.
It shall have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and all of the purposes of the
Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that it may deem
128385
L
U X E M B O U R G
necessary, advisable or useful or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the General Manager has,
and shall have full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and
powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.
The General Manager may, from time to time, appoint officers or agents of the Company considered necessary for
the operation and management of the Company, provided however that the holders of Ordinary Shares may not act on
behalf of the Company without jeopardising their limited liability.
The officers and/or agents appointed, unless otherwise stipulated in the Articles, shall have the powers and duties given
to them by the General Manager.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the General Manager, acting through one
or more of its duly authorised signatories as designated by the General Manager at its sole discretion, or such person(s)
to which such power has been delegated.
Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company
by the above mentioned General Manager.
In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Manager from acting
as manager of the Company, the Company shall not be dissolved and liquidated, provided a general meeting of Share-
holders is held. At such general meeting, the Shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority
requirements for amendment of the Articles, a successor General Manager. Failing such appointment, the Company shall
be dissolved and liquidated.
No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected or invali-
dated by the fact that the General Manager or any one more of Shareholder, managers or officers of the General Manager
is interested in, or is a shareholder, director, officer or employee of such other company or entity with which the Company
shall contract or otherwise engage in business. The General Manager or such officers shall not by reasons of such affiliation
with such other company or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.
Title V - General Meetings of Shareholders
Art. 20. Powers and voting rights. Any regularly constituted meeting of Shareholders (a “General Meeting”) shall
represent the entire body of Shareholders of the Company. Any resolution shall require the consent of the General
Manager.
Each Share entitles its holder to one (1) vote at any General Meeting.
Art. 21. Convening and participation. The annual General Meeting is held every year at the Company's registered office
or at any other address in Luxembourg indicated in the convening notice. The annual General Meeting shall be held on
the third Thursday of June at 2.00 pm (Luxembourg time) unless this day is not a business day, in which case the meeting
shall be held on the next following business day.
The provisions of the 1915 Law relating to the notice periods, convening procedure as well as to the conduct of general
meetings shall apply to the General Meetings of the Company, unless otherwise provided herein.
A General Meeting of Shareholders shall be convened by the General Manager pursuant to a notice setting forth the
agenda and sent to the Shareholders by registered letter at least eight calendar days prior to the meeting. The General
Manager may determine any conditions which must be fulfilled by the Shareholders in order to participate in such General
Meeting.
If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of the meeting.
Shareholders representing one tenth of the share capital of the Company may impose on the General Manager to call
a General Meeting.
A Shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a Shareholder) in order
to be represented at any General Meeting.
Each Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar
means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
Each Shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place
and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to
(a) vote in favor, (b) vote against, or (c) abstain from voting. Voting forms must be sent back by the Shareholders to the
registered office of the Company. Only voting forms received 1 (one) day prior to the General Meeting are taken into
account for the calculation of the quorum. Voting forms which show neither a vote (in favor or against the proposed
resolutions) nor an abstention are void.
Art. 22. Quorum and Majority rules. Unless otherwise required by laws or by these Articles, resolutions of the General
Meeting are passed by a simple majority of the votes cast subject to the provisions of article 20 hereabove.
128386
L
U X E M B O U R G
The General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is represented and the agenda
indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments to the object or
form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by means of notices
published twice, at eight (8) days interval at least and eight (8) days before the meeting in the Memorial and in two
Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate the date and results
of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the proportion of the
capital represented. At both General Meeting, resolutions must be adopted by at least two-third of the votes cast subject
to the provisions of article 20 hereabove.
The nationality of the Company may only be changed with the unanimous consent of the Shareholders.
Art. 23. Bureau and minutes. All General Meetings shall be chaired by the General Manager or by any duly authorized
person designated by the General Manager.
The minutes of the General Meeting shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary appointed by the
chairman and the scrutiny, elected by the General Meeting.
Art. 24. General Meetings of Compartment(s). The General Manager may at any time convene a general meeting of
Shareholders of one or several specific Compartment(s) in order to decide on any matter, which relate exclusively to
such Compartment(s).
Legal provisions as well as provisions of these Articles relating to the general meetings of Shareholders of the Company
shall apply to the extent possible mutatis mutandis to the general meetings of Shareholders of one or several specific
Compartment(s).
Title VI - Accounts - Distributions
Art. 25. Accounting year and Accounts. The accounting year of the Company shall commence each year on the first
of January and shall end on the thirty-first of December of the same year.
Each year, the General Manager prepares the annual report in compliance with the 2007 Law. Such annual report must
include a balance sheet or a statement of assets and liabilities, a profit and loss account, a report on the activities of the
past financial year as well as any significant information.
The annual accounts shall be approved by the annual General Meeting.
Art. 26. Reference currency. The Company shall prepare consolidated accounts in Euro. For the purpose of deter-
mining the capital of the Company, the net assets attributable to each Compartment shall, if not denominated in Euro,
be converted into Euro and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the Compartments.
Art. 27. Auditor. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent
auditor (“réviseur d'entreprises agréé”) appointed by the General Manager and remunerated by the Company.
The auditor shall fulfill the duties prescribed by the 2007 Law.
Art. 28. Distributions. The annual General Meeting of Shareholders shall approve the profit allocation proposed by
the General Manager in accordance with the allocations rules set out in the PPM and in particular as set forth in each
Compartment Specifications.
The General Manager may in its discretion decide to pay interim dividends at any point in time unless otherwise
provided for in the PPM and, in particular, as set forth in the relevant Compartment Specifications.
Distributions shall be paid in Euro or in the base currency of a Compartment and at such time and place that the
General Manager shall determine from time to time.
No distribution may be made which would result in the Net Asset Value of the Company to fall below the minimum
capital required by the 2007 Law.
Title VII - Dissolution - Liquidation
Art. 29. Term, Liquidation and Merger of Compartments. The Compartments may be created for any undetermined
period or for a fixed period as provided for in the PPM and, specifically, in the relevant Compartment Specifications. In
case a Compartment is created for a fixed period, it will terminate automatically on its maturity date provided for in the
relevant Compartment Specifications.
The General Manager may also decide to liquidate one Compartment if the net assets of such Compartment have
decreased to, or have not reached, an amount determined by the General Manager to be the minimum level for such
Compartment to be operated in an economically efficient manner or if a change in the economic or political situation
relating to the Compartment concerned would justify such liquidation. All Shareholders will be notified by the Company
of any decision to liquidate the relevant Compartment prior to the effective date of the liquidation and the notice will
indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations.
In the same circumstances as provided above, the General Manager may decide to terminate one Compartment and
contribute its assets into another existing or new Compartment. The General Manager may organize the merger of two
or more Compartments if it believes that such a course of action is in the best interests of the Shareholders of the relevant
128387
L
U X E M B O U R G
Compartments. Affected Shareholders will be notified of any such decision and relevant information in relation to the
new Compartment. Notice will be provided at least one month before the date on which the merger becomes effective
in order to enable Shareholders to request that their Shares be redeemed, without any fees or costs, before the merger
is completed.
Where assets are to be contributed to another collective investment vehicle, the merger will be binding only on
Shareholders in the relevant Compartment who expressly consent to such merger.
Where the General Manager does not have the authority to do so or where the General Manager determines that
the decision should be put to the Shareholders for their approval, the decision to liquidate or to merge a Compartment
shall instead be taken at a General Meeting of the relevant Compartment. In such an event, the General Meeting of the
Compartment shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of Sha-
reholders holding 50% of the Shares represented at such General Meeting subject to the provisions of article 20
hereabove.
Shareholders will be notified by the Company of any resolution to proceed with liquidation or merger at least one
month before the effective date of the liquidation or merger of the Compartment in order to enable Shareholders to
request redemption or conversion of their Shares, without any fees or costs, before the liquidation or merger of the
Compartment takes place.
As soon as the decision to liquidate or merge a Compartment is taken, the issue of Shares in such Compartment is
prohibited and shall be deemed void.
Each Compartment may be separately dissolved without impacting any other Compartment. The dissolution of the
last Compartment causes ipso jure the liquidation of the Company.
Art. 30. Dissolution and liquidation of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of
the General Meeting resolving in the conditions prescribed for the amendment of these Articles. The Company shall also
be dissolved upon dissolution of the last existing Compartment.
Whenever the share capital falls below two third of the minimum capital indicated in Article 5 above, the question of
the dissolution of the Company shall be referred to the General Meeting by the General Manager. In such an event, the
General Meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of
Shareholders holding 50% of the Shares represented at such General Meeting.
Whenever the share capital falls below one quarter of the minimum capital indicated in Article 5 above, the question
of the dissolution of the Company shall be referred to the General Meeting by the General Manager. In such an event,
the General Meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of
Shareholders holding 25% of the Shares represented at such General Meeting.
Where the holding of a General Meeting is required in accordance with the paragraphs above, such General Meeting
must be convened so that it is held within a period of forty days from the assessment that the net assets of the Company
have fallen below two third or one quarter of the legal minimum, as the case may be.
In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be
physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding on such dissolution and subject to the
approval of the CSSF. The operations of liquidation will be carried out pursuant to Luxembourg applicable laws.
Art. 31. Liquidation proceeds. The net proceeds of liquidation corresponding to each Compartment shall be distributed
by the liquidator(s) to the Shareholders of the relevant Compartment in accordance with the rules applicable to the
allocation of profits in such Compartment.
Any liquidation proceeds that cannot be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the liquidation
will be deposited with the Luxembourg “Caisse de Consignation”.
Art. 32. Consolidation/Splitting of Shares. The General Manager may consolidate Shares of different Classes within a
Compartment or split the Shares of a Compartment into two or more different Classes. A consolidation or split may
also be resolved by a General Meeting of the Compartment concerned deciding, without any quorum requirements, at
the simple majority of the Shares present or represented subject to the provisions of article 20 hereabove.
Title VIII - General
Art. 33. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915
Law and the 2007 Law as such laws have been or may be amended from time to time.
<i>Transitory dispositionsi>
1. The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and will end on 31 December 2012.
2. The first annual general meeting of Shareholders will be held in 2013 with regards to the accounting year ending on
31 December 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscriber has subscribed for the following Shares in the Company:
128388
L
U X E M B O U R G
Management Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Ordinary Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000
Total Shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100
The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros)
is from now on at the free disposal of the Company, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 2,400 (two thousand four hundred Euros).
<i>Extraordinary general meetingi>
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
<i>First resolutioni>
The registered office of the Company is 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
KPMG Luxembourg S.à r.l., a limited liability company, with registered office in L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer,
inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 149.133 is appointed as
external auditor of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English.
WHEREUPON the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this
deed.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by the surname, first name, civil status and residence, said proxy-holder signed together with the notary the present
original deed.
Signé: V. LINARI-PIERRON, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 août 2012. LAC/2012/39147. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2012.
Référence de publication: 2012131864/572.
(120173889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
North REOF Cuza S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.
R.C.S. Luxembourg B 120.912.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 12 Juin 2012i>
Il résulte des décisions de l'associé unique de North REOF Cuza Sarl, North REOF Holding Sarl, une société à res-
ponsabilité limitée ayant son siège social 3, rue Rénert L-2422 Luxembourg immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 6120.564 que:
- il a été nommé, avec effet 21 Juin 2012 et pour une durée indéterminée, en tant que gérant de la Société, Monsieur
David Clark, né le 7 Février 1963 à Peterborough, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à West Wing, Frances
House Sir William Place, St Peter Port GY GX Guernsey, Royaume-Uni.
Il en résulte donc que le conseil de gérance de North REOF Cuza Sarl se composera désormais comme suit:
- Monsieur Thomas Haines, en tant que gérant de la Société; et
- Monsieur David Clark, en tant que gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
128389
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 12 Juin 2012.
<i>Pour North REOF Holding Sarl
i>Signature
<i>Manageri>
Référence de publication: 2012131524/23.
(120173681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
North REOF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.
R.C.S. Luxembourg B 120.564.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012131526/10.
(120173625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
PEF Turkey MENA II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 134.436.
Il résulte de résolutions écrites prises par l’associé unique de la Société le 19 septembre 2012 que:
- M. Jan Baldem Reinhard MENNICKEN et M. Oliver MAY ont été révoqués de leur poste de gérants de la Société,
avec effet au 19 septembre 2012;
- M. Robert MUNDAY a démissionné de son poste de gérant de la Société, avec effet au 19 septembre 2012;
- M. Benjamin HARTMEIER, né le 20 avril 1978 à Sulingen (Allemagne) et M. Rachid OUAICH, né le 4 janvier 1977 à
Liège (Belgique), tous deux ayant leur adresse professionnelle au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), ont été nommés comme gérants de la Société avec effet au 19 septembre 2012 et pour une
période indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société sera composé au 19 septembre 2012 par les gérants suivants:
- M. Benjamin Hartmeier, gérant; et
- M. Rachid Ouaich, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131564/21.
(120173648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Industeam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck I.
R.C.S. Luxembourg B 48.582.
L'an deux mille douze.
Le vingt-sept août.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDUSTEAM S.A. (ci-après "la
Société"), avec siège social à L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck I (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg
section B numéro 48582, constituée sous la dénomination de TRAINLORLUX S.A., suivant acte reçu par Maître Aloyse
BIEL, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 17 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 506 du 6 décembre 1994,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus:
- par le notaire instrumentant en date du 23 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 1610 du 9 novembre 2002,
- par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mars 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 712 du 9 juillet 2004,
- par Maître Emile SCHLESSER, préqualifié, en date du 23 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 730 du 11 avril 2006,
128390
L
U X E M B O U R G
- par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 14 septembre 2006, en cours de publication
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2270 du 6 décembre 2006,
- par le notaire instrumentant en date du 18 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2391 du 22 décembre 2006,
- par le notaire instrumentant en date du 30 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2180 du 8 septembre 2008.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo PERRONE, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé,
demeurant professionnellement à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Réduction du capital social d’un montant de 16.500, EUR pour le porter de son montant actuel de 165.000. EUR
à 148.500, EUR, par le retrait et l’annulation de 1.000 actions propres.
2.- Augmentation subséquente du capital social d’un montant de 16.500, EUR pour le porter de son montant réduit
de 148.500. EUR à 165.000, EUR, par incorporation de réserves.
3.- Suppression de la valeur nominale.
4.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
5.- Nomination d’un nouvel administrateur.
6.- Désignation du président du conseil d’administration.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions
qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et
le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de 16.500.- EUR (seize mille cinq cents euros) pour le
ramener de son montant actuel de 165.000.- EUR (cent soixante cinq mille euros) à 148.500.- EUR (cent quarante huit
mille cinq cents euros).
Cette réduction du capital social est réalisée par le retrait et l’annulation de 1.000 (mille) actions propres actuellement
détenues par la Société, conformément aux dispositions de l’article 69-2 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter de manière subséquente le capital social à concurrence de 16.500. EUR (seize mille
cinq cents euros), en vue de le porter de son montant actuel après réduction de 148.500.- EUR (cent quarante huit mille
cinq cents euros) à 165.000.- EUR (cent soixante cinq mille euros), sans émission d’actions nouvelles, mais par augmen-
tation de la valeur nominale des 9.000 (neuf mille) actions restantes.
L'assemblée décide de réaliser cette augmentation de capital par incorporation au capital de réserves disponibles à
concurrence de 16.500. EUR (seize mille cinq cents euros).
La justification de l'existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents compta-
bles.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale attachée aux 9.000 (neuf mille) actions de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article trois des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante cinq mille euros (165.000.- EUR), représenté par neuf mille (9.000)
actions sans désignation de valeur nominale."
128391
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer la société T.F. INVESTISSEMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois
établie et ayant son siège social à L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck I, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le
numéro B 124064, en tant que nouvel administrateur, avec effet à compter de ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article 51 bis de la Loi sur les Sociétés Commerciales, la société T.F. INVESTIS-
SEMENTS S.A. a désigné Monsieur Sylvain REDELER, né le 9 avril 1959 à Metz (France), demeurant professionnellement
à L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck I, en tant que représentant permanent chargé de l’exécution de sa mission
d’administrateur de la Société.
Le mandat de l’administrateur prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2016.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, décident de désigner, pour
une durée indéterminée, la société T.F. INVESTISSEMENTS S.A., préqualifiée, en tant que président du conseil d’admi-
nistration, conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-
proximativement à la somme de mille deux cent cinquante euros.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Massimo PERRONE, Alain THILL, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 03 septembre 2012. Relation GRE/2012/3224. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012132024/98.
(120173832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Nova Metrix (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 155.364.
Les comptes annuels 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131528/10.
(120173589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Nova Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 159.366.
Les comptes annuels pour la période du 25 février 2011 au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131529/11.
(120173626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Nesah S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.131.
Remplace bilan déposé le 30.12.2011 N. L110213031
128392
L
U X E M B O U R G
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012131530/11.
(120173601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Avolon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 153.147.
EXTRAIT
Il résulte de la décision des associés du 4 octobre 2012 que:
1) le mandat de gérant de la Société de M. Caspar Berendsen a pris fin avec effet au 24 septembre 2012,
2) M. Marc Lamberty, né le 10 octobre 1977 à Wittlich (Allemagne), demeurant professionnellement au 4, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg a été nommé en tant que nouveau gérant Cinven de la Société avec effet au 24 septembre
2012, pour une durée indéterminée:
Le conseil de gérance de la Société est désormais constitué comme suit:
<i>Gérants Cinveni>
- Mr Marc Lamberty;
- Mr Maxim Crewe;
- Mrs Daniele Arendt-Michels;
<i>Gérants CVCi>
- Mrs Emanuela Brero;
- Mr Manuel Mouget;
- Mr Peter Rutland;
<i>Gérants Oak Hilli>
- Mr Paul Barton;
- Mrs Céline Pignon;
- Mr Douglas Kaden;
<i>Gérant GICi>
Mr Robin Jarrat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012132299/32.
(120173984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
New Equities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 136.797.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131531/9.
(120173682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 133.568.
Les Comptes Annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
128393
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131534/11.
(120173691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Stonehage Corporate Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 3A, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 160.651.
<i>Extrait du procès - verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société qui s'est déroulée à Luxembourg le 25 septembrei>
<i>2012.i>
[...]
7. Nomination des membres du conseil d'administration
Les actionnaires de la Société ont renouvelé les mandats des membres du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en l'année 2013, à savoir:
- M. Ian Crosby, administrateur et président du conseil
- M. Ari Tatos, administrateur
- M. Niall McCallum, administrateur
- M. Eric Osch, administrateur et délégué à la gestion journalière en tant qu'administrateur-délégué
- M. Peter Egan, administrateur et délégué à la gestion journalière en tant qu'administrateur-délégué adjoint.
[---]
Le bureau de l'assemblée générale des actionnaires:
Signatures
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
<i>Extrait du procès - verbal de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est déroulée à Luxembourg le 25 septembrei>
<i>2012.i>
[...]
3. Nomination du réviseur d'entreprises agréé
Conformément à l'article 22 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle qu'elle a été modifiée, le conseil
d'administration de la Société a nommé PricewaterhouseCoopers S.àr.l., inscrite au registre de commerce de Luxembourg
avec le numéro R.C.S. Luxembourg B65 477, ayant son adresse au 400 route d'Esch L-1014 Luxembourg, comme personne
chargée du contrôle des comptes et comme réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en l'année 2013.
[...]
Peter Egan / Eric Osch
<i>Administrateur-délégué adjoint / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012132224/34.
(120173792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Pandore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 158.427.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s 'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PANDORE S.A.
i>Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012131557/14.
(120173697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
128394
L
U X E M B O U R G
Phoenix Finance & Immo Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10A, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 166.431.
L'an deux mille douze, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Monsieur Marco RUSSO, gérant de fortune, né à Castelfiorentino (Italie) le 9 mai 1970, demeurant à I-50122 Florence,
Borgo Degli Albizi, 10,
ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant professionnellement
à Bascharange,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 31 juillet 2012, laquelle procuration, après avoir été signée
«ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être
formalisée avec elles,
détenteur de cent vingt-six (126) parts sociales.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité
limitée "Phoenix Finance & Immo Luxembourg S.à r.l." (numéro d'identité 2012 24 00 957), avec siège social à L-3441
Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 166.431, constituée suivant
acte reçu par le notaire Carlo WERSANDT, de résidence à Luxembourg, en date du 13 janvier 2012, publié au Mémorial
C, numéro 644 du 12 mars 2012,
a requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte à
L-8070 Bertrange, 10a, rue des Mérovingiens et de modifier le 1
er
alinéa de l'article 3 des statuts de la société pour lui
donner la teneur suivante:
" Art. 3. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Bartringen (Grossherzogtum Luxemburg)."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 5 octobre 2012. Relation: CAP/2012/3759. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bascharage, le 8 octobre 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012132316/40.
(120173924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
PEF Turkey MENA III S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 134.434.
Il résulte de résolutions écrites prises par l’associé unique de la Société le 19 septembre 2012 que:
- M. Jan Baldem Reinhard MENNICKEN et M. Oliver MAY ont été révoqués de leur poste de gérants de la Société,
avec effet au 19 septembre 2012;
- M. Robert MUNDAY a démissionné de son poste de gérant de la Société, avec effet au 19 septembre 2012;
- M. Benjamin HARTMEIER, né le 20 avril 1978 à Sulingen (Allemagne) et M. Rachid OUAICH, né le 4 janvier 1977 à
Liège (Belgique), tous deux ayant leur adresse professionnelle au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), ont été nommés comme gérants de la Société avec effet au 19 septembre 2012 et pour une
période indéterminée.
128395
L
U X E M B O U R G
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société sera composé au 19 septembre 2012 par les gérants suivants:
- M. Benjamin Hartmeier, gérant; et
- M. Rachid Ouaich, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131565/21.
(120173647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
PEF Turkey MENA Nisantasi Commercial S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 134.440.
Il résulte de résolutions écrites prises par l’associé unique de la Société le 19 septembre 2012 que:
- M. Jan Baldem Reinhard MENNICKEN et M. Oliver MAY ont été révoqués de leur poste de gérants de la Société,
avec effet au 19 septembre 2012;
- M. Robert MUNDAY a démissionné de son poste de gérant de la Société, avec effet au 19 septembre 2012;
- M. Benjamin HARTMEIER, né le 20 avril 1978 à Sulingen (Allemagne) et M. Rachid OUAICH, né le 4 janvier 1977 à
Liège (Belgique), tous deux ayant leur adresse professionnelle au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), ont été nommés comme gérants de la Société avec effet au 19 septembre 2012 et pour une
période indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société sera composé au 19 septembre 2012 par les gérants suivants:
- M. Benjamin Hartmeier, gérant; et
- M. Rachid Ouaich, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131566/21.
(120173650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Traveling S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 63.335.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TRAVELING S.A., SPF
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012131585/12.
(120173663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
TCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 104.578.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131571/10.
(120173642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., Industrie per le Telecomunicazioni, Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 50.677.
Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
128396
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUNICAZIONI
Référence de publication: 2012131575/11.
(120173657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
TCRe2, Trade Crédit Re Carré S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 112.941.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2011i>
L’assemblée des actionnaires de la société TRADE CREDIT RE CARRE S.A. a pris, en date du 27 avril 2011, la résolution
suivante:
Le mandat du réviseur BDO Compagnie Fiduciaire n’est pas renouvelé.
L’assemblée décide de nommer MAZARS LUXEMBOURG, ayant son siège social 10A, rue Henri M. Schnadt à L-2530
Luxembourg (RCS Luxembourg B 159.962 en tant que réviseur de la société.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2017.
Luxembourg, le 27.04.2011.
Pour avis conforme
Référence de publication: 2012131583/16.
(120173706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
BlackRock Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 6.317.
Monsieur Douglas Shaw a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec date effective le 19 Sep-
tembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour Blackrock Global Funds
i>The Bank of New York Mellon (Luxembourg) SA
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Jérémy Colombé / Peter BUN
Référence de publication: 2012131743/17.
(120173717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Transalliance Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle de Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 32.666.
Par décision de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 4 juin 2012, le mandat de réviseur d'entreprises
confié à la société EUROLUX AUDIT SàRL est renouvelé pour une année jusqu'à la tenue de l'assemblée prévue en 2013
statuant sur les comptes de l'exercice social 2012.
Référence de publication: 2012131584/10.
(120173604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Triplewell S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 97.606.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
128397
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TRIPLEWELL S.A R.L.
Société à Responsabilité Limitée
Référence de publication: 2012131589/12.
(120173588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Virovest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 140.322.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VIROVEST S.à R.L.
Société à Responsabilité Limitée
Référence de publication: 2012131599/11.
(120173586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Fotex Holding, Société Européenne.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 146.938.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 avril 2012i>
Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2012 que:
- Les mandats des Administrateurs MM. Gabor VARSZEGI, David VARSZEGI, Wiggert KARREMAN, Bob DOLE, Jan
Thomas LADENIUS et Madame Anna RAMMMER, ont été renouvelés pour une durée de un an, expirant à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.;
- Monsieur Péter KADAS, né le 27 février 1962, résidant au 3, Holford Road, London NW3 (Royaume-Unis), est
nommé administrateur pour une durée de un an. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de l'an 2013;
- Le mandat d'administrateur de la société TITAN S.à r.l. n'a pas été renouvelé;
- Le mandat du Commissaire aux comptes VAN CAUTER-SNAUWAERT & CO S.à r.l. est renouvelé pour une durée
de un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013;
- La durée du mandat du réviseur d'entreprises agrée ERNST & YOUNG Luxembourg, dont l'échéance était initiale-
ment prévue à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015, est réduite pour une durée de un an, expirant à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.
Luxembourg, le 8 octobre 2012.
<i>Pour: Fotex Holding
i>Société Européenne
Experta Luxembourg
Société anonyme
Ana-Paula Duarte / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2012131959/27.
(120173861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
PEF Turkey MENA Nisantasi Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 134.443.
Il résulte de résolutions écrites prises par l’associé unique de la Société le 19 septembre 2012 que:
- M. Jan Baldem Reinhard MENNICKEN et M. Oliver MAY ont été révoqués de leur poste de gérants de la Société,
avec effet au 19 septembre 2012;
- M. Robert MUNDAY a démissionné de son poste de gérant de la Société, avec effet au 19 septembre 2012;
- M. Benjamin HARTMEIER, né le 20 avril 1978 à Sulingen (Allemagne) et M. Rachid OUAICH, né le 4 janvier 1977 à
Liège (Belgique), tous deux ayant leur adresse professionnelle au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Grand-
128398
L
U X E M B O U R G
Duché de Luxembourg), ont été nommés comme gérants de la Société avec effet au 19 septembre 2012 et pour une
période indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société sera composé au 19 septembre 2012 par les gérants suivants:
- M. Benjamin Hartmeier, gérant; et
- M. Rachid Ouaich, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131638/21.
(120173652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Vigicore Lux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7841 Tuntange, 21C, rue de Brouch.
R.C.S. Luxembourg B 130.608.
Statuts coordonnés suivant acte du 25 septembre 2012, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012131606/11.
(120173711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Vigroup Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 136.933.
Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'administrateur de votre société et ce avec effet à dater
de ce jour.
Clémency, le 3 octobre 2012.
<i>Pour Flexoffice Sàrl
i>9, rue Basse
L-4963 Clémency
Philippe Vanderhoven
<i>Représentant permanenti>
Référence de publication: 2012131607/15.
(120173656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Fosbele Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.635.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 6 septembrei>
<i>2012i>
1. Le mandat d'administrateur de Monsieur Xavier SOULARD venu à échéance n'a pas été renouvelé.
2. Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe TOUSSAINT venu à échéance n'a pas été renouvelé.
3. Le mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration de Monsieur Eric MAGRINI venu à échéance
n'a pas été renouvelé.
4. Monsieur Pascal ROBINET, administrateur de sociétés, né à Charleville-Mézières (France), le 21 mai 1950, domicilié
à L-7412 Bour (Grand-Duché de Luxembourg), 5, Rue d'Arlon, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2015.
5. Mademoiselle Gabrielle ROBINET, administrateur de sociétés, née à Paris 11
ème
(France), le 18 août 1982, domi-
ciliée à 1004 Lausanne (Suisse), 9, Chemin de Renens, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2015.
6. La société anonyme NOETRIB ADMINISTRATION S.A., R.C.S. Luxembourg B 74517, ayant son siège social à L-2212
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 6, Place de Nancy, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2015.
7. Monsieur Pascal ROBINET a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2015.
128399
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FOSBELE INVESTMENTS S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012131971/28.
(120173974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Vigroup Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 136.933.
Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'administrateur de votre société et ce avec effet à dater
de ce jour.
Clémency, le 3 octobre 2012.
Philippe Vanderhoven
9, rue Basse
L-4963 Clémency
Référence de publication: 2012131609/13.
(120173656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Vigroup Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 136.933.
Par la présente, je vous informe de ma démission en tant que commissaire aux comptes de votre société et ce avec
effet à dater de ce jour.
Clémency, le 3 octobre 2012.
SV SERVICES SARL
9, rue Basse
L-4963 Clémency
Représentée par M. Jean Yves Stasser
Référence de publication: 2012131610/14.
(120173656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Q.I.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.617.
<i>Extrait de la résolution prise lors du conseil d'administration du 28 juin 2012:i>
Le conseil d'administration décide de nommer Market Overview S.A., dont le siège social se situe au 117 Route d'Arlon,
L-8009 Strassen et représenté par Monsieur Patrick Abadie, résidant professionnellement au 117 Route d'Arlon, L-8009
Strassen, en remplacement de Monsieur Vincent Pons, avec effet au 22 juin 2012, date de l'accord préalable de la CSSF.
Le conseil d'administration décide que cette nomination sera présentée pour ratification à la prochaine assemblée
générale du «General Partner».
Société Générale Securities Services Luxembourg
C. BOUILLON
<i>Corporate and Domiciliary Agenti>
Référence de publication: 2012131753/16.
(120173714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
128400
Avolon Investments S.à r.l.
BlackRock Global Funds
Clearness Investment Fund S.C.A., SICAV-SIF
Data Center Infrastructure S.à r.l.
DataEurope Co-Invest S.à r.l.
FFH Financial Holding S.A.
Five Arrows Nautilus Co-Invest Feeder SCA
Fosbele Investments S.A.
Fotex Holding
Henrik Andersen Sportpromotion AG
Immoconsulting Lux S.à r.l.
Industeam S.A.
ING (L) Liquid
International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg
Lainal S.C.I.
Langwies II sa
LCE Allemagne 1 S.à r.l.
LCE Allemagne 3 S.à r.l.
LCE Allemagne 3 S.à r.l.
LCE Allemagne 4 S.à r.l.
LCE Allemagne 4 S.à r.l.
Litsea S.à r.l.
Lux-Vitrerie S.à r.l.
Maxalice S.A.
MEIF 3 Luxembourg B Holdings, S.à r.l.
MGM 1 S.à r.l.
Monier Investissement S.C.A.
Mountain Aviation S.A.
Nesah S.A.
New Equities S.A.
North REOF Cuza S.à r.l.
North REOF Holding S.à r.l.
Nova Metrix (Luxembourg) S.à r.l.
Nova Ventures S.à r.l.
Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS
Pandore S.A.
PEF Turkey MENA III S.à r.l.
PEF Turkey MENA II S.à r.l.
PEF Turkey MENA Nisantasi Commercial S.à r.l.
PEF Turkey MENA Nisantasi Office S.à r.l.
Phoenix Finance & Immo Luxembourg S.à.r.l.
Q.I.M. S.A.
Royalty Opportunities Feeder S.A.
Stonehage Corporate Services Luxembourg S.A.
TCI S.A.
TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., Industrie per le Telecomunicazioni
Trade Crédit Re Carré S.A.
Transalliance Europe
Traveling S.A., SPF
Triplewell S.à.r.l.
Vigicore Lux
Vigroup Finance S.A.
Vigroup Finance S.A.
Vigroup Finance S.A.
Virovest