This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 708
16 mars 2012
SOMMAIRE
Adler Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33958
Biocera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33944
Cetim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33984
CMP II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33939
Express Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33978
Global Financial and Commercial Holdings
Coral S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33959
Global Financial and Commercial Holdings
Pink S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33965
Global Financial and Commercial Holdings
Yellow S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33973
Green'Up S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33959
HMTF CPD Canada Luxco S. à r. l. . . . . . .
33945
Ibralux Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
33957
Lenta Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
33940
Lux e-shelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33941
Magni S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33939
OCM Luxembourg Yachts Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33944
Onea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33938
Origink S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33941
Padostom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33957
Parcis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33958
Parker Hannifin Holding EMEA S.à r.l. . . .
33943
Parker Hannifin Outbound S.à r.l. . . . . . . .
33943
Parker-Migliorini International Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33944
Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
33952
Peninsula Property Development S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33943
Petercam (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .
33958
Pharlyse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33938
Pharus Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33958
Polyvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33959
PRH Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33963
Project Bird Holding IIIB S. à r.l. . . . . . . . .
33956
Project Bird Holding IIIC S.à r.l. . . . . . . . . .
33957
Quartier Kirchberg-Luxembourg, S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33963
RECM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33978
RE Development S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
33965
Regent House (Brentwood) S.à r.l. . . . . . . .
33964
Restaurant Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
33964
Rhombus Mezzco S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
33978
Rodaco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33978
Roermond Holding (No. 1) S.à r.l. . . . . . . .
33964
Roermond Holding (No. 2) S.à r.l. . . . . . . .
33965
Roermond Holding (No. 3) S.à r.l. . . . . . . .
33977
Ship Luxco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
33964
Superlift Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
33945
Utah JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33950
Valfore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33938
Vector Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
33952
Vitol Holding II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33953
Vodafone Investments Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33938
Wagner Immobilien Deutschland SA . . . .
33969
33937
L
U X E M B O U R G
Vodafone Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.082.108.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 79.256.
Veuillez prendre note du changement d’adresse de 4 gérants comme suit:
- M. Guy Harles, avec adresse au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg
- M. Marinus Minderhoud, avec adresse au 72 Langeweg, 2371 EJ Roelofarendsveen, Pays-Bas
- M. Paul Stephenson, avec adresse au Babbage House, the Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN Royaume-
Uni
- M. Christian Billon, avec adresse au 18 rue d’Orange, L-1011 Luxembourg
Luxembourg, le 03 Février 2012.
Référence de publication: 2012018046/15.
(120021801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Onea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 130.986.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ONEA S.A.
Référence de publication: 2012017970/10.
(120021585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Pharlyse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 19.000.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012017989/14.
(120022042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Valfore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.001,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 132.039.
Par résolutions prises en date du 9 janvier 2012, les associés ont pris les décisions suivantes:
1) acceptation de la démission de Patrick LSURGER, avec adresse professionnelle au 11-13, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg, de son mandat de 'Geschäftsführer' avec effet au 31 août 2011.
2) nomination de René BELTJENS, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant avec effet au 18 octobre 2011 et pour une durée indéterminée.
3) acceptation de la démission de Beatrice GHIOCA, avec adresse professionnelle au 11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg, de son mandat de 'Geschäftsführer' avec effet au 26 octobre 2011.
4) nomination de Paulina DENIS, avec adresse professionnelle au 11-13, Boulevard de la Foire L-1258 Luxembourg,
au mandat de gérant avec effet au 26 octobre 2011 et pour une durée indéterminée.
33938
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2012.
Référence de publication: 2012018045/19.
(120021954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
CMP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 135.328.
Lors de l'Assemblée Générale annuelle tenue en date du 30 janvier 2012 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.
2. Acceptation de la démission de Marie-Catherine Brunner, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.
3. Nomination de Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au
mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
4. Nomination de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat
de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012018215/19.
(120022904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Magni S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 60.426.
L'an deux mille onze.
Le vingt-huit décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MAGNI S.A.", ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 60.426, constituée suivant
acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 5 août 1997, publié au Mémorial C numéro 640 du 17 novembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois par acte de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 23 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2841 du 28 décembre 2010.
Le capital social est fixé à six cent mille Euros (EUR 600.000,-) divisé en six cents (600) actions d’une valeur nominale
de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.
L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT-VALENT, employée privée, demeurant professionnellement
à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Bob PLEIN, employé privé, demeurant professionnellement à
L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
2. Nomination de la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 153141, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats.
4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
33939
L
U X E M B O U R G
signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l’étude de celui-ci.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est réguliêrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée désigne comme liquidateur de la société, la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", ayant
son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 153.141.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par
les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société, à savoir Monsieur Philippe TOUS-
SAINT, président du conseil d’administration, Monsieur Xavier SOULARD et Monsieur Pietro LONGO, ainsi qu’au
commissaire de la société, à savoir la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., pour l'exécution de leurs
mandats respectifs.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille cent cinquante Euros.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Christina SCHMIT-VALENT, Bob PLEIN, Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 02 janvier 2012. Relation GRE/2012/17. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012017938/67.
(120022138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Lenta Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.043,75.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.411.
<i>Extrait rectificatif du dépôt n° 110161876.05 du 11 octobre 2011i>
L'extrait pour publication de la Société enregistré le 11 octobre 2011 ayant pour référence L110161876.05 et publié
au Mémorial C en date du 16 novembre 2011, était erroné et est rectifié par le présent extrait rectificatif.
Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 26 janvier 2012, que:
1) le mandat de gérant de classe B de M. Clive Denis Bode a pris fin en date du 26 janvier 2012;
2) M. Ronald Cami n'a pas été nommé gérant de classe B, comme il était spécifié dans l'extrait;
de sorte que le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
<i>Gérant de classe A:i>
- M. Pedro Fernandes das Neves
<i>Gérant de classe B:i>
- M. John E. Viola
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33940
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 31 Janvier 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012018122/23.
(120022218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Origink S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 101.029.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2012.
Pour ordre
PRODESSE sarl
Signature
Référence de publication: 2012017972/13.
(120022101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Lux e-shelter, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 897.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 162.692.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
e-shelter Holdings LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States
of America, with registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware, 198, United States of America,
here represented by Mr. Sébastien Gaddini, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,
given on 23 November 2011, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Lux e-shelter, a société à responsabilité limitée,
with a share capital of EUR 57,500.-, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorpo-
rated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 3 August 2011, published in the
Memorial C Recueil des Sociétés et Associations on 30 September 2011 under number 2337, registered with the Lu-
xembourg trade and companies register under section B number 162692.
The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:
<i>First Resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital from its current amount of fifty-seven thousand
five hundred euro (EUR 57,500.-) up to an amount of eight hundred ninety-seven thousand five hundred euro (EUR
897,500.-) through the issuance of eight hundred forty thousand (840,000) new shares with a par value of one euro (EUR
1.-) each.
The new shares are subscribed by e-shelter Holdings LLC, prequalified.
The shares subscribed have been paid up by the abovementioned subscriber through a cash contribution of a total
amount of eight hundred forty thousand euro (EUR 840,000.-), and such cash contribution is as of now at the disposal of
the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
The total cash contribution of eight hundred forty thousand euro (EUR 840,000.-) is entirely allocated to the share
capital of the Company.
The Sole Shareholder resolves to authorise Mr. Marc Elvinger, Ms. Caroline Streiff, or Mr. Sébastien Gaddini, all lawyers
and residing in Luxembourg, acting individually, to make the appropriate amendments in the shareholders' register of the
Company in order to reflect the abovementioned capital increase.
33941
L
U X E M B O U R G
<i>Second Resolutioni>
As a consequence, the Sole Shareholder resolves that article 6 of the Company's articles of association shall now read
as follows:
“ Art. 6. The Company's share capital is set at eight hundred ninety-seven thousand five hundred euro (EUR 897,500.-)
represented by eight hundred ninety-seven thousand five hundred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes
Im Jahre zweitausendelf, den fünfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
SIND ERSCHIENEN:
e-shelter Holdings LLC, eine limited liability company gegründet und bestehend nach dem Recht des Staates Delaware,
Vereinigte Staaten von Amerika, mit Sitz in c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wil-
mington, Delaware, 198, United States of America,
hier vertreten durch Herrn Sébastien Gaddini wohnhaft zu Luxemburg, durch privatschriftliche Vollmacht, erteilt am
23 November 2011, welche nach Zeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegen-
wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben registriert zu werden.
Solche erschienene Partei ist alleinige Gesellschafterin von Lux e-shelter (die „Alleinige Gesellschafterin“), eine société
à responsabilité limitée, mit einem Stammkapital von EUR 57,500, mit Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg,
gegründet am 3. August 2011 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Joseph Elvinger, veröffentlicht im Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations am 30. September 2011 unter Nummer 2337, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 162692.
Hiernach fasst die das gesamte Gesellschaftskapital vertretende alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital von seinem derzeitigen Betrag von siebenundfünf-
zigtausendfünfhundert Euro (EUR 57,500.-) auf einen Betrag von achthundertsiebenundneunzigtausendfünfhundert Euro
(EUR 897,500) durch die Ausgabe von achthundertvierzigtausend (840,000) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Nenn-
wert von einem Euro (EUR 1.-) zu erhöhen.
Die neuen Gesellschaftsanteile werden von e-shelter Holdings, LLC, vorbezeichnet, gezeichnet.
Die gezeichneten Gesellschaftsanteile sind von dem oben genannten Zeichner durch eine Bareinlage in Höhe von
achthundertvierzigtausend Euro (EUR 840,000) bezahlt worden, und diese Bareinlage steht zum jetzigen Zeitpunkt der
Gesellschaft zur Verfügung, wie es dem unterzeichnenden Notar bewiesen wurde.
Die gesamte Bareinlage von achthundertvierzigtausend (EUR 840,000) wird dem Gesellschaftskapital zugeführt.
Die Alleinige Gesellschafterin beschließt Herrn Marc Elvinger, Frau Caroline Streiff und Herrn Sébastien Gaddini, alle
Juristen mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg, zu ermächtigen, die erforderlichen Änderungen im Gesellschafterre-
gister vorzunehmen, um die oben genannte Kapitalerhöhung widerzuspiegeln.
<i>Zweiter Beschlussi>
Demzufolge beschließt die alleinige Gesellschafterin Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
„ Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt achthundertsiebenundneunzigtausendfünfhundert Euro (EUR 897,500) und
ist in achthundertsiebenundneunzigtausendfünfhundert (897,500) Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-) aufgeteilt.
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.“
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
33942
L
U X E M B O U R G
Signé: S. GADDINI, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52570. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 02 décembre 2011.
Référence de publication: 2012018981/95.
(120023055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Parker Hannifin Holding EMEA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 158.169.
EXTRAIT
Selon l'acte d'apport du 24 juin 2011, Parker Hannifin Luxembourg Acquisitions S.à r.l., apporte les 12.501 parts sociales
qu'elle détient dans la Société à Parker Hannifin Partner I GP une société en nom collectif ayant son siège social au
Clarendon House. 2 Church Street, Hamilton, HM 11 Bermudes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
des Bermudes sous le numéro 45446 Ainsi Parker Hannifin Partner I GP devient associé unique de Parker Hannifin Holding
EMEA S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 février 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012017973/16.
(120021663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Peninsula Property Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 147.935.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Peninsula Property Development S.à r.l.
i>Signature
<i>Un Géranti>
Référence de publication: 2012017978/12.
(120022210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Parker Hannifin Outbound S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 160.477.
EXTRAIT
Selon l'acte d'apport du 22 juin 2011, Parker Hannifin Luxembourg Acquisitions S.à r.l., apporte les 12.505 parts sociales
qu'elle détient dans la Société à Parker Hannifin Partner I GP une société en nom collectif ayant son siège social au
Clarendon House. 2 Church Street, Hamilton, HM 11 Bermudes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
des Bermudes sous le numéro B45446.
Ainsi Parker Hannifin Partner I GP devient associé unique de Parker Hannifin Outbound S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 février 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012017974/16.
(120021931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
33943
L
U X E M B O U R G
Parker-Migliorini International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 925.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 163.067.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012017975/11.
(120021853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Biocera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 88.269.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Biocera S.A. tenu au siège de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> juin 2011i>
Tous les Actionnaires sont présents.
Les Actionnaires ont pris les décisions suivantes:
Les Actionnaires décident:
- de renouveler les mandats des administrateurs et administrateur délégué pour une nouvelle période de six ans à
dater de ce jour et qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.
1) Mme LEVY Fabienne, Administrateur, demeurant à 1, Rue Mazagran F-54000 NANCY. Mme LEVY Fabienne est
également nommée Administrateur délégué avec pouvoir de signature individuelle.
2) M. LELOUP Raynald, Administrateur, demeurant à 12, Rue des Loups F-57590 ABONCOURT-SUR-SEILLE.
3) Mme THIBAUT Marie-Aude, Administrateur, demeurant à 1, Rue Keup L-1860 Luxembourg.
- De révoquer la société CONCORD INTERNATIONAL MARKETING SARL (B50577) ayant son siège social à 165
A, Route de Longwy L-4751 PETANGE en tant que Commissaire aux comptes.
- De nominer la société PRISMA CONSULTING SARL (B 101674) ayant son siège social à Z.I. de Kehlen L-8287
KEHLEN en tant que nouveau Commissaire aux comptes pour une période qui viendra à échéance lors de l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2017.
Les décisions ont été admises à l'unanimité.
Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
BIOCERA S.A.
Mme LEVY Fabienne / Mme THIBAUT Marie-Aude / M. LELOUP Raynald
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012018097/27.
(120021918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
OCM Luxembourg Yachts Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 149.223.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé Unique de la Société prises le 3 février 2012i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- De transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 26A, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg avec effet rétroactif au 1
er
juin 2011;
- En conséquence de ce transfert, l'adresse professionnelle de Monsieur Szymon DEC devient également 26A, boule-
vard Royal L-2449 Luxembourg;
- D'accepter la démission de Mr Jean-Pierre BACCUS de son poste de Gérant de la Société avec effet immédiat;
- De nommer Mr Jabir CHAKIB, né le 5 novembre 1967 à Casablanca (Maroc) ayant son adresse professionnelle au
26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33944
L
U X E M B O U R G
Hervé Leclercq
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012018685/21.
(120023089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Superlift Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.700,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 122.459.
EXTRAIT
Par résolution écrite en date du 31 janvier 2012, les associés de la Société ont décidé:
- de constater et d'accepter la démission, avec effet au 26 janvier 2012 de Till Hufnagel de son mandat de gérant de
catégorie B de la Société;
- de nommer Stephan Eilers, né le 7 octobre 1959 à Bonn en Allemagne et ayant son adresse professionnelle à: Im
Zollhafen 24, 50678 Cologne, Allemagne en tant que gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 27 janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Superlift Holding S.à r.l.
i>Stefan Lambert
<i>Gérant de catégorie Ai>
Référence de publication: 2012018141/18.
(120021725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
HMTF CPD Canada Luxco S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 191.808,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 113.271.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette,
There appear:
(1) Whiskey Trail Investments, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the United States of
America with registered office at 53, 16528 State Highway, USA - 73458 Springer, Oklahoma, United States of America,
registered with the IRS under the number FEDER.ID NUMBER 20-3895969, holder of 165 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of at-
torney given under private seal;
(2) HMTF Fund V Cayman, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Isles with registered
office at 36A, Dr. Roy's Drive, KY - 1043GT Grand Cayman, Cayman Isles, registered with the Registrar of Exempted
Limited Partnerships under the number CR-12476, holder of 5,373 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(3) HM5-P Coinvestors Cayman L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Isles with
registered office at 36A, Dr. Roy's Drive, KY - 1043GT Grand Cayman, Cayman Isles, registered with the Registrar of
Exempted Limited Partnerships under the number CR-12473, holder of 110 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(4) The MacDonald Family Trust, a trust under the laws of Alberta with registered office at 11116, 33
rd
Avenue NW,
CDN - T6J 3Y3 Edmonton, Alberta, Canada, registered with the Tax Registration under the number T27639910, holder
of 25 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(5) BVT Associates Inc, a public limited liability company incorporated under the laws of Canada with registered office
at 6029, Rideau Valley Drive, CDN - K4M 1B2 Manotick, Ontario, Canada, registered with the Industry Canada under
the number 419737-2, holder of 4 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
33945
L
U X E M B O U R G
(6) HM5-E Coinvestors Cayman L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Isles with
registered office at 36A, Dr. Roy's Drive, KY - 1043GT Grand Cayman, Cayman Isles, registered with the Registrar of
Exempted Limited Partnerships under the number CR-12692, holder of 7 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(7) Richard M. and Cheryl A. Dailey Trust, a trust company incorporated under the laws of the United States of America
with registered office at 10353, Burned Oak Lane, USA - 92026 Escondido, California, United States of America, registered
with the IRS under the number TAX ID NUMBER 130 48 4391, holder of 10 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(8) LaVelle Investments LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the United States of America
with registered office at 89697, Scheffler Rd, USA - OR 97437 Elmira, United States of America, registered with the
Secretary of State of Oregon under the number 363326-90, holder of 15 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(9) Jennifer Anne Rikely, with professional address at 23, 1201 Lameys's Mill Road, CDN - V6H 3S8 Vancouver, BC,
Canada, holder of 1 share of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(10) Raysa Evelyn Hidalgo Tejada, with professional address at 99, Avenue Rd, CDN - M5R 2G5 PH06 Toronto ON,
Canada, holder of 2 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(11) Daniel J. Hopkin, with professional address at 344, Cove Drive, USA - TX 75019 Coppell, United States of America,
holder of 1 share of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(12) Cameron Mehlenbacher, with professional address at 200, Panorama Rd, CDN - BC V0N 2E0 Lions Bay, Canada,
holder of 1 share of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(13) Shi Zheng, with professional address at 2904, Wren Lane, USA - 75082-3122 Richardson, Texas, United States
of America, holder of 1 share of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(14) Peter Scott, with professional address at 21183, 58
th
Avenue, CDN - BC V1M 253 Ft. Langley, Canada, holder
of 3 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
(15) John Junghun Park, with professional address at 729, Escondido Road, Apt. 424, USA - CA 94305-7579 Stanford
- United States of America, holder of 1 share of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal; and
(16) Olivier Vincent, with professional address at 1909, Taylor Creek Place, CDN - North Vancouver, British Columbia,
Canada, holder of 7 shares of the Company,
hereby represented by François Bernard, by virtue of a power of attorney given under private seal;
The appearing parties referred to under items (1) to (16) above are collectively referred to below as the Shareholders.
The powers of attorney of the Shareholders, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Share-
holders and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.
The Shareholders, represented as stated above, request the undersigned notary to record that:
I. The Shareholders collectively hold all the 5,726 (five thousand seven hundred and twenty-six) shares representing
the entire subscribed share capital of HMTF CPD CANADA LUXCO S.à r.l. (the Company), a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 113.271, incorporated on
15 December 2005 pursuant to a notarial deed recorded by Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch
(Luxembourg), published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations), n° 672 dated 1 April 2006 The Company has been dissolved and put into liquidation by a
deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg dated 30 December 2010, published in the Official Gazette
(Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) n° 631 dated 4 April
2011.
II. The Shareholders wish to pass resolutions on the following items:
1. Waiver of convening notices;
2. Presentation of the report of the liquidation auditor (commissaire à la liquidation);
3. Discharge (quitus) to Fides (Luxembourg) S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme),
having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies register under number B 41.469 as liquidator of the Company, for all its duties during, and in connection
with, the liquidation of the Company;
33946
L
U X E M B O U R G
4. Discharge (quitus) to Euraudit S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limi-
tée), having its registered office at 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies register under number B 42.889 as liquidation auditor (commissaire à la liquidation), for all its duties during,
and in connection with, the liquidation of the Company;
5. Decision to close the liquidation of the Company on the date of this deed; and
6. Decision to set the place where the Company's books and corporate documents are to be kept during five years
following the publication of the closing of the liquidation in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations) at the following address: 46A, Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg.
After deliberation, the Shareholders passed, by a unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entire share capital of the Company being represented, the Shareholders waive the convening notices, consider
themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them
in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders hear and resolve to accept the report of Euraudit S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 42.889 (appointed liquidation auditor (commissaire
à la liquidation) by the shareholders of the Company on 21 December 2011), on the good performance of the actions
taken and the reports presented by Fides (Luxembourg) S.A., a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg trade and companies register under number B 41.469 (appointed liquidator (liquidateur) of the Company by the
extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 30 December 2010) (the Liquidator) during
the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to give full discharge (quitus) to Fides (Luxembourg) S.A., a Luxembourg public limited liability
company (société anonyme), having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 41.469 as Liquidator, for all its duties during, and in
connection with, the liquidation of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to give full discharge (quitus) to Euraudit S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 42.889 as liquidation auditor (commissaire à la
liquidation), for all its duties during, and in connection with, the liquidation of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
After considering that the outstanding liabilities of the Company have all been discharged and that no liquidation
proceeds are outstanding, the Shareholders resolve to close the liquidation on the date of this deed.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve to set the place where the Company's books and corporate documents are to be kept during
five years following the publication of the closing of the liquidation in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-
Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) at the following address: 46A, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company in relation to the present deed is estimated to be approximately one thousand two hundred euro (€
The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the proxyholder of
the above appearing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of
the proxyhokder of the appearing persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the
English version shall prevail.
Whereas, this notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, the said proxyholder signed together
with us, the notary the present original deed.
33947
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
Comparaissent:
(1) Whiskey Trail Investments, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée sous les
lois des Etats-Unis d'Amérique ayant son siège social au 53, 16528 State Highway, USA -73458 Springer, Oklahoma, United
States of America, immatriculée auprès de l'IRS sous le numéro FEDER.ID NUMBER 20-3895969, détentrice de 165 parts
sociales de la Société,
ici représentée par François Bernard, avocat, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé;
(2) HMTF Fund V Cayman, L.P., un limited partnership constitué sous les lois des Iles Cayman ayant son siège social
au 36A, Dr. Roy's Drive, KY - 1043GT Grand Cayman, Cayman Isles, immatriculé auprès du Registrar of Exempted
Limited Partnerships sous le numéro CR-12476, détenteur de 5.373 parts sociales de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(3) HM5-P Coinvestors Cayman L.P., un limited partnership constitué sous les lois des Iles Cayman ayant son siège
social au 36A, Dr. Roy's Drive, KY - 1043GT Grand Cayman, Cayman Isles, immatriculé auprès du Registrar of Exempted
Limited Partnerships sous le numéro CR-12476, détenteur de 110 parts sociales de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(4) The MacDonald Family Trust, un trust constitué sous les lois d'Alberta ayant son siège social au 11116, 33
rd
Avenue
NW, CDN - T6J 3Y3 Edmonton, Alberta, Canada, immatriculée auprès du Tax Registration sous le numéro T27639910,
détentrice de 25 parts sociales de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(5) BVT Associates Inc, une société anonyme constituée sous les lois du Canada ayant son siège social au 6029, Rideau
Valley Drive, CDN - K4M 1B2 Manotick, Ontario, Canada, immatriculée auprès du Industry Canada sous le numéro
419737-2, détentrice de 4 parts sociales de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(6) HM5-E Coinvestors Cayman L.P., un limited partnership constitué sous les lois des Iles Cayman ayant son siège
social au 36A, Dr. Roy's Drive, KY - 1043GT Grand Cayman, Cayman Isles, immatriculé auprès du Registrar of Exempted
Limited Partnerships sous le numéro CR-12476, détenteur de 7 parts sociales de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(7) Richard M. and Cheryl A. Dailey Trust, une trust company constituée sous les lois des Etats-Unis d'Amérique ayant
son siège social au 10353, Burned Oak Lane, USA - 92026 Escondido, California, United States of America, immatriculée
auprès de l'IRS sous le numéro TAX ID NUMBER 130 48 4391, détentrice de 10 parts sociales de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(8) LaVelle Investments LLC, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois des Etats-Unis d'Amérique
ayant son siège social au 89697, Scheffler Rd, USA - OR 97437 Elmira, United States of America, immatriculée auprès du
Secretary of State of Oregon sous le numéro 363326-90, détentrice de 15 parts sociales de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(9) Jennifer Anne Rikely, demeurant professionnellement au 23, 1201 Lameys's Mill Road, CDN - V6H 3S8 Vancouver,
BC, Canada, détentrice d'1 part sociale de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(10) Raysa Evelyn Hidalgo Tejada, demeurant professionnellement au 99, Avenue Rd, CDN - M5R 2G5 PH06 Toronto
ON, Canada, détentrice de 2 parts sociales de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(11) Daniel J. Hopkin, demeurant professionnellement au 344, Cove Drive, USA - TX 75019 Coppell, United States
of America, détenteur d'1 part sociale de la Société,
ici représenté par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(12) Cameron Mehlenbacher, demeurant professionnellement au 200, Panorama Rd, CDN - BC V0N 2E0 Lions Bay,
Canada, détentrice d'1 part sociale de la Société,
ici représentée par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(13) Shi Zheng, demeurant professionnellement au 2904, Wren Lane, USA - 75082-3122 Richardson, Texas, United
States of America, détenteur d'1 part sociale de la Société,
ici représenté par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
(14) Peter Scott, demeurant professionnellement au 21183, 58
th
Avenue, CDN - BC V1M 253 Ft. Langley, Canada,
détenteur de 3 parts sociales de la Société,
ici représenté par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
33948
L
U X E M B O U R G
(15) John Junghun Park, demeurant professionnellement au 729, Escondido Road, Apt. 424, USA - CA 94305-7579
Stanford - United States of America, détenteur d'1 part sociale de la Société,
ici représenté par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
(16) Olivier Vincent, demeurant professionnellement au 1909, Taylor Creek Place, CDN - North Vancouver, British
Columbia, Canada, détenteur de 7 parts sociales de la Société,
ici représenté par François Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Les parties comparantes mentionnées aux points (1) à (16) ci-dessus sont collectivement désignées ci-dessous comme
les Associés.
Les procurations des Associés, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des Associés et par le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, requièrent le notaire instrumentant d'acter ce que:
I. Les Associés détiennent collectivement toutes les 5.726 (cinq mille sept cent vingt-six) parts sociales, représentant
l'intégralité du capital social de HMTF CPD CANADA LUXCO S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.271, constituée suivant acte reçu par Maître Henri
Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch (Luxembourg), en date du 15 Décembre 2005, publié au Journal Officiel
du Grand Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 672 du 1 avril 2006. La Société a
été dissoute et mise en liquidation par acte notarié du 30 décembre 2010, publié au Journal Officiel du Grand Duché de
Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 631 du 4 avril 2011;
II. Les Associés souhaitent passer des résolutions sur les points suivants:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Présentation du rapport du commissaire à la liquidation;
3. Décharge (quitus) à accorder à Fides (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés sous le numéro B 41.469 en tant que liquidateur de la Société;
4. Décharge (quitus) à accorder à Euraudit S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant
son siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés
sous le numéro B 42.889 en tant que commissaire à la liquidation de la Société;
5. Clôture de la liquidation de la Société à la date du présent acte; et
6. Décision de déposer et conserver les livres et documents sociaux de la Société pendant cinq ans, à partir de la date
de publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations à l'adresse suivante: 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Après délibération, les Associés ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée, les Associés renoncent aux formalités de convocation,
se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
préalablement communiqué.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés prennent connaissance et acceptent le rapport d'Euraudit S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, immatriculée auprès du registre
de commerce et des sociétés sous le numéro B 42.889 (nommé commissaire à la liquidation par les associés de la Société
le 21 décembre 2011), sur la bonne exécution par Fides (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de com-
merce et des sociétés sous le numéro B 41.469 (nommé liquidateur de la Société par l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la Société tenue en date du 30 décembre 2010) (ci-après, le Liquidateur), de ses fonctions et activités en
relation avec la liquidation volontaire de la Société décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de
la Société tenue le 30 décembre 2010.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés accordent décharge (quitus) à Fides (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de com-
merce et des sociétés sous le numéro B 41.469, en tant que Liquidateur, pour l'exécution de tous ses devoirs et obligations
pendant, et en relation avec, la liquidation de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés accordent décharge (quitus) à Euraudit S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois ayant son siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et
33949
L
U X E M B O U R G
des sociétés sous le numéro B 42.889, en tant que commissaire à la liquidation de la Société, pour l'exécution de tous
ses devoirs et obligations pendant, et en relation avec, la liquidation de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés prennent connaissance de ce que toutes les dettes de la Société ont été payées et qu'il n'y a pas de boni
de liquidation dus et payables aux Associés et décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société à la date du
présent acte.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq
ans, à partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, à l'adresse suivante: 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par
la Société se rapportant au présent acte est estimé à environ mille cinq euros (€ 1.500,-).
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du mandataire des
comparants, le présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande du
mandataire des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé ensemble avec le notaire
le présent acte.
Signé: Bernard, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2012. Relation: EAC/2012/434. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012014739/277.
(120017637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Utah JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 148.852,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 141.982.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth of January;
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED
CEREP III Sweden S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under
number B 128.648,
here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal on 23 January 2012. The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing
party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Utah JV S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) (the "Company"), established and having its registered office at 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Registry under number B 141.982, incorporated by deed drawn up by Maître Joseph Elvinger, on 23 September
2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2530, page 121427,
dated 16 October 2008. The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of
Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 13 December 2011, not yet published in the Mémorial.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of four thousand five hundred
Euros (EUR 4,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) up
to seventeen thousand Euros (EUR 17,000.-) by the issue of ninety (90) shares, having a nominal value of fifty Euros (EUR
33950
L
U X E M B O U R G
50.-) each and having the same rights and obligations as the existing shares of the Company (referred to as the "New
Shares").
The New Shares are wholly subscribed by the Sole Shareholder and paid up by a contribution in cash for an aggregate
amount of four thousand five hundred Euros (EUR 4,500.-) (the "Contribution") which shall be allocated to the share
capital of the Company.
Evidence of the Contribution has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital from Euro to Swedish Krona at an exchange
rate fixed on 19 January 2012 (SEK 8.756 for EUR 1.-), so that the Company's share capital is fixed at one hundred and
forty-eight thousand eight hundred and fifty-two Swedish Krona (SEK 148,852.-) and, further to the change of currency
of the share capital of the Company, to change the nominal value of the existing shares which shall be one Swedish Krona
(SEK 1.-) per share so that the Sole Shareholder now holds one hundred and forty-eight thousand eight hundred and fifty-
two (148,852) shares in the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolutions the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of
article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:
" Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at one hundred and forty-eight thousand eight hundred and fifty-two Swedish Krona
(SEK 148,852.-) represented by one hundred and forty-eight thousand eight hundred and fifty-two (148,852) shares. Each
share has a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1) (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares
are together referred to as the "Shareholders"."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand four hundred Euros (EUR 1.400,-).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party known to the notary by its name, civil status and residence,
the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-quatre janvier;
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, instrumentant;
A COMPARU:
CEREP III Sweden S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.648,
ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé le 23 janvier 2012. Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire
de la partie comparante et la partie comparante et le notaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
lui.
Laquelle partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") d'une société à responsabilité limitée Utah JV S.à
r.l." (la "Société"), établie et ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 141.982, constituée par
un acte de Maître Joseph Elvinger, le 23 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
"Mémorial") le 16 octobre 2008, numéro 2530, page 121427. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un
acte de Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 décembre 2011, pas encore publié au Mémorial.
La partie comparante représentant l'entièreté du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre mille cinq cents euros (EUR
4.500,-), afin de l'augmenter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à dix-sept mille euros
(EUR 17.000,-), par la création et l'émission de quatre-vingt-dix (90) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante
euros (EUR 50,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la Société (désignées
les "Nouvelles Parts Sociales").
33951
L
U X E M B O U R G
Les Nouvelles Parts Sociales sont intégralement souscrites par l'Associé Unique et libérées par un apport en numéraire
pour un montant total de quatre mille cinq cents euros et (EUR 4.500,-) (l' "Apport") lequel sera alloué au capital social
de la Société.
La preuve de l'Apport a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la devise du capital social d'euros en couronnes suédoises selon le taux de change
fixé au 19 janvier 2012 (SEK 8,756 pour EUR 1,-), de telle sorte que le capital social de la Société est fixé à cent quarante-
huit mille huit cent cinquante-deux couronnes suédoises (SEK 148.852,-) et, par suite du changement de devise de capital
social de la Société, de modifier la valeur nominale des parts sociales existantes qui sera d'une couronne suédoise (SEK
1,-) par part sociale, de telle sorte que l'Associé Unique détient désormais cent quarante-huit mille huit cent cinquante-
deux (148.852) parts sociales dans la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Par suite des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des
statuts de la Société qui sera rédigé désormais comme suit:
" Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital souscrit est fixé cent quarante-huit mille huit cent cinquante-deux couronnes suédoises (SEK 148.852,-)
représenté par cent quarante-huit mille huit cent cinquante-deux (148.852) parts sociales, ayant une valeur nominale
d'une couronne suédoise (SEK 1,-) chacune (ci-après les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis
ci-après comme les "Associés"."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison du présent acte, est évalué à environ EUR 1.400,-(mille quatre cents Euros).
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, dont le notaire connaît le nom,
état civil et domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S.LECOMTE, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 25 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3926. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I.THILL.
Référence de publication: 2012016966/116.
(120020427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.
Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 82.605.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012017976/10.
(120021608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Vector Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.349.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement du 12 janvier 2012 que:
1. l'assemblée a pris note des démissions des administrateurs, Monsieur Khagani Bashirov, Monsieur Jean Riwers et
de la démission de l'administrateur et administrateur-délégué Monsieur Ulvi Kasimov. L'assemblée a décidé de nommer
33952
L
U X E M B O U R G
comme administrateurs Monsieur Muslim GEDYGUSHEV, dirigeant de sociétés, né le 14 décembre 1974 à Tallinn (Es-
tonie), demeurant professionnellement au 3 st., Zakharyevskaya, 191123, Saint-Pétersbourg (Russie) et Monsieur Elmar
Baghirzade, employé privé, né le 30 août 1961 à Bakou, Azerbaïdjan, demeurant à L-1361 Luxembourg, 5, Ordre de la
Couronne de Chêne. L'assemblée a décidé de réduire le nombre des membres du Conseil d'Administration de quatre à
trois. Le mandat des administrateurs nommés prendra fin lors de l'assemblée générale de l'an 2013.
2. L'assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes FIDEX AUDIT S.à r.l. (RCS Luxembourg B48513),
avec siège social établi à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse. L'assemblée décide de nommer en tant que
nouveau Commissaire aux Comptes la société International Stratégie Advisory S.à r.l. (RCS Luxembourg B-138010), avec
siège social établi à L - 2320 Luxembourg, 21, Boulevard de la Pétrusse. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée
générale annuelle de l'an 2013.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la suite de l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement du 12 janvier 2012 que le siège de la société a été transféré au 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2012018146/29.
(120021815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Vitol Holding II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 43.512.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of January.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg. Is held an extraordinary general meeting (the
Meeting) of the sole shareholder of Vitol Holding II S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme),
having its registered office at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 43.512, incorporated pursuant to a deed in Curaçao dated 13 December
1989 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for
the last time pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer residing in Luxembourg, dated December 30, 2011 not yet
published in the Luxembourg Mémorial C.
The Meeting is opened by the Chairman, Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue
Cents.
The Chairman appoints as Secretary of the Meeting, Solange Wolter, with professional address in L-1319 Luxembourg,
101, rue Cents.
The General Meeting elects as Scrutineer of the Meeting, Arlette Siebenaler, with professional address in L-1319
Luxembourg, 101, rue Cents.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. Suppression of articles 19.5., 19.6. and 19.7. of the Articles with effect as of 31 December 2011;
2. Renumbering with effect as of 31 December 2011 of articles 19.8. to 19.15. into articles 19.5. to 19.12. as a result
of the suppression in item 1. above.;
3. Amendment to the new article 19.6. of the Articles with effect as of 31 December 2011;
4. Amendment to the new article 19.7. of the Articles with effect as of 31 December 2011;
5. Amendment to the article 20.2. of the Articles with effect as of 31 December 2011;
6. Amendment to the article 20.3. of the Articles with effect as of 31 December 2011;
7. Amendment to the article 20.5. of the Articles with effect as of 31 December 2011; and
8. Miscellaneous.
II. The proxyholder representing the sole shareholder and the number of the shares it holds are shown on an atten-
dance list. This attendance list as well as the proxy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party,
the officers of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the issued share capital of the Company is represented at the Meeting,
so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.
IV. The Meeting takes the following resolutions:
33953
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to suppress articles 19.5., 19.6. and 19.7. of the Articles with effect as of 31 December 2011.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to renumber with effect as of 31 December 2011 articles 19.8. to 19.15. into articles 19.5. to
19.12. as a result of the suppression in the above resolution.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend the new article 19.6. of the Articles which shall henceforth read as follows with effect
as of 31 December 2011:
“ 19.6. If amounts have been written off from reserve accounts in order to cover losses that have been suffered, the
profit of future years shall be allocated as follows:
Due amounts written off from the reserve accounts D and/or P shall be reallocated to these accounts, beginning with
the reserve account P of the oldest year and in the last instance to the reserve account D of the most recent year.”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the new article 19.7. of the Articles which shall henceforth read as follows with effect
as of 31 December 2011:
“ 19.7. The General Meeting of Shareholders may, provided such resolution is taken by the meeting unanimously and
representing the entire issued capital, deviate from one or more provisions of paragraphs 19.5. and 19.6.”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the article 20.2. of the Articles which shall henceforth read as follows with effect as
of 31 December 2011:
“ 20.2. Out of the balance of the Company's assets remaining after payment of all debts, shall first be distributed to
the holders of shares Di, and secondly to the holders shares P an amount corresponding to the total of (i) the par value
of such shares, and (ii) any entitlements pertaining to such shares which have not been waived by the holders concerned;
thereafter there shall as far as possible be distributed to the holders of the Di shares the amounts of funds in the cor-
responding reserve accounts Di. Thereafter, unless and to the extent paragraph 20.3. shall apply, the amounts of the
reserve accounts P of the various years shall be paid to the holders of the corresponding shares P in pro rata to the
nominal share capital paid on the relative shares.
The balance remaining after the above-mentioned distributions shall only and finally be paid to the holders of shares
D pro rata to the nominal share capital paid on their shares, without prejudice to paragraph 20.3.”
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the article 20.3. of the Articles which shall henceforth read as follows with effect as
of 31 December 2011:
“ 20.3. If the allocations set forth in paragraph 19.5 have been made in full the balance shall, in deviation from paragraph
20.2., in the first instance be applied to compensate for the deficiency of these allocations.”
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to amend the article 20.5. of the Articles which shall henceforth read as follows with effect as
of 31 December 2011:
“ 20.5. All disputes arising in connection with this Article shall be settled by arbitration and paragraph 19.8. shall apply
to such arbitration.”
<i>Declaration - Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingtième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
33954
L
U X E M B O U R G
Se tient une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Vitol Holding II S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.512, constituée suivant un acte
à Curaçao daté du 13 décembre 1989 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 30 décembre 2011, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations de Luxembourg.
L'Assemblée est ouverte par Le Président, Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg,
101, rue Cents.
Le Président désigne comme Secrétaire de l'Assemblée, Solange Wolter, demeurant professionnellement à L-1319
Luxembourg, 101, rue Cents.
L'Assemblée Générale choisit comme Scrutateur de l'Assemblée, Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement
à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
Le bureau de l'Assemblée ayant été ainsi formé, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Suppression des articles 19.5., 19.6. et 19.7. des Statuts avec effet à compter du 31 décembre 2011;
2. Renumérotation avec effet au 31 décembre 2011 des articles 19.8. à 19.15 en articles 19.5. à 19.12. suite à la
suppression susmentionnée au point 1.;
3. Modification du nouvel article 19.6. des Statuts avec effet à compter du 31 décembre 2011;
4. Modification du nouvel article 19.7. des Statuts avec effet à compter du 31 décembre 2011;
5. Modification de l'article 20.2. des Statuts avec effet à compter du 31 décembre 2011;
6. Modification de l'article 20.3. des Statuts avec effet à compter du 31 décembre 2011;
7. Modification de l'article 20.5. des Statuts avec effet à compter du 31 décembre 2011; et
8. Divers.
II. Le mandataire qui représente l'actionnaire unique ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur
une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que la procuration, après signature ne varietur par le mandataire de
la partie comparante, le bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte.
III. Il ressort de ladite liste de présence que la totalité du capital social émis de la Société est représentée à l'Assemblée,
de sorte que l'Assemblée peut valablement statuer sur tous les points à l'ordre du jour.
IV. L'Assemblée prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de supprimer les articles 19.5., 19.6. et 19.7. des Statuts avec effet à compter du 31 décembre
2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de renuméroter avec effet à compter du 31 décembre 2011. les articles 19.8. à 19.15 en articles
19.5. à 19.12. suite à la suppression indiquée dans la résolution précédente.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le nouvel article 19.6. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante avec effet à
compter du 31 décembre 2011:
" 19.6. Si les montants ont été annulés des comptes de réserve afin de couvrir les pertes qui ont été subies, le bénéfice
des années à venir sera affecté comme suit:
Les montants exigibles annulés des comptes de réserve D et/ou P seront réaffectés à ces comptes, premièrement au
compte de réserve P de l'année la plus ancienne et en dernier lieu au compte de réserve D de l'année la plus récente."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le nouvel article 19.7. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante avec effet à
compter du 31 décembre 2011:
" 19.7. L'Assemblée Générale des Actionnaires peut, à condition que cette résolution soit prise à l'unanimité des votes
par l'assemblée et qu'elle représenté la totalité du capital émis, déroger à une ou plusieurs dispositions des paragraphes
19.5. et 19.6."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 20.2. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante avec effet à compter
du 31 décembre 2011:
" 20.2. En-dehors du solde des actifs restants de la Société après paiement de toutes les dettes, il sera distribué aux
détenteurs des actions Di en premier lieu et aux détenteurs des actions P en second lieu, un montant correspondant au
33955
L
U X E M B O U R G
total de (i) la valeur nominale de ces actions, et (ii) tous droits liés à ces actions auxquels les détenteurs en question n'ont
pas renoncé; sur ce les montants des fonds dans les comptes de réserve Di seront distribués dans la mesure du possible
aux détenteurs des actions Di. Sur ce, à moins que et dans la mesure où le paragraphe 20.3. serait applicable, les montants
des comptes de réserve P des nombreuses années seront versés aux détenteurs des actions P correspondantes propor-
tionnellement au capital social nominal versé pour les parts relatives.
Le solde restant après la réalisation des distributions mentionnées ci-dessus sera uniquement et définitivement versé
aux détenteurs des actions D proportionnellement au capital social nominal versé pour leurs actions, sans préjudice du
paragraphe 20.3."
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 20.3. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante avec effet à compter
du 31 décembre 2011:
" 20.3. Si les affectations mentionnées au paragraphe 19.5 ont été effectuées intégralement le solde s'appliquera, par
dérogation au paragraphe 20.2., en premier lieu afin de compenser le déficit de ces affectations."
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 20.5. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante avec effet à compter
du 31 décembre 2011:
" 20.5. Tous litiges découlant du présent Article seront arbitrés et le paragraphe 19.8. sera applicable à cet arbitrage."
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses en raison du présent acte est estimé à environ EUR 1.500,.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie
comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de ladite partie
comparante il est stipulé qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte original.
Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3603. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 février 2012.
Référence de publication: 2012016973/170.
(120020452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.
Project Bird Holding IIIB S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 78.012.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 137.301.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 1 i>
<i>eri>
<i> février 2012i>
L'associé unique de la Société a accepté la démission de M. Ian Michael Stuart Downie et Mme Eva Monica Kalawski
de leurs fonctions de gérant de la Société avec date d’effet au 1
er
février 2012.
L'associé unique de la Société a nommé pour une durée illimitée M. Sunil Sethy, employé privé, né le 27 mars 1951 à
Dehradun Uttranchal en Inde, demeurant professionnellement à Flat n°151, 5
th
Floor, Everest Apartments, Mount plea-
sant Road, Mumbai, 400 006 Inde, comme gérant avec pouvoir de signature A de la Société avec date d’effet au 1
er
février
2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2012.
Référence de publication: 2012017980/17.
(120021805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
33956
L
U X E M B O U R G
Ibralux Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.760.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 janvier 2012i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2016:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg,
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg
Le mandat d'administrateur et de Président du conseil d'administration de Monsieur Guy HORNICK n'est pas renou-
velé.
Est nommé commissaire, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au
31 décembre 2016:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 27 janvier 2012i>
Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant
professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission
ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Référence de publication: 2012018937/29.
(120023324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Project Bird Holding IIIC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 138.937.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 1 i>
<i>eri>
<i> février 2012i>
L'associé unique de la Société a accepté la démission de M. Ian Michael Stuart Downie et Mme Eva Monica Kalawski
de leurs fonctions de gérant de la Société avec date d’effet au 1
er
février 2012.
L'associé unique de la Société a nommé pour une durée illimitée M. Sunil Sethy, employé privé, né le 27 mars 1951 à
Dehradun Uttranchal en Inde, demeurant professionnellement à Flat n°151, 5
th
Floor, Everest Apartments, Mount plea-
sant Road, Mumbai, 400 006 Inde, comme gérant avec pouvoir de signature A de la Société avec date d’effet au 1
er
février
2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2012.
Référence de publication: 2012017981/17.
(120021804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Padostom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 10, rue d'Audun.
R.C.S. Luxembourg B 93.867.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
33957
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 6 février 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012017983/10.
(120021947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Parcis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.531.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PARCIS S.A.
Référence de publication: 2012017985/10.
(120021593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Adler Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.546.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé unique du 31 décembre 2011i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Claudine Schinker, en tant que Gérant de Classe A, et ce avec effet au 23 janvier 2012;
- de nommer Alexandra Petitjean, née le 22 juillet 1979 à Remiremont, France, résidant professionnellement au 20
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg en tant que Gérant de classe A, et ce avec effet au 23 janvier 2012 et
pour une période illimitée.
Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012018087/17.
(120022105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Petercam (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 1A, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 22.418.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012017988/10.
(120022142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Pharus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 90.212.
<i>Rectificatif au dépôt N° L120018105 du 30/01/2012i>
Le Rapport Annuel audité au 30 septembre 2011 et la distribution des dividendes relative à l’Assemblée Générale
Ordinaire du 27 janvier 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012017990/12.
(120021793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
33958
L
U X E M B O U R G
Polyvest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 36.811.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012017993/14.
(120022215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Green'Up S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 166.308.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 03 février 2012:i>
1) L’Assemblée décide d’accepter la démission, avec effet immédiat, de leurs postes d’administrateurs de la société,
Monsieur Daniel Galhano, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg et Monsieur
Laurent Teitgen, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg
2) L’Assemblée décide de nommer, aux postes d’administrateurs de la Société, Monsieur Maurizio Leprini, né le 27
avril 1968 à Roma, Italie, demeurant à Via dei Gladioli 41, I-00042 Anzio Roma, Italie et Monsieur Germano Leprini, né
le 21 octobre 1960 à Pergola, Italie, demeurant à Via Motta 46, I-20069 Vaprio d’Adda, Italie, avec effet immédiat pour
une période débutant ce jour et venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires
de la Société devant se tenir en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GREEN’UP S.A.
Référence de publication: 2012018313/18.
(120022386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Global Financial and Commercial Holdings Coral S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.750.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Global Financial and Commercial
Holdings Coral S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered
office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 164.750 (the Company). The Company has been incorporated
on November 11, 2011 pursuant to a deed enacted by the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended
since the incorporation of the Company.
THERE APPEARED:
Global Financial and Commercial Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) with registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 162.130 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
The said power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
33959
L
U X E M B O U R G
I. The one hundred and twenty-five thousand (125,000) shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR
0.10) each, representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this Meeting which is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notice;
2. Approval of the interim accounts of the Company under Luxembourg general accounting principles;
3. Transfer of the legal seat (siège social) of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Republic of
Italy, at 21, Via Montenapoleone, 20121 Milan (Italy), without liquidation, effective as of the date of registration of the
Company with the Italian register of companies (Registro delle Imprese) (the Effective Date); henceforth renunciation by
the Company to the nationality of Luxembourg and adoption of the Italian nationality (the Transfer);
4. Complete restatement of the Articles so as to conform them to the laws of the Republic of Italy, providing, in
particular, rules about the circulation of the shares, the quorums for the first and the second General Meeting and rules
about the management and the representation of the Company which shall resemble, to the maximum extent possible,
the current Articles of the Company, adoption of the legal form of società a responsabilità limitata, and change of the
corporate denomination of the Company from “Global Financial and Commercial Holdings Coral S.à r.l.” into “Global
Financial and Commercial Holdings Coral Srl” effective as of the Effective Date;
5. Confirmation that the Company will, upon Transfer and change of nationality, remain the owner of all its assets and
liabilities without discontinuity or limitations;
6. Approval that the mandate of the managers of the Company shall continue upon the Transfer and change of natio-
nality;
7. Appointment of any employee and/or lawyer of Stibbe Avocats in Luxembourg and any manager of the Company,
each one of them acting individually, to perform in the Grand-Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection
with the Company moving its registered office from Luxembourg to the Republic of Italy;
8. Appointment of any manager of the Company, each one of them acting individually, as an authorised person within
the meaning of the laws of the Republic of Italy, to perform in the Republic of Italy any acts and formalities in connection
with the Transfer; and
9. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice, the Sole
Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
After the presentation of the interim accounts of the Company for the period ending on December 29, 2011, which
have further been prepared in accordance with Luxembourg accounting law and principles, the Sole Shareholder resolves
to approve these accounts. These accounts, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer, effective as of the Effective Date (as defined hereafter), the legal seat (siège
social) of the Company (the Transfer) from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Republic of Italy, at 21, Via Monte-
napoleone, 20121 Milan (Italy), without liquidation, which shall become the Company’s registered office.
As a result of the Transfer, the Company will henceforth be subject to the laws of the Republic of Italy, has renounced
to the nationality of Luxembourg and adopted the Italian nationality. The change of nationality and the Transfer will be
carried out without interruption in the legal personality of the Company, under the suspensive condition of the registration
of the Company with the Italian register of companies (Registro delle Imprese) (the Effective Date) and will be effective
as of the Effective Date.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the Articles, effective as of the Effective Date, to the extent necessary so as
to conform them to the laws of the Republic of Italy, in the form of the memorandum and articles of association of the
Company as a company governed by the laws of the Republic of Italy, and providing, in particular, rules about the circulation
of the shares, the quorums for the first and the second General Meeting and rules about the management and the
representation of the Company which shall resemble, to the maximum extent possible, the current Articles of the Com-
pany. The meeting decides to approve the contents of the aforementioned proposed restated form of Italian memorandum
and articles of association of the Company.
33960
L
U X E M B O U R G
The Company will further adopt the legal form of società a responsabilità limitata and change its corporate denomi-
nation from “Global Financial and Commercial Holdings Coral S.à r.l.” into “Global Financial and Commercial Holdings
Coral Srl”.
It is understood that the legal requirements set forth under the laws of the Republic of Italy for the registration of the
Company with the Italian register of companies (Registro delle Imprese) need to be accomplished.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confirm that the Company will, upon Transfer and change of nationality, remain the
owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity. The Company will thus continue to own all
its assets and liabilities incurred or entered into before the Transfer and change of nationality.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve that the mandate of Mrs. Mara Vanzetta, Mr. Massimiliano di Maria and Mr.
Rohan Maxwell as managers of the Company shall continue upon the Transfer and change of nationality.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder decides to appoint any employee and/or lawyer of Stibbe Avocats in Luxembourg and any
manager of the Company, each one of them acting individually, to perform in the Grand-Duchy of Luxembourg any acts
and formalities in connection with the Transfer, in particular the removal of the Company from the Luxembourg Register
of Commerce and Companies.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to appoint any manager of the Company, each one of them acting individually, as an
authorised person within the meaning of the laws of the Republic of Italy, to perform in the Republic of Italy any acts and
formalities in connection with the Company moving its registered office from Luxembourg to the Republic of Italy, if any.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,800.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Global Financial and Com-
mercial Holdings Coral S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.750 (la Société). La Société a été constituée le 11 novembre 2011 suivant
acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la
Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
A COMPARU:
Global Financial and Commercial Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.130 (l’Associé Unique),
ici représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante, et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. Les cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées, représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la
présente Assemblée, qui est, par conséquent, régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour
reproduits ci-après;
33961
L
U X E M B O U R G
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation des comptes intérimaires de la Société en vertu des principes comptables généraux luxembourgeois;
3. Transfert du siège social de la Société du Grand-Duché du Luxembourg vers l’Italie, au 21, Via Montenapoleone,
20121 Milan (Italie), sans liquidation, avec effet à la date d’enregistrement de la Société au Registre des Sociétés italien
(Registro delle Imprese) (la Date d'Effectivité); renonciation par la Société à la nationalité luxembourgeoise et acquisition
de la nationalité italienne (le Transfert);
4. Refonte complète des statuts de la Société afin de les adapter à la législation italienne, en prévoyant plus particu-
lièrement les règles concernant la circulation des parts sociales, les règles de quorum pour la première et deuxième
Assemblée Générale, et les règles relatives à la gestion et à la représentation de la Société, qui devront dans la mesure
du possible, se rapprocher des Statuts actuels de la Société; adoption de la forme légale de società a responsabilità limitata,
et modification de la dénomination sociale de la Société de “Global Financial and Commercial Holdings Coral S.à r.l.“ en
“Global Financial and Commercial Holdings Coral Srl”;
5. Confirmation que tous les actifs et passifs de la Société resteront, suite au Transfert et au changement de nationalité,
la propriété de la Société sans discontinuité ni restrictions;
6. Confirmation que les mandats des gérants continueront suite au Transfert et au changement de la nationalité;
7. Mandat donné à tout employé et/ou tout avocat de Stibbe Avocats au Luxembourg et tout gérant de la Société,
chacun d’eux agissant individuellement, afin d’effectuer au Grand-Duché de Luxembourg, tous les actes et formalités en
rapport avec le transfert du siège social de la Société du Luxembourg vers l’Italie;
8. Mandat donné à tout gérant de la Société, chacun d’eux agissant individuellement, en qualité de personne autorisée
selon les termes des lois italiennes, afin d’effectuer en Italie, tous les actes et formalités en rapport avec le Transfert; et
9. Divers.
Ces faits exposés, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a requis le notaire instrumentant
d’enregistrer les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l’As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
Après la présentation des comptes intérimaires de la Société de la période prenant fin au 29 décembre 2011, préparés
en vertu des règles et principes comptables luxembourgeois, l’associée unique décide d’approuver ces comptes. Ces
comptes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, res-
teront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associée Unique décide de transférer, avec effet à la Date d’Effectivité (telle que définie ci-après), le siège social de
la Société (le Transfert), sans liquidation, du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, au 21, Via Montenapoleone, 20121
Milan (Italie), ce qui sera le siège social de la Société.
En conséquence du Transfert, la Société sera dorénavant soumise à la législation italienne, a renoncé à la nationalité
luxembourgeoise et a acquis la nationalité italienne. Le changement de nationalité et le Transfert s’effectueront sans
interruption de la personnalité morale de la Société, sous la condition suspensive de l’enregistrement de la Société au
Registre des Sociétés italien (Registro delle Imprese) (la Date d'Effectivité), et seront effectifs à la Date d’Effectivité.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les Statuts, avec effet à la Date d’Effectivité dans la mesure nécessaire afin de les mettre
en conformité avec la législation italienne, dans la forme du mémorandum et des statuts de la Société en tant que société
régie par la législation italienne, en prévoyant plus particulièrement les règles concernant la circulation des parts sociales,
les règles de quorum pour la première et deuxième Assemblée Générale, et les règles relatives à la gestion et à la
représentation de la Société, qui devront dans la mesure du possible, se rapprocher des Statuts actuels de la Société.
L'Assemblée décide d'approuver le contenu et texte desdits mémorandum et statuts modifiés de la Société.
La Société adoptera également la forme légale de società a responsabilità limitata, et changera sa dénomination sociale
de “Global Financial and Commercial Holdings Coral S.à r.l.“ en “Global Financial and Commercial Holdings Coral Srl”.
Il est entendu que les formalités prévues par la législation italienne pour l’enregistrement de la Société au Registre des
Sociétés italien (Registro delle Imprese) devront être exécutées.
33962
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associée Unique décide de confirmer que la Société demeurera, suite au Transfert et au changement de nationalité,
propriétaire de l’ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations ni discontinuité. La Société continuera dès lors d’être
propriétaire de tous ses actifs et passifs encourus ou nés avant le Transfert et le changement de nationalité.
<i>Sixième résolutioni>
L’Associée Unique décide d’approuver le fait que les mandats de Mme Mara Vanzetta, M. Massimiliano di Maria et M.
Rohan Maxwell en tant que gérants de la Société continueront suite au Transfert et au changement de nationalité.
<i>Septième résolutioni>
L’Associée Unique décide de donner mandat à tout employé et/ou avocat de Stibbe Avocats au Luxembourg et tout
gérant de la Société, chacun d’eux agissant individuellement, afin d’effectuer au Grand-Duché de Luxembourg, tous les
actes et formalités en rapport avec le transfert du siège social de la Société du Luxembourg vers l’Italie, et en particulier
la radiation de la Société du Registre du Commerce.
<i>Huitième résolutioni>
L’Associée Unique décide de donner mandat à tout gérant de la Société, chacun d’eux agissant individuellement, en
qualité de personne autorisée selon les termes des lois italiennes, afin d’effectuer en Italie, tous les actes et formalités en
rapport avec le Transfert, dans la mesure du nécessaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.800,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé ensemble avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: T. SOMMEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1515. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Référence de publication: 2012018292/217.
(120022793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
PRH Management, Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 112, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 138.536.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012017994/11.
(120021667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Quartier Kirchberg-Luxembourg, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 9.789.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33963
L
U X E M B O U R G
<i>Pour Quartier Kirchberg Luxembourg s.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012017996/11.
(120021637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Ship Luxco Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 156.893.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 31 janvier 2012, d’accepter la démission avec effet
immédiat de:
- Madame Maike KIESELBACH et de Monsieur Desmond MITCHELL.
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 31 janvier 2012, de nommer en tant que en tant
que Administrateur de catégorie A de la Société avec effet immédiat:
- Madame Myriam DELTENRE, née le 16 février 1963 à Arlon, Belgique, résidant au 48, Le Pas de Loup, B-6791
Guerlange, Belgique, et
- Monsieur Fergal O'HANNRACHAIN, né le 27 novembre 1964 à Dublin, Irlande, résidant au 7 rue Tubis, L-2629
Luxembourg, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 février 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012018022/20.
(120022044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Regent House (Brentwood) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 140.401.
Par résolution prise en date du 18 janvier 2012, l'associe unique a accepte la démission de René Beltjens, avec adresse
professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 17 janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2012.
Référence de publication: 2012017997/12.
(120021953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Restaurant Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.171.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63738 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012017999/10.
(120022104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Roermond Holding (No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 84.836.
Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018000/9.
(120021645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
33964
L
U X E M B O U R G
Roermond Holding (No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 84.770.
Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018001/9.
(120021644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
RE Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 95.208.
EXTRAIT
Il résulte du contrat de transfert signé en date du 30 janvier 2012, que les 500 (cinq cents) parts sociales de la Société
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune ont été transférées à Mme Cecilia Bertoni, avec adresse à Via di
Vorno n°67-73, 55060 Vorno-Capannori (LU), Italie.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012018003/14.
(120021878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Global Financial and Commercial Holdings Pink S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.823.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Global Financial and Commercial
Holdings Pink S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered
office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 163.823 (the Company). The Company has been incorporated
on October 3, 2011 pursuant to a deed enacted by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 2857, page 137115, dated November 23, 2011. The articles of association of the Com-
pany (the Articles) have not been amended since the incorporation of the Company.
THERE APPEARED:
Global Financial and Commercial Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) with registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 162.130 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
The said power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. The one hundred and twenty-five thousand (125,000) shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR
0.10) each, representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this Meeting which is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notice;
2. Change of the term of the first financial period of the Company from December 31, 2011 to December 31, 2012,
the Company having been incorporated on October 3, 2011;
3. Approval of the interim accounts of the Company under Luxembourg general accounting principles;
4. Transfer of the legal seat (siège social) of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Republic of
Italy, at 21, Via Montenapoleone, 20121 Milan (Italy), without liquidation, effective as of the date of registration of the
33965
L
U X E M B O U R G
Company with the Italian register of companies (Registro delle Imprese) (the Effective Date); henceforth renunciation by
the Company to the nationality of Luxembourg and adoption of the Italian nationality (the Transfer);
5. Complete restatement of the Articles so as to conform them to the laws of the Republic of Italy, providing, in
particular, rules about the circulation of the shares, the quorums for the first and the second General Meeting and rules
about the management and the representation of the Company which shall resemble, to the maximum extent possible,
the current Articles of the Company, adoption of the legal form of società a responsabilità limitata, and change of the
corporate denomination of the Company from “Global Financial and Commercial Holdings Pink S.à r.l.” into “Global
Financial and Commercial Holdings Pink Srl” effective as of the Effective Date;
6. Confirmation that the Company will, upon Transfer and change of nationality, remain the owner of all its assets and
liabilities without discontinuity or limitations;
7. Approval that the mandate of the managers of the Company shall continue upon the Transfer and change of natio-
nality;
8. Appointment of any employee and/or lawyer of Stibbe Avocats in Luxembourg and any manager of the Company,
each one of them acting individually, to perform in the Grand-Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection
with the Company moving its registered office from Luxembourg to the Republic of Italy;
9. Appointment of any manager of the Company, each one of them acting individually, as an authorised person within
the meaning of the laws of the Republic of Italy, to perform in the Republic of Italy any acts and formalities in connection
with the Transfer; and
10. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice, the Sole
Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the term of the first financial period of the Company from December 31,
2011 to December 31, 2012, the Company having been incorporated on October 3, 2011.
<i>Third resolutioni>
After the presentation of the interim accounts of the Company for the period ending on December 29, 2011, which
have further been prepared in accordance with Luxembourg accounting law and principles, the Sole Shareholder resolves
to approve these accounts. These accounts, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer, effective as of the Effective Date (as defined hereafter), the legal seat (siège
social) of the Company (the Transfer) from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Republic of Italy, at 21, Via Monte-
napoleone, 20121 Milan (Italy), without liquidation, which shall become the Company's registered office.
As a result of the Transfer, the Company will henceforth be subject to the laws of the Republic of Italy, has renounced
to the nationality of Luxembourg and adopted the Italian nationality. The change of nationality and the Transfer will be
carried out without interruption in the legal personality of the Company, under the suspensive condition of the registration
of the Company with the Italian register of companies (Registro delle Imprese) (the Effective Date) and will be effective
as of the Effective Date.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the Articles, effective as of the Effective Date, to the extent necessary so as
to conform them to the laws of the Republic of Italy, in the form of the memorandum and articles of association of the
Company as a company governed by the laws of the Republic of Italy, and providing, in particular, rules about the circulation
of the shares, the quorums for the first and the second General Meeting and rules about the management and the
representation of the Company which shall resemble, to the maximum extent possible, the current Articles of the Com-
pany. The meeting decides to approve the contents of the aforementioned proposed restated form of Italian memorandum
and articles of association of the Company.
The Company will further adopt the legal form of società a responsabilità limitata and change its corporate denomi-
nation from “Global Financial and Commercial Holdings Pink S.à r.l.” into “Global Financial and Commercial Holdings
Pink Srl”.
It is understood that the legal requirements set forth under the laws of the Republic of Italy for the registration of the
Company with the Italian register of companies (Registro delle Imprese) need to be accomplished.
33966
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confirm that the Company will, upon Transfer and change of nationality, remain the
owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity. The Company will thus continue to own all
its assets and liabilities incurred or entered into before the Transfer and change of nationality.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve that the mandate of Mrs. Mara Vanzetta, Mr. Massimiliano di Maria and Mr.
Rohan Maxwell as managers of the Company shall continue upon the Transfer and change of nationality.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to appoint any employee and/or lawyer of Stibbe Avocats in Luxembourg and any
manager of the Company, each one of them acting individually, to perform in the Grand-Duchy of Luxembourg any acts
and formalities in connection with the Transfer, in particular the removal of the Company from the Luxembourg Register
of Commerce and Companies.
<i>Ninth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to appoint any manager of the Company, each one of them acting individually, as an
authorised person within the meaning of the laws of the Republic of Italy, to perform in the Republic of Italy any acts and
formalities in connection with the Company moving its registered office from Luxembourg to the Republic of Italy, if any.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand eight hundred
euro (EUR 1,800.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Global Financial and Com-
mercial Holdings Pink S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.823 (la Société). La Société a été constituée le 3 octobre 2011 suivant
acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2857, page 137115,
daté du 23 novembre 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
A COMPARU:
Global Financial and Commercial Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.130 (l'Associé Unique),
ici représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante, et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées, représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la
présente Assemblée, qui est, par conséquent, régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour
reproduits ci-après;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification du terme du premier exercice social de la Société du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012, la
Société ayant été constituée le 3 octobre 2011;
33967
L
U X E M B O U R G
3. Approbation des comptes intérimaires de la Société en vertu des principes comptables généraux luxembourgeois;
4. Transfert du siège social de la Société du Grand-Duché du Luxembourg vers l'Italie, au 21, Via Montenapoleone,
20121 Milan (Italie), sans liquidation, avec effet à la date d'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés italien
(Registro delle Imprese) (la Date d'Effectivité); renonciation par la Société à la nationalité luxembourgeoise et acquisition
de la nationalité italienne (le Transfert);
5. Refonte complète des statuts de la Société afin de les adapter à la législation italienne, en prévoyant plus particu-
lièrement les règles concernant la circulation des parts sociales, les règles de quorum pour la première et deuxième
Assemblée Générale, et les règles relatives à la gestion et à la représentation de la Société, qui devront dans la mesure
du possible, se rapprocher des Statuts actuels de la Société; adoption de la forme légale de società a responsabilità limitata,
et modification de la dénomination sociale de la Société de “Global Financial and Commercial Holdings Pink S.à r.l.“ en
“Global Financial and Commercial Holdings Pink Srl”;
6. Confirmation que tous les actifs et passifs de la Société resteront, suite au Transfert et au changement de nationalité,
la propriété de la Société sans discontinuité ni restrictions;
7. Confirmation que les mandats des gérants continueront suite au Transfert et au changement de la nationalité;
8. Mandat donné à tout employé et/ou tout avocat de Stibbe Avocats au Luxembourg et tout gérant de la Société,
chacun d'eux agissant individuellement, afin d'effectuer au Grand-Duché de Luxembourg, tous les actes et formalités en
rapport avec le transfert du siège social de la Société du Luxembourg vers l'Italie;
9. Mandat donné à tout gérant de la Société, chacun d'eux agissant individuellement, en qualité de personne autorisée
selon les termes des lois italiennes, afin d'effectuer en Italie, tous les actes et formalités en rapport avec le Transfert; et
10. Divers.
Ces faits exposés, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a requis le notaire instrumentant
d'enregistrer les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée Unique décide de modifier le terme du premier exercice social de la Société du 31 décembre 2011 au 31
décembre 2012, la Société ayant été constituée le 3 octobre 2011.
<i>Troisième résolutioni>
Après la présentation des comptes intérimaires de la Société de la période prenant fin au 29 décembre 2011, préparés
en vertu des règles et principes comptables luxembourgeois, l'associée unique décide d'approuver ces comptes. Ces
comptes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, res-
teront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associée Unique décide de transférer, avec effet à la Date d'Effectivité (telle que définie ci-après), le siège social de
la Société (le Transfert), sans liquidation, du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, au 21, Via Montenapoleone, 20121
Milan (Italie), ce qui sera le siège social de la Société.
En conséquence du Transfert, la Société sera dorénavant soumise à la législation italienne, a renoncé à la nationalité
luxembourgeoise et a acquis la nationalité italienne. Le changement de nationalité et le Transfert s'effectueront sans
interruption de la personnalité morale de la Société, sous la condition suspensive de l'enregistrement de la Société au
Registre des Sociétés italien (Registro delle Imprese) (la Date d'Effectivité), et seront effectifs à la Date d'Effectivité.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les Statuts, avec effet à la Date d'Effectivité dans la mesure nécessaire afin de les mettre
en conformité avec la législation italienne, dans la forme du mémorandum et des statuts de la Société en tant que société
régie par la législation italienne, en prévoyant plus particulièrement les règles concernant la circulation des parts sociales,
les règles de quorum pour la première et deuxième Assemblée Générale, et les règles relatives à la gestion et à la
représentation de la Société, qui devront dans la mesure du possible, se rapprocher des Statuts actuels de la Société.
L'Assemblée décide d'approuver le contenu et texte desdits mémorandum et statuts modifiés de la Société.
La Société adoptera également la forme légale de società a responsabilità limitata, et changera sa dénomination sociale
de “Global Financial and Commercial Holdings Pink S.à r.l.“ en “Global Financial and Commercial Holdings Pink Srl”.
Il est entendu que les formalités prévues par la législation italienne pour l'enregistrement de la Société au Registre des
Sociétés italien (Registro delle Imprese) devront être exécutées.
33968
L
U X E M B O U R G
<i>Sixième résolutioni>
L'Associée Unique décide de confirmer que la Société demeurera, suite au Transfert et au changement de nationalité,
propriétaire de l'ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations ni discontinuité. La Société continuera dès lors d'être
propriétaire de tous ses actifs et passifs encourus ou nés avant le Transfert et le changement de nationalité.
<i>Septième résolutioni>
L'Associée Unique décide d'approuver le fait que les mandats de Mme Mara Vanzetta, M. Massimiliano di Maria et M.
Rohan Maxwell en tant que gérants de la Société continueront suite au Transfert et au changement de nationalité.
<i>Huitième résolutioni>
L'Associée Unique décide de donner mandat à tout employé et/ou avocat de Stibbe Avocats au Luxembourg et tout
gérant de la Société, chacun d'eux agissant individuellement, afin d'effectuer au Grand-Duché de Luxembourg, tous les
actes et formalités en rapport avec le transfert du siège social de la Société du Luxembourg vers l'Italie, et en particulier
la radiation de la Société du Registre du Commerce.
<i>Neuvième résolutioni>
L'Associée Unique décide de donner mandat à tout gérant de la Société, chacun d'eux agissant individuellement, en
qualité de personne autorisée selon les termes des lois italiennes, afin d'effectuer en Italie, tous les actes et formalités en
rapport avec le Transfert, dans la mesure du nécessaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille huit cents Euros (EUR 1.800.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé ensemble avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: T. SOMMEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1506. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015362/228.
(120018743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Wagner Immobilien Deutschland SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 166.611.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am neunzehnten Januar.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg
erschienen:
Groupe Wagner Luxembourg SA, Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in L-2557 Luxemburg, 9, rue Robert Stüm-
per, einregistriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 153.347,
hier vertreten durch Herrn Pierre Berna, Anwalt, mit Berufsadresse in L-1528 Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 12. Januar 2012.
Die Erschienene hat beschlossen, eine Aktiengesellschaft gemäß folgender Satzung zu gründen:
Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck
Art. 1. Bezeichnung. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Wagner Immobilien Deutschland SA"
gegründet.
Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
33969
L
U X E M B O U R G
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Luxemburg verlegt werden; die Verlegung des Gesellschaftssitzes außerhalb dieser Gemeinde kann nur durch
Beschluss der Hauptversammlung erfolgen.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche
die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem
Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur vollständigen Wiederherstel-
lung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei Auswirkungen
auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft
bleiben wird.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können weitere Betriebstellen, Zweigstellen und Büros sowohl im
Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann durch Beschluss der Aktionäre aufgelöst
werden.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendeiner Form an an-
deren in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwertung dieser Beteiligungen.
Gegenstand der Gesellschaft ist auch der An- und Verkauf, die Erschließung, die Verwaltung und Verwertung von
Immobilien jeglicher Art im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.
Die Gesellschaft kann ihre Immobilien mit Hypotheken belasten.
Die Gesellschaft ist befugt, Anleihen (Obligationen), Pfandbriefe oder ähnliche Schuldverschreibungen zu schaffen und
auszugeben. Des Weiteren ist die Gesellschaft befugt, den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist,
jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit zu gewährleisten.
Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte wie auch sämtliche Transaktionen mobiliarer und immobiliarer Natur tä-
tigen, die direkt oder indirekt an den Gesellschaftszweck anknüpfen oder diesen begünstigen oder fördern können.
Aktienkapital - Aktien
Art. 5. Aktienkapital. Das Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihunder-
tzehn (310) Aktien ohne Nennwert.
Das Aktienkapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, der unter denselben Bedingungen wie
bei Satzungsänderungen zu nehmen ist, erhöht oder reduziert werden.
Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Art. 6. Aktien. Die Aktien werden je nach Belieben des Aktionärs entweder als Namens- oder Inhaberaktien ausge-
geben, mit Ausnahme derjenigen Aktien, die durch Gesetz Namensaktien sein müssen.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einzel- oder als Globalzertifikate, über mehrere Aktien lautend,
ausgestellt werden.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 7. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitglie-
dern besteht, die nicht Aktionäre sein müssen.
Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass
nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung für eine Dauer von maximal sechs Jahren
ernannt.
Sie können von der Hauptversammlung jederzeit abberufen werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind wieder wählbar.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit, für die es gewählt wurde aus, so können die ver-
bleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger für den Rest der Amtsdauer bestellen, soweit
dies gesetzlich zulässig ist. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.
Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des
Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz
oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Die eventuelle Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt.
Art. 8. Vorsitzender. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und, eventuell, einen oder
mehrere stellvertretende Vorsitzende. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben. Der erste Vorsitzende kann von der anschließenden Hauptversammlung ernannt
werden.
Art. 9. Einberufung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
33970
L
U X E M B O U R G
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zu jeder Sitzung mindestens acht (8) Tage vor ihrem Beginn durch schriftliche
Einladung, die eine Tagesordnung zu enthalten hat, in der sämtliche Punkte von Bedeutung für die Sitzung aufgeführt sind,
zu benachrichtigen, außer wenn sich aus Umständen eine besondere Dringlichkeit ergibt. In diesem Falle ist die Natur
dieser Umstände in der Einberufung darzulegen.
Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten, wenn alle Verwaltungs-
ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu
haben.
Die Sitzungen finden an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde statt.
Art. 10. Beschlussfähigkeit. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Vertretung durch
ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder durch ein ähnli-
ches Kommunikationsmittel folgt, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telefax, E-Mail oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden.
Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden von dem Vorsitzenden und vom Schriftführer der betreffenden
Verwaltungsratssitzung unterschrieben.
Im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege, das heißt durch Brief, Telefax oder
E-Mail gefasst werden (Zirkularbeschlüsse).
Die Teilnahme per Videokonferenz oder Benutzung von Telekommunikationsmedien ist erlaubt, vorausgesetzt, dass
jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese Tech-
nologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt per
Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.
Art. 11. Interessenkonflikte. Ein Verwaltungsratsmitglied, das der Gesellschaft gegenüber in einer Angelegenheit, die
dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird, entgegengesetzte Interessen hat, ist verpflichtet, die Verwaltungs-
ratsmitglieder hierüber zu benachrichtigen und muss eine diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben.
Dieses Verwaltungsratsmitglied ist nicht befugt, an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates teilzunehmen.
Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonflikts enthalten muss, werden Beschlüsse,
die durch die Mehrheit des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung gefasst werden, als gültig angesehen.
Art. 12. Gesellschaftsverpflichtung. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden verpflichtet. Im lau-
fenden Verkehr mit den Behörden und der Justiz wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des
Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Im Übrigen wird die Gesellschaft durch Sonderbevollmächtigte im Rahmen ihres Mandats rechtsgültig vertreten.
Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-
testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.
Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsbe-
rechtigt.
Art. 13. Tägliche Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die
Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser Geschäftsführung entweder einem oder mehreren seiner Mitglieder, die
als "geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder" bezeichnet werden, übertragen, oder einer oder mehreren anderen
Personen, die den Titel "Geschäftsführer" tragen.
Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung ist jedes geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied oder jeder Geschäfts-
führer befugt, die Gesellschaft Dritten gegenüber mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig zu verpflichten.
Art. 14. Aufsicht. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem von der Hauptversammlung ernannten Buchprüfer
(commissaire), der nicht Aktionär sein muss. Die Dauer der Amtszeit und die eventuelle Vergütung des Buchprüfers
werden von der Hauptversammlung festgelegt. Die Amtszeit darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten. Der Buchprüfer
ist wieder wählbar. Er kann jederzeit beliebig abberufen werden.
Insofern die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, wird der Buchprüfer (commissaire) durch einen Wirtschaftsprüfer
(réviseur d'entreprises agréé) ersetzt, der unter den Mitgliedern des „Institut des réviseurs d'entreprises" von der Haupt-
versammlung bestimmt wird.
Hauptversammlung
Art. 15. Befugnisse der Hauptversammlung. Die rechtmäßig einberufene Hauptversammlung umfasst alle Aktionäre.
Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind
auch bindend für die Aktionäre, die nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.
33971
L
U X E M B O U R G
Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt gemäß den gesetzlichen Formen und Fristen. Von diesem Erfordernis
kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der
Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie identifi-
zieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit und
Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht geei-
gnet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen
ständig zu übertragen sind.
Art. 16. Ort und Datum. Die Hauptversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung
angegebenen Ort zusammen, und zwar am letzten Freitag des Monats Juni um neun (9.00) Uhr.
Sofern dieser Tag kein Werktag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 17. Stimmrecht. Jede Aktie gibt seinem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes
vorsieht.
Art. 18. Außerordentliche Hauptversammlung. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann von dem Verwaltungs-
rat oder von dem(n) Buchprüfer(n) einberufen werden. Sie muss ebenfalls einberufen werden, wenn eine schriftliche
Anfrage von Aktionären vorliegt, die mindestens zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Hauptver-
sammlung kann die Satzung in jeglicher Weise abändern, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen.
Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverteilung -
Vorschussdividenden - Kapitaltilgung
Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31.
Dezember desselben Jahres.
Art. 20. Jahresabschluss. Der Verwaltungsrat erstellt den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss, der die Bilanz, die
Gewinn-und Verlustrechnung, sowie den Anhang umfasst.
Art. 21. Gewinnausschüttung. Fünf (5) Prozent des Reingewinns fließen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn
(10) Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig, wenn und
solange der Reservefonds zehn (10) Prozent des Nennwertes des Kapitals beträgt. Unter Berücksichtigung der gesetzli-
chen Bestimmungen und auf der Grundlage eines Gewinnverwendungsvorschlags des Verwaltungsrates befindet die
Hauptversammlung über die Verwendung des Saldos. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat
zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung.
Art. 22. Vorschussdividenden. Der Verwaltungsrat kann, soweit gesetzlich zulässig, Vorschussdividenden auszahlen.
Der Verwaltungsrat beschließt den Betrag und das Datum, an dem ein solcher Vorschuss ausgezahlt wird.
Auflösung - Liquidation
Art. 23. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
tionsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Hauptversammlung unter
Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Allgemeine Bestimmung
Art. 24. Allgemeine Bestimmung. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer
auf die luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste ordentliche Hauptversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannte Erschienene hat die Gesamtheit der dreihundertzehn (310) Aktien gezeichnet:
Alle Aktien wurden sofort zu hundert (100) Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag
von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
33972
L
U X E M B O U R G
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, die der Ge-
sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend achthundert Euro (EUR 1.800,-).
<i>Außerordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann trat die eingangs erwähnte Partei, die das gesamte Aktienkapital vertritt, zu einer außerordentlichen Haupt-
versammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennt und fasst, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammen-
setzung dieser Versammlung festgestellt hat, folgende Beschlüsse:
1) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
- Herr Aloyse Wagner, maître-électricien, geboren in Troisvierges am 24. August 1954, mit Berufsadresse in L-2557
Luxemburg, 9, rue Robert Stümper.
- Herr Romain Hartmann, directeur technique, geboren in Luxemburg am 20. Oktober 1970, mit Berufsadresse in
L-2557 Luxemburg, 9, rue Robert Stümper.
- Herr Luc Tapella, directeur financier et administratif, geboren in Luxemburg am 25. Juni 1968, mit Berufsadresse in
L-2557 Luxemburg, 9, rue Robert Stümper.
Die Mandate der Vewaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2016.
2) Es wird zum Buchprüfer (commissaire) ernannt:
G.T. Experts Comptables S.à r.l, mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 121.917.
Das Mandat des Buchprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2016.
3) Herr Aloyse Wagner vorbenannt wird gemäß Artikel 8 der Statuten als Vorsitzender des Verwaltungsrates ernannt.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2557 Luxemburg, 9, rue Robert Stümper.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube, am Datum, wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Gezeichnet: Pierre BERNA, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3337. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks Veröf-
fentlichung erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 25. Januar 2012.
Tom METZLER.
Référence de publication: 2012017065/211.
(120020004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.
Global Financial and Commercial Holdings Yellow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.857.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Global Financial and Commercial
Holdings Yellow S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered
office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 163.857 (the Company). The Company has been incorporated
on October 3, 2011 pursuant to a deed enacted by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 2858, page 137164, dated November 23, 2011. The articles of association of the Com-
pany (the Articles) have not been amended since the incorporation of the Company.
THERE APPEARED:
Global Financial and Commercial Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) with registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 162.130 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
33973
L
U X E M B O U R G
The said power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. The one hundred and twenty-five thousand (125,000) shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR
0.10) each, representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this Meeting which is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notice;
2. Change of the term of the first financial period of the Company from December 31, 2011 to December 31, 2012,
the Company having been incorporated on October 3, 2011;
3. Approval of the interim accounts of the Company under Luxembourg general accounting principles;
4. Transfer of the legal seat (siège social) of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Republic of
Italy, at 21, Via Montenapoleone, 20121 Milan (Italy), without liquidation, effective as of the date of registration of the
Company with the Italian register of companies (Registro delle Imprese) (the Effective Date); henceforth renunciation by
the Company to the nationality of Luxembourg and adoption of the Italian nationality (the Transfer);
5. Complete restatement of the Articles so as to conform them to the laws of the Republic of Italy, providing, in
particular, rules about the circulation of the shares, the quorums for the first and the second General Meeting and rules
about the management and the representation of the Company which shall resemble, to the maximum extent possible,
the current Articles of the Company, adoption of the legal form of società a responsabilità limitata, and change of the
corporate denomination of the Company from “Global Financial and Commercial Holdings Yellow S.à r.l.” into “Global
Financial and Commercial Holdings Yellow Srl” effective as of the Effective Date;
6. Confirmation that the Company will, upon Transfer and change of nationality, remain the owner of all its assets and
liabilities without discontinuity or limitations;
7. Approval that the mandate of the managers of the Company shall continue upon the Transfer and change of natio-
nality;
8. Appointment of any employee and/or lawyer of Stibbe Avocats in Luxembourg and any manager of the Company,
each one of them acting individually, to perform in the Grand-Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection
with the Company moving its registered office from Luxembourg to the Republic of Italy;
9. Appointment of any manager of the Company, each one of them acting individually, as an authorised person within
the meaning of the laws of the Republic of Italy, to perform in the Republic of Italy any acts and formalities in connection
with the Transfer; and
10. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice, the Sole
Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the term of the first financial period of the Company from December 31,
2011 to December 31, 2012, the Company having been incorporated on October 3, 2011.
<i>Third resolutioni>
After the presentation of the interim accounts of the Company for the period ending on December 29, 2011, which
have further been prepared in accordance with Luxembourg accounting law and principles, the Sole Shareholder resolves
to approve these accounts. These accounts, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer, effective as of the Effective Date (as defined hereafter), the legal seat (siège
social) of the Company (the Transfer) from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Republic of Italy, at 21, Via Monte-
napoleone, 20121 Milan (Italy), without liquidation, which shall become the Company's registered office.
As a result of the Transfer, the Company will henceforth be subject to the laws of the Republic of Italy, has renounced
to the nationality of Luxembourg and adopted the Italian nationality. The change of nationality and the Transfer will be
carried out without interruption in the legal personality of the Company, under the suspensive condition of the registration
of the Company with the Italian register of companies (Registro delle Imprese) (the Effective Date) and will be effective
as of the Effective Date.
33974
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the Articles, effective as of the Effective Date, to the extent necessary so as
to conform them to the laws of the Republic of Italy, in the form of the memorandum and articles of association of the
Company as a company governed by the laws of the Republic of Italy, and providing, in particular, rules about the circulation
of the shares, the quorums for the first and the second General Meeting and rules about the management and the
representation of the Company which shall resemble, to the maximum extent possible, the current Articles of the Com-
pany. The meeting decides to approve the contents of the aforementioned proposed restated form of Italian memorandum
and articles of association of the Company.
The Company will further adopt the legal form of società a responsabilità limitata and change its corporate denomi-
nation from “Global Financial and Commercial Holdings Yellow S.à r.l.” into “Global Financial and Commercial Holdings
Yellow Srl”.
It is understood that the legal requirements set forth under the laws of the Republic of Italy for the registration of the
Company with the Italian register of companies (Registro delle Imprese) need to be accomplished.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confirm that the Company will, upon Transfer and change of nationality, remain the
owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity. The Company will thus continue to own all
its assets and liabilities incurred or entered into before the Transfer and change of nationality.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve that the mandate of Mrs. Mara Vanzetta, Mr. Massimiliano di Maria and Mr.
Rohan Maxwell as managers of the Company shall continue upon the Transfer and change of nationality.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to appoint any employee and/or lawyer of Stibbe Avocats in Luxembourg and any
manager of the Company, each one of them acting individually, to perform in the Grand-Duchy of Luxembourg any acts
and formalities in connection with the Transfer, in particular the removal of the Company from the Luxembourg Register
of Commerce and Companies.
<i>Ninth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to appoint any manager of the Company, each one of them acting individually, as an
authorised person within the meaning of the laws of the Republic of Italy, to perform in the Republic of Italy any acts and
formalities in connection with the Company moving its registered office from Luxembourg to the Republic of Italy, if any.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand eight hundred
Euros (EUR 1,800.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Global Financial and Com-
mercial Holdings Yellow S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.857 (la Société). La Société a été constituée le 3 octobre 2011 suivant
acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2858, page 137164,
daté du 23 novembre 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
A COMPARU:
Global Financial and Commercial Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.130 (l'Associé Unique),
33975
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante, et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées, représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la
présente Assemblée, qui est, par conséquent, régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour
reproduits ci-après;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification du terme du premier exercice social de la Société du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012, la
Société ayant été constituée le 3 octobre 2011;
3. Approbation des comptes intérimaires de la Société en vertu des principes comptables généraux luxembourgeois;
4. Transfert du siège social de la Société du Grand-Duché du Luxembourg vers l'Italie, au 21, Via Montenapoleone,
20121 Milan (Italie), sans liquidation, avec effet à la date d'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés italien
(Registro delle Imprese) (la Date d'Effectivité); renonciation par la Société à la nationalité luxembourgeoise et acquisition
de la nationalité italienne (le Transfert);
5. Refonte complète des statuts de la Société afin de les adapter à la législation italienne, en prévoyant plus particu-
lièrement les règles concernant la circulation des parts sociales, les règles de quorum pour la première et deuxième
Assemblée Générale, et les règles relatives à la gestion et à la représentation de la Société, qui devront dans la mesure
du possible, se rapprocher des Statuts actuels de la Société; adoption de la forme légale de società a responsabilità limitata,
et modification de la dénomination sociale de la Société de “Global Financial and Commercial Holdings Yellow S.à r.l.“
en “Global Financial and Commercial Holdings Yellow Srl”;
6. Confirmation que tous les actifs et passifs de la Société resteront, suite au Transfert et au changement de nationalité,
la propriété de la Société sans discontinuité ni restrictions;
7. Confirmation que les mandats des gérants continueront suite au Transfert et au changement de la nationalité;
8. Mandat donné à tout employé et/ou tout avocat de Stibbe Avocats au Luxembourg et tout gérant de la Société,
chacun d'eux agissant individuellement, afin d'effectuer au Grand-Duché de Luxembourg, tous les actes et formalités en
rapport avec le transfert du siège social de la Société du Luxembourg vers l'Italie;
9. Mandat donné à tout gérant de la Société, chacun d'eux agissant individuellement, en qualité de personne autorisée
selon les termes des lois italiennes, afin d'effectuer en Italie, tous les actes et formalités en rapport avec le Transfert; et
10. Divers.
Ces faits exposés, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a requis le notaire instrumentant
d'enregistrer les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
A L'Associée Unique décide de modifier le terme du premier exercice social de la Société du 31 décembre 2011 au
31 décembre 2012, la Société ayant été constituée le 3 octobre 2011.
<i>Troisième résolutioni>
Après la présentation des comptes intérimaires de la Société de la période prenant fin au 29 décembre 2011, préparés
en vertu des règles et principes comptables luxembourgeois, l'associée unique décide d'approuver ces comptes. Ces
comptes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, res-
teront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associée Unique décide de transférer, avec effet à la Date d'Effectivité (telle que définie ci-après), le siège social de
la Société (le Transfert), sans liquidation, du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, au 21, Via Montenapoleone, 20121
Milan (Italie), ce qui sera le siège social de la Société.
En conséquence du Transfert, la Société sera dorénavant soumise à la législation italienne, a renoncé à la nationalité
luxembourgeoise et a acquis la nationalité italienne. Le changement de nationalité et le Transfert s'effectueront sans
interruption de la personnalité morale de la Société, sous la condition suspensive de l'enregistrement de la Société au
Registre des Sociétés italien (Registro delle Imprese) (la Date d'Effectivité), et seront effectifs à la Date d'Effectivité.
33976
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les Statuts, avec effet à la Date d'Effectivité dans la mesure nécessaire afin de les mettre
en conformité avec la législation italienne, dans la forme du mémorandum et des statuts de la Société en tant que société
régie par la législation italienne, en prévoyant plus particulièrement les règles concernant la circulation des parts sociales,
les règles de quorum pour la première et deuxième Assemblée Générale, et les règles relatives à la gestion et à la
représentation de la Société, qui devront dans la mesure du possible, se rapprocher des Statuts actuels de la Société.
L'Assemblée décide d'approuver le contenu et texte desdits mémorandum et statuts modifiés de la Société.
La Société adoptera également la forme légale de società a responsabilità limitata, et changera sa dénomination sociale
de “Global Financial and Commercial Holdings Yellow S.à r.l.“ en “Global Financial and Commercial Holdings Yellow Srl”.
Il est entendu que les formalités prévues par la législation italienne pour l'enregistrement de la Société au Registre des
Sociétés italien (Registro delle Imprese) devront être exécutées.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associée Unique décide de confirmer que la Société demeurera, suite au Transfert et au changement de nationalité,
propriétaire de l'ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations ni discontinuité. La Société continuera dès lors d'être
propriétaire de tous ses actifs et passifs encourus ou nés avant le Transfert et le changement de nationalité.
<i>Septième résolutioni>
L'Associée Unique décide d'approuver le fait que les mandats de Mme Mara Vanzetta, M. Massimiliano di Maria et M.
Rohan Maxwell en tant que gérants de la Société continueront suite au Transfert et au changement de nationalité.
<i>Huitième résolutioni>
L'Associée Unique décide de donner mandat à tout employé et/ou avocat de Stibbe Avocats au Luxembourg et tout
gérant de la Société, chacun d'eux agissant individuellement, afin d'effectuer au Grand-Duché de Luxembourg, tous les
actes et formalités en rapport avec le transfert du siège social de la Société du Luxembourg vers l'Italie, et en particulier
la radiation de la Société du Registre du Commerce.
<i>Neuvième résolutioni>
L'Associée Unique décide de donner mandat à tout gérant de la Société, chacun d'eux agissant individuellement, en
qualité de personne autorisée selon les termes des lois italiennes, afin d'effectuer en Italie, tous les actes et formalités en
rapport avec le Transfert, dans la mesure du nécessaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille huit cents Euros (EUR 1.800,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé ensemble avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: T. SOMMEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1502. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015367/228.
(120018332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Roermond Holding (No. 3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 89.296.
Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
33977
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018002/9.
(120021646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
RECM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 92.025.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2012.
Référence de publication: 2012018006/10.
(120021712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Rodaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 23.914.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Rodaco s.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012018008/11.
(120021638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Express Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 4.516.
Le conseil d'administration de la Société a décidé par résolution circulaire du 2 février 2012 prise conformément à
l'article 11 des statuts de la Société de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée délégué à la gestion
journalière de la Société avec la fonction de gérant technique M. Bodo Rehr, de nationalité allemande, né le 13 juillet 1963
à Bad Bergzabern, Allemagne, demeurant actuellement à 39, Pastor-Thielens-Strasse, à D-66773 Schwalbach, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012018104/15.
(120022183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Rhombus Mezzco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.540.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of January.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Rhombus Midco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, not yet
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given
under private seal in Luxembourg, on 20 January 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
33978
L
U X E M B O U R G
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose – Duration – Name – Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of “Rhombus Mezzco S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven
hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint coowners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
33979
L
U X E M B O U R G
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
33980
L
U X E M B O U R G
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by Rhombus Midco S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, den dreiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rhombus Midco S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxembourg, mit einem Gesellschaftskapital von 15.000 Britische Pfund, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister noch ausste-
hend ist,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten,
ausgestellt in Luxemburg, am 20. Januar 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
33981
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an inund ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhombus Mezzco S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-
fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
33982
L
U X E M B O U R G
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
33983
L
U X E M B O U R G
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von Rhombus Midco S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.200,- geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3746. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR.
<i>Le Receveuri> (Signé): Irène THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.-
Luxemburg, den siebenundzwanzigsten Januar zweitausendundzwölf.
Référence de publication: 2012014948/322.
(120017291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Cetim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 120.522.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012019897/9.
(120025278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
33984
Adler Lux Sàrl
Biocera S.A.
Cetim S.A.
CMP II S.à r.l.
Express Services
Global Financial and Commercial Holdings Coral S.à r.l.
Global Financial and Commercial Holdings Pink S.à r.l.
Global Financial and Commercial Holdings Yellow S.à r.l.
Green'Up S.A.
HMTF CPD Canada Luxco S. à r. l.
Ibralux Investments S.A.
Lenta Luxembourg S.à r.l.
Lux e-shelter
Magni S.A.
OCM Luxembourg Yachts Holdings S.à r.l.
Onea S.A.
Origink S.A.
Padostom S.A.
Parcis S.A.
Parker Hannifin Holding EMEA S.à r.l.
Parker Hannifin Outbound S.à r.l.
Parker-Migliorini International Luxembourg S.à r.l.
Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Peninsula Property Development S.à r.l.
Petercam (Luxembourg) S.A.
Pharlyse S.A.
Pharus Sicav
Polyvest Holding S.A.
PRH Management
Project Bird Holding IIIB S. à r.l.
Project Bird Holding IIIC S.à r.l.
Quartier Kirchberg-Luxembourg, S.à.r.l.
RECM S.à r.l.
RE Development S.à r.l.
Regent House (Brentwood) S.à r.l.
Restaurant Holding II S.à r.l.
Rhombus Mezzco S. à r.l.
Rodaco S.à r.l.
Roermond Holding (No. 1) S.à r.l.
Roermond Holding (No. 2) S.à r.l.
Roermond Holding (No. 3) S.à r.l.
Ship Luxco Holding S.A.
Superlift Holding S.à r.l.
Utah JV S.à r.l.
Valfore S.à r.l.
Vector Investments S.A.
Vitol Holding II S.A.
Vodafone Investments Luxembourg S.à r.l.
Wagner Immobilien Deutschland SA