logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 452

21 février 2012

SOMMAIRE

Asturias Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21669

Cabo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21667

CanGro Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21662

Capgemini Reinsurance Company  . . . . . . .

21662

CBRE Global Investors Open-Ended GP

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21667

Cedre Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21667

CEREP Strategic Land S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

21678

Certifica Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

21682

Cheylaroise de Participation S. à r.l.  . . . . .

21662

Chicago Mercantile Exchange Luxem-

bourg Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21663

Clara Vision S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21683

Cognos Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

21683

Compagnie Européenne de Luxe et Tradi-

tions S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21683

Compagnie Européenne de Luxe et Tradi-

tions S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21683

Cotralux S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21683

CR PropCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21684

CS Italian Opportunities No.1 S.à r.l.  . . . .

21692

CWI Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21692

DAB Investments 2 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

21694

Danieldale S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21694

Delilah S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21668

Delta Spain S.à r.l., SICAR  . . . . . . . . . . . . . .

21693

DELTA TRANSACTIONS (Holdings) SAH

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21664

Dizzy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21694

Donaldson Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

21693

Dounia S.A., S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21694

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . .

21695

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . .

21695

Dyneurope S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21693

Engueran S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21695

Estée Lauder S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21696

Europe Voyager Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

21696

Façades et Structures Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21663

Fire-Innov SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21692

Forest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21682

Isar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21664

Isometall Distribution S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

21668

La Financière de Luxembourg S.A., S.P.F.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21663

Magna Financing Luxembourg S.à r.l.  . . . .

21684

Main S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21678

Media Factory Holding Société Anonyme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21696

Media Factory Holding Société Anonyme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21696

Niam III Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

21693

NIAM IV Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

21695

Oceanfront Hospitality S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

21650

PythAgoria Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21681

RIVER Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21682

Synergix International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

21684

21649

L

U X E M B O U R G

Oceanfront Hospitality S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 165.958.

DRAFT TERMS AND CONDITIONS OF THE CROSS-BORDER MERGER

BETWEEN:
(1) OCEANFRONT HOSPITALITY S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) orga-

nized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(R.C.S. Luxembourg) (RCS) under the number B 165.958 and having a share capital of three hundred seventeen thousand
five hundred Canadian Dollars (CAD 317,500.-) (the Absorbing Company), represented by Michael Kidd and Eric Lechat,
acting in their capacity as managers; and

(2) Cherson Investments BV, a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

heid) incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Barbara Strozzilaan 201, Office 4.08L,
1083  HN  Amsterdam,  the  Netherlands,  registered  with  the  Chamber  of  Commerce  for  Amsterdam  under  number
34133540 (the Absorbed Company), represented by Trust International Management (T.I.M.) B.V., its sole managing
director and on its turn represented by its authorised representatives.

The Absorbing Company and the Absorbed Company are together referred to as the Companies.
WHEREAS:
A. The Companies established these draft terms and conditions of the reversed cross-border merger (the Merger

Proposal) in compliance with article 257 and subsequent of the Luxembourg law dated August 10, 1915, as amended on
commercial companies (the Law) and in compliance with article 2:312 read in conjunction with articles 2:333 and 2:333d
of the Dutch Civil Code (“DCC”);

B. As at the date hereof, the Absorbed Company owns one hundred per cent (100%) of the shares of the Absorbing

Company;

C.  The  Companies  will  have  to  submit  the  present  Merger  Proposal  to  their  general  meeting  of  shareholders  in

compliance with article 263 of the Law;

D. In accordance with article 272 of the Law and article 2:333i DCC, the reversed cross-border merger (the Merger)

will take effect between the Absorbed Company and the Absorbing Company when the concurring decisions of the
Companies shall have been adopted, i.e. on the date of the last general meeting of the sole shareholder of the Companies
approving the proposed Merger (the Effective Date); and

E. The Merger shall only take effect towards third parties after the publication of the minutes of the general meeting

of sole shareholder of the Absorbing Company, in accordance with article 9 and article 273 ter of the Law.

IT HAS BEEN AGREED AS FOLLOWS:

1. Characteristics of the contemplated reversed cross-border merger.
1.1 Contemplated merger
The management of all the Companies have decided to enter into the Merger process with the effect of transferring

the assets and liabilities of the Absorbed Company by operation of law to the Absorbing Company as of the Effective
Date in compliance with articles 272, 273 and 274 of the Law and articles 2:309 and 2:310 read in conjunction with 2:311
DCC.

1.2. Characteristics of the Companies involved in the Merger: article 261 (2) (a) of the Law and article 2:312 DCC
a) The Absorbing Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under the number B 165.958 and having a share capital of three
hundred seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 317,500.-).

The Absorbing Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated December 13, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations. The articles of association of the Absorbing Company have been amended for the last time on
December 20, 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Its share capital currently stands at three hundred seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 317,500.-)

divided into twelve thousand seven hundred (12,700) shares of twenty-five Canadian Dollars (CAD 25.-) each, fully paid
up. The Absorbing Company has not issued any securities other than those shares making up its share capital.

The Absorbing Company's corporate object is the following:

“Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad,

in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular

21650

L

U X E M B O U R G

acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit, loans (whether performing or non-performing), residential mortgages and other
debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity what-
soever. The Company may enter into transactions, including financial transactions, with its affiliates on any terms including,
without limitation, other than on arms length terms.

The Company may incorporate or acquire subsidiaries from time to time.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds  of  any  borrowings and/or  issues  of  debt  securities  to  its subsidiaries,  affiliated  companies  or  to  any  other
company.  It  may  also  give  guarantees  and  grant  securities  in  favour  of  third  parties  to  secure  its  obligations  or  the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments

in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.

The Company may acquire to resell or buy and sell real property or any other moveable or immoveable property in

any country.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.”

b) The Absorbed Company is a private limited liability company (besloten vennootschap) incorporated under the laws

of the Netherlands, having its registered office at Barbara Strozzilaan 201, Office 4.08L, 1083 HN Amsterdam, the Ne-
therlands, registered with the Chamber of Commerce for Amsterdam under number 34133540.

The Absorbed Company was incorporated on April 20, 2000 pursuant to a deed of incorporation, executed by a civil

law notary in Rotterdam, registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 34133540 on
May 8, 2000. The articles of association of the Absorbed Company have not been amended since its incorporation.

The issued share capital of the Absorbed Company is currently twenty thousand euros (€ 20,000). The share capital

is divided into two hundred (200) shares having a nominal value of one hundred euros (€ 100.-) each, fully paid up. The
Absorbed Company has not issued any securities other than those shares making up its share capital.

The Absorbed Company's corporate object is the following (free translation):
a. to incorporate, to participate in any way in, to participate in another way in to provide advice and manage the affairs

of other services to companies and businesses of any kind;

b. to provide interim distributions;
c. to finance companies and other businesses;
d. to borrow, lend and raise funds including, issuing bonds, debentures or other securities and entering into related

agreements;

e. to provide guarantees, entering into agreements on behalf of the company and encumber the assets of the company

for companies and businesses that are affiliated with the company in a group and of third parties;

f. for its own account or for third parties to acquire, transfer, encumber, exploit, rent, lease and otherwise acquire

and provide (registered) property in use or enjoyment;

g. to trade in general in currencies, securities and asset values;
h. to exploit and trade patents, trade marks, licenses, knowhow and other industrial property rights; and
i. to explore all sorts of industrial, financial and commercial activities, as well as to carry out all that which is incidental

or conducive to the above, in the broadest sense.

1.3 Motives and objectives behind the Merger
a) The reasons for the Merger are the expected efficiencies and cost reductions, as well as the simplification and the

rationalization of the group structure. The group has indeed decided to centralize its holding company in one jurisdiction
in order to achieve efficiency and cost reduction.

b) It is not expected that the Merger will have any economic consequences other than efficiencies and cost reductions.

2. The Merger.
2.1 Valuation and methods of valuation of the contribution: article 261 (4) d) of the Law and article 2:333d DCC
In order to determine the valuation of the Merger, for accounting and legal purposes, the contributed assets and

liabilities of the Absorbed Company are valued, based on generally accepted accountancy principles at their book value

21651

L

U X E M B O U R G

at thirty-eight million seven hundred thirty-seven thousand five hundred eighty-seven Euro (EUR 38,737,587.-) based on
the interim financial statements of the Absorbed Company as of December 31, 2011, to be converted in Canadian Dollars
(CAD) pursuant to the official foreign exchange rate published by the ECB on the Effective Date (the Converted Book
Value).

2.2 Share capital increase and subsequent share capital reduction: article 261 (2) c) of the Law and articles 2:312 and

2:311 read in conjunction with articles 2:325 and 2:326 DCC

The Absorbed Company will contribute, by way of the Merger, all its assets and liabilities in their entirety without

exception or reserve to the Absorbing Company.

In remuneration for the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Company, the Absorbing Company

will increase its share capital by an amount of five hundred twenty thousand Canadian Dollars (CAD 520,000.-) so as to
raise it from its present amount of three hundred seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 317,500.-)
to eight hundred thirty-seven thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 837,500.-) through the issuance of twenty
thousand eight hundred (20,800) new shares having a par value of twenty-five Canadian Dollars (CAD 25.-) each, of the
same kind and carrying the same rights and obligations as the existing shares of the Absorbing Company, together with
a share premium in an amount equal to the difference between the Converted Book Value and the five hundred twenty
thousand Canadian Dollars (CAD 520,000.-) allocated to the share capital reserve account, to be allocated to the share
premium reserve account of the Absorbing Company.

The newly issued shares of the Absorbing Company will all be allocated to the sole shareholder of the Absorbed

Company.

The twelve thousand seven hundred (12,700) own shares of the Absorbing Company that it has acquired as a result

of the transfer of all the assets and liabilities by operation of law of the Absorbed Company will be cancelled simultaneously
with the issuance of the new shares so that the share capital of the Absorbing Company will be decreased by an amount
of three hundred seventeen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 317,500.-) simultaneously with the above
share capital increase.

Article 6 of the articles of association of the Absorbing Company will be amended accordingly.
2.3 Registration of the new shares and of the cancelled shares
The newly issued shares and the cancelled shares will be registered in the shareholders register of the Absorbing

Company as of the Effective Date.

2.4 Right of the new shares to participate to the profit: article 261 (2) d) of the Law and article 2:326 subsection b

DCC

The newly issued shares will entitle the sole shareholder to participate in the profits of the Absorbing Company, it

being understood that these rights only concern the undistributed dividends as of the Effective Date and any future
dividends. This right is subject to no special condition.

2.5 Accounting date of the Merger: article 261 (2) e) of the Law and article 2:333i read in conjunction with 2:312

paragraph 2 subsection f DCC

For accounting purposes, the Merger shall be deemed to be effective as of the Effective Date.
2.6 Rights conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to the holders of securities

other than shares or corporate units, or the measures proposed concerning them: article 261 (2) f) of the Law

The rights and advantages granted to the sole shareholder of the Absorbed Company are similar to the rights and

advantages granted to the sole shareholder of the Absorbing Company. Therefore, it is not required that the Absorbing
Company creates shares conferring special rights.

2.7 Special advantages granted to the experts referred to in article 266 of the Law, to the members of the management

board, board of directors and to the statutory auditors of the Companies and to any of the persons (if any) referred to
in article 261 (2) g) of the Law and article 2:312 paragraph 2 subsection d DCC

Neither the experts referred to in article 266 of the Law, nor the members of the management board, board of

directors and the statutory auditors of the Companies and any of the persons (if any) referred to in article 261 (2) g) of
the Law and article 2:312 paragraph 2 subsection d DCC shall be entitled to receive any special advantages in connection
with or as a result of the Merger.

2.8 Articles of association of the Absorbing Company
The articles of association of the Absorbing Company were drawn up by deed of incorporation executed on the

thirteenth day of December two thousand eleven before Maître Martine Schaeffer, civil law notary in Luxembourg and
amended by a deed executed on the twentieth day of December two thousand eleven before Maître Henri Hellinckx.
The consecutive wording of the articles of association of the Absorbing Company as per the date of the Merger Proposal
and the articles of association as they will read on the Effective Date are attached as Annex A and Annex B to the Merger
Proposal, respectively.

2.9 Likely effects on the employment: article 261 (4) b) and c) of the Law and article 2:312 paragraph 2 subsection h

read in conjunction with article 2:333 d subsection b DCC

The Merger is not expected to have any effect on the employment as the Absorbed Company has no employee.

21652

L

U X E M B O U R G

2.10 Annual accounts or interim financial statements used to determine the valuation of the Merger: article 261 (4) e)

of the Law and article 2:333d DCC read in conjunction with article 2:313 DCC

The dates of the most recently adopted annual accounts of the Companies' accounts used to establish the conditions

of the Merger are:

a) For the Absorbing Company:
Since the Absorbing Company has been incorporated on December 13, 2011 and the first financial year of the Ab-

sorbing Company will end on December 31, 2012, interim financial statements as of December 31, 2011 have been used.

b) For the Absorbed Company:
The annual accounts for the financial years ended respectively on December 31, 2008, December 31, 2009 and De-

cember 31, 2010, together with the interim statements as of December 31, 2011 have been used.

2.11 Exercise of rights by the creditors: article 262 (2) c) of the Law and article 2:316 read in conjunction with 2:333e

paragraph 1 subsection c DCC

The details of the arrangements made for the exercise of the rights of the creditors will be in the national laws as

follows:

a) the Absorbed Company: article 2:316 DCC read in conjunction with article 2:333e paragraph 1 subsection c DCC;

and

b) the Absorbing Company: article 268 of the Law.
The creditors of the Companies may obtain the complete information on the details made for the exercise of their

rights at the following address:

a) OCEANFRONT HOSPITALITY S.à r.l.
Registered office: 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
b) Cherson Investments B.V.
Registered office: Barbara Strozzilaan 201, Office 4.08L, 1083 HN Amsterdam, the Netherlands.
2.12 Granting of rights or compensations for the account of the Absorbing Company pursuant to article 2:320 read

in conjunction with 2:312 paragraph 2 subsection c DCC

No rights or compensations will be granted.
2.13 Effects of the Merger on the goodwill and the distributable reserves of the Absorbing Company
The effects of the Merger on the goodwill and the distributable reserves will be as follows: none.
2.14 Information concerning the procedure of the codetermination of the arrangements with respect to the codeter-

mination in the Absorbing Company

Due to the fact that the Absorbed Company has no employee, there is no requirement to make information concerning

the procedure of the determination of the arrangements with respect to the codetermination in the Absorbing Company
available.

2.15 Contemplated continuation or termination of activities
The activities of the Absorbed Company will be continued by the Absorbing Company. For the avoidance of doubt,

the Merger will not imply or provoke any termination of activities of the Companies.

2.16 Corporate approvals with respect to the Merger
The Merger Proposal and the Merger have been approved by the board of managers of the Absorbing Company. No

prior approval by any body of the Absorbed Company is required with respect to the Merger.

2.17 Proposal for the height of compensation of shareholders
No cash compensation for shareholders that vote against the Merger Proposal is contemplated as the sole shareholder

of the Absorbing Company is the Absorbed Company which will not vote against the Merger.

2.18 Management reports on the Merger Proposal: article 265 (1) of the Law and article 2:327 DCC
In accordance with article 265 (1) of the Law and article 2:327 DCC the management of each of the Companies issued

a report on the Merger which will be presented to the shareholders of the Companies.

2.19 Examination of the Merger Proposal by independent auditors: article 266 (1) of the Law and article 2:328 DCC
In accordance with article 266 (5) of the Law, article 2:328 paragraph six DCC and article 8 of the Directive 2005/56/

EC, the shareholders of the Absorbing Company and of the Absorbed Company will waive the examination of the Merger
Proposal by the independent auditors and the auditors' reports required by article 266 (1) and (2) of the Law and the
first sentence of paragraph 1 and paragraph 2 of article 2:328 DCC.

A separate accounting report will be drafted by PKF Wallast for the purpose of the second sentence of paragraph 1

of article 2:328 DCC.

3. Consequences of the Merger.
3.1 Universal transfer

21653

L

U X E M B O U R G

The Merger will trigger ipso jure all the consequences detailed in article 274 of the Law and articles 2:309 and 2:310

read in conjunction with 2:311 DCC. in particular, as a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist
and all its shares in issue shall be cancelled.

The Absorbing Company will become the owner of the assets transferred by the Absorbed Company by operation

of law as they exist on the Effective Date, with no right of recourse whatsoever against the Absorbed Company.

The Absorbing Company shall pay, as from the Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance

premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been contributed.

As from the Effective Date, the Absorbing Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the

Absorbed Company.

The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company

with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be subrogated,
without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Company with respect to all assets and
against all debtors without any exception.

The Absorbing Company shall incur all debts and liabilities of any kind of the Absorbed Company. In particular, it shall

pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Absorbed Company.

3.2 Corporate Documents
All corporate documents of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company

for as long as prescribed by the DCC.

3.3 Mandate of the management / statutory auditor(s) (if any)
The mandates of the members of the board of directors and of the statutory auditor(s) (if any) of the Absorbed

Company will be terminated on the Effective Date. Full discharge (quitus) is given to the members of the board of directors
and to the statutory auditor(s) for the performance of their mandate.

The mandates of the members of the board of managers of the Absorbing Company will not be affected by the Merger.
3.4 Winding up of the Absorbed Company
The Absorbed Company shall be wound up automatically at the Effective Date.
The Absorbed Company's winding up shall not require any liquidation.

4. Miscellaneous.
4.1 Registration
The Merger Proposal and the documentation as referred to in clause 4.2 under a. up to and including c. and e. of this

Merger Proposal will be deposited by the Absorbed Company at the Dutch trade register of the Chamber of Commerce
in Amsterdam, the Netherlands (Het handelsregister van de Kamers van Koophandet te Amsterdam) and will be published
in the Dutch national gazette (Staatscourant) and a Dutch national newspaper at least one month prior to the extraor-
dinary general meetings of the Absorbing Company and of the Absorbed Company to approve the Merger Proposal
pursuant to articles 9 and 262 of the Law and articles 2:314 read in conjunction with articles 2:316 and 2:317 DCC.

The Merger Proposal and the documentation as referred to in clause 4.2 under a. up to and including c. and e. of this

Merger Proposal will be deposited by the Absorbing Company at the RCS and then published in the Journal Officiel du
Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C at least one month prior to the ex-
traordinary general meetings of the Absorbing Company and of the Absorbed Company to approve the Merger Proposal
pursuant to articles 9 and 262 of the Law and articles 2:314 read in conjunction with articles 2:316 and 2:317 DCC.

4.2 Documents available for inspection by the shareholders of the Companies: article 267 (1) of the Law and article

2:314 paragraph 2 read in conjunction with 2:328 paragraph 5 DCC

The sole shareholder of each of the Companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered

office of the Companies, at least one month before the date of the general meetings of the sole shareholder called to
decide on the terms of the Merger:

a) Merger Proposal;
b) annual accounts of the Absorbed Company for the last three financial years together with the management reports

and, if necessary, an interim balance sheet, audited if need be, drawn up as per a date which must not be earlier than the
first day of the third month preceding the date of the publication of the Merger Proposal, if the last annual accounts of
the Absorbed Company relate to a year that ended more than six months before that date; and

c) interim balance sheet of the Absorbing Company drawn up as per a date which must not be earlier than the first

day of the third month preceding the date of the publication of the Merger Proposal;

d) the management reports of article 265 (1) of the Law and article 2:313 DCC for each of the Companies;
e) the accounting report of article 2:328 paragraph 1 second sentence DCC read in conjunction with 2:328 paragraph

6 DCC for the Absorbed Company.

A copy of the above mentioned documents will be obtainable upon request and the documents under a. up to and

including c. and e. are attached to the Merger Proposal under Annex C.

4.3. Powers - costs - choice of domicile

21654

L

U X E M B O U R G

All powers are vested to any lawyer of Ober & Beerens to make the filings and publications required by law, to fulfill

all legal formalities and to make all necessary notifications and, after the contribution has occurred, notify of and register
this Merger Proposal wherever this may be necessary.

The charges and rights of the Merger Proposal and all those resulting from it directly or indirectly will be paid for by

the Absorbing Company.

(Remainder of page intentionally left blank - Signature page follows)

On February 3, 2012, in Luxembourg, in four originals.

OCEANFRONT HOSPITALITY S.à r.l.
<i>The Absorbing Company
Eric Lechat / Michael Kidd
<i>Manager / <i>Manager

Jan-Willem Terlouw
<i>Directeur CHERSON INVESTMENTS B.V.

On February 3, 2012, in Luxembourg, in four originals.

CHERSON INVESTMENTS B.V.
<i>The Absorbed Company
INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT (T.I.M.) B.V.
<i>Managing Director
Mr. Dennis C. Kulk / Mr. Huig J. Braamskamp
<i>Attorney-in-fact-A / <i>Attorney-in-fact-A

Annexes to these draft terms form an integrated part of the Merger Proposal.

Annexes:
Annex A Current articles of association of the Absorbing Company
Annex B Articles of association as of the Effective Date
Annex C Documents mentioned in 4.2 above under a. up to and including c. and e.

PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE

ENTRE:
(3) OCEANFRONT HOSPITALITY S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant le droit luxembour-

geois, ayant son siège social au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 165.958
et ayant un capital social de trois cent dix-sept mille cinq cent dollars canadiens (CAD 317,500.-) (la Société Absorbante),
représentée par Michael Kidd and Eric Lechat, en leur qualité de gérants; et

(4) Cherson Investments BV, une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid) constituée selon le droit néerlandais, ayant son siège social à Barbara Strozzilaan 201, Office 4.08L, 1083 HN
Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34133540 (la
Société Absorbée), représentée par Trust International Management (T.I.M.) B.V., son gérant unique et à son tour re-
présenté par ses représentants autorisés.

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont mentionnées comme étant les Sociétés.
CONSIDÉRANT QUE:
A. Les Sociétés ont établi le projet de fusion transfrontalière inversée (le Projet de Fusion) en conformité avec les

articles 257 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la
Loi) et en conformité avec l'article 2:312 lu ensemble avec les articles 2:333 et 2:333 d du Code Civil néerlandais (le
CCN);

B. A ce jour, la Société Absorbée détient cent pour cent (100%) des parts sociales de la Société Absorbante;
C. Les Sociétés devront soumettre le présent Projet de Fusion à l'assemblée générale de leurs associés respectives en

conformité avec l'article 263 de la Loi;

D. Selon l'article 272 de la Loi et l'article 2:333 i du CCN, la fusion transfrontalière inversée (la Fusion) prendra effet

entre la Société Absorbée et la Société Absorbante lorsque les décisions concomitantes des Sociétés seront adoptées,
c'est-à-dire à la date de la dernière assemblée générale de l'associé unique de l'une des Sociétés approuvant la Fusion
proposée (la Date d'Effet); et

E. La Fusion prendra effet à l'égard des tiers après la publication des minutes de l'assemblée générale de l'associé unique

de la Société Absorbante conformément à l'article 9 et à l'article 273 ter de la Loi.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:

21655

L

U X E M B O U R G

1. Caractéristiques de la fusion transfrontalière inversée envisagée.
1.1 Fusion envisagée
La gérance des Sociétés ont décidé de rentrer dans le processus de la Fusion pour transférer par l'effet de la loi les

actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante à la Date d'Effet en conformité avec les articles 272, 273
et 274 de la Loi et les articles 2:309 et 2:310 lu ensemble avec l'article 2:311 du CCN.

1.2 Caractéristiques des Sociétés impliquées dans la Fusion: article 261 (2) a de la Loi et article 2:312 du CCN
i. La Société Absorbante est une société à responsabilité limitée constituée suivant le droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du RCS
sous  le  numéro  B  165.958  et  ayant  un  capital  social  de  trois  cent  dix-sept  mille  cinq  cents  dollars  canadiens  (CAD
317,500.-).

La Société Absorbante a été constituée par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg, en date du 13 décembre 2011 et pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations. Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés pour la dernière fois le 20 décembre 2011 par un
acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, pas encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Son capital social s'élève actuellement à trois cent dix-sept mille cinq cents dollars canadiens (CAD 317.500,-) divisé

en douze mille sept cents (12.700) parts sociales de vingt-cinq dollars canadiens (CAD 25,-) chacune, totalement libérées.
La Société Absorbante n'a pas émis d'autres titres que les parts sociales composant son capital social.

L'objet social de la Société Absorbante est le suivant:

« Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme

que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière dès actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt, prêts (portant intérêts ou non), et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières
et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. La Société pourra conclure toutes transactions, y
compris des transactions financières, avec ses filiales quelqu'en soient les termes et conditions.

La Société pourra également constituer des filiales ou acquérir des sociétés.
La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de
valeurs mobilières à ses filiales, Sociétés affiliées ou toute autre Société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, Sociétés affiliées ou toute autre Société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change,
taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-

vestissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.

La Société pourra acquérir pour revendre ou acquérir puis revendre tout types d'actifs mobiliers ou immobiliers dans

tous pays.

L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.»

ii. La Société Absorbée est une société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap niet beperkle acnopra-

ketyk heid) constituée selon le droit néerlandais, ayant son siège social à Barbara Strozzilaan 201, Office 4.08L, 1083 HN
Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34133540.

La Société Absorbée a été constituée le 20 avril 2000 conformément à un acte de constitution, exécuté par un notaire

de Rotterdam, enregistré dans le registre du commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 34133540 le 8
mai 2000. Les statuts de la Société Absorbée n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

Le capital social émis de la Société Absorbée s'élève actuellement à vingt mille euros (EUR 20.000,-). Le capital social

est divisé en deux cents (200) parts sociales ayants une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement
libérées. La Société Absorbée n'a pas émis de titres autres que ces actions composant son capital social.

L'objet social de la société absorbée est le suivant (traduction libre):
a. constituer, participer en toute manière, participer en une autre manière pour fournir des conseils et gérer les affaires

des autres services des entreprises et business de toute nature;

b. fournir des distributions intérimaires;

21656

L

U X E M B O U R G

c. financer les entreprises et autres business;
d. emprunter, prêter et collecter des fonds, y compris, l'émission d'obligations, de débentures ou d'autres valeurs

mobilières et conclure les accords inhérents;

e. fournir des garanties, conclure des contracts au nom de la société et gager les actifs de la société pour les entreprises

et les business qui sont affiliées à la société dans un groupe et à des tiers;

f. pour son propre compte ou pour compte de tiers, acquérir, transférer, gager, exploiter, louer ou autrement acquérir

et fournir des propriétés (enregistrées) pour utilisation ou jouissance;

g. faire la commerce en général en devises, titres et valeurs d'actif;
h. exploiter et faire la commerce de brevets, marques, licences, expertise et autres droits de propriété industrielle; et
i. explorer toutes sortes d'activités industrielles, financières et commerciales, ainsi que d'accomplir tout ce qui est

accessoire ou propice à ce qui précède, dans le sens large du terme.

1.3 Motivations et objectifs derrière la Fusion
a) Les raisons de la Fusion sont les rendements et réductions des coûts attendues, ainsi que la simplification et la mise

en ordre de la structure du groupe. Le groupe a en effet décidé de centraliser sa société holding dans une seule juridiction
en vue d'atteindre le rendement et la réduction des coûts attendus.

b) Il n'est pas prévu que la Fusion ait de conséquences économiques autres que le rendement et la réduction des coûts.

2. La Fusion.
2.1 Valorisation et méthodes d'évaluation de la contribution: l'article 261(4) d) de la Loi et l'article 2:333d du CCN
Afin de déterminer la valeur de la Fusion, pour des fins comptables et légales, les actifs et passifs apportés à la Société

Absorbée sont évalués, fondés sur des principes de comptabilité généralement reconnus, à leur valeur comptable de
trente-huit millions sept cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingt sept Euros (EUR 38.737.587,-) sur la base du bilan
intérimaire de la Société Absorbée daté du 31 décembre 2011, devant être converti en Dollars Canadiens (CAD) sur la
base du taux de change officiel publié par la BCE à la Date d'Effet (la Valeur Comptable Convertie).

2.2 Augmentation de capital et réduction du capital social subséquente: l'article 261 (2) c) de la Loi et les articles 2:312

et 2:311 lus ensemble avec les articles 2:325 et 2:326 du CCN

La Société Absorbée contribuera, par le biais de la Fusion, tous ses actifs et passifs dans leur intégralité, sans exception

ni réserve à la Société Absorbante.

En rémunération de l'apport des actifs et passifs de la Société Absorbée, la Société Absorbante augmentera son capital

social d'un montant de cinq cent vingt mille Dollars Canadiens (CAD 520.000,-) de manière à l'augmenter de son montant
actuel de trois cent dix-sept mille cinq cents Dollars Canadiens (CAD 317.500,-) à huit cent trente-sept mille cinq cents
Dollars Canadiens (CAD 837.500,-) par l'émission de vingt mille huit cents (20.800) nouvelles parts sociales ayants une
valeur nominale de vingt-cinq Dollars Canadiens (CAD 25,-) chacune, de la même nature et conférant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes de la Société Absorbante, ensemble avec une prime d'émission d'un montant
égal à la différence entre la Valeur Comptable Convertie et les cinq cent vingt mille Dollars Canadiens (CAD 520.000,-)
affectés au compte de réserve du capital social, qui sera affecté au compte de réserve du prime d'émission de la Société
Absorbante.

Les parts sociales nouvellement émises de la Société Absorbante seront tous attribués à l'associé unique de la Société

Absorbée.

Les douze mille sept cents (12.700) parts sociales propres de la Société Absorbante qu'elle a acquis à la suite du

transfert de plein droit de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront annulées simultanément à l'émission
des nouvelles parts sociales afin que le capital social de la Société Absorbante soit diminué d'un montant de trois cent
dix-sept mille cinq cents Dollars Canadiens (CAD 317.500,-) simultanément avec l'augmentation du capital ci-dessus.

L'article 6 des statuts de la Société Absorbante sera modifié en conséquence.
2.3 Enregistrement des nouvelles parts sociales et des parts sociales annulées
Les parts sociales nouvellement émises et les parts sociales annulées seront enregistrées dans le registre des associés

de la Société Absorbante à compter de la Date d'Effet.

2.4 Le droit accordé par les nouvelles parts sociales de participer aux bénéfices: article 261 (2) d) de la Loi et l'article

2:326 sous-section b du CCN

Les parts sociales nouvellement émises donneront droit à l'associé unique de participer aux bénéfices de la Société

Absorbante, étant entendu que ces droits ne concernent que les dividendes non distribués à compter de la Date d'Effet
et les dividendes futurs. Ce droit n'est subordonné à aucune condition particulière.

2.5 Date d'écriture comptable de la Fusion: l'article 261 (2) e) de la Loi et l'article 2:333i lu ensemble avec l'article

2:312 paragraphe 2 sous-section f du CCN

À des fins comptables, la Fusion doit être considérée comme effective à compter de la Date d'Effet.
2.6 Les droits conférés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres

autres que actions ou parts sociales, ou les mesures proposées à leur égard: l'article 261 (2) f) de la Loi

21657

L

U X E M B O U R G

Les droits et avantages accordés à l'associé unique de la Société Absorbée sont similaires aux droits et avantages

accordés à l'associé unique de la Société Absorbante. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que la Société Absorbante
crée des parts sociales conférents des droits particuliers.

2.7 Avantages particuliers accordés aux experts visés à l'article 266 de la Loi, aux membres du conseil d'administration,

au conseil de gérance et aux commissaires aux comptes des Sociétés et à toutes les personnes (le cas échéant) mentionnés
à l'article 261 (2) g) de la Loi et l'article 2:312 paragraphe 2 sous-section d du CCN

Ni les experts visés à l'article 266 de la Loi, ni les membres du conseil d'administration, du conseil de gérance ni les

commissaires aux comptes des Sociétés ni toutes les personnes (le cas échéant) mentionnées à l'article 261 (2) g) de la
Loi et à l'article 2:312 paragraphe 2 sous-section d CCN ne recevront des avantages particulier en connexion avec, ou
résultant de la Fusion.

2.8 Les statuts de la Société Absorbante
Les statuts de la Société Absorbante ont été établis par acte de constitution passé le treizième jour de décembre deux

mille onze devant Maître Martine Schaeffer, notaire au Luxembourg et modifiés par un acte passé le vingtième jour de
décembre deux mille onze par devant Maître Henri Hellinckx. Les statuts de la Société Absorbante tels qu'ils seront à la
date de la Proposition de Fusion et les statuts de la Société Absorbante tels qu'ils seront à la Date d'Effet sont joints
respectivement comme Annexes A et B de la Proposition de Fusion respectivement.

2.9 Les effets probables sur l'emploi: l'article 261 (4) b) et c) de la Loi et l'article 2:312 paragraphe 2 sous-section h lu

ensemble avec l'article 2:333 d sous-section b du CCN

La Fusion n'aura aucun effet sur l'emploi étant donné que la Société Absorbée n'a aucun salarié.
2.10 Les comptes annuels ou les bilans intérimaires utilisées pour déterminer l'évaluation de la Fusion: l'article 261 (4)

e) de la Loi et l'article 2:333 d CCN lu ensemble avec l'article 2:313 CCN

Les dates des plus récents comptes annuels adoptés des Sociétés utilisées pour établir les conditions de la Fusion sont:
a) Pour la Société Absorbante:
Sachant que la Société Absorbante a été constituée le 13 décembre 2011 et la première année financière de la Société

Absorbante se terminera le 31 décembre 2012, le bilan intérimaire daté le 31 décembre 2011 a été utilisé.

b) Pour la Société Absorbée:
Les comptes annuels pour les exercices clos respectivement le 31 décembre 2008, le 31 décembre 2009 et le 31

décembre 2010, ensemble avec le bilan intérimaire daté le 31 décembre 2011 ont été utilisés.

2.11 Exercice des droits par les créanciers: l'article 262 (2) c) de la Loi et l'article 2:316 lu ensemble avec l'article

2:333e paragraphe 1 sous-section c du CCN

Les détails des dispositions prises pour l'exercice des droits des créanciers seront dans les lois nationales comme suit:
a) la Société Absorbée: l'article 2:316 CCN lu ensemble avec l'article 2:333 paragraphe 1 sous-section c CCN; et
b) la Société Absorbante: l'article 268 de la Loi.
Les créanciers des Sociétés peuvent obtenir les renseignements complets sur les détails établis pour l'exercice de leurs

droits à l'adresse suivante:

a) OCEANFRONT HOSPITALITY S.à r.l.
Siège social: 46, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
b) Cherson Investissements B.V.
Siège social: Barbara Strozzilaan 201, Bureau 4.08L, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas.
2.12 Octroi des droits ou compensations pour le compte de la Société Absorbante en application de l'article 2:320 lu

ensemble avec l'article 2:312 paragraphe 2 sous-section c du CCN

Aucun droit ou compensation ne seront accordés.
2.13 Effets de la Fusion sur les fonds de commerce et les réserves distribuables de la Société Absorbante
Les effets de la Fusion sur les fonds de commerce et les réserves distribuables seront comme suit: aucun.
2.14 Renseignements concernant la procédure de codétermination des arrangements eu égard à la codétermination

dans la Société Absorbante

En raison du fait que le Société Absorbée n'a aucun salarié, il n'est pas nécessaire de rendre disponible l'information

concernant la procédure de codétermination des arrangements eu égard à la codétermination dans la Société Absorbante.

2.15 Continuation ou cessation d'activités envisagées
Les activités de la Société Absorbée seront poursuivies par la Société Absorbante. Pour éviter tout doute, la Fusion

n'entraînera ni provoquera aucune cessation des activités des Sociétés.

2.16 Approbations de la Fusion
Le Projet de Fusion et la Fusion ont été approuvés par le conseil de gérance de la Société Absorbante. Aucune ap-

probation préalable par aucun organe de la Société Absorbée n'est requise.

2.17 Proposition de la hauteur de la rémunération des associés

21658

L

U X E M B O U R G

Aucune compensation en espèces n'est envisagée pour les associés qui voteront contre le Projet de Fusion étant donné

que l'associé unique de la Société Absorbante est la Société Absorbée, qui ne votera pas contre la Fusion.

2.18 Les rapports des gérants sur la Proposition de Fusion: l'article 265 (1) de la Loi et l'article 2:327 CCN
En conformité à l'article 265 (1) de la Loi et à l'article 2:327 CCN, les conseils de gérance de chacune des Sociétés

ont émis un rapport sur la Fusion qui sera présenté aux associés des Sociétés.

2.19 L'examen de la Proposition de Fusion par des auditeurs indépendants: l'article 266 (1) de la Loi et l'article 2:328

CCN

Conformément à l'article 266 (5) de la Loi, l'article 2:328 paragraphe six du CCN et l'article 8 de la Directive 2005/56/

CE, les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée dérogeront à l'examen de la Proposition de Fusion
par les auditeurs indépendants et aux rapports des auditeurs indépendants requis par l'article 266 (1) et (2) de la Loi et
la première phrase du paragraphe 1 et paragraphe 2 de l'article 2:328 DCC.

Un rapport comptable distinct sera rédigé par PKF Wallast comme requis par la deuxième phrase du paragraphe 1 de

l'article 2:328 DCC.

3. Conséquences de la fusion.
3.1 Transfert universel
La Fusion va déclencher ipso jure toutes les conséquences détaillées dans l'article 274 de la Loi et dans les articles

2:309 et 2:310 lus ensemble avec 2:311 CCN, en particulier, résultant de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister
et toutes ses parts sociales en circulation seront annulées.

La Société Absorbante deviendra propriétaire de plein droit des actifs transférés par la Société Absorbée tels qu'ils

existent à la Date d'Effet, sans droit de recours de toute sorte contre la Société Absorbée.

La Société Absorbante doit payer, à compter de la Date d'Effet, toutes les taxes, cotisations, frais, prélèvements et

primes d'assurance qui seront ou peuvent devenir exigibles à l'égard de la propriété des actifs qui ont été versés.

A partir de la Date d'Effet, la Société Absorbante doit exécuter tous les accords et les obligations de toute sorte de

la Société Absorbée.

Les droits et les revendications compris dans les actifs de la Société Absorbée doivent être transférés à la Société

Absorbante avec tous les titres, soit réels ou personnels, qui y sont joints. La Société Absorbante doit être ainsi subrogée,
sans novation, dans tous les droits, soit réels ou personnels, de la Société Absorbée en ce qui concerne tous les biens et
contre tous les débiteurs sans aucune exception.

La Société Absorbante doit encourir toutes les dettes et les passifs de toute nature de la Société Absorbée. En par-

ticulier,  elle  doit  payer  les  intérêts  et  les  montants  principaux  sur  toutes  les  dettes  et  obligations  de  toute  nature
contractées par la Société Absorbée.

3.2 Documents sociaux
Tous les documents sociaux de la Société Absorbée doivent être conservés au siège social de la Société Absorbante

aussi longtemps que prescrit par le CCN.

3.3 Mandat du conseil de gérance / commissaire(s) aux comptes (le cas échéant)
Les mandats des membres du conseil de gérance et du commissaire(s) (le cas échéant) de la Société Absorbée seront

résiliés à la Date d'Effet. Quitus est donné aux membres du conseil de gérance et au(x) commissaire(s) pour l'exécution
de leur mandat.

Les mandats des membres du conseil de gérance de la Société Absorbante ne seront pas affectés par la Fusion.
3.4 Dissolution de la Société Absorbée
La Société Absorbée doit être dissoute automatiquement à la Date d'Effet.
La dissolution de la Société Absorbée n'exigera aucune liquidation.

4. Divers.
4.1 Enregistrement
La Proposition de Fusion et la documentation visée à l'alinéa 4.2 sous a. jusqu'à et y compris c. et e. de cette Proposition

de Fusion seront déposées par la Société Absorbée au registre du commerce néerlandais de la Chambre de Commerce
d'Amsterdam, Pays-Bas (Het Handelsregister van de Kamers van Koophandel te Amsterdam) et sera publié dans la Gazette
nationale  néerlandais  (Staatscourant)  et  dans  un  journal  national  néerlandais  au  moins  un  mois  avant  les  assemblées
générales extraordinaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée décidant de l'approbation de la Proposition
de Fusion conformément aux articles 9 et 262 de la Loi et à l'article 2:314 lu ensemble avec les articles 2:316 et 2:317
CCN.

La Proposition de Fusion et la documentation visée à l'alinéa 4.2 sous a. jusqu'à et y compris c. et e. de cette Proposition

de Fusion seront déposées par la Société Absorbante au RCS, puis publié au Journal Officiel du Grand-Duché du Lu-
xembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C au moins un mois avant les assemblées générales extraor-
dinaires  de  la  Société  Absorbante  et  de  la  Société  Absorbée  décidant  de  l'approbation  de  la  Proposition  de  Fusion
conformément aux articles 9 et 262 de la Loi et à l'article 2:314 lu conjointement avec les articles 2:316 et 2:317 CCN.

21659

L

U X E M B O U R G

4.2 Documents disponibles pour l'inspection par les associés des Sociétés: l'article 267 (1) de la Loi et l'article 2:314

paragraphe 2 lu ensemble avec l'article 2:328 paragraphe 5 du CCN

L'associé unique de chacune des Sociétés doit avoir le droit d'inspecter les documents suivants au siège social des

Sociétés, au moins un mois avant la date des assemblées générales de l'associé unique appelée à se prononcer sur les
modalités de la Fusion:

a) la Proposition de Fusion;
b) les comptes annuels de la Société Absorbée pour les trois derniers exercices ainsi que les rapports de gestion et,

si nécessaire, un bilan intérimaire, audités si besoin est, émis à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour
du troisième mois précédant la date de publication du Projet de Fusion, si les derniers comptes annuels de la Société
Absorbée se rapportent à une année qui s'est terminée plus de six mois avant cette date;

c) le bilan intérimaire de la Société Absorbante rédigé en une date qui ne doit pas être antérieure à celle du premier

jour du troisième mois précédant la date de publication du Projet de Fusion;

d) les rapports de gestion selon l'article 265 (1) de la Loi et l'article 2:313 du CCN pour chacune des Sociétés;
e) le rapport comptable du reviseur selon l'article 2:328 paragraphe 1 deuxième phrase CCN lu ensemble avec 2:328

paragraphe 6 CCN pour la Société Absorbée.

Une copie des documents mentionnés ci-dessus pourra être obtenu sur demande et les documents sous a. jusqu'à et

y compris c. et e. sont attachés à la Proposition de Fusion dans l'annexe C.

4.3 Pouvoirs - coûts - choix du domicile
Tous les pouvoirs sont dévolus à tout avocat d'Ober &amp; Beerens pour faire les classements et publications prescrits

par la loi, accomplir à toutes les formalités légales et faire toutes les notifications nécessaires et, après que la contribution
a eu lieu, notifier et enregistrer ce Projet de Fusion où cela pourra être nécessaire.

Les charges et les droits de la Proposition de Fusion et tous ceux qui en résultent directement ou indirectement seront

payés par la Société Absorbante.

(Le reste de cette page a été intentionnellement laissé en blanc - La page de signature suit)

Luxembourg, le 3 février 2012, en quatre originaux.

OCEANFRONT HOSPITALITY S.à r.l.
<i>La Société Absorbante
Eric Lechat / Michael Kidd
<i>Gérant / <i>Gérant

Jan-Willem Terlouw
<i>Directeur CHERSON INVESTISSEMENTS B.V.

Luxembourg, le 3 février 2012, en quatre originaux.

CHERSON INVESTISSEMENTS B.V.
<i>La Société Absorbée
INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT (T.I.M.) B.V.
<i>Administrateur Délégué
M. Dennis C. Kulk / M. Huig J. Braamskamp
<i>Mandataire A / <i>Mandataire A

Les annexes de ce projet constituent une partie intégrante à cette proposition.

Annexes:
Annexe A statuts actuels de la Société Absorbante
Annexe B statuts à la Date d'Effet
Annexe C Documents mentionnés au paragraphe 4.2 ci-dessus sous a. jusqu'à et y compris c. et e.

<i>CHERSON INVESTMENTS B.V.

<i>Amsterdam

<i>Balance Sheet as at December 31, 2011

<i>(before appropriation of results)

<i>(expressed in euros)

Notes

2011

2010

ASSETS
Fixed Assets
Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) 43,791,795

6,019,285

Loan receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)

75,709

75,438

21660

L

U X E M B O U R G

Loan receivable back-to-back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(6) 13,627,620 13,578,757

57,495,124 19,673,480

Current Assets
Interest receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7)

9,301

740

Interest receivable back-to-back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(8)

0

0

Cash at banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9)

23,319

56,834

VAT receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605

368

33,225

57,942

TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,528,349 19,731,422

SHAREHOWER'S EQUITY AND LIABILITIES
Shareholder's Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10)

Issued and fully paid share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,000

20,000

Share premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,300,786

2,710,331

Accumulated deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1,277,948)

(989,505)

Net result for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,694,749

(288,443)

38,737,587

1,452,383

Long-term Liabilities
Loan payable back-to-back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11) 13,627,620 13,578,757

Loan payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12)

4,000,098

1,582,213

17,627,718 15,160,970

Current Liabilities
Short term payables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(13)

0

452,625

Interest payable back-to-back loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(14)

790,722

2,543,171

Interest payable loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(15)

364,009

116,142

Accounts payable and accrued expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(16)

8,313

6,131

1,163,044

3,118,069

TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY AND LlABlLITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,528,349 19,731,422

The accompanying notes form part of these accounts.

Signed in Amsterdam, The Netherlands on February 3, 2012.

TRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT (T.I.M.) B.V.
<i>Managing director
Mr. Dennis C. Kulk / Mr. Huig J. Braamskamp
<i>Attorney-in-fact A / <i>Attorney-in-fact A
Jan-Willem Terlouw
<i>Directeur CHERSON INVESTMENTS B.V.

<i>CHERSON INVESTMENTS B.V.

<i>Amsterdam

<i>Bilan au 31 décembre 2011

<i>(avant affectation des résultats)

<i>(exprimé en euros)

Notes

2011

2010

ACTIF
Actif immobilisé
Investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4 43 791 795

6 019 285

Sommes à recevoir sur emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5

75 709

75 438

Sommes à recevoir sur financements intra-groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6 13 627 620 13 578 757

57 495 124 19 673 480

Actif circulant
Intérêts à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7

9 301

740

Intérêts à recevoir sur financements intra-groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8

0

0

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9

23 319

56 834

TVA à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605

368

33 225

57 942

21661

L

U X E M B O U R G

TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 528 349 19 731 422

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10

Capital émis et entièrement libéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 000

20 000

Prime d'émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 300 786

2 710 331

Déficit cumulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 277 948)

(989 505)

Résultat net sur l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 694 749

(288 443)

38 737 587

1 452 383

Passif à long terme
Sommes à payer sur financements intra-groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-11 13 627 620 13 578 757

Sommes à payer sur emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-12

4 000 098

1 582 213

17 627 718 15 160 970

Passif
Dettes à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-13

0

452 625

Intérêts à payer sur financements intra-groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14

790 722

2 543 171

Intérêts à payer sur emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-15

364 009

116 142

Comptes fournisseurs et charges à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-16

8 313

6 131

1 163 044

3 118 069

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 528 349 19 731 422

Les notes ci-jointes font partie intégrante des comptes.
Référence de publication: 2012022090/689.
(120028041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

CanGro Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.768,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.759.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2012007537/10.
(120008370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Capgemini Reinsurance Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 24.867.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 11 avril 2011

8. Le Conseil décide de transférer le siège social de la société du 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg au 534, rue

de Neudorf L-2220 Luxembourg avec effet au 21 mars 2011.

<i>Pour la société CAPGEMINI REINSURANCE COMPANY
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012007538/12.
(120007910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Cheylaroise de Participation S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 138.878.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

21662

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 30.11.2011.

<i>POUR LA GERANCE
Signatures

Référence de publication: 2012007539/12.
(120008242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Chicago Mercantile Exchange Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 150.918.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012007540/9.
(120008101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Façades et Structures Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7305 Steinsel, 7, In der Duerrwiss.

R.C.S. Luxembourg B 111.668.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31/05/2011

Il ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31/05/2011 que l’assemblée:
- accepte la démission de Monsieur Henri Moos de son poste d’administrateur;
- désigne Madame Mannes Tirza Chawah, née à Zurich (Suisse), le 21 janvier 1969 et demeurant à B-2018 Antwerpen,

138 Belgielei au poste d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2017;

- décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Richard Moos et Jonathan Moos jusqu’à l’assemblée

générale à tenir en 2017;

- décide de renouveler le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Richard Moos jusqu’à l’assemblée générale à

tenir en 2017;

- décide de renouveler le mandat de commissaire de Monsieur Thanh Liêm Nguyen jusqu’à l’assemblée générale à tenir

en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Steinsel, le 10/01/2012.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2012007635/21.
(120008377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

La Financière de Luxembourg S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 28.401.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2011:

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Christoph PIEL, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Lu-

xembourg  en  remplacement  de  Monsieur  René  SCHLIM,  40,  Boulevard  Joseph  II,  L-1840,  Luxembourg.  Son  mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2017.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme comme administrateurs:
- Monsieur Robert RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin

2017.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- Fiduciaire de Luxembourg S.A. avec siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2017.

21663

L

U X E M B O U R G

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2012009023/22.
(120009925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

DELTA TRANSACTIONS (Holdings) SAH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 59.033.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée a décidée de nommer comme Administrateur avec effet 10 Janvier 2012

Mr Pierre Leneveu , commerçant , né le 1 

er

 septembre 1960 à Montreal , résident à 2100 St-Joseph Blvd Lachine,

Quebec H8S 2N7 Canada

Luxembourg, le 10 Janvier 2012.

Mr Daren Zenner
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012007577/14.
(120008543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Isar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 142.018.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of December.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held a meeting of the shareholders of Isar S.à r.l, (the "Company"), a Luxembourg société à responsabilité limitée,

incorporated by a notarial deed drawn up on 25 September 2008 by Me Joseph Elviger, having its registered office at 13,
rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 142.018 and whose articles of association (the "Articles") have been published in
the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 2551, page 122409 dated
18 October 2008 and have been amended for the last time by a notarial deed drawn up by Me Martine Schaeffer, notary
public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 3 July 2009, published in the Mémorial on 4 August 2009
number 1497 page 71843. The Articles have not been amended since.

The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman appointed as Secretary, Mr Raymond THILL, employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as Scrutineer, Mr Gianpiero SADDI, prenamed.
The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The names of the shareholders represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders and the

number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed ne varietur by the
proxyholders of the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with
it.

II.- It appears from the attendance list, that the one thousand (1,000) shares representing the whole share capital of

the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed of the agenda of the
meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and
can validly deliberate on all items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to amend the object clause of the Company, i.e. article 3 of the articles of association of the Company

(the "Articles") as follows:

Art. 3. Object.
3.1 The Company's sole object is:

21664

L

U X E M B O U R G

3.1.1 to hold interests and participations in Luxembourg or foreign entities the sole object and purpose of which is,

according to their articles or constitutional documents, to acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate
("Real Estate Companies"); and/or

3.1.2 to hold interests and participations in Luxembourg or foreign entities the sole object of which is, according to

their articles or constitutional documents, to hold interests and participations in Real Estate Companies; and/or

3.1.3 to directly invest in, acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate.
3.2 To serve the object of the Company, the Company may perform all operations and all transactions which are

necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of
its purpose, by including, but not limited to, granting of loans to companies within the meaning of 3.1 above, in which it
has a direct or indirect interest and by encumbering its assets and assigning and pledging claims from legal relationships
relating to its assets as security for loans taken up by the Company, it being understood that (i) as long as the Company
is a direct or indirect subsidiary of the Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS, the Company will only enter into such
transactions which do not result in a breach of the investment powers and restrictions applicable to the Alpina Real Estate
Fund SCA SICAV-FIS and (ii) the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector."

2. Miscellaneous.
After due and careful deliberation, the following resolution is taken unanimously:

<i>Sole resolution

The meeting of the shareholders resolves to amend the object clause, i.e. article 3 of the Articles of the Company as

follows:

Art. 3. Object.
3.1 The Company's sole object is:
3.1.1 to hold interests and participations in Luxembourg or foreign entities the sole object and purpose of which is,

according to their articles or constitutional documents, to acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate
("Real Estate Companies"); and/or

3.1.2 to hold interests and participations in Luxembourg or foreign entities the sole object of which is, according to

their articles or constitutional documents, to hold interests and participations in Real Estate Companies; and/or

3.1.3 to directly invest in, acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate.
3.2 To serve the object of the Company, the Company may perform all operations and all transactions which are

necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of
its purpose, by including, but not limited to, granting of loans to companies within the meaning of 3.1 above, in which it
has a direct or indirect interest and by encumbering its assets and assigning and pledging claims from legal relationships
relating to its assets as security for loans taken up by the Company, it being understood that (i) as long as the Company
is a direct or indirect subsidiary of the Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS, the Company will only enter into such
transactions which do not result in a breach of the investment powers and restrictions applicable to the Alpina Real Estate
Fund SCA SICAV-FIS and (ii) the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 1300.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the the persons

appearing, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing
person, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée des associés de Isar S.à r.l, (la "Société") une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, constituée selon acte notarié du notaire Joseph Elvinger, en date du 25 septembre 2008, ayant son siège social
au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.018 et dont les statuts (les "Statuts") furent publiés au Mémorial C,

21665

L

U X E M B O U R G

Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 18 octobre 2008 numéro 2551 page 122409 et furent
modifiés par un acte notarié de Me Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le
3 juillet 2009, publié au Mémorial du 4 août 2009 numéro 1497 page 71843. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Mr Gianpiero SADDI, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme Secrétaire Mr Raymond THILL, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme Scrutateur Mr Gianpiero SADDI, précité
Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert du notaire qu'il acte que:
I.- Les noms des associés représentés à l'assemblée, les procurations des associés représentés et le nombre de parts

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration ne varietur, une fois
signées par les mandataires des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être
enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la

Société sont représentées à la présente assemblée. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de
l'ordre du jour de l'assemblée et renoncent aux formalités de convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée
et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Agenda

1. Décision de modifier la clause d'objet de la Société (article 3) qui sera dorénavant lue comme suit:

Art. 3. Objet.
3.1 Le seul objet de la société est:
3.1.1 de détenir des intérêts et participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, dont le seul objet est,

conformément à leur statuts ou documents statutaires, d'acquérir, détenir, administrer, gérer, développer, louer et dis-
poser d'immobilier (les "Sociétés Immobilières"); et/ou

3.1.2 de détenir des intérêts et participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, dont le seul objet est,

conformément à leur statuts ou documents statutaires, de détenir des intérêts et participations dans des Sociétés Im-
mobilières; et/ou

3.1.3 d'investir directement dans, acquérir, détenir, administrer, développer, louer et disposer de biens immobiliers.
3.2 Afin de réaliser l'objet de la Société, la Société pourra accomplir toutes opérations et toutes transactions néces-

saires à la réalisation de son objet ainsi que toutes opérations liées directement ou indirectement à l'accomplissement
de son objet, en ce compris, sans limitation, d'octroyer des prêts à des sociétés, dans le sens de l'article 3.1. ci-dessus,
dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte, en grevant ses biens et en transférant et en
mettant en garantie les créances issues de relations liées à ses biens en tant que garanties pour tous prêts contracté par
la Société, étant entendu (i) qu'aussi longtemps que la Société est une filiale directe ou indirecte d'Alpina Real Estate Fund
SCA SICAV-FIS de telles activités n'aient pas pour effet de violer ni les pouvoirs des investisseurs ni les restrictions
applicables à Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS et (ii) que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait
qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier."

2. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

<i>Résolution unique

L'assemblée des associés décide de modifier la clause d'objet de la Société qui sera dorénavant lue comme suit:

Art. 3. Objet.
3.1 Le seul objet de la société est:
3.1.1 de détenir des intérêts et participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, dont le seul objet est,

conformément à leur statuts ou documents statutaires, d'acquérir, détenir, administrer, gérer, développer, louer et dis-
poser d'immobilier (les "Sociétés Immobilières"); et/ou

3.1.2 de détenir des intérêts et participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, dont le seul objet est,

conformément à leur statuts ou documents statutaires, de détenir des intérêts et participations dans des Sociétés Im-
mobilières; et/ou

3.1.3 d'investir directement dans, acquérir, détenir, administrer, développer, louer et disposer de biens immobiliers.
3.2 Afin de réaliser l'objet de la Société, la Société pourra accomplir toutes opérations et toutes transactions néces-

saires à la réalisation de son objet ainsi que toutes opérations liées directement ou indirectement à l'accomplissement
de son objet, en ce compris, sans limitation, d'octroyer des prêts à des sociétés, dans le sens de l'article 3.1. ci-dessus,
dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte, en grevant ses biens et en transférant et en
mettant en garantie les créances issues de relations liées à ses biens en tant que garanties pour tous prêts contracté par
la Société, étant entendu (i) qu'aussi longtemps que la Société est une filiale directe ou indirecte d'Alpina Real Estate Fund

21666

L

U X E M B O U R G

SCA SICAV-FIS de telles activités n'aient pas pour effet de violer ni les pouvoirs des investisseurs ni les restrictions
applicables à Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS et (ii) que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait
qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier."

<i>Coûts

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement EUR 1300.

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte

soit dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de ces mêmes personnes, et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.
Après que lecture de l'acte a été faite au mandataire des personnes comparantes, connues du notaire par son nom,

prénom, statut marital, lieu de résidence, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 janvier 2012. Relation: LAC/2012/690. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

<i>Le Receveur

 (signé): pd. Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007129/166.
(120007600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2012.

CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.331.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2012007546/11.
(120007983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Cedre Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 141.930.

Par la présente, je dénonce avec effet immédiat le contrat de domiciliation me liant avec la société CEDRE HOLDING

SARL ainsi que le siège social de la prédite société.

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

A. KRONSHAGEN.

Référence de publication: 2012007547/9.
(120008067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Cabo Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 59.495.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 décembre 2011 que
Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre

2011:

- Monsieur Christian THIRY, Entrepreneur, demeurant professionnellement au 14, rue Michel Flammang L-1524 Lu-

xembourg

- Monsieur François THIRY, Entrepreneur, demeurant professionnellement au 14 rue Michel Flammang L-1524 Lu-

xembourg

Est élu Administrateur, en remplacement de Monsieur Jacques ELVINGER, dont le mandat est arrivé à son terme:

21667

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Christophe THIRY, employé, demeurant 13, rue de Moutfort L-5355 Oetrange.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31

décembre 2011.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Alain GODAR, Directeur financier, demeurant professionnellement au 14,rue Michel Flammang L-1524

Luxembourg.

Luxembourg le 16 décembre 2011.

Pour Extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2012009331/25.
(120010015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Delilah S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 114.215.900,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.734.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’associé unique de la Société tenue à Luxembourg en

date du 30 décembre 2011 que:

1. L’assemblée générale décide de clôturer la liquidation.
2. L’assemblée générale décide que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une

durée de cinq ans à partir de cette publication au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012007567/17.
(120007774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Isometall Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 4, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 95.714.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2011

Il a été décidé comme suit:
de renouveler pour un nouveau terme de six ans les mandats des administrateurs et du Commissaire, leurs mandats

prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2017, soit:

- Monsieur Urbin SCHNEIDERS, Administrateur de sociétés, demeurant à B-6670 GOUVY, 19, rue de Bého, admi-

nistrateur, administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration;

- Madame Myriam COLLIN, employée, demeurant à B-6670 GOUVY, 19, rue de Bého, administrateur;
- Monsieur Raymund MICHAELIS, Administrateur de sociétés, demeurant à B-4791 BURGREULAND, Braunlauf 42A,

administrateur;

- FN-SERVICES S.à r.l., avec siège social au 61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH, Commissaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 16 janvier 2012.

<i>Pour ISOMETALL DISTRIBUTION S.A.
Société Anonyme
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2012008997/22.
(120009929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

21668

L

U X E M B O U R G

Asturias Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 166.078.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Riopaila Castilla S.A., a public company limited by shares (sociedad anónima) incorporated under the laws of Colombia,

having its registered office at Carrera 1 n°24-56 Santiago de Cali – Valle del Cauca – Colombia, registered with the
Chamber of Commerce of Cali under number 686130 – 4,

here represented by Annick Braquet, private employee, whose professional address is in L-1319 Luxembourg, 101,

rue Cents, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
The name of the company is “ASTURIAS HOLDING SARL” (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period.

21669

L

U X E M B O U R G

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), represented by twenty-five thousand (25,000)

shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares to third parties owing to death must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board)

constituted of at least one class A manager and one class B manager.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented, with at least one class
A manager voting in favour. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if
no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii)Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of one Class A manager and one Class

B manager, except for those relating to dayto-day management of the Company (including, without limitation, payment
of invoices, transfers of cash, administrative actions, tax returns, registrations with the Luxembourg Register of Commerce

21670

L

U X E M B O U R G

and Companies or any other authority) not exceeding more than ten thousand Euros (EUR 10,000.-) in which case the
Company is bound by the signature of any manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated by the Company.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders’ circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii)The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters

of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirtyfirst (31) of December of each year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

21671

L

U X E M B O U R G

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d’entreprises agréés).

14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts;

(iv) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company’s
assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

<i>Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2012.

<i>Subscription and Payment

Riopaila Castilla S.A. represented as stated above, subscribes to twenty-five thousand (25,000) shares in registered

form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of
twentyfive thousand Euro (EUR 25,000.-).

The amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) is at the Company’s disposal and evidence thereof has been

given to the undersigned notary.

21672

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,400.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following person is appointed as class A manager of the Company for an indefinite period:
- Alfonso OCAMPO GAVIRIA, engineer, born on June 17, 1950, in Santiago de Cali, Colombia, having his professional

address at Carrera 1 N° 24-56, 8 

th

 floor, Santiago de Cali, Colombia.

2. The following person is appointed as class B manager of the Company for an indefinite period:
- Jacob MUDDE, lawyer, born on October 14, 1969, in Rotterdam, The Netherlands, having his professional address

at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The registered office of the Company is located at, 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing party, who have signed it together with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le vingt-septième jour de décembre.
Pardevant le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Riopaila Castilla S.A., une société anonyme (sociedad anónima) régie par les lois de Colombie, dont le siège social se

situe au Carrera 1 n°24-56 Santiago de Cali – Valle del Cauca – Colombie, inscrite auprès de la Chambre de Commerce
de Cali, sous le numéro 686130 -4,

représentée par Annick Braquet, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-

curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "ASTURIAS HOLDING SARL" (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par

21673

L

U X E M B O U R G

souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000), représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales

sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos)à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil) composé

d’au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure

21674

L

U X E M B O U R G

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, y compris
au moins un gérant de catégorie A votant en faveur. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux
signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature d’un gérant de Catégorie A et un

gérant de Catégorie B, sauf pour ce qui est de la gestion quotidienne de la Société (y compris notamment, le paiement
de factures, le transfert de liquidités, les procédures administratives, les déclarations fiscales, l’immatriculation auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés ou tout autre autorité) ne dépassant pas dix mille euros (EUR 10.000), auquel cas
la Société sera engagée par la signature de tout gérant.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par la Société.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’ Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

21675

L

U X E M B O U R G

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii)Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l’Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-etun (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être
renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les

associés doivent reverser l’excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf

21676

L

U X E M B O U R G

décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Libération

Riopaila Castilla S.A., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt-cinq mille (25.000) parts sociales

sous forme nominative, d’une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et accepte de les libérer intégralement par
un apport en numéraire d’un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000).

Le montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire

instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à EUR 1.400.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:
Alfonso OCAMPO GAVIRIA, ingénieur, né le 17 juin 1950 à Santiago de Cali, Colombie, résidant professionnellement

au Carrera 1 N°24-56, 8 

th

 floor, Santiago de Cali, Colombie.

2. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:
Jacob MUDDE, avocat, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, résidant professionnellement au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/167. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

21677

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Référence de publication: 2012006908/491.
(120007513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2012.

CEREP Strategic Land S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 156.531.

Les comptes annuels pour la période du 5 novembre 2010 (date de constitution) au 30 juin 2011 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007549/11.
(120008218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Main S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 140.736.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of December.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held a meeting of the shareholders of Main S.à r.l, (the "Company"), a Luxembourg société à responsabilité limitée,

incorporated by a notarial deed drawn up on 25 July 2008 by Me Joseph Elvinger, having its registered office at 13, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 140.736 and whose articles of association (the "Articles") have been published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 2085, page 100064 dated 28
August 2008 and have been amended for the last time by a notarial deed drawn up by Me Joseph Elvinger on 6 November
2009, published in the Mémorial on 14 December 2009 number 2429 page 116567. The Articles have not been amended
since.

The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman appointed as Secretary, Mr Raymond THILL, employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting appointed as Scrutineer, Mr Gianpiero SADDI, prenamed.
The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The names of the shareholders represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders and the

number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed ne varietur by the
proxyholders of the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with
it.

II.- It appears from the attendance list, that the one thousand (1,000) shares representing the whole share capital of

the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed of the agenda of the
meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and
can validly deliberate on all items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to amend the object clause of the Company, i.e. article 3 of the articles of association of the Company

(the "Articles") as follows:

Art. 3. Object.
3.1 The Company's sole object is:
3.1.1 to hold interests and participations in Luxembourg or foreign entities the sole object and purpose of which is,

according to their articles or constitutional documents, to acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate
("Real Estate Companies"); and/or

3.1.2 to hold interests and participations in Luxembourg or foreign entities the sole object of which is, according to

their articles or constitutional documents, to hold interests and participations in Real Estate Companies; and/or

3.1.3 to directly invest in, acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate.

21678

L

U X E M B O U R G

3.2 To serve the object of the Company, the Company may perform all operations and all transactions which are

necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of
its purpose, by including, but not limited to, granting of loans to companies within the meaning of 3.1 above, in which it
has a direct or indirect interest and by encumbering its assets and assigning and pledging claims from legal relationships
relating to its assets as security for loans taken up by the Company, it being understood that (i) as long as the Company
is a direct or indirect subsidiary of the Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS, the Company will only enter into such
transactions which do not result in a breach of the investment powers and restrictions applicable to the Alpina Real Estate
Fund SCA SICAV-FIS and (ii) the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector."

2. Miscellaneous.
After due and careful deliberation, the following resolution is taken unanimously:

<i>Sole resolution

The meeting of the shareholders resolves to amend the object clause, i.e. article 3 of the Articles of the Company as

follows:

Art. 3. Object.
3.1 The Company's sole object is:
3.1.1 to hold interests and participations in Luxembourg or foreign entities the sole object and purpose of which is,

according to their articles or constitutional documents, to acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate
("Real Estate Companies"); and/or

3.1.2 to hold interests and participations in Luxembourg or foreign entities the sole object of which is, according to

their articles or constitutional documents, to hold interests and participations in Real Estate Companies; and/or

3.1.3 to directly invest in, acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate.
3.2 To serve the object of the Company, the Company may perform all operations and all transactions which are

necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of
its purpose, by including, but not limited to, granting of loans to companies within the meaning of 3.1 above, in which it
has a direct or indirect interest and by encumbering its assets and assigning and pledging claims from legal relationships
relating to its assets as security for loans taken up by the Company, it being understood that (i) as long as the Company
is a direct or indirect subsidiary of the Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS, the Company will only enter into such
transactions which do not result in a breach of the investment powers and restrictions applicable to the Alpina Real Estate
Fund SCA SICAV-FIS and (ii) the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 1300.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the the persons

appearing, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing
person, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée des associés de Main S.à r.l, (la "Société") une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, constituée selon acte notarié de Me Joseph Elvinger, en date du 25 juillet 2008, ayant son siège social au 13,
rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.736 et dont les statuts (les "Statuts") furent publiés au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 28 août 2008 numéro 2085 page 100064 et furent modifiés par
un acte notarié du notaire Joseph Elvinger, le 6 novembre 2009, publié au Mémorial du 14 décembre 2009 numéro 2429
page 116567. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Mr Gianpiero SADDI, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme Secrétaire Mr Raymond THILL, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

21679

L

U X E M B O U R G

L'assemblée choisit comme Scrutateur Mr Gianpiero SADDI, précité.
Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert du notaire qu'il acte que:
I.- Les noms des associés représentés à l'assemblée, les procurations des associés représentés et le nombre de parts

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration ne varietur, une fois
signées par les mandataires des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être
enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la

Société sont représentées à la présente assemblée. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de
l'ordre du jour de l'assemblée et renoncent aux formalités de convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée
et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Agenda

1. Décision de modifier la clause d'objet de la Société (article 3) qui sera dorénavant lue comme suit:

Art. 3. Objet.
3.1 Le seul objet de la société est:
3.1.1 de détenir des intérêts et participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, dont le seul objet est,

conformément à leur statuts ou documents statutaires, d'acquérir, détenir, administrer, gérer, développer, louer et dis-
poser d'immobilier (les "Sociétés Immobilières"); et/ou

3.1.2 de détenir des intérêts et participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, dont le seul objet est,

conformément à leur statuts ou documents statutaires, de détenir des intérêts et participations dans des Sociétés Im-
mobilières; et/ou

3.1.3 d'investir directement dans, acquérir, détenir, administrer, développer, louer et disposer de biens immobiliers.
3.2 Afin de réaliser l'objet de la Société, la Société pourra accomplir toutes opérations et toutes transactions néces-

saires à la réalisation de son objet ainsi que toutes opérations liées directement ou indirectement à l'accomplissement
de son objet, en ce compris, sans limitation, d'octroyer des prêts à des sociétés, dans le sens de l'article 3.1. ci-dessus,
dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte, en grevant ses biens et en transférant et en
mettant en garantie les créances issues de relations liées à ses biens en tant que garanties pour tous prêts contracté par
la Société, étant entendu (i) qu'aussi longtemps que la Société est une filiale directe ou indirecte d'Alpina Real Estate Fund
SCA SICAV-FIS de telles activités n'aient pas pour effet de violer ni les pouvoirs des investisseurs ni les restrictions
applicables à Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS et (ii) que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait
qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier."

2. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

<i>Résolution unique

L'assemblée des associés décide de modifier la clause d'objet de la Société qui sera dorénavant lue comme suit:

Art. 3. Objet.
3.1 Le seul objet de la société est:
3.1.1 de détenir des intérêts et participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, dont le seul objet est,

conformément à leur statuts ou documents statutaires, d'acquérir, détenir, administrer, gérer, développer, louer et dis-
poser d'immobilier (les "Sociétés Immobilières"); et/ou

3.1.2 de détenir des intérêts et participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, dont le seul objet est,

conformément à leur statuts ou documents statutaires, de détenir des intérêts et participations dans des Sociétés Im-
mobilières; et/ou

3.1.3 d'investir directement dans, acquérir, détenir, administrer, développer, louer et disposer de biens immobiliers.
3.2 Afin de réaliser l'objet de la Société, la Société pourra accomplir toutes opérations et toutes transactions néces-

saires à la réalisation de son objet ainsi que toutes opérations liées directement ou indirectement à l'accomplissement
de son objet, en ce compris, sans limitation, d'octroyer des prêts à des sociétés, dans le sens de l'article 3.1. ci-dessus,
dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte, en grevant ses biens et en transférant et en
mettant en garantie les créances issues de relations liées à ses biens en tant que garanties pour tous prêts contracté par
la Société, étant entendu (i) qu'aussi longtemps que la Société est une filiale directe ou indirecte d'Alpina Real Estate Fund
SCA SICAV-FIS de telles activités n'aient pas pour effet de violer ni les pouvoirs des investisseurs ni les restrictions
applicables à Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS et (ii) que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait
qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier."

21680

L

U X E M B O U R G

<i>Coûts

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement EUR 1300.

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte

soit dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de ces mêmes personnes, et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.
Après que lecture de l'acte a été faite au mandataire des personnes comparantes, connues du notaire par son nom,

prénom, statut marital, lieu de résidence, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 janvier 2012. Relation: LAC/2012/692. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

<i>Le Receveur

 (signé): pd. Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007192/166.
(120007591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2012.

PythAgoria Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 45, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 161.425.

L'an deux mil onze, le neuf novembre.
Pardevant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Pierre-Yves THOMAS, né à Vielsalm (B), le 5 avril 1967, demeurant à B-6600 Bastogne, rue du Bois d'Hazy,

32,

lequel comparant a exposé au notaire:
- que la société «PythAgoria Sàrl» a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, de résidence à Wiltz,

en date du 27 mai 2011, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1830, du 10 août
2011,

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 161.425,
- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- €) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation

de valeur nominale,

- que le comparant est le seul et unique associé représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée

«PythAgoria Sàrl» avec siège social à L-8436 Steinfort, 71, route de Kleinbettingen,

Ensuite le comparant, agissant comme prédit a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'associé décide de transférer le siège social de la société de Steinfort à L-9530 Wiltz, 45, Grand-Rue et de modifier

l'article 2 - alinéa 1 

er

 - des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Wiltz.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P.-Y. Thomas, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 11 novembre 2011 - WIL/2011/884 - Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

21681

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-

ciétés.

Wiltz, le 8 décembre 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2012008031/39.
(120008123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Certifica Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 86.770.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2012007550/11.
(120008299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Forest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 41.646.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2011:

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Madame Annette SCHROEDER, 40, Boulevard Joseph II, L-1840,

Luxembourg et Monsieur Henri REITER, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg en remplacement de Monsieur
Marco NEUEN, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg et Monsieur René SCHLIM, 40, Boulevard Joseph II, L-1840,
Luxembourg. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2013.

L’Assemblée renomme comme administrateur:
Monsieur Jacques RECKINGER, administrateur, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Lu-

xembourg.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.
L’Assemblée renomme comme commissaire aux comptes:
Fiduciaire de Luxembourg S.A., avec siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2012008261/23.
(120008858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

RIVER Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 51.310.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 29 décembre 2011, enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2012, LAC/2012/418, aux droits de soixante-
quinze euros (75.- EUR), que la société RIVER Spf S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire Marthe THYES-WALCH, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 17 mai 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 426 du 2 septembre 1995, dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg en date du
11 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1373 du 16 juillet 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1373 du 16 juillet 2009.

La liquidation de la société a été décidée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire

instrumentaire en date du 28 octobre 2011, pas encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

21682

L

U X E M B O U R G

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et autres documents de la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans après la clôture de liquidation

au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Référence de publication: 2012009180/24.
(120010432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Clara Vision S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 144.265.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007555/10.
(120008234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Cognos Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 54, Zone Industrielle Am Bann.

R.C.S. Luxembourg B 105.908.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012007558/9.
(120007802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Compagnie Européenne de Luxe et Traditions S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.512.

Les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2012007559/11.
(120008371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Compagnie Européenne de Luxe et Traditions S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.512.

Les comptes annuels pour la période du 9 août 2007 (date de constitution) au 31 décembre 2007 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2012007560/11.
(120008373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Cotralux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 93.294.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012007561/10.
(120008380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

21683

L

U X E M B O U R G

CR PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 151.419.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007563/10.
(120008228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Synergix International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 74.420.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 19 dé-

cembre 2011 que:

- Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs:
* Madame Joëlle MAMANE
* Monsieur Claude Jacques BLOCH
* Madame Micheline Pauline COHEN-BLOCH, demeurant au 6, rue Rabbi Tarfon, 93592 Jerusalem, Israël.
Le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, née le 14/01/1951 à Fes

(Maroc), demeurant professionnellement au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, est confirmé pour une durée illi-
mitée.

- A été réélue au poste de Commissaire:
* Montbrun Révision Sàrl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 67.501, et ayant son siège social à

L-1653 Luxembourg, «Le Dôme» Espace Pétrusse – 2, Avenue Charles de Gaulle.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012008594/23.
(120009007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Magna Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.017.041,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 148.304.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of December,
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Magna Financing Luxembourg Canada Limited, registered as an Ontario corporation at the Ministry of Government

Services of the Province of Ontario, Canada, under number 002295935, with a registered head office located at 337
Magna Drive, Aurora, Ontario L4G 7K1, Canada, acting through its branch, Magna Financing Luxembourg Canada Limited
– Luxembourg Branch, with registered office at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg register of Commerce and Companies under number B 164.603 (the “Sharehol-
der”),

Hereby represented by Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

on 20 December 2011,

The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder, represented as above stated, has requested the undersigned notary to record that the Shareholder

is the sole shareholder of Magna Financing Luxembourg S.à r.l. (formerly Philipp S.à r.l.), a société à responsabilité limitée
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of seventeen thousand forty-one US
Dollars (17,041.-), with registered office at 15, Rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, of 21 September 2009, published

21684

L

U X E M B O U R G

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2020 of 15 October 2009 and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 148.304 (the "Company"). The articles of incor-
poration of the Company have last been amended pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in
Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg dated 11 November 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To create a new class of mandatory redeemable preferred shares, having such rights and privileges as set out in the

articles of incorporation of the Company following their restatement and the law of 10 August 1915 relating to commercial
companies, as amended.

2. To increase the share capital of the Company by an amount of eleven million US Dollars (USD 11,000,000.-) so as

to raise it from its present amount of seventeen thousand forty-one US Dollars (USD 17,041.-) to an amount of eleven
million seventeen thousand forty-one US Dollars (USD 11,017,041.-).

3. To issue eleven million (11,000,000) new mandatory redeemable preferred shares, with a nominal value of one US

Dollar (USD 1.-) per share.

4. To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of one billion

eighty-nine million US Dollars (USD 1,089,000,000.-), by the Shareholder and to accept payment in full for such new
shares by a contribution in cash.

5. To amend articles 1, 5, 6, 24, 28 and 29 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect, inter alia,

the foregoing proposed resolutions.

6. Miscellaneous.
requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to create a new class of mandatory redeemable preferred shares, having such rights and

privileges as set out in the articles of incorporation of the Company following their restatement and the law of 10 August
1915 relating to commercial companies, as amended.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of eleven million US Dollars

(USD 11,000,000.-) so as to raise it from its present amount of seventeen thousand forty-one US Dollars (USD 17,041.-)
to an amount of eleven million seventeen thousand forty-one US Dollars (USD 11,017,041.-).

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to issue eleven million (11,000,000) new mandatory redeemable preferred shares with a

nominal value of one US Dollar (USD 1.-) per share.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared the Shareholder, represented by Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, prenamed, by virtue of the

above mentioned proxy.

The Shareholder, declared to subscribe for the eleven million (11,000,000) new mandatory redeemable preferred

shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount
of one billion eighty-nine million US Dollars (USD 1,089,000,000) and to fully pay in cash for these new shares.

The amount of one billion one hundred million US Dollars (USD 1,100,000,000.-) was thus as from that moment at

the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

In view of the above, the Shareholders resolved to amend articles 1, 5, 6, 24, 28 and 29 of the articles of incorporation

of the Company so as to reflect, inter alia, the foregoing resolutions.

As a result, the first paragraph of Article 1 shall from now on read as follows:

“ Art. 1. Form, Name. There is established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the

"Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code (the “Laws”) and by the present articles of incorporation
(the "Articles of Incorporation").”

As a result, Article 5 shall from now on read as follows:

“ Art. 5. Capital. The issued capital of the Company is set at eleven million seventeen thousand forty-one US Dollars

(USD 11,017,041.-) represented by two (2) classes of shares as follows: seventeen thousand forty-one (17,041) ordinary

21685

L

U X E M B O U R G

shares (hereinafter referred to as the “Ordinary Shares”) and eleven million (11,000,000) mandatory redeemable pre-
ferred shares (hereinafter referred to as the “Mandatory Redeemable Preferred Shares” and together with the Ordinary
Shares shall be referred to as the “Shares”), with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all of which are fully
paid up.

The shareholder owning Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium

paid for the subscription of Ordinary Shares. The shareholder owning Mandatory Redeemable Preferred Shares will be
exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium paid for the subscription of Mandatory Redeemable
Preferred Shares.

Share premium paid on Ordinary Shares or Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in specific share

premium accounts, as follows:

- any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an ordinary shares' share premium account (hereinafter

referred to as the “Ordinary Shares' Share Premium Account”) and such share premium shall remain attached to the
Ordinary Shares upon which the share premium was paid;

- any share premium paid on Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in a mandatory redeemable

preferred shares' share premium account (hereinafter referred to as the “Mandatory Redeemable Preferred Shares' Share
Premium Account”) and such share premium shall remain attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares upon
which the share premium was paid”.

As a result, Article 6 shall from now on read as follows:

“ Art. 6. Shares. All Shares will be issued in registered form. Each Share entitles to one vote, regardless of its nature

and class to which they belong.

Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed

amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its Shares.
When the Company is composed of several shareholders, the Shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

The Company may acquire its own Ordinary Shares in view of their immediate cancellation.
All Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued in the form of redeemable shares. The redemption of the

Mandatory Redeemable Preferred Shares can only be made by means of sums available for distribution pursuant to the
Laws (distributable funds, inclusive of amounts booked to the Mandatory Redeemable Preferred Shares' Share Premium
Account or proceeds of a new issue made for the redemption purpose). Mandatory Redeemable Preferred Shares will
be redeemed pursuant to the following terms and conditions:

(i) if the Mandatory Redeemable Preferred Shares are not converted, the Company shall redeem all Mandatory Re-

deemable Preferred Shares then in issue upon expiry of a thirteen (13) years period from the date on which the relevant
Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued (hereinafter referred to as the “Final Mandatory Redemption Date”);

(ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the holder of Mandatory

Redeemable Preferred Shares is entitled to request (in one or several occasions) in writing the Company to redeem all
or part of its Mandatory Redeemable Preferred Shares; and

(iii) the holder of any Mandatory Redeemable Preferred Share, that has been redeemed, is entitled to receive a payment

in cash or in kind per redeemed Mandatory Redeemable Preferred Share (hereinafter referred to as the “Redemption
Price”) equal to:

1. the par value of the redeemed shares; plus
2. all and any accrued and unpaid dividends that the holder of redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares is

entitled to receive at the time of the redemption; plus

3. an amount corresponding to a portion of the Mandatory Redeemable Preferred Shares' Share Premium Account

equal to the balance of the Mandatory Redeemable Preferred Shares' Share Premium Account divided by the number of
outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares prior to the redemption; plus

4. to the extent not already covered by the component under point 2. of the Redemption Price, an amount corres-

ponding to the portion of the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account (as such expression is defined
in Article 28 below) divided by the number of outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares prior to the re-
demption.

Redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after redemption.

21686

L

U X E M B O U R G

All Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued in the form of shares convertible into Ordinary Shares. Man-

datory  Redeemable  Preferred  Shares  may  be  converted  into  Ordinary  Shares  (the  “Conversion”)  pursuant  to  the
following terms and conditions:

(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares may

at any time before such date, request (in one or several occasions) in writing to convert in Ordinary Shares all or part
of the Mandatory Redeemable Preferred Shares;

(ii) the Board of Managers is authorized and empowered to proceed with the Conversion, and to this effect record

or have recorded such Conversion in a notarial deed In such a case, the issuance of Ordinary Shares will be recorded in
a notarial deed amending these Articles of Incorporation and do whatsoever else is required to implement such Con-
version;

(iii) the Mandatory Redeemable Preferred Shares will be converted into a fair market value of Ordinary Shares (the

fair market value of each Ordinary Share being determined by the Board of Managers in good faith on the basis of a fair
valuation methodology) equal to the respective Mandatory Redeemable Preferred Shares par value, accrued and unpaid
dividends, attached Mandatory Redeemable Shares Premium Account and attached Mandatory Redeemable Shares Re-
serve Account. No decimal of Shares will be available. The board of managers of the Company may (in case of decimals)
either round up or round down to the closest appropriate number of Ordinary Shares.”

As a result, the first paragraph of Article 24 shall from now on read as follows:

“ Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of Shares represented, by a simple majority of votes cast.”

As a result, Article 28 shall from now on read as follows:

“ Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each

year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to
be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s) as follows:

(i) The holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares will be entitled to annual cumulative and preferential divi-

dend (the “MRPS Dividend”) at the annual rate of zero point one percent (0.1%) that will be

computed on the nominal value of the Mandatory Redeemable Preferred Shares and attached share premium (if any).
(ii) The holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares will be entitled to dividend payments provided that and to

the extent that the Company has sufficient liquid assets available, after each dividend payment is made to cover its current
expenses immediately after the payment of the dividend and one of the following two (2) events has occurred:

(i) the distribution of such a dividend payment is approved in compliance with the Laws and the Articles of Incorpo-

ration; or

(ii) Mandatory Redeemable Preferred Shares (including any attached share premium) are redeemed at the request of

the holder of the Mandatory Redeemable Preferred Shares.

Should profits of a given financial year be sufficient to distribute a dividend on the Mandatory Redeemable Preferred

Shares, in whole or in part, and the shareholder, or in case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders,
decide nonetheless to make no such distribution, the amount of the dividend that would have been distributed to the
holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be allocated to a distributable reserve booked in a Man-
datory Redeemable Preferred Shares reserve account (hereinafter referred to as the “Mandatory Redeemable Preferred
Shares Reserve Account”).

For the avoidance of doubts, converted Mandatory Redeemable Preferred Shares shall, following conversion, entitle

to dividend payments, including out of distributable amounts constituted prior to such conversion.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the holder of Ordinary Shares. The Manager(s) fix the amount and the
date of payment of any such advance payment.

In case of dissolution of the Company, the rights of the holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares will rank

junior to all other debts incurred by the Company but will rank senior to the holder of Ordinary Shares as set forth in
article 29 below.

Ordinary shares entitle to all distributions once Mandatory Redeemable Preferred Shares have received all distributions

to which they are entitled pursuant to these Articles of Incorporation”

21687

L

U X E M B O U R G

As a result, Article 29 shall from now on read as follows:

“ Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by

half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders in charge of such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

After the payment of all debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the remaining

available amount will be paid first in priority to the holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares up to an amount
corresponding to the Redemption Price as defined in Article 6 above and provided that the other conditions under Article
28 above are fulfilled. The Holder of Ordinary Shares will then be entitled to the remaining available amount (if any) on
a pro rata basis, according to the number of Ordinary shares held in the Company's capital by the holder of such Ordinary
shares.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of inconsistencies between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his or her

surname, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausendelf, am einundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz in Rambrouch (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

Magna Financing Luxembourg Canada Limited, eine in Ontario registrierte Gesellschaft, die beim Ministerium für Öf-

fentliche Dienstleistung in der Provinz von Ontario, Kanada unter der Nummer 002295935 eingetragen ist und ihren Sitz
in 337, Magna Drive, Aurora, Ontario L4G 7K1, Kanada hat, handelt über ihre Niederlassung, Magna Financing Luxem-
bourg Canada Limited – Luxembourg Branch, mit Sitz in 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg und eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 164.603 (der „Ge-
sellschafter“),

hier vertreten durch Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, Rechtsanwalt, mit Anschrift in Luxemburg, kraft einer, am

20. Dezember 2011 erteilten Vollmacht.

Die vorgenannte Vollmacht, bleibt dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Der Gesellschafter hat den unterzeichnenden Notar gebeten anzugeben, dass der Gesellschafter der alleinige Gesell-

schafter  von  Magna  Financing  Luxembourg  S.à  r.l.  (ehemals  Philipp  S.à  r.l.),  eine  nach  dem  luxemburgischen  Recht
gegründete société à responsabilité limitée, mit einem Gesellschaftskapital von siebzehntausendeinundvierzig US Dollar
(USD 17.041,-), mit Sitz in 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß
einer Urkunde von Maître Jean-Joseph Wagner, Notar, mit Amtssitz in Sanem, vom 21. September 2009 und im Mémorial
C unter Nummer 2020 am 15. Oktober 2009 veröffentlicht wurde und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsre-
gister Luxemburg unter der Nummer B 148.304 eingetragen ist (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde
zum letzten Mal gemäß einer Urkunde vom unterzeichnenden Notar vom 11. November 2011 geändert und ist noch
nicht im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg, Mémorial C, veröffentlicht worden.

Der Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärt über die Beschlüsse ausführlich informiert zu sein, welche

auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

<i>Tagesordnung

1. Eine neue Anteilsklasse von verpflichtend rückzahlbaren Vorzugsanteilen auszugeben, mit den gleichen Rechten, wie

sie in der Satzung der Gesellschaft nach ihrer Neufassung und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften gemäß seiner geänderten Fassung aufgeführt sind.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von elf Millionen US Dollar (USD 11.000.000,-), um das beste-

hende Kapital von siebzehntausendeinundvierzig US Dollar (USD 17.041,-), auf elf Millionen siebzehntausendeinundvierzig
US Dollar (USD 11.017.041,-) zu erhöhen.

3. Ausgabe von elf Millionen (11.000.000) neuen verpflichtend rückzahlbaren Vorzugsanteilen mit einem Nennwert

von jeweils einem US Dollar (USD 1,-) pro Gesellschaftsanteil.

21688

L

U X E M B O U R G

4.  Annahme  der  Zeichnung  der  neuen  Gesellschaftsanteile  und  vollständige  Zahlung  des  Aufgeldes  in  Höhe  eines

Gesamtbetrags von einer Milliarde achtundneunzig Millionen US Dollar (USD 1.089.000.000,-) durch den Gesellschafter
und vollständige Zahlung der neuen Gesellschaftsanteilen in bar.

5. Neufassung der Artikel 1, 5, 6, 24, 28 und 29 der Satzung, um die oben genannten Beschlüsse abzubilden.
6. Verschiedenes.
Der vorgenannt Erschienene forderte daraufhin den unterzeichnenden Notar auf Folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschließt eine neue Anteilsklasse von verpflichtend rückzahlbaren Vorzugsanteilen auszugeben,

mit den gleichen Rechten, wie sie in der Satzung der Gesellschaft nach ihrer Neufassung und dem Gesetz vom 10 August
1915 über Handelsgesellschaften gemäß seiner geänderten Fassung aufgelistet sind.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von elf Millionen US Dollar (USD 11.000.000,-)

zu erhöhen, um das bestehende Kapital von siebzehntausendeinundvierzig US Dollar (USD 17.041,-), auf elf Millionen
siebzehntausendeinundvierzig US Dollar (USD 11.017.041,-) zu erhöhen.

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, elf Millionen (11.000.000) neue verpflichtend rückzahlbaren Vorzugsanteile mit einem

Nennwert von jeweils einem US Dollar (USD 1,-) pro Gesellschaftsanteil auszugeben.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erschien der Gesellschafter, vertreten durch Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, vorerwähnt, gemäß der

oben genannten Vertretungsmacht.

Der Gesellschafter erklärte die Zeichnung von elf Millionen (11.000.000) neuer verpflichtend rückzahlbaren Vorzugs-

anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem US Dollar (USD 1,-) pro Gesellschaftsanteil und vollständige Zahlung des
Aufgeldes in Höhe eines Gesamtbetrags von einer Milliarde achtundneunzig Millionen US Dollar (USD 1.089.000.000,-)
und durch Zahlung diese neuen Anteile in bar.

Der Betrag von einer Milliarde einhundert Millionen US Dollar (USD 1.100.000.000,-) stand ab diesem Zeitpunkt der

Gesellschaft zur Verfügung und der unterschreibende Notar hat die notwendigen Dokumente dies belegend erhalten.

<i>Vierter Beschluss

In Anbetracht der obigen Beschlüsse, beschließt der Gesellschafter Artikel 1, 5, 6, 24, 28 und 29 der Satzung der

Gesellschaft abzuändern, um diese Beschlüsse, unter anderen, widerzuspiegeln.

Der Paragraph 1 von Artikel 1 der Satzung wird wie folgt abgeändert:

„ Art. 1. Form, Name. Es ist hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responabilité limitée) (die

„Gesellschaft“) gegründet, die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden
Fassung, Artikel 1832 des Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung (das „Gesetz“) und den Bestimmungen
der vorliegenden Satzung (die „Satzung“) unterliegen.“

Der Artikel 5 der Satzung wird wie folgt abgeändert:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt elf Millionen siebzehntausendeinund-

vierzig US Dollar (USD 11.017.041,-), eingeteilt in zwei (2) Gesellschaftsanteilsklassen wie folgt: siebzehntausendeinund-
vierzig (17.041) Stammanteile (im Folgenden bezeichnet als „Stammanteile“) und elf Millionen (11.000.000) verpflichtend
rückzahlbare Vorzugsanteile (im Folgenden bezeichnet als „Verpflichtend Rückzahlbare Vorzugsanteile“ und gemeinsam
mit den Stammanteilen im Folgenden als die „Anteile“ bezeichnet) mit einem Nennwert von je einem US Dollar (USD
1,-). Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.

Der Eigentümer der Stammanteile hat alleinigen Anspruch an den Rechten, die auch die Zahlung des Agio im Rahmen

der Zeichnung der Stammanteilen entstanden sind. Der Eigentümer der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen hat
alleinigen Anspruch an den Rechten, die durch die Zahlung des Agio im Rahmen der Zeichnung der Verpflichtend Rück-
zahlbaren Vorzugsanteilen entstanden sind.

Das Agio, das auf Stammanteilen oder Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen gezahlt wurde, soll jeweils auf

spezifischen Agio Konten erfasst werden:

- jegliches Agio, das auf Stammanteilen gezahlt wurde soll in einem Stammanteil Agio Konto gebucht werden (nach-

folgend das „Stammanteil Agio Konto"). Das Agio soll mit den Stammanteilen verbunden bleiben, für die das Agio bezahlt
wurde;

- jegliches Agio, das auf Verpflichtend Rückzahlbare Vorzugsanteile gezahlt wurde soll in einem Verpflichtend Rück-

zahlbaren  Vorzugsanteils  Konto  gebucht  werden  (Nachfolgenden  das  "Verpflichtend  Rückzahlbaren  Vorzugsanteils
Konto"), Das Agio soll mit den Verpflichtend Rückzahlbare Vorzugsanteile verbunden bleiben, für die das Agio bezahlt
wurde.“

21689

L

U X E M B O U R G

Der Artikel 6 der Satzung wird wie folgt abgeändert:

„ Art. 6. Anteile. Alle Anteile werden in Namensform ausgegeben. Jeder Anteil hat ein Stimmrecht, unabhängig von

seiner Form und zu welcher Anteilsklasse er gehören.

Jeder Anteil ist unteilbar.
Miteigentümer der Anteile müssen gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten, ob er unter

ihnen ernannt ist oder nicht, vertreten werden.

Wenn die Gesellschaft aus einem alleinigen Gesellschafter besteht, kann der alleinige Gesellschafter seine Anteile frei

übertragen.

Wenn die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern besteht, können die Anteile frei unter den Gesellschaftern über-

tragen werden, die Anteile können jedoch nur an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, sofern die Gesellschafter dies
mit mindestens einer drei viertel (3/4) Mehrheit des Gesellschaftskapitals genehmigen.

Die Übertragung von Anteilen erfolgt durch eine notarielle Urkunde oder durch einen privat-rechtlichen Vertrag. Eine

solche Übertragung ist nur für die Gesellschaft und für Dritte bindend, wenn die Gesellschaft ordnungsgemäß benach-
richtigt worden ist oder wenn die Übertragung von der Gesellschaft, unter Anwendung von Artikel 1690 des Luxem-
burgers Zivilgesetzbuchs angenommen wurde.

Das Halten von Anteilen geht mit der implizierten Annahme der Statuten und der Beschlüsse, die wirksam durch den/

die Gesellschafter beschlossen wurden, einher.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Stammanteile im Hinblick auf deren sofortige Aufhebung erwerben.
Alle Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteile sind in Form von rückzahlbaren Anteilen ausgegeben. Der Rückkauf

von Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteile kann nur durch gesetzlich ausschüttbaren Beträgen ausgegeben werden
(ausschüttungsfähiges Vermögen, einschließlich der Beträge welche im Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteils Agio
Konto blockiert werden oder die Einnahmen aus einer neuen Ausgabe für den Zweck des Rückkaufs gemacht werden).
Verpflichtend Rückzahlbare Vorzugsanteile werden gemäß den folgenden Bedingungen zurückgekauft:

(i) wenn Verpflichtend Rückzahlbare Vorzugsanteile nicht konvertiert wurden, muss die Gesellschaft alle Verpflichtend

Rückzahlbare Vorzugsanteile nach Ablauf einer dreizehn (13) Jahres-Frist ab dem Datum der Ausgabe der Verpflichtend
Rückzahlbaren Vorzugsanteile zurückkaufen (Nachfolgend "Endgültiger Verbindlicher Rückzahlungstag");

(ii) ungeachtet des Endgültigen Verbindlichen Rückzahlungstags und zu jedem Zeitpunkt vor diesem Datum, ist der

Halter  der  Verpflichtend  Rückzahlbaren  Vorzugsanteilen  berechtigt  schriftlich  die  Gesellschaft  anzufragen,  (ein-oder
mehrmalig), alle oder einen Teil seiner Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteile einzulösen; und

(iii) der Besitzer jeder Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteile, die eingelöst wurden, ist berechtigt, eine Zahlung

in bar oder in Sachleistungen pro eingelöster Verpflichtend Rückzahlbarer Vorzugsanteile (Nachfolgend der "Rücknah-
mepreis"), entsprechend:

1. dem Nennwert der zurückgekauften Anteile; zuzüglich
2. alle angefallenen und nicht ausgezahlten Dividenden, die dem Halter der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsan-

teilen rechtmäßig am Tag der des Rückkaufs zustehen; zuzüglich

3. einem Betrag in Höhe des Anteils des Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteils Agio Konto im gleichen Betrag

wie die Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteils Agio Konto geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Verpflichtend
Rückzahlbaren Vorzugsanteils Agio Konto vor der Einlösung; zuzüglich

4. soweit noch nicht durch den Bestandteil des Rückkaufpreises unter 2. erfaßt, den Anteil des Reservekontos der den

Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen entspricht (dieser Begriff ist in Artikel 28 definiert) geteilt durch die Anzahl
der ausgegebenen Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen vor dem Rückkauf.

Eingelöste Verpflichtend Rückzahlbare Vorzugsanteile werden unverzüglich nach Rücknahme annulliert.
Alle Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteile sind in Stammanteilen wandelbar. Verpflichtend Rückzahlbare Vor-

zugsanteile können in Stammaktien (die "Wandlung") gemäß den folgenden Bestimmungen und Bedingungen umgewandelt
werden:

(i) trotz des Endgültigen Verbindlichen Rückzahlungstags kann der Besitzer der Zwingend Einlösbaren Vorzugsanteile

jederzeit vor diesem Datum schriftlich anfragen, (ein-oder mehrmalig) alle oder einen Teil der Verpflichtend Rückzahl-
baren Vorzugsanteile in Stammanteile umzuwandeln;

(ii) die Geschäftsführungsrat ist bevollmächtigt und ermächtigt, die Wandlung durchzuführen, und zu diesem Zweck

eine solche Wandlung in eine notarielle Urkunde einzutragen, in einem solchen Fall wird die Ausgabe von Stammanteilen
in einer notariellen Urkunde erfasst, welche eine Änderung der Statuten sowie alles sonst Erforderliche zu Folge hat, um
eine solche Wandlung durchzuführen;

(iii) die Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen werden zum Marktwert der Stammanteile umgewandelt (der

Marktwert von Stammanteilen wird durch den Geschäftsführungsrat gutgläubig anhand einer angemessenen Bewertungs-
methode ermittelt) entsprechend dem Nennwert der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen, angefallener und
nicht ausgezahlter Dividenden, dem entsprechenden Agio Konto der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen sowie
dem Reservekonto der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen."

Der Artikel 24 der Satzung wird wie folgt abgeändert:

21690

L

U X E M B O U R G

„ Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Hauptversammlung der Gesellschafter, die nicht im Hinblick auf die Änderung der

Satzung oder die Abstimmung von Beschlüssen, die dem Quorum oder Mehrheitsanforderungen einer Satzungsänderung
unterliegen, wie dies der Fall sein kann, die Quorum und Mehrheitsregelungen der abgeänderten Satzung, sollen die
Beschlüsse von Gesellschaftern beschlossen werden, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung (oder einer schriftlich Beschlussfassung) erreicht wird,
werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen (oder konsultiert) und die Beschlüsse werden dann unabhängig von
der Anzahl der vertretenen Anteile, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst."

Der Artikel 28 der Satzung wird wie folgt abgeändert:

„ Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%)

der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald die Rücklage von
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn

verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr
vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien wie folgt an
die Gesellschafter ausschütten:

(i) Den Eigentümer von Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen ist jährlich zu kumulierten Vorzugsdividenden

(die "VRV Dividende") in Höhe von der jährlichen Rate von null Komma eins Prozent (0,1%), die auf Basis des Nominal-
werts sowie dem dazugehörigen Agio (soweit zutreffend) berechnet wird.

(ii) Der Halter von Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen ist zu Dividendenzahlungen berechtigt, vorausgesetzt

die Gesellschaft verfügt über ausreichende liquide Mittel, nachdem jene Dividende gezahlt wurde, um die laufenden Kosten
umgehend nach der Zahlung der Dividende zu decken und insofern einer der folgenden zwei (2) Umstände eintritt:

(i) Die Dividendenausschüttung ist rechtmäßig und im Einverständnis mit den Statuten vereinbar, oder
(ii)  Verpflichtend  Rückzahlbare  Vorzugsanteile  (zusammen  mit  jedwedem  entsprechendem  Agio)  werden  auf  den

Wunsch des Halters der Verpflichtend Rückzahlbare Vorzugsanteilen zurückgekauft.

Sollten die Gewinne eines Geschäftsjahres ausreichend für eine Dividendenausschüttung für die Verpflichtend Rück-

zahlbaren  Vorzugsanteilen  sein,  im  Ganzen  oder  zum  Teil,  und  der  Gesellschafter,  oder  im  Falle  einer  Vielzahl  von
Gesellschaftern, die Gesellschafterversammlung, entscheidet trotz allem keine Ausschüttung durchzuführen, dann soll die
Dividende, die den Haltern der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen ausgeschüttet hätte werden können, als ein
ausschüttbare Reserve in dem Reservekonto der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen erfasst werden (hiernach
als „Reservekonto der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteilen“ bezeichnet).

Zur  Vermeidung  von  Zweifeln,  umgewandelte  Verpflichtend  Rückzahlbare  Vorzugsanteile,  berechtigen  nach  der

Wandlung zu Dividendenzahlung, die ausschüttbaren Beträge, die vor der Wandlung konstituiert wurden umfassen kön-
nen.

Unter gesetzlichen Bestimmungen (sofern anwendbar) und in Übereinstimmung mit den vorstehenden Bestimmungen,

kann/können der/die Geschäftsführer eine Vorauszahlung auf Dividenden an die Besitzer von Stammanteilen machen. Der/
die Geschäftsführer setzen den Betrag und den Zeitpunkt einer solchen Vorauszahlung fest.

Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, sind die Rechte der Eigentümer der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugs-

anteile  nachrangig  zu  allen  anderen  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  zu  behandeln,  sind  jedoch  vorrangig  vor  den
Rechten der Eigentümer von Stammaktien wie unter Artikel 29 beschrieben.

Stammanteile berechtigen zu Ausschüttungen sofern alle Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteile gemäß der Sat-

zung ausgeschüttet wurden."

Der Artikel 29 der Satzung wird wie folgt abgeändert:

„ Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst

werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei viertel (4/3) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.

Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt

(diese können natürliche oder juristische Personen sein), welche durch die Gesellschafterversammlung bestimmt werden,
die die Verantwortlichen für diese Auflösung sind und welche die Befugnisse und Vergütung bestimmen.

Nach der Zahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder jeder Hinterlegung von Vermögen in

diesem Sinne, wird der verfügbare Betrag zuerst an den Inhaber der Verpflichtend Rückzahlbaren Vorzugsanteile bis zu
einem Betrag der dem Rückkaufpreis wie unter Artikel 6 definiert entspricht vorausgesetzt die Bedingungen aus Artikel
28 sind erfüllt. Die Inhaber der Stammanteile sind dann an der restlichen verfügbaren Betrag (falls vorhanden) auf einer
pro rata Basis berechtigt, basierend auf der Anzahl der Stammanteile im Gesellschaftskapital geteilt durch die Anzahl an
Inhabern dieser Stammanteile."

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf sechstausendsiebenhundert Euro (EUR 6.700,-) geschätzt.

21691

L

U X E M B O U R G

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen

genannten Person das vorliegende Dokument auf englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage derselben
Person und im Falle verschiedener

Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll der Englische Vorrang haben.

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar
unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Bertomeu-Savalle, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 27 décembre 2011. Relation: RED/2011/2902. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 27. Dezember 2011.

Référence de publication: 2012006550/430.
(120006164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2012.

CS Italian Opportunities No.1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 117.980.

Par résolutions signées en date du 14 octobre 2011, l'associé unique a pris la décision de nommer Lorna Mackie, avec

adresse au 10, Rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indé-
terminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007565/13.
(120007925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

CWI Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 139.296.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société CWI HOLDING, société anonyme qui s'est tenue

<i>en date du 14 décembre 2011.

Il a été décidé
- de nommer Monsieur Philippe Pedrini, Administrateur de sociétés, demeurant 27, rue de la Gare, L-8229 Marner, à

la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012007566/15.
(120008070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Fire-Innov SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.604.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 2 janvier 2012

que:

- Décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Jean-Philippe AUMERCIER de ses fonctions d'administrateur

et d'administrateur délégué de la société, avec effet immédiat.

- Décision a été prise de nommer en remplacement Monsieur Thibault KORCHIA, demeurant 8, rue Pierre Morlanne,

F-57000 Metz, France, aux fonctions d'administrateur de la société, avec effet immédiat.

21692

L

U X E M B O U R G

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
Le Conseil d'Administration se compose désormais des personnes suivantes:
- Mr Thibault KORCHIA
- Mr Gérard QUILLET
- Mr Ermes CLENZI
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de notre société, tenu en date du 2 janvier 2012 que:
- Décision a été prise de nommer Monsieur Thibault KORCHIA, prénommé, aux fonctions d'administrateur délégué

de la société, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2012009346/26.
(120010312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Delta Spain S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 116.321.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007568/11.
(120007761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Donaldson Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 173.577.450,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 74.029.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007570/10.
(120008205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Dyneurope S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 85.895.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Danelli Barbara.

Référence de publication: 2012007571/10.
(120008262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Niam III Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 101.197.

EXTRAIT

En date du 12 décembre 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Transfert du siège social au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et

21693

L

U X E M B O U R G

- Nomination de Monsieur Ian Kent, employé privé, né le 3 décembre 1976, à Birmingham, Royaume-Uni, résidant

professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société et pour une
durée illimitée (en remplacement de Monsieur Christophe Munsch, démissionnaire).

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Urban Ehrling;
- Monsieur Anders Lundqvist;
- Monsieur Simon Barnes; et
- Monsieur Ian Kent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012009361/23.
(120010309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

DAB Investments 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 81.244.

Les comptes annuels au 31 juillet 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007572/10.
(120008206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Danieldale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.937.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Référence de publication: 2012007573/10.
(120008213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Dizzy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.479.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012007579/9.
(120008187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Dounia S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 39.846.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

21694

L

U X E M B O U R G

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012007580/13.
(120008388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 93.199.

Les comptes annuels au 21 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012007584/9.
(120007812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 93.199.

Les comptes annuels au 30 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012007585/9.
(120008071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Engueran S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 116.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012007593/10.
(120007811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

NIAM IV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.283.

EXTRAIT

En date du 12 décembre 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Transfert du siège social au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
- Nomination de Monsieur Ian Kent, employé privé, né le 3 décembre 1976, à Birmingham, Royaume Uni, résidant

professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de gérant de catégorie B de la Société
et pour une durée illimitée (en remplacement de Monsieur Christophe Munsch, démissionnaire).

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Stefan Albinsson, gérant de catégorie A;
- Monsieur Anders Lundqvist, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ian Kent, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

21695

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012009362/23.
(120010314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Estée Lauder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.364.800,00.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

R.C.S. Luxembourg B 101.019.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 26 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 762 du 24 juillet 2004.

Les comptes annuels de la Société au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Estée Lauder S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2012007594/14.
(120008316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Europe Voyager Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 4.852.188,35.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 134.469.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Référence de publication: 2012007595/10.
(120008235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Media Factory Holding Société Anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.

R.C.S. Luxembourg B 82.184.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012010359/10.
(120012102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Media Factory Holding Société Anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.

R.C.S. Luxembourg B 82.184.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012010360/10.
(120012103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

21696


Document Outline

Asturias Holding Sàrl

Cabo Holding S.A.

CanGro Holding S.à r.l.

Capgemini Reinsurance Company

CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l.

Cedre Holding S. à r.l.

CEREP Strategic Land S.à r.l.

Certifica Luxembourg S.à r.l.

Cheylaroise de Participation S. à r.l.

Chicago Mercantile Exchange Luxembourg Holdings S.à r.l.

Clara Vision S.A.

Cognos Consulting S.à r.l.

Compagnie Européenne de Luxe et Traditions S.C.A.

Compagnie Européenne de Luxe et Traditions S.C.A.

Cotralux S.à.r.l.

CR PropCo S.à r.l.

CS Italian Opportunities No.1 S.à r.l.

CWI Holding S.A.

DAB Investments 2 Sàrl

Danieldale S.à r.l.

Delilah S.à r.l.

Delta Spain S.à r.l., SICAR

DELTA TRANSACTIONS (Holdings) SAH

Dizzy S.à r.l.

Donaldson Luxembourg S.à r.l.

Dounia S.A., S.P.F.

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l.

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l.

Dyneurope S.A.

Engueran S.à r.l.

Estée Lauder S.à r.l.

Europe Voyager Holdings S.à r.l.

Façades et Structures Luxembourg S.A.

Fire-Innov SA

Forest S.A.

Isar S.à r.l.

Isometall Distribution S.A.

La Financière de Luxembourg S.A., S.P.F.

Magna Financing Luxembourg S.à r.l.

Main S.à r.l.

Media Factory Holding Société Anonyme

Media Factory Holding Société Anonyme

Niam III Luxembourg S.à r.l.

NIAM IV Luxembourg S.à r.l.

Oceanfront Hospitality S.à r.l.

PythAgoria Sàrl

RIVER Spf S.A.

Synergix International S.A.