logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 143

18 janvier 2012

SOMMAIRE

ABH Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6831

Allianz Finance VIII Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6818

American European Alliance for Education

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6855

Boscolo International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

6831

Cerac Finance I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6832

DIH/HMD Investco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

6832

Ferges S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6836

Festivo International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

6840

Fideurope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6841

Financière de Vauban S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

6839

Financière Dube S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6830

Financière Leka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6837

F.Int. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6831

Finzels Reach Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

6840

Floreanville Investholding S.à r.l.  . . . . . . . .

6841

Foncière de l'Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

6841

Fordale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6848

Fordale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6854

Fordale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6854

Form & Design S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6848

Fortyfifty Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . . .

6854

Frecolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6861

Future Brands Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6861

Gasherbrun 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6862

Gateway Telecom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6863

Gecomat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6830

Gelustok SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6863

GeMoBa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6862

Gestion pour Décharges et Carrières S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6864

Gimo Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6864

Gläsener Transports S. à r. l.  . . . . . . . . . . . .

6862

Global Assurance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6864

Global Metall, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6837

Global Metall, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6837

GM Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6864

Goreway Luxembourg Holdings S.à r.l.  . .

6862

Gosdorf S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6832

Gravilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6864

Greenwich Data (Rochester) S.à r.l.  . . . . .

6862

Halliba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6861

Halliba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6863

Heart (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

6839

King Charter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6838

L'Orchidea S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6830

Luxon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6838

Mediterranean Investments S.A.  . . . . . . . .

6855

Merlin Entertainments Group Luxem-

bourg 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6841

NDX Market S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6838

Neo Invest Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6840

Nova Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6849

OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6839

ProLogis UK X S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6836

ProLogis UK XV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6863

RE Car Parts S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6841

RE Coatings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6854

San José Immobilien S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

6842

Stores Concept S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6846

Sun Life (Luxembourg) Finance No. 2 Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6839

THEOLIA Utilities Investment Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6823

Winsway Coking Coal Holdings  . . . . . . . . .

6840

6817

L

U X E M B O U R G

Allianz Finance VIII Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.-D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 165.116.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, den achtzehnten November,
vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,

ist erschienen

Allianz Finance II Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à

responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 128.975,

hier vertreten durch Frau Victoria Leyens, Anwalt, (avocat à la Cour), mit Berufsanschrift in L-1855 Luxembourg, 33

avenue J. F. Kennedy,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 10. November 2011.
Die Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den unterzeichnenden Notar und den Vertreter der Er-

schienenen, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie eingangs erwähnt, hat den unterzeichnenden Notar sodann ersucht eine Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu gründen, welche der folgenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit der Firmenbe-

zeichnung "Allianz Finance VIII Luxembourg S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögen, insbesondere von Anteilen

an Kapital-sowie Immobiliengesellschaften, zur eigenen Vermögensanlage. Die Gesellschaft darf, mit Ausnahme der Auf-
nahme von Fremdmitteln, alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und
diesem unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann jederzeit in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des alleinigen

Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeindegrenzen durch einen Beschluss
des Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile

mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (einem Cent) pro Anteil.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem alleinigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß

Artikel 13 dieser Satzung abgeändert werden.

Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen

Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.

Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen.

Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.

Art. 9. Der Übertragung von Anteilen durch einen Gesellschafter, der dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz

unterliegt, kann, sofern diese Anteile dem Sicherungsvermögen zugeführt sind, nur mit vorheriger Zustimmung des bes-
tellten Treuhänders oder einem seiner Stellvertreter nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes erfolgen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs

oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer geleitet, die den Geschäftsführerrat bilden, bestehend aus

Geschäftsführern A und Geschäftsführern B. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein. Die
Geschäftsführer A und B werden durch den alleinigen Gesellschafter, bzw. die Generalversammlung der Gesellschafter,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen, ernannt, widerrufen und ersetzt, ohne dass es hierbei der Angabe
von Gründen bedarf.

Der Geschäftsführerrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen,

welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

Um die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und zu verpflichten, bedarf es (i) der gemeinsamen Unterschrift

eines Geschäftsführers A und eines Geschäftsführers A oder B, bzw. eines ad hoc Agenten gemäß Artikel 11, Absatz 5

6818

L

U X E M B O U R G

der Satzung oder (ii) der gemeinsamen Unterschrift eines Geschäftsführers B und eines Geschäftsführers A, bzw. eines
ad hoc Agenten gemäß Artikel 11, Absatz 5 der Satzung.

Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern, die Geschäftsführer A sind, einen Geschäftsführer-Vertreter

bestimmen,  der  die  Gesellschaft  durch  seine  alleinige  Unterschrift  verpflichten  kann,  vorausgesetzt,  dass  dieser  Ge-
schäftsführer-Vertreter im Rahmen der Befugnisse des Geschäftsführerrates handelt.

Der alleinige Gesellschafter, bzw. die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat können ihre Befugnisse

für spezifische Geschäftsbereiche oder Einzelgeschäfte einem oder mehreren ad hoc Agenten übertragen.

Der alleinige Gesellschafter, bzw. die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse

und eine etwaige Entschädigung der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats
bestimmen.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates müssen von je zwei Geschäftsführern angenommen werden, wobei die Zustim-

mung von mindestens einem Geschäftsführer A zwingend erforderlich ist.

Sitzungen des Geschäftsführerrates können nur im Großherzogtum Luxemburg stattfinden. Sitzungen, welche nicht

im Großherzogtum Luxemburg stattfinden sind null und nichtig.

Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail wenigstens

24 (vierundzwanzig) Stunden vor Abhalten des Geschäftsführerrats informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine
schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestätigen,
dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für Si-
tzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates
festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax, Tele-
gramm, Telex oder E-Mail zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstim-
men,  müssen  dies  jedoch  schriftlich  bestätigen.  Beschlüsse  können  nur  dann  gefasst  werden,  wenn  mindestens  zwei
Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind, wobei die Anwesenheit oder Vertretung eines Geschäftsführers A zwin-
gend erforderlich ist.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbes-

chluss  gefasst  werden.  Ein  Umlaufbeschluss  gilt  dann  als  gefasst,  wenn  eines  oder  mehrere  Dokumente,  welche  den
Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als
Datum des Beschlusses.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie im

Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.

Art. 13. Der alleinige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls

es  mehrere  Gesellschafter  gibt,  hat  jeder  Gesellschafter  das  Recht,  an  den  gemeinsamen  Beschlüssen  teilzunehmen,
unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse
sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen
werden.

Ungeachtet Artikel 11 dieser Satzung kann der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, während

der ersten Gesellschafterversammlung, die unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, eine dritte Per-
son dazu bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.

Beschlüsse  im  Rahmen  von  Satzungsabänderungen  bedürfen  der  Mehrheit  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des

Gesellschaftskapitals besitzen.

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 15. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der

oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und Passiva
der Gesellschaft auf.

Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes

Gesellschafters zur Verfügung.

Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft kann ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer betraut

werden.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt den oder die Wirtschaftsprüfer und legt deren

Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann den oder die Wirtschaftsprüfer jederzeit ab-

berufen. Der bzw. die Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

Art. 16. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Re-

ingewinn  der  Gesellschaft.  Aus  diesem  Reingewinn  sind  fünf  Prozent  (5%)  für  die  Bildung  der  gesetzlichen  Rücklage
zurückzustellen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verblei-
bende Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder die
Gesellschafter sowie die Geschäftsführer können Zwischendividenden ausschütten.

6819

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liquida-

toren  können  Gesellschafter  oder  Nichtgesellschafter  sein.  Sie  werden  von  dem  alleinigen  Gesellschafter  bzw.  der
Gesellschafterversammlung ernannt, der bzw. die ihre Rechte und ihr Gehalt festlegt.

Art. 18. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Alle 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile werden von der Allianz Finance II Luxembourg S.à r.l., vorbenannt, gezeichnet

und ganz in bar eingezahlt, sodass der Betrag von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) der Gesellschaft zur Verfügung steht,
worüber dem unterzeichnenden Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis erbracht wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, jeglicher Form, welche für die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

anfallen, betragen schätzungsweise EUR 1.500 (eintausendfünfhundert Euro).

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 3 (drei) festgelegt.
Als Geschäftsführer A wird auf unbegrenzte Zeit ernannt:
Herr Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen (Luxemburg), geschäftsansässig in L-2450

Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

Als Geschäftsführer B werden auf unbegrenzte Zeit ernannt:
- Herr Johannes Christian Maria Zarnitz, geboren am 21. April 1959 in Augsburg (Deutschland), geschäftsansässig in

NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht; und

- Herr Cornelis Bunschoten, geboren am 11. Mai 1957 in Krommenie (Niederlande), mit beruflicher Anschrift in

NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht.

Der alleinige Gesellschafter beschließt, dass die Geschäftsführer fortan den Geschäftsführerrat der Gesellschaft bilden.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt.
3) Der alleinige Gesellschafter beschließt, die gesetzliche Rücklage vorab und vollständig in bar einzuzahlen, sodass

diese bereits EUR 5.000 (fünftausend Euro) und somit 10% des Gesellschaftskapitals erreicht. Dem unterzeichnenden
Notar wurde der Nachweis erbracht, dass EUR 5.000 (fünftausend Euro) auf das Konto der Gesellschaft überwiesen
wurden.

Der unterzeichnende Notar, der englischen Sprache mächtig, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen des Bevollmäch-

tigten der erschienenen Partei, die Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer englischen
Übersetzung; ebenfalls auf Verlangen des Bevollmächtigten der erschienenen Partei stellt der unterzeichnende Notar fest,
dass, im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die deutsche Fassung maßgebend
ist.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, hat dieser

mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Es folgt die Übersetzung in die englische Sprache des vorausgegangenen Textes:

In the year two thousand eleven, on the eighteenth November,
before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg,

there appeared

Allianz Finance II Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg law private limited liability company (société à responsabilité

limitée), with registered office in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under the number B 128.975,

here represented by Ms Victoria Leyens, lawyer (avocat à la Cour), residing professionally in L-1855 Luxembourg, 33

avenue J. F. Kennedy,

by virtue of a power of attorney under private seal, given in Luxembourg, on 10 November 2011.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder of the appearing

party, shall remain attached to the present deed to be registered therewith.

6820

L

U X E M B O U R G

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Allianz Finance

VIII Luxembourg S.à r.l." (the Company).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition and the management of assets, especially shares in investment

and real estate companies, for the investment of its own assets. The Company is entitled to carry out all transactions
pertaining and directly or indirectly beneficial to the Company's object, with the exception of borrowings.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an ordinary resolution of its

sole shareholder or its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of
the board of managers of the Company.

The Company may have branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company's share capital is fixed at EUR 50,000 (fifty thousand euro), represented by 5,000,000 (five million)

shares having a nominal value of EUR 0.01 (one cent) per share.

Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the

shareholders, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. The transfer of shares held by any shareholder which is subject to the German Insurance Supervision Act must

be authorised, prior to the transfer, by the appointed trustee or one of its agents in accordance with § 70 of the German
Insurance Supervision Act, provided that these shares are affected to the guaranteed assets.

Art. 10.  The  death,  suspension  of  civil  rights,  insolvency  or  bankruptcy  of  the  sole  shareholder  or  of  one  of  the

shareholders will not terminate the Company.

Art. 11. The Company is managed by the managers, who constitute the board of managers, consisting of managers A

and managers B. The managers need not to be shareholders. The managers A and B are appointed, revoked and replaced,
without the obligation to indicate any reason, by the sole shareholder respectively the general meeting of the shareholders,
by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The board of managers is authorized to lead the Company's business and all powers not expressly reserved by law or

the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of
managers.

To represent and bind the Company towards third parties, either (i) the joint signature of an A manager together with

an A manager or a B manager, respectively an ad hoc agent in the sense of article 11 paragraph 5 or (ii) the joint signature
of a B manager together with an A manager, respectively an ad hoc agent in the sense of article 11 paragraph 5, is required.

The board of managers may elect among its A members a general manager who may bind the Company by his sole

signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general meeting of shareholders or the board of managers may subdelegate their powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents.

The general meeting of shareholders or the board of managers will determine this agent's responsibilities and indemnity

(if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by two managers, the adoption by at least one A manager

being compulsory.

Meetings of the board of managers can only take place in the Grand Duchy of Luxembourg, every meeting taking place

outside of the Grand Duchy of Luxembourg being null and void.

Each manager will be convened to any meeting of the board of managers, in writing or by letter, telefax, telegram,

telex or e-mail, at least 24 hours before such meeting takes place, except in circumstances of urgency. The convening
notice may be waived if all the managers are present or represented at the meeting and if they declare to have been
informed on the agenda of the meeting. A convening notice shall not be required for meetings held at the time and place
decided in a previously adopted resolution of the board of managers. Any manager may appoint by letter, telefax, telegram,
telex or e-mail another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone, provided that such vote
is confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least two of its members are present
or represented at the meeting of the board of managers, the presence or representation of an A manager being com-
pulsory.

6821

L

U X E M B O U R G

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
such a circular resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company and within the framework of their powers.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders. In case of

plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares
he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly
taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Notwithstanding article 11 of the articles of association, the sole shareholder or the general meeting of the share-

holders may, at the first meeting of the shareholders immediately following the incorporation of the Company, authorize
a third person to acquire shares in one or more existing companies.

Resolutions modifying the articles of association of the Company are adopted by the majority of the shareholders of

the Company representing three quarters of the share capital of the Company.

Art. 14. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the board of managers

prepare the balance sheet, the profit and loss statements and an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above profit and loss statements and balance sheet at the Company's registered

office.

For auditing and supervisory purposes of the activities of the Company, one or more independent external auditors

may be appointed.

The sole shareholder or the general meeting of the shareholders appoint the independent external auditor(s) and

determine the term of their office, which may not exceed six years.

The sole shareholder or the general meeting of the shareholders may revoke the independent external auditor(s) at

any time. They shall be eligible for re-appointment.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to their share holding in the
Company. The sole shareholder or the general meeting of the shareholders as well as the board of managers may decide
to pay interim dividends.

Art. 17. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders who shall determine their
powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the modified act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription - Payment

All 5.000.000 (five million) shares are subscribed by Allianz Finance II Luxembourg S.à r.l., prenamed, and fully paid up

by a contribution in cash, so that the amount of EUR 50.000 (fifty thousand euro) is at the free disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin at the date of incorporation of the Company and it shall end on 31 December 2011.

<i>Estimate of cost

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500 (one thousand five hundred euro).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder adopted the following resolutions:
1) the number of managers is set at 3 (three).
As manager A is appointed for an unlimited period of time:
Mr Alain Jean Pierre Schaedgen, born on 2 September 1958 in Petange, with professional address in L-2450 Luxem-

bourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

As managers B are appointed for an unlimited period of time:

6822

L

U X E M B O U R G

- Mr Johannes Christian Maria Zarnitz, born on 21 April 1959 in Augsburg (Germany), with professional address in

NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht; and

-  Mr  Cornelis  Bunschoten,  geboren  am  11  May  1957  in  Krommenie  (Niederlande),  with  professional  address  in

NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht.

The sole shareholder resolves, that the managers constitute henceforth the board of managers of the Company.
2) The registered office of the Company is established in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
3) The sole shareholder resolves to fully constitute the legal reserve of the Company by a payment in cash, so that

the legal reserve amounts to EUR 5.000 (five thousand euro) and accordingly to 10% of the share capital. Evidence, that
EUR 5.000 (five thousand euro) have been transferred on the Company's bank account has been given to the undersigned
notary.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in German, followed by an English version; at the request of the
same proxyholder and in case of discrepancies between the German and the English texts, the German version will be
prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the date

stated above.

The document having been read to the to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together

with the notary, the present original deed.

Gezeichnet: V. LEYENS und J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A. C., le 23 novembre 2011. LAC / 2011 / 51935. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 7. Dezember 2011.

Référence de publication: 2011167888/295.
(110194882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.

THEOLIA Utilities Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 163.329.

In the year two thousand and eleven, on the fifth day of December.
Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of THEOLIA Utilities Investment Com-

pany S.A., a Luxembourg société anonyme with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
163.329 (the Company). The Company has been incorporated on August 22, 2011 pursuant to a deed of Me Léonie
Grethen, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2683,
page 128767 of November 4, 2011. The articles of association of the Company have been restated on August 31, 2011
pursuant  to  a  deed  of  Me  Martine  Schaeffer,  notary  residing  in  Luxembourg,  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  not  yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

1. THEOLIA S.A.,a société anonyme under the laws of France, with a share capital of EUR 127,418,347, having its

registered office of at 75, rue Denis Papin, Aix-en-Provence, France, registered with the Register of Companies and Trade
of Aix-en-Provence under number 423 127 281;

here represented by Me Anne-Claire Wax, avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

2. IWB Renewable Power AG,a société anonyme under the laws of Switzerland, with a share capital of CHF 14,100,000,

having its registered office at Margarethenstrasse 40, 4002 Basel, Switzerland, registered with the Register of Commerce
of Basel under number CH-270.3.014.408-5;

here represented by Me Anne-Claire Wax, avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

3. BADENOVA AG &amp; Co. KG, a Kommanditgesellschaft under the laws of Germany, with a share capital of EUR

58,665,970, having its registered office at Tullastrasse 61, 79108 Freiburg im Breisgau, Germany, registered with the Court
Register of Freiburg under number HRA 4777, represented by badenova Verwaltungs-AG, registered with the Court
Register of Freiburg under number HRB 6647;

here represented by Me Anne-Claire Wax, avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

6823

L

U X E M B O U R G

Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representatives of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The shareholders of the Company (the Shareholders) have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
Amendement of article 3.1 of the articles of association of the Company (the Articles) as follows:
“3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises active in the field of wind energy and, in principle, amenable to pursuing their purpose in the public interest
through the supply of energy to the shareholders, as well as the management of such participations. The Company may
in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other parti-
cipation  securities,  bonds,  debentures,  certificates  of  deposit  and  other  debt  instruments  and  more  generally,  any
securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.”

2. Creation of a new class of shares, namely the class C ordinary shares of the Company (the Class C Shares) by

converting thirteen thousand two hundred eighty four (13,284) class A ordinary shares of the Company having a par value
of one euro (EUR 1) each, into thirteen thousand two hundred eighty four (13,284) Class C Shares having a par value of
one euro (EUR 1) each and having the same rights and features as the existing shares of the Company;

3. Amendement of article 5 of the Articles;
4. Amendement of article 6.2 of the Articles;
5. Amendement of article 8.1 (i) and (ii) of the Articles;
6. Amendement of article 8.3 (vii) and (viii) of the Articles;
7. Amendement of article 8.4 (ii) and (iii) of the Articles;
8. Amendement of article 8.5 of the Articles;
9. Amendment to the register of registered shares of the Company in order to reflect the above changes with power

and authority given to any director of the Company and any employee of Capita Fiduciary S.A., each individually, to
proceed on behalf of the Company with the registration of the newly created shares in the register of shareholders of
the Company;

10. Appointment of class C directors of the Company; and
11. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice requi-

rements, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend article 3.1 of the Articles which shall henceforth be read as follows:

“ 3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises active in the field of wind energy and, in principle, amenable to pursuing their purpose in the public interest
through the supply of energy to the shareholders, as well as the management of such participations. The Company may
in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other parti-
cipation  securities,  bonds,  debentures,  certificates  of  deposit  and  other  debt  instruments  and  more  generally,  any
securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.”

<i>Third resolution

The Meeting resolves to create a new class of ordinary shares of the Company, namely the Class C Shares.
The Meeting resolves to convert thirteen thousand two hundred eighty four (13,284) class A ordinary shares of the

Company having a par value of one euro (EUR 1) each, into thirteen thousand two hundred eighty four (13,284) Class C
Shares having a par value of one euro (EUR 1) each and having the same rights and features as the existing shares of the
Company.

6824

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 5 of the Articles which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Capital. The share capital is set at forty-four thousand two hundred and eighty-four euro (EUR 44,284),

represented by forty-four thousand two hundred and eighty-four euro (EUR 44,284.-) shares (individually a Share and
collectively the Shares), divided into seventeen thousand seven hundred sixteen (17,716) class A ordinary shares (the
Class A Ordinary Shares), thirteen thousand two hundred eighty four (13,284) class B ordinary shares (the Class B
Ordinary Shares) and thirteen thousand two hundred eighty four (13,284) class C ordinary shares (the Class C Ordinary
Shares) in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

Subject to any written agreement that may be entered into from time to time by and between the shareholders of the

Company, the share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”

<i>Fifth resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 6.2 of the Articles which shall henceforth

read as follows:

“ 6.2. The Class A Ordinary Shares, the Class B Ordinary Shares and the Class C Ordinary Shares shall constitute

separate classes in the Company, but shall rank pari passu in all respects save as for those specific rights attached to them
such as those stated in article 8.1. below.”

<i>Sixth resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 8.1 (i) and (ii) of the Articles which

shall henceforth read as follows:

“ 8.1. Composition of the board of directors
(i) The Company is managed by a board of directors (the Board) composed of at least seven (7) members, who need

not be Shareholders.

(ii) Subject to the above, at all time,
(a) the Class A Ordinary shareholders shall have the right to propose three (3) directors (to be designated as the Class

A Directors) for appointment by the General Meeting;

(b) the Class B Ordinary shareholders shall have the right to propose two (2) directors (to be designated as the Class

B Directors) for appointment by the General Meeting; and

(c) the Class C Ordinary shareholders shall have the right to propose two (2) directors (to be designated as the Class

C Directors) for appointment by the General Meeting.

<i>Seventh resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 8.3 (vii) and (viii) of the Articles which

shall henceforth read as follows:

“ 8.3. Procedure.
(vii) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, it being

understood that at least one (1) Class A Director, one (1) Class B Director and one (1) Class C Director shall be present.
If such quorum is not reached, that resolution shall be placed on the agenda of the next Board meeting, to be convened
by the Chairman and to be held without the quorum set out above.

(viii) Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented, it

being understood that resolutions regarding Qualified Majority Matters provided in article 8.2 (i) above, are validly taken
by the positive vote of at least five (5) directors.”

<i>Eighth resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 8.4 (ii) and (iii) of the Articles which

shall henceforth read as follows:

“ 8.4. Investment Committee.
(ii) The Investment Committee shall be composed of at least three (3) members, who shall be directors. The members

of the Investment Committee shall be appointed for an initial term of two (2) years, renewable for the same time period,
without limitations.

(iii) Subject to the above, at all time,
(a) the Class A shareholders shall have the right to propose one (1) member (to be designated as the Class A Member)

for appointment by the Shareholders;

6825

L

U X E M B O U R G

(b) the Class B shareholders shall have the right to propose one (1) member (to be designated as the Class B Member)

for appointment by the Shareholders; and

(c) the Class C shareholders shall have the right to propose one (1) member (to be designated as the Class C Member)

for appointment by the Shareholders.”

<i>Ninth resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 8.5 of the Articles which shall henceforth

read as follows:

“ 8.5. Representation.
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of one (1) Class A Director and

one (1) Class B Director or one (1) Class A Director and one (1) Class C Director.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special

signatory powers have been delegated.”

<i>Tenth resolution

The Meeting resolves to amend the register of registered shares of the Company in order to reflect the above changes

and empower and authorize any director of the Company and any employee of Capita Fiduciary S.A., each individually,
to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of
the Company.

<i>Eleventh resolution

The Meeting resolves to appoint the following persons as class C directors for a period of two years:
- Dr. Thorsten Radensleben , born on November 11, 1962 in Berlin (Germany), Chief Executive Officer, residing

professionally at Tullastraße 61 79108 Freiburg im Breisgau, Germany; and

- Mr. Maik Wassmer, born on July 26, 1969 in Überlingen (Germany), Chief Financial Officer, residing professionally

at Tullastraße 61 79108 Freiburg im Breisgau, Germany.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,800.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le cinquième jour du mois de décembre.
Pardevant Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de THEOLIA Utilities Investment

Company S.A., une société anonyme organisée selon les lois de Luxembourg avec siège social au 6, rue Guillaume Schnei-
der, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 163.329 (la Société). La Société a été constituée le 22 août 2011 suivant un acte de Me
Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
2683, page 128767 du 4 novembre 2011. Les statuts de la Société ont été refondus le 31 août 2011 suivant un acte de
Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

ONT COMPARU:

1. THEOLIA S.A., une société anonyme organisée selon les lois françaises, au capital social de EUR 127.418.347, avec

siège social au 75, rue Denis Papin, Aix-en-Provence, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Aix-en-Provence sous le numéro 423 127 281;

représentée par Me Anne-Claire Wax, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privée.

2. IWB Renewable Power AG, a société anonyme organisée selon les lois suisses, au capital social de CHF 14,100,000,

avec siège social au Margarethenstrasse 40, 4002 Basel, Suisse, immatriculée au Registre du Commerce de Basel sous le
numéro CH-270.3.014.408-5;

6826

L

U X E M B O U R G

représentée par Me Anne-Claire Wax, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privée.

3. BADENOVA AG &amp; Co. KG, une société en commandite simple organisée selon les lois allemandes, au capital social

EUR 58.665.970, avec siège social au Tullastrasse 61, 79108 Freiburg im Breisgau, Allemagne, immatriculée au Registre
du Tribnal de Freiburg sous le numéro HRA 4777, représentée pas badenova Verwaltungs-AG, immatriculée au Registre
du Tribnal de Freiburg sous le numéro HRB 6647;

représentée par Me Anne-Claire Wax, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privée.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par les mandataires agissant pour le compte des parties comparantes

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès de l'enregis-
trement.

Les actionnaires de la Société (les Actionnaires) ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les Actionnaires détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 3.1 des statuts de la Société (les Statuts) comme suit:

« 3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises actives dans le domaine de l'énergie éolienne et, principalement, susceptible de la poursuite de leur but dans
l'intérêt public par la provision d'énergie aux Actionnaires, ainsi que la gestion de ces participations. La Société peut
notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes
valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée Elle peut participer à la création, au dévelop-
pement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la
gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.»

3. Création d'une nouvelle classe d'actions, appelées les actions ordinaires de classe C de la Société (les Actions de

Classe C) par conversion de treize mille deux cent quatre-vingt-quatre (13.284) actions ordinaires de classe A de la
Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, en treize mille deux cent quatre-vingt-quatre (13.284)
Actions de Classe C ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune et ayant les mêmes droits et caractéristiques
que les actions existantes de la Société;

4. Modification de l'article 5 des Statuts;
5. Modification de l'article 6.2 des Statuts;
6. Modification de l'article 8.1 (i) et (ii) des Statuts;
7. Modification de l'article 8.3 (vii) et (viii) des Statuts;
8. Modification de l'article 8.4 (ii) et (iii) des Statuts;
9. Modification de l'article 8.5 des Statuts;
10. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de Capita Fiduciary S.A., chacun individuellement, pour procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement créées dans le registre des associés de la
Société;

11. Nomination des administrateurs de classe C de la Société; et
12. Divers.
III. Les Actionnaires ont adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les

Actionnaires représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite con-
naissance de l'ordre du jour, lequel leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 3.1 des Statuts, lequel prend la teneur suivante:

« 3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises actives dans le domaine de l'énergie éolienne et, principalement, susceptible de la poursuite de leur but dans
l'intérêt public par la provision d'énergie aux Actionnaires, ainsi que la gestion de ces participations. La Société peut
notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes
valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée Elle peut participer à la création, au dévelop-
pement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la

6827

L

U X E M B O U R G

gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de créer une nouvelle classe d'actions ordinaires de la Société, nommément les Actions de Classe

C.

L'Assemblée décide de convertir treize mille deux cent quatre-vingt-quatre (13.284) actions ordinaires de classe A de

la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, en treize mille deux cent quatre-vingt-quatre (13.284)
Actions de Classe C de la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune et ayant les mêmes droits et
caractéristiques que les actions existantes de la Société.

<i>Quatrième résolution

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts, lequel prend la teneur suivante:

« Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à un montant de quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre euros

(EUR 44.284), représenté par quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre (44.284) actions (appelées individuel-
lement une Action et collectivement les Actions), divisées en dix-sept mille sept cent seize (17.716) actions ordinaires
de  catégorie  A  (les  Actions  Ordinaires  de  Catégorie  A),  treize  mille  deux  cent  quatre-vingt-quatre  (13.284)  actions
ordinaires de classe B (les Actions Ordinaires de Catégorie B), et treize mille deux cent quatre-vingt-quatre (13.284)
actions ordinaires de classe C (les Actions Ordinaires de Catégorie C), actions sous forme nominative, ayant une valeur
nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Sous réserve de tout accord écrit susceptible d'être conclu à quelque moment que ce soit par et entre les actionnaires

de la Société, le capital social peut être augmenté ou revu à la baisse en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée
générale, agissant conformément aux conditions prescrites aux fins d'amendement des Statuts.»

<i>Cinquième résolution

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 6.2 des Statuts, lequel prend la teneur suivante:

« 6.2. Les Actions Ordinaires de Catégorie A, les Actions Ordinaires de Catégorie B et les Actions Ordinaires de

Catégorie C devront constituer des catégories séparées au sein de la Société, mais devront être classées pari passu à
tous égards sous réserve des droits spécifiques s'y rapportant, tels que ceux prévus à l'article 8.1. ci-dessous.»

<i>Sixième résolution

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 8.1 (i) et (ii) des Statuts, lequel prend la teneur suivante:

“ 8.1. Composition du Conseil d'administration.
(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins sept (7) membres, qui ne

doivent pas être des Actionnaires.

(ii) Sous réserve de ce qui a été mentionné précédemment, à tout moment,
(a) Les actionnaires détenant des Actions Ordinaires de Catégorie A auront le droit de proposer trois (3) adminis-

trateurs (devant être désignés en tant qu'Administrateurs de catégorie A) en vue d'une nomination par l'Assemblée
générale,

(b) Les actionnaires détenant des Actions Ordinaires de Catégorie B auront le droit de proposer deux (2) adminis-

trateurs (devant être désignés en tant qu'Administrateurs de catégorie B) en vue d'une nomination par l'Assemblée
générale, et

(c) Les actionnaires détenant des Actions Ordinaires de Catégorie C auront le droit de proposer deux (2) adminis-

trateurs (devant être désignés en tant qu'Administrateurs de catégorie C) en vue d'une nomination par l'Assemblée
générale.»

<i>Septième résolution

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 8.3 (vii) et (viii) des Statuts, lequel prend la teneur suivante:

« 8.3. Procédure.
(vii) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés,

étant étendu qu'au moins un (1) Administrateur de Catégorie A, un (1) Administrateur de Catégorie B et un (1) Admi-
nistrateur de Catégorie C doivent être présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la décision est reportée à l'ordre du jour
de la réunion suivante du Conseil d'administration, à convenir avec le Président, et devant être tenue sans le quorum
susvisé.

(viii) Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-

présentés, étant entendu que les décisions relatives aux Sujets requérant une majorité des voix («Qualified Majority
Matters») prévus à l'article 8.2 (i) ci-avant, sont valablement adoptées grâce au vote positif d'au moins cinq (5) adminis-
trateurs.»

6828

L

U X E M B O U R G

<i>Huitième résolution

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 8.4 (ii) et (iii) des Statuts, lequel prend la teneur suivante:

“ 8.4. Comité d'investissement.
(ii) Le Comité d'investissement doit être composé de trois (3) membres au moins qui sont également administrateurs.

Les membres du Comité d'investissement sont nommés pour un mandat initial de deux (2) ans, renouvelable pour la
même durée, et ce sans limitation.

(iii) Sous réserve de ce qui a été mentionné précédemment, à tout moment,
(a) Les actionnaires de catégorie A auront le droit de proposer un (1) membre (qui sera désigné en tant que Membre

de la Catégorie A) en vue d'être nommé par les Actionnaires,

(b) Les actionnaires de catégorie B auront le droit de proposer un (1) membre (qui sera désigné en tant que Membre

de la Catégorie B) en vue d'être nommé par les Actionnaires, et

(c) Les actionnaires de catégorie C auront le droit de proposer un (1) membre (qui sera désigné en tant que Membre

de la Catégorie C) en vue d'être nommé par les Actionnaires.»

<i>Neuvième résolution

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 8.5 des Statuts, lequel prend la teneur suivante:

“ 8.5. Représentation.
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature conjointe d'un (1) Administrateur

de catégorie A et d'un (1) Administrateur de catégorie B ou d'un (1) Administrateur de catégorie A et d'un (1) Admi-
nistrateur de catégorie C.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui

des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.»

<i>Dixième résolution

l'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec

pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de Capita Fiduciary S.A., chacun individuellement, pour
procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement créées dans le registre des associés
de la Société.

<i>Onzième résolution

l'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de classe C pour une durée de 2

ans:

-  Dr.  Thorsten  Radensleben  ,  né  le  11  novembre  1962  à  Berlin  (Allemagne),  Chief  Executive  Officer,  demeurant

professionnellement Tullastraße 61 79108 Freiburg im Breisgau, Allemagne; et

- Mr. Maik Wassmer, né le 26 juillet 1969 à Überlingen (Allemagne), Chief Financial Officer, demeurant profession-

nellement Tullastraße 61 79108 Freiburg im Breisgau, Allemagne.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de EUR 1.800.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: A.-C. WAX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54704. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 décembre 2011.

Référence de publication: 2011169918/346.
(110197177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2011.

6829

L

U X E M B O U R G

Financière Dube S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 67.553.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2011171634/11.

(110199445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

L'Orchidea S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4818 Rodange, 9, rue Dr. Gaasch.

R.C.S. Luxembourg B 103.936.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 15 décembre 2010.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2011171773/14.

(110200405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Gecomat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9573 Wiltz, 38, rue Michel Thilges.

R.C.S. Luxembourg B 106.741.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 25 novembre

<i>2011 à 10.00 heures

L’assemblée générale renouvelle pour une période de six ans les mandats de l’administrateur délégué et des adminis-

trateurs suivants:

Monsieur Francis MATHIEU, administrateur et administrateur délégué, né à Luxembourg (L) le 08.10.1962, demeurant

à L – 8510 Redange/Attert, 24, Grand-Rue

Madame Viviane BRAUCH, administrateur, née Wiltz (L) le 30.04.1953, demeurant à L – 1621 Luxembourg, 11A, Rue

des Genêts

Monsieur Guy FEIDT, administrateur, né à Luxembourg (L) le 28.07.1964, demeurant à L – 7227 Bereldange, 41,Rue

de la Forêt

Ces mandats se termineront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2017

Le mandat du commissaire aux comptes SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH SA. et remplacé par la société

EWA REVISION S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 38 937,
avec siège social à L – 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy. Ce mandat se terminera également à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de l’an 2017.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2011170734/24.

(110198678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

6830

L

U X E M B O U R G

ABH Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 151.018.

<i>Résolutions circulaires du conseil d’administration de la Société du 24 novembre 2011

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d’administration de la Société du 24 novembre 2011 que le conseil

d’administration de la Société:

- prend note de la démission de M. Jonach Johann de son mandat d’administrateur de la Société, avec effet au 24

novembre 2011;

- décide de coopter Mme Maria Neofytou, né à Nicosie (Chypre) le 14 février 1973, résidant à Themistokli Dervi, 5,

Elenion Building, 2 

è

 étage, P.C. 1066, Nicosie, Chypre, en tant qu’administrateur de la Société, avec effet au 24 novembre

2011 et pour un mandat qui expirera à l’assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer sur les comptes annuels
de la Société au 31 décembre 2011.

Suite à ces résolutions, le conseil d’administration de la Société est composé comme suit:
- Pavel Nazarian;
- Ildar Karimov;
- Maria Neofytou.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

<i>Pour un mandataire

Référence de publication: 2011170572/23.
(110198682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

F.Int. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 85.244.

Il résulte d'un procès verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue le 20 octobre 2011 que:
Monsieur Riccardo MORALDI a démissionné de sa fonction d'administrateur.
Madame Orietta RIMI, actuelle administrateur a été nommée Président du Conseil d'administration.
Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés, né à Paris 19 

e

 (Paris) le 21 novembre 1961 et demeurant

professionnellement au 3, rue Belle-Vue L-1227 Luxembourg a été nommé administrateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'Assemblé générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011172421/15.
(110200198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Boscolo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 72.920.

<i>Extrait de résolutions adoptées par l’assemblée générale et par le conseil d’administration tenus le 12 décembre 2011

L’assemblée générale prend acte de la démission de Madame Cristina PITTARELLO de ses fonctions d’administrateur

A et Présidente du conseil d’administration.

L’assemblée nomme l’actuel administrateur B Jean-Luc JOURDAN aux fonctions d’administrateur A pour un mandat

échéant à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2012.

L’assemblée nomme Monsieur Andrea GHIRINGHELLI, demeurant professionnellement au 38, Via Nassa CH-6900

Lugano, aux fonctions d’administrateur B pour un mandat échéant à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en
l’an 2012.

Le Conseil d’administration nomme Monsieur Thierry BLIN aux fonctions de Président du conseil d’administration

jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011170622/18.
(110198701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

6831

L

U X E M B O U R G

Cerac Finance I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 158.181.

<i>Extrait des résolutions de l'associé de la société

L'associé a pris unanimement les décisions suivantes:
La révocation avec effet au 13 décembre 2011 de Sami Sassoun, comme gérant B de la société.
La confirmation de la nomination avec effet au 13 décembre 2011 d'Eliahu Oz, avec adresse privé au 3 Kashtan, Haifa,

Israel, comme gérant B de la société pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance se constitue donc avec effet au 13 décembre 2011 de:
- Adam Ofek, gérant de classe A
- Ron Weissberg, gérant de classe A
- Helmut Krausser, gérant de classe B
- Eliahu Oz, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétés

Référence de publication: 2011170631/21.
(110198687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Gosdorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 64.875,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 129.906.

EXTRAIT

En date du 14 décembre 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Mikael Gutierrez, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Wim Rits, 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat et

ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Référence de publication: 2011172454/15.
(110200533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

DIH/HMD Investco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.458.

In the year two thousand and eleven, on the fifth day of December.
Before Maître Carlo WERSANDT notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

DIH Finanz and Consult GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, with registered office at 18,

Rossertstrasse, 60323 Frankfurt am Main, Germany, here represented by Me Pierre Lancelin, lawyer, with professional
address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached

to the present deed to be filed at the same time.

Who declared and requested the notary to state:
That DIH Finanz and Consult GmbH, prenamed, is the sole shareholder of DIH/HMD Investco S.à r.l., a Luxembourg

limited liability company, société à responsabilité limitée, with registered office at 13, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg, under number B 110458, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch,
on 16 

th

 August 2005, published in the Mémorial C number 100 on 16 

th

 January 2006, lastly amended by a deed of Maître

6832

L

U X E M B O U R G

Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, on 14 

th

 December 2005, published in the Mémorial C number 1292 on

th

 July 2006 (the “Company”).

After this had been set forth, the above named, representing the entire subscribed share capital of the Company, has

decided to take the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to accept the resignation of Mr. Raphael KOZIOLLEK in his capacity of class A manager

of the Company with immediate effect.

The sole shareholder further decides to grant full and entire discharge to the resigning manager for the exercise of

his mandate. Such discharge will be ratified by the sole shareholder upon the approval of the Company`s annual accounts
for the year ending 2011.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to transform the A Parts and B Parts into one class of ordinary Parts. Article 7 shall now

read as follows:

“ Art. 7. The company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented

by one hundred (100) Parts with a par value of EUR 125.- EUR (one hundred twenty-five euro) each.”

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to restate article 9 to article 11 of the Company’s articles of association so as to read

as follows:

“ Art. 9. The company is managed by a board of managers (the “Board of Managers”) composed of at least one class

A Manager and one class B Manager.

The Managers are appointed by the general meeting of participants or the sole participant, as the case may be, for an

indefinite period.

The Class A Manager and the Class B Manager shall not receive compensation for their services from the Company,

except for compensation for reasonable travel or other related expenses in connection with attending the meetings of
the Board of Managers.

The Company will be bound by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager.”

“ Art. 10. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the

accomplishment  of  the  corporate  purpose  of  the  Company,  except  those  expressly  reserved  by  law  to  the  general
meeting.

The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers

shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.

The managers jointly represent the Company towards third parties and any litigation involving the corporation, either

as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the managers.

The Board of Managers may also delegate the power of the Company’s representation to one or several managers or

to any other person (shareholder or not) who will represent individually or jointly the Company for specific transactions
as determined by the Board of Managers.

“ Art. 11. The Board of Managers shall hold regular quarterly meetings (or such other meetings as the Board of

Managers may deem appropriate).

All meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.
Managers who are not able to be present at a meeting in person may give a proxy to another manager for purposes

of such meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or

e-mail another Manager as his proxy.

Each manager shall be entitled to cast one vote in voting on all matters submitted to the Board of Managers. The

presence or valid representation by proxy of all managers shall constitute a quorum.

All decisions of the Board of Managers shall be made by the unanimous vote of all managers present and eligible to

cast a vote with respect to such decision.

6833

L

U X E M B O U R G

Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.”

<i>Fourth resolution

As a result of the foregoing:
- Mr. Patrick FELLER, born on 7 August 1970 in Stättligen, Switzerland professionally residing at Rossertstrasse 18

60323, Frankfurt Germany is appointed as Class A Manager.

- Mr. Eric VANDERKERKEN, born on 27 January 1964, in Esch-Sur-Alzette, professionally residing at 22-24 rives de

Clausen, L-2165 Luxembourg is appointed as Class B Manager.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to amend article 14 of the Company’s articles of association so as to read as follows:

“ Art. 14. The participant’s meeting, or the sole shareholder, as the case may be shall have the exclusive power to

resolve upon all matters reserved to the participants under the law dated August 10, 1915, referring to commercial
companies, as amended from time to time.”

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are

estimated at approximately one thousand two hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, last name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German Version

Im Jahr zweitausendundelf, am fünften Dezember.
Vor Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIEN:

DIH Finanz und Consult GmbH, eine Gesellschaft gegründet nach deutschem Recht mit Sitz in D-60323 Frankfurt am

Main (Deutschland), Rossertstraße 18, hier vertreten durch Herrn Pierre Lancelin, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift
in Luxembourg, bevollmächtigt durch eine Vollmacht unter eine privatschriftliche Urkunde.

Welche Vollmacht "ne varietur" unterschrieben werden soll von der Erschienenen Person und vom Notar und soll an

dem hier vorliegenden Dokument beigelegt werden, um zur gleichen Zeit eingereicht zu werden.

Welche erklärt und den Notar zu beurkunden ersucht:
Dass die vorgenannte DIH Finanz und Consult GmbH der alleinige Anteilsinhaber der DIH/HMD Investco S.à r.l. ist,

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 13, Boulevard Royal,
eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg unter Nummer B 110458, gegründet durch Urkunde auf-
genommen von Maître Henri Hellinckx, Notar mit damaligen Amtssitz zu Mersch, am 16. August 2005, veröffentlicht im
Mémorial C Nr. 100 vom 16. Januar 2006, deren Statuten zuletzt geändert wurden durch Urkunde aufgenommen von
Maître Henri Hellinckx, Notar mit damaligen Amtssitz zu Mersch, am 14. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial C
Nr. 1292 vom 4. Juli 2006 (die „Gesellschaft“).

Nach wessen Feststellung die Erschienene, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft vertritt, die folgenden Be-

schlüsse gefasst hat:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Rücktritt von Herrn Raphael KOZIOLLEK von seinem Amt als Klasse „A“

Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung anzunehmen.

Der alleinige Gesellschafter beschließt weiterhin, dem zurückgetretenen Geschäftsführer vollumfängliche Entlastung

für die Ausübung seines Amtes zu gewähren. Die Entlastungserteilung wird durch den alleinigen Geschäftsführer anlässlich
der Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 ratifiziert werden.

<i>Zweiter Beschluss

Der  alleinige  Gesellschafter  beschließt,  die  Anteilsklassen  „A“  und  „B“  in  eine  einzige  Klasse  ordentlicher  Gesell-

schaftsanteile umzuwandeln. Artikel 7 erhält die folgende Fassung:

6834

L

U X E M B O U R G

„ Art. 7. Das Kapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in

einhundert (100) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro).“

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, die Artikel 9 bis 11 der Statuten wie folgt neu zu fassen:

„ Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführerrat (der „Geschäftsführerrat“) geführt, der aus mindestens

einem Klasse „A“ Geschäftsführer und einem Klasse „B“ Geschäftsführer besteht.

Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise durch den alleinigen

Gesellschafter auf unbestimmte Zeit ernannt.

Die Klasse A Geschäftsführer und die Klasse B Geschäftsführer erhalten für die Ausübung ihrer Funktion keine Ent-

schädigung von der Gesellschaft, ausgenommen der Entschädigung für vernünftige Reisekosten oder ähnlicher Kosten im
Zusammenhang mit der Teilnahme an Versammlungen des Vorstandes der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift eines Klasse „A“ Geschäftsführers und eines Klasse „B“

Geschäftsführers rechtswirksam verpflichtet.“

„ Art. 10. Der Geschäftsführerrat hat die weitestgehenden Befugnisse, all jene Handlungen zur Verwaltung und Ge-

schäftstätigkeit der Gesellschaft vorzunehmen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, ausgenommen
der Befugnisse, welche ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung zustehen.

Der Geschäftsführerrat kann unter der Voraussetzung Zwischendividenden auszahlen, dass ihm vor Fassung dieses

Beschlusses ein Zwischenabschluss der Gesellschaft vorliegt, aus dem hervorgeht, dass die Gesellschaft über hinreichende
Mittel zur Auszahlung einer solchen Zwischendividende verfügt.

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinsam gegenüber Dritten, und jeder Rechtsstreit, an dem die

Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte beteiligt ist, wird im Namen der Gesellschaft durch die Geschäftsführer geführt.

Der Geschäftsführerrat kann die Befugnis zur Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Geschäftsführer

oder an jede andere Person, die kein Gesellschafter sein muss, übertragen, welche die Gesellschaft einzeln oder gemein-
sam bei bestimmten Rechtshandlungen gemäß der Festlegung durch den Geschäftsführerrat vertreten können“.

„ Art. 11. Der Geschäftsführerrat tritt regelmäßig vierteljährlich zusammen (oder zu solchen Zeitpunkten wie es der

Vorstand für notwendig erachtet).

Alle Sitzungen des Geschäftsführerrates finden in Luxemburg statt.
Ein oder mehrere Geschäftsführer können an einer Sitzung per Telefonkonferenz oder durch jedes andere, von Lu-

xemburg aus initiierte Kommunikationsmittel teilnehmen, das es mehreren Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander
zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme steht der physischen Teilnahme an einer Sitzung gleich. Ein auf diese Weise
gefasster Beschluss kann in einem einzigen Schriftstück oder in mehreren getrennten Schriftstücken gleichen Inhalts, die
von allen Teilnehmern der Sitzung unterschrieben sind, dokumentiert werden.

Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung teilnehmen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Faxübertra-

gung oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer als seinen Vertreter bestellt.

Hinsichtlich der Beschlussfassung hat jeder Geschäftsführer eine Stimme für alle Angelegenheiten, welche dem Vor-

stand zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Anwesenheit oder wirksame Vertretung durch Vollmacht hinsichtlich aller
Geschäftsführer soll ein Quorum bilden.

Alle Entscheidungen des Vorstandes werden einstimmig durch alle anwesenden und zur Abstimmung berechtigten

Geschäftsführer getroffen.

Beschlüsse, die im Umlaufverfahren getroffen werden und von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates unterzeichnet

sind, sind ebenso wirksam und gültig, wie wenn sie in einer wirksam einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Ge-
schäftsführerrates  gefasst  worden  wären.  Diese  Unterschriften  können  sich  auf  einem  einzigen  Dokument  oder  auf
mehreren Kopien des gleichen Beschlusses befinden und können per Brief, Telefax oder ähnlichem Kommunikationsmittel
übermittelt werden.“

<i>Vierter Beschluss

Infolge des Vorstehenden beschließt der alleinige Gesellschafter:
- Herr Patrick FELLER, geboren am 7. August 1970 in Strättligen, Schweiz, mit beruflicher Anschrift in D-60323 Frank-

furt am Main, Deutschland, Rossertstraße 18, wird zum Klasse „A“ Geschäftsführer ernannt.

- Herr Eric VANDERKERKEN, geboren am 27. Januar 1964 in Esch-sur-Alzette, mit beruflicher Anschrift in L-2165

Luxemburg, 22-24, rives de Clausen, wird zum Klasse „B“ Geschäftsführer ernannt.

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 14 der Statuten der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen:

„ Art. 14. Die Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise der alleinige Gesellschafter haben das exklusive

Recht, unter den folgenden Bedingungen bezüglich aller Angelegenheiten abzustimmen, die ihnen durch das von Zeit zu
Zeit abgeänderte luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften zugewiesen sind.“

6835

L

U X E M B O U R G

<i>Schätzung der Kosten

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen und Zahlungen jeglicher Art, die durch die Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr eintausendzweihundert Euro geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der erschienenen

Person die vorstehende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Ersuchen derselben
erschienenen Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text hat die englische
Fassung den Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche Personen dem Notar durch Vorname, Name, Stand und

Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Signé: P. LANCELIN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2011. LAC/2011/54173. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170676/196.
(110198173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

ProLogis UK X S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.889.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 13 decembre 2011 quinze (15) parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaire unique, càd, ProLogis European Finance XVI Sàrl ont étés transférées à ProLogis UK XXXVII Sàrl ayant son
siège social à 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom
et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:
Repartitions des parts sociales:

ProLogis UK XXXVII Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 parts sociales

Luxembourg, le 13 decembre 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représente par Gerrit Jan Meerkerk
<i>Gérant

Référence de publication: 2011172890/20.
(110200862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Ferges S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.315.

<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle du 2 mai 2011

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la société, tenue à Luxembourg le 2 mai 2011, que les résolutions

suivantes ont été adoptées:

- L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Vadim KHARIN au poste d'administrateur de la société et

ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

- L'assemblée décide de renouveler le mandat de Patrice Declérieux au poste de commissaire aux comptes de la société

et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

6836

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011170712/19.
(110198685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Financière Leka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 67.554.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2011171635/11.
(110199444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Global Metall, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 102.617.

<i>Extrait du Procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue au siège social 171, route de Longwy, L-1941

<i>LUXEMBOURG, le 18 octobre 2011 à 11h00

<i>Délibérations

Après analyse et délibérations:
1. Conformément à l’article 11Bis par. 2 3 LSC, l’Assemblée prend acte du changement de dénomination sociale de

l’associé: Hightly Corporation S.A. en Hightly Corporation S.C.A., en date du 14 avril 2010.

Il est rappelé que le Gérant est:
Monsieur Michel HIRNER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011170740/18.
(110198715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Global Metall, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 102.617.

<i>Extrait du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue au siège social 171, route de Longwy, L-1941

<i>LUXEMBOURG, le 18 octobre 2011 à 12h00

<i>Délibérations

Après analyse et délibérations:
1. L’Assemblée prend acte et accepte, à l’unanimité, la cession de vingt cinq (25) parts sociales, établie en date du 11

décembre 2008 entre le Cédant: Higthly Corporation S.C.A., RCS 98871, siège social 171 route de Longwy L-1941
Luxembourg

et le Cessionnaire: J.B. Steels and Services Sàrl, RCS 144031, siège social 217 route d’Esch L-1471 Luxembourg,
au prix de 20.000€ la part sociale, soit un montant total de 500.000€.
L’Assemblée agréée à l’unanimité le nouvel Associé: J.B. Steels and Services Sàrl.
2. L’Assemblée prend acte et accepte, à l’unanimité, la cession de une (1) part sociale, établie en date 17 octobre 2011

entre

le Cédant: Maître Yann Baden, Avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme

Pargestion S.A., établie et ayant eu son siège social 27 rue Jean-Baptiste Esch L-2163 Luxembourg, déclarée en faillite par
jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, en date du 15 octobre 2010,

6837

L

U X E M B O U R G

Détenteur à titre fiduciaire d’une part sociale, représentant la participation au capital de la société Global Metall Sàrl.
et le Cessionnaire: Higthly Corporation S.C.A., RCS 98871, siège social 171 route de Longwy L-1941 Luxembourg.Il

est rappelé que le Gérant est:

Monsieur Michel HIRNER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011170741/28.
(110198715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

NDX Market S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 115.425.

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire que les organes de la société se composent dès-à-présent comme

suit:

- Monsieur Gernot Kos, né le 23.01.1970 à Eisenstadt (A), demeurant professionnellement à 19, rue de Bitbourg L-1273

Luxembourg, administrateur,

- Monsieur Thierry Hellers, né le 13.09.1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 19, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg, administrateur,

- G.T. Fiduciaires S.A., inscrite au RCS Luxembourg B 121.820, avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19 rue de

Bitbourg, administrateur, avec comme représentant permanent Monsieur Gernot Kos, né le 23.01.1970 à Eisenstadt (A),
demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg

- G.T. Experts Comptables (anciennement dénommée Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés Sàrl), inscrite au RCS Lu-

xembourg B 121.917, avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont nommés pour une période d’une année.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2011170875/23.
(110198683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

King Charter S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 71.708.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugements rendus en date du 17 novembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actifs les opérations de liquidation des sociétés
suivantes:

- la société anonyme KING CHARTER S.A (RCS B 71708) dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard

Royal, a été dénoncé en date du 7 mars 2008.

Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Stéphanie STAROWICZ»
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011172856/16.
(110201313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Luxon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 142.276.

Les comptes annuels de l'année 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

6838

L

U X E M B O U R G

Mersch, le 14 décembre 2011.

<i>Pour LUXON S.A.
Arend &amp; Partners S.à r.l.
Mersch
Signature

Référence de publication: 2011171806/14.
(110199253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.099.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 juillet 2011

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- de transférer le siège social de la Société du 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 26A, boulevard Royal L-2449

Luxembourg avec effet au 1 

er

 juin 2011;

- En conséquence les adresses professionnelles de Mr Szymon DEC et de Mr Jean-Pierre BACCUS deviennent égale-

ment 26A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg;

- de nommer Mme Figen EREN, née le 10 février 1978 à Besançon (France) ayant sa résidence professionnelle au 26A

Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 18 juillet 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2)
Szymon DEC
<i>Gérant

Référence de publication: 2011170889/19.
(110198700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Sun Life (Luxembourg) Finance No. 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 159.293.

Merci de modifier l'adresse du gérant Phil Zwack comme suit:
- 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg

Luxembourg, le 14.12.2011.

Référence de publication: 2011170963/10.
(110198698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Financière de Vauban S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 88.246.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011171622/10.
(110200357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Heart (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 160.514.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d'accepter la démission avec

effet immédiat de:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW

Surbiton, Royaume-Uni.

6839

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 Décembre 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011172467/15.
(110201126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Winsway Coking Coal Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.000,00.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 165.044.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites du 7 novembre 2011 de l'associé unique de la Société que:
- Monsieur Wang Xingchun a été révoqué de son poste de gérant de la Société avec effet au 18 octobre 2011;
- Monsieur Luc Gérondal, né le 23 avril 1976 à Kinshasa, République Démocratique du Congo résidant au 19, avenue

du Bois, L-1251 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie A de la Société avec effet au 18 octobre 2011 et ce pour
une durée indéterminée;

- Monsieur Philippe Salpetier, né le 19 août 1970 à Libramont (Belgique) résidant professionnellement au 12, rue

Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie A de la Société avec effet au 18 octobre 2011
et ce pour une durée indéterminée;

- Monsieur Apolonius Struijk, né le 19 mars 1956 à Rotterdam (Pays-Bas) résidant au Suite 2700, 20 

th

 Floor Pacific

Place Apartments, Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong a été nommé gérant de catégorie B de la Société avec effet
au 18 octobre 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171048/23.
(110198714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Finzels Reach Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.892.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171623/10.
(110200206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Festivo International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 122.430.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171629/9.
(110199026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Neo Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 138.012.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

6840

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011171856/12.
(110199334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Fideurope, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 128.464.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171630/9.
(110200422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Floreanville Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine fa-

milial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 84.815.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171640/10.
(110199404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Merlin Entertainments Group Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 346.300,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 109.647.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 5 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1300 du 30 novembre 2005.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Merlin Entertainments Group Luxembourg 3 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011171810/14.
(110199863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Foncière de l'Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 100.558.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171642/9.
(110200075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

RE Car Parts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.324.800,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.608.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société adoptées le 7 décembre 2011

L'associé unique de la Société a décidé de révoquer Monsieur Volker Schmidt de son mandat de gérant de catégorie

B de la Société avec effet au 30 novembre 2011.

6841

L

U X E M B O U R G

L'associé unique de la Société a décidé de nommer M. Peter Schaberger, né à Esslingen am Neckar (Allemagne) le 12

février 1972, demeurant professionnellement à Alter Hof 5, 80331 Munich, Allemagne, en tant que nouveau gérant de
catégorie B de la Société avec effet au 30 novembre 2011 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RE Car Parts S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011172629/17.
(110200991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

San José Immobilien S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 165.239.

STATUTEN

Im Jahr zweitausendelf, am siebten Dezember.
Vor Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

INTER GLOBE TRUST Spf S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft mit Sitz in 1, An de Gaalgen, L-5752 Frisange,

eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 52.927, hier rechtsmäßig vertreten durch den
Delegierten des Verwaltungsrats mit Einzelzeichnungsrecht, Herrn Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, beruflich
wohnhaft in Luxemburg.

Welcher Komparent den amtierenden Notar dazu angehalten hat die Gründungsurkunde einer anonymen Gesellschaft

zu beurkunden, welche der Komparent gründete, und von welcher er die Satzung wie folgt bestimmt:

Art. 1. Es ist durch den Komparenten, und unter all jenen welche in der Folge Eigentümer der hiernach ausgegebenen

Aktien werden, eine luxemburgische anonyme Gesellschaft gegründet, unter dem Namen „San José Immobilien S.A.“.

Art. 2. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Sie kann aufgelöst werden durch eine Entscheidung der Gene-

ralversammlung der Aktionäre welche mit der Mehrheit abstimmt wie für Satzungsänderungen erforderlich.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Pétange.
Er kann durch einfache Entscheidung der Verwaltungsrats an jeden anderen Ort innerhalb derselben Gemeinde verlegt

werden, sowie durch Entscheidung einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wie in Angelegenheiten
einer Satzungsänderung abstimmend, in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Sitz
kann ins Ausland verlegt werden, durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrats, wenn außergewöhnliche Umstände
militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur der normalen Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz im
Wege stehen, oder imminent sind, und dies bis zur Beendigung solcher Umstände.

Unbeschadet einer solchen Verlegung ins Ausland, welche immer nur temporärer Natur sein kann, bleibt die Natio-

nalität der Gesellschaft immer luxemburgisch.

Unter jeglichen Umständen kann die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft ins Ausland, sowie die Annahme einer

ausländischen Nationalität durch die Gesellschaft, immer nur durch den einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter sowie
aller Anleiheeigner erfolgen, welche zum diesem Zwecke in einer außerordentlichen Generalversammlung versammelt
sein müssen.

Die Gesellschaft kann ihre Umwandlung von einer anonymen in eine europäische Gesellschaft (S.E.) luxemburgischen

Rechts beschließen.

Die Gesellschaft mag per Beschluss des Verwaltungsrats sowohl im Großherzogtum Luxemburg, wie auch im Ausland,

Tochtergesellschaften, Zweitsitze, Zweigstellen, Agenturen und Büros eröffnen.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung und die Ver-

wertung von, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gelegenen Immobilien.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,

der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere
Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die
Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die  Gesellschaft  kann  sich  an  der  Gründung  und  Entwicklung  jeder  finanziellen,  industriellen  oder  kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.

6842

L

U X E M B O U R G

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbe-

weglichen,  kommerziellen  und  industriellen  Operationen  machen,  welche  sie  für  nötig  hält  zur  Verwirklichung  und
Durchführung ihres Zweckes.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) unterteilt in eintausend

Aktien (1.000) mit einem Nennwert von jeweils einunddreißig Euro (31.-EUR), alle voll und ganz gezeichnet. Die Aktien
können als Namensaktien oder Inhaberaktien ausgestellt werden, je nach Wahl der Aktionäre.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder

heruntergesetzt werden, sofern die Generalversammlung, wie unter den Bedingungen für eine Satzungsänderung vor-
geschrieben, abgehalten wird.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen und Anforderungen, ihre eigenen Aktien erwerben.
Die Gesellschaft kann mit einem einzigen Aktionär bestehen.

Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die

Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Dauer von nicht mehr als sechs (6) Jahren gewählt. Sie sind wieder
wählbar. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten und eventuell einen Vizepräsidenten.

Wenn durch Abtritt, Sterbefall, oder aus einem anderen Grund, ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird,

können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diesen provisorisch durch eine andere Person ersetzen. In diesem
Fall muss die Generalversammlung, bei ihrer nächsten Sitzung, die endgültige Wahl vornehmen.

Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, und dieser Umstand rechtsverbindlich festgestellt ist,

können die Funktionen des Verwaltungsrates durch eine einzige Person ausgeführt werden, welche Person nicht unbedingt
der einzige Aktionär sein muss.

Wenn eine juristische Person zum Verwaltungsrat bestimmt wird ist dieselbe verpflichtet einen permanenten Vertreter

zu bestimmen, welcher die Aufgabe hat diese Mission auszuführen und dies im Namen und für Rechnung derjenigen
juristischen Person.

Dieser Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und hat dieselbe rechtliche Verantwortung als würde er die Mission

in seinem eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Schadensersatzp-
flicht der juristischen Person welche er vertritt. Dieselbe kann ihren Vertreter nur dann abberufen wenn sie gleichzeitig
dessen Nachfolger bestimmt.

Die Ernennung und die Beendigung der Funktionen des Vertreters unterliegen denselben Bestimmungen bezüglich der

Veröffentlichung als würde er die Mission in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausführen.

Die Verwaltungsratsmitglieder, sowie jegliche Personen welche den Sitzungen dieses Organs beiwohnen, haben die

Verpflichtung nichts nach außen bekannt zu geben, dies auch nicht nach Beendigung ihrer Tätigkeiten, was jegliche Infor-
mationen anbetrifft über welche sie bezüglich der Gesellschaft verfügen, und deren Veröffentlichung der Gesellschaft
Schaden zufügen könnte, mit Ausnahme der Fälle wo eine Veröffentlichung verlangt oder erlaubt ist, sei es entweder
durch gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen, oder im Interesse der Allgemeinheit.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Vollmachten um die Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, sowie

jegliche Transaktionen durchzuführen welchen den gesellschaftlichen Zwecken dienen oder denselben nützlich sein kön-
nen, unter Ausnahme derjenigen welche laut Gesetz oder laut diesen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten
sind. Er kann zum Zwecke einer Arbitrage Kompromisse zeichnen, gütliche Einigungen per Transaktion eingehen, sowie
auch jegliche Verzichte oder Aufhebungen von Sicherheiten, gegen Zahlung oder ohne Zahlung, verfügen.

Der Verwaltungsrat kann die Tagesgeschäfte der Gesellschaft ganz oder auch teilweise, sowie auch die Vertretung der

Gesellschaft was diese Verwaltung anbetrifft, an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Vertreter, welche alle nicht Aktionär sein müssen, delegieren.

Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern, oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift einer
hierfür durch den Verwaltungsrat bestimmten Person.

Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht jede Informationen zu erhalten, welche an den Verwaltungsrat herange-

tragen werden.

Die Abgabe der Vertretung für tagesgeschäftliche Dinge an ein Mitglied des Verwaltungsrates oder die Vergabe von

speziellen Vertretungsbefugnissen an ein solches Mitglied, verpflichtet den Verwaltungsrat jährlich darüber der ordentli-
chen Generalversammlung Rechenschaft, sowie über jegliche Entlohnungen, Bezüge, und Vorteile, wie auch immer geartet,
die dadurch an den Vertreter oder diese Verwaltungsratsmitglieder geleistet wurden, zu geben.

Art. 8. Die gerichtlichen Anträge, sowohl wenn die Gesellschaft klagt oder beklagt wird, werden immer im Namen

der Gesellschaft alleine, vertreten durch ihren Verwaltungsrat, ausgeführt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat versammelt sich so oft wie die Interessen der Gesellschaft dies verlangen. Die Versamm-

lungen werden durch den Präsidenten, und in dessen Abwesenheit, vom Vizepräsidenten oder durch zwei Verwaltungs-
ratsmitglieder einberufen.

Der Verwaltungsrat kann gültig abstimmen, wenn eine Mehrheit dessen Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

6843

L

U X E M B O U R G

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei Sitzungen vertreten lassen, dies durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann immer nur einen seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.

Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit gefällt. Im Falle eines Patts hat der Präsident

nicht die entscheidende Stimme.

Im Falle von Dringlichkeit können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und durch jegliche Telekom-

munikationstechniken abgeben.

Der Verwaltungsrat kann mit Hilfe einer Videokonferenz abstimmen. Die Abstimmung wird vom Gesellschaftssitz aus

geschaltet. Das Protokoll der Abstimmung anlässlich einer Videokonferenz, wird am Sitz der Gesellschaft durch den
Sekretär des Verwaltungsrates erstellt.

Er wird den Verwaltungsratsmitgliedern innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Zeitpunkt der Sitzung zugestellt. Jedes

Mitglied kann dem Sekretär schriftlich seine Zustimmung oder seine Einwände mitteilen.

Wenn im Laufe einer Videokonferenz eine substantielle Uneinigkeit zwischen den Teilnehmern entsteht, kann jedes

Verwaltungsratsmitglied die Vertagung jenes Punktes der Tagesordnung, welcher Anlass zur Uneinigkeit gibt, auf eine
kommende Sitzung des Verwaltungsgrates vertagen lassen, welche dann innerhalb von dreißig (30) Tagen abgehalten
werden muss, und anlässlich derselben die Mitglieder physisch zugegen oder vertreten sein müssen. Der erste Absatz
dieses Artikels findet dann Anwendung.

Sofern keine abweichende und striktere Bestimmung des internen Reglements Anwendung findet, sind diejenigen Ver-

waltungsratsmitglieder welche an einer Videokonferenz teilnehmen als präsent zu werten, zum Zwecke der Ausrechnung
des Quorums sowie der erforderlichen Mehrheit der Teilnahme, sofern die Identität des Teilnehmers an der Videokon-
ferenz  oder  durch  eine  anderes  Telekommunikationsmittel  festgestellt  werden  kann.  Diese  technischen  Mittel  zur
Identifikation müssen eine effektive und kontinuierliche Teilnahme an der Sitzung, deren Abstimmungen kontinuierlich
übertragen werden, gewährleisten.

Jede Sitzung welche durch technische Übertragung auf Distanz abgehalten wird, gilt als auf dem Gesellschaftssitz ab-

gehalten.

Die Gesellschaft kann sich ein internes Reglement geben, welches für alle Verwaltungsratsmitglieder bindend ist, und

welches die zusätzlichen Anforderungen für das Abhalten von Sitzungen auf Distanz gilt.

Der Verwaltungsrat kann jegliche Beschlüsse durch Rundschreiben fassen. Die Vorschläge für die Beschlussfassungen

werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates in dem Falle schriftlich mitgeteilt, und diese geben ihre Entscheidung dann
per Rückschreiben und schriftlich bekannt. Die Entscheidungen gelten als getroffen wenn eine Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder ihre Stimme dafür abgibt.

Über die Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden Protokolle errichtet. Auszüge aus den Protokollen werden

mit der Unterschrift vom Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit, mit den Unterschriften von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern gefasst.

Art. 10. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär

zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs (6) Jahre

nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest. Sie können wiedergewählt werden.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwal-

tungsrat erstellt eine Bilanz und eine Gewinn-und Verlustrechnung, sowie die Anlagen zu den Jahreskonten.

Art. 12. Der Verwaltungsrat hat das Recht eine Generalversammlung einzuberufen sofern er dies als opportun ansieht.

Er ist dazu verpflichtet eine solche innerhalb eines Monats einzuberufen, sofern Aktionäre welche mindestens zehn Pro-
zent des Gesellschaftskapitals darstellen ihn dazu schriftlich auffordern, und gleichzeitig die gewünschte Tagesordnung
darlegen.

Die Einberufung jeglicher Generalversammlungen beinhaltet die Tagesordnung.
Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um jegliche Geschäfte zu tätigen oder zu ratifizieren

sofern dieselben die Interessen der Gesellschaft berühren.

Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellen, können

der Tagesordnung ein oder mehrere neuen Punkte hinzufügen lassen. Die dementsprechende Anträge müssen der Ge-
sellschaft an deren Sitz per Einschreibebrief mitgeteilt werden, dies mindestens fünf Tage vor Abhalten der Versammlung.

Die Auszüge der Protokolle der Generalversammlungen werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrates, sonst

durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates als konform attestiert.

Art. 13. Jeder Aktionär hat das Recht entweder persönlich oder durch einen Vertreter, welch letzterer nicht selbst

Aktionär sein muss, an Abstimmungen teilzunehmen. Jede Aktie gibt das Recht zu einer Stimme.

Art. 14. Die alljährliche Generalversammlung wird an jedem ersten Montag des Monats Mai um 10.30 Uhr, entweder

am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in derselben Gemeinde abgehalten, wie im Einberufungsschreiben zu

6844

L

U X E M B O U R G

bestimmen.  Sollte  dieser  Tag  ein  gesetzlicher  Feiertag  sein,  dann  wird  die  Versammlung  am  nächst  darauf  folgenden
Werktag zur selben Uhrzeit abgehalten.

Die alljährliche Generalversammlung ist dazu berufen die Konten und die jährlichen Geschäftsberichte anzunehmen,

sowie sich über die Entlastung der Gesellschaftsorgane auszudrücken.

Sie bestimmt über die Verwendung und die Ausschüttung des Nettogewinns. Vom Nettogewinn werden fünf Prozent

(5%) dazu verwendet einen gesetzlichen Reservefonds zu speisen; diese Speisung des gesetzlichen Reservefonds ist nicht
mehr obligatorisch wenn diese Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat, muss allerdings wieder bis zur
vollständigen Auffüllung aufgenommen werden wenn immer und aus welchem Grund auch immer, die gesetzliche Reserve
beansprucht wurde.

Der Rest steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat ist dazu befugt im Laufe eines Geschäftsjahres Vorauszahlungen auf Dividende zu zahlen, dies unter

den Bedingungen und Bestimmungen wie im Gesetz verankert.

Art. 15. Für jegliche nicht in den vorliegenden Satzungen geregelten Punkte, vereinbaren die Parteien, dass die Bes-

timmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Änderungen Anwendung finden.

<i>Übergangsbestimmung

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Jahr 2013 abgehalten.

<i>Zeichnung der Anteile

Das Gesellschaftskapital und dessen eintausend (1.000) Aktien wurden alle durch den Komparenten INTER GLOBE

TRUST Spf S.A., vorbenannt, gezeichnet.

Alle Aktien, welche auf diese Art gezeichnet wurden, sind zu 100% (hundert Prozent) in Bar eingezahlt, so dass die

Summe von einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem Notar per
Banknachweis bescheinigt wurde.

<i>Erklärung

Der Notar erklärt die Erfüllung der Bedingungen wie in Artikel 26 des Gesetzes über Handelsgesellschaften ausgeführt,

überprüft zu haben, und erklärt ausdrücklich, dass dieselben erfüllt sind.

<i>Kostenveranschlagung

Der Summe der Kosten, Auslagen, Gehälter sowie Lasten, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft

bei dieser Gründung entstehen, betragen ungefähr eintausendeinhundert Euro (1.100.- EUR).

<i>Anmerkung

Der amtierende Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft

vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftsz-
weck sein muss, was der Komparent ausdrücklich anerkannt hat.

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Und im selben Augenblick hat der Komparent, welcher die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertritt, sich in einer

außerordentlichen Generalversammlung konstituiert, zu welcher er sich regelkonform einberufen erklärt, und er hat
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf einen: diejenige des Kommissars wird festgelegt auf einen.
2. Das Mandat des Verwaltungsratsmitgliedes sowie des Kommissars endet mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2017.

3. Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Herr Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, geboren in München (Deutschland), am 15. Juni 1946, beruflich wohn-

haft in 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

4. Zum Kommissar wird ernannt:
FIDES INTER-CONSULT S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft, mit Sitz in 62, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 52.925.

5. Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Worüber  Urkunde,  verhandelt  und  aufgenommen  in  Luxemburg,  am  Tag,  Monat  und  Jahr,  wie  am  Anfang  dieser

Urkunde geschrieben.

Und nach Vorlesung dieser Urkunde an den Komparenten hat derselbe diese mit Uns Notar zusammen unterschrieben.
Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.

6845

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2011. LAC/2011/55020. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170955/218.
(110198289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Stores Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 5, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 165.248.

STATUTS

L'an deux mille onze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée "BFI S.à r.l.", avec siège social à L-3895 Foetz, 5, rue de l'Avenir, (R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 105.199),

ici dûment représentée par deux de ses gérants:
- Monsieur Sébastien JUNGEN, gérant de société, demeurant à L-5651 Mondorf-les-Bains, 8, rue de la Résistance, et
- Monsieur Joel PAIS, gérant de société, demeurant à L-4419 Belvaux, 3, rue du Bois.
2.- Madame Nathalie CHANTRAINE, directrice, née à Ixelles, (Belgique), le 31 décembre 1963, demeurant à B-6792

Rachecourt, 275, rue de la Strale.

3.- Monsieur Raffaele PASQUARELLI, gestionnaire de chantiers, né à Pizzoferrato, (Italie), le 26 juin 1968, demeurant

à L-8237 Mamer, 10, rue Henry Kirpach.

4.- Monsieur Emmanuel THIRY, installateur, né à Arlon, (Belgique), le 1 septembre 1969, demeurant à B-6792 Rache-

court, 275, rue de la Strale.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les

statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent par la présente.

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de "STORES CONCEPT S.à r.l.".

Art. 3. La société a pour objet la fourniture, la pose, la réparation de systèmes de protection solaire, volets, stores

intérieurs et extérieurs, marquises, voilages et tentures.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi dans la Commune de Mondercange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente milles euros (30.000,- EUR), représenté par cent vingt (120) parts sociales de

deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

6846

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre la même année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- La société à responsabilité limitée "BFI S.à r.l.", avec siège social à L-3895 Foetz, 5, rue de l'Avenir,
quarante parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.- Madame Nathalie CHANTRAINE, directrice, demeurant à B-6792 Rachecourt, 275, rue de la Strale,
vingt parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.- Monsieur Raffaele PASQUARELLI, gestionnaire de chantiers, demeurant à L-8237 Mamer, 10, rue Henry
Kirpach. quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

4.- Monsieur Emmanuel THIRY, installateur, demeurant à B6792 Rachecourt, 275, rue de la Strale, vingt
parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

6847

L

U X E M B O U R G

Total: cent vingt parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de trente mille euros

(30.000,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ 1.200,- EUR.

<i>Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- L'adresse du siège social est établie à L-3895 Foetz, 5, rue de l'Avenir.
2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société:
- Madame Nathalie CHANTRAINE, directrice, née à Ixelles, (Belgique), le 31 décembre 1963, demeurant à B-6792

Rachecourt, 275, rue de la Strale, gérante technique;

- Monsieur Raffaele PASQUARELLI, gestionnaire de chantiers, né à Pizzoferrato, (Italie), le 26 juin 1968, demeurant à

L-8237 Mamer, 10, rue Henry Kirpach, gérant administratif.

3.- La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sébastien JUNGEN, Joel PAIS, Nathalie CHANTRAINE, Raffaele PASQUARELLI, Emmanuel THIRY, Jean SEC-

KLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2011. Relation GRE/2011/4462. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170995/126.
(110198605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Fordale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 139.005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171645/9.
(110199850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Form &amp; Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.714.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011171648/10.
(110199039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

6848

L

U X E M B O U R G

Nova Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 165.227.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the seventh of December.
Before us, Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company of German Law The Butler UG, having its registered office at D-72379 Hechingen, Walkenmühleweg

42, registered with the Companies' Register of the district court of Stuttgart under the number B 731161,

hereby represented by Ms. Sophie BATARDY, lawyer, residing professionally in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue

Pasteur, by virtue of a proxy given on December 1, 2011

Said proxy after signature "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing company, represented as said before, has requested the notary to draw up the following Articles of

Incorporation of a public limited company governed by the relevant law and the present articles.

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a public limited company (société anonyme) under the name of NOVA TECHNOLO-

GIES S.A..

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the Company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any Luxembourg or foreign companies and enterprises in whatsoever form, to the administration, the ma-
nagement, the control and the development of these participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of

any securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, the development and the control of any
enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way
whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these
securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or
guarantees.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal provisions.

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are

in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.

Art. 5. The corporate capital is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (€ 31,000.-), represented by one hundred

(100) shares with a par value of THREE HUNDRED TEN EURO (€ 310.-).

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

Administration - Supervision

Art. 6. In case of several shareholders, the corporation shall be managed by a Board of directors composed of at least

three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

In case of a sole shareholder the number of directors may be reduced to one.

Art. 7. The board of directors or the sole director has full power to perform such acts as shall be necessary or useful

to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles
of Incorporation are within the competence of the board of directors or the sole director.

6849

L

U X E M B O U R G

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director

may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telefax or e-mail, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telefax or e-mail.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.

Art. 10. The Company shall be bound towards third parties in all matters by:
- in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director or
- the joint signatures of any two members of the Board or
- by the sole signature of the managing director(s) regarding the daily management of the company, or
- the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted

by the Board or the Sole Director.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It

has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

In case of one sole shareholder, this one is vested with all the powers that are granted to the general meeting by law.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is subject to the provisions of the law (especially Art 72-2 of the law of 10 August 1915 on

commercial companies) authorised to pay interim dividends.

Art. 16. The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the

convening notices on the 17 

th

 of July at 11.00 a.m..

Art. 17. The Law of August 10 

th

 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory disposition

1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2012.
2) The first annual general meeting will be held in the year 2013.
3) Exceptionally, the first managing director(s) and the first chairman of the board of directors can be appointed by

the first general meeting of shareholders.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the one hundred (100) shares have been subscribed by the

sole shareholder

All the one hundred (100) shares have been fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the

amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (€ 31,000.-) is from this day on at the free disposal of the Company and
proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law on

Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

6850

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The appearing party has estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne

by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand four
hundred Euro (€ 1,400.-).

<i>Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole shareholder:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
- Mr. Nico HANSEN, private employee, born on the 31 

st

 of March 1969 in Differdange, residing professionally in

L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur,

- Ms. Sophie BATARDY, lawyer, born on the 22 

nd

 of January 1963 in Lille (France) residing professionally in L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur,

- Mr. Alain BARTHOLME, private employee, born on the 25 

th

 of August 1972 in Ettelbrück, residing professionally

in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

3) Mr. Nico HANSEN, prenamed, is appointed as chairman of the board of directors.
4) Has been appointed as managing director of the company:
Mr. Nico HANSEN, prenamed, who can bind the company in the daily management by his sole signature.
5) Has been appointed auditor:
The company MGI FISOGEST S.à r.l., having its registered office in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, re-

gistered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 20.114.

6) The mandates of the directors, the managing director, the chairman of the board of directors and the auditor shall

expire immediately after the annual general meeting of 2016.

7) The registered office is fixed in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing person, the present

incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, acting as said before, the said appearing person signed

together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung der Urkunde:

Im Jahre zweitausend elf, den siebten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach, Grossherzogtum Luxemburg.
Die Gesellschaft deutschen Rechts The Butler UG, mit Sitz in D-72379 Hechingen, Walkenmühleweg 42, eingetragen

beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer B 731161,

hier vertreten durch Frau Sophie BATARDY, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue

Pasteur, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 1. Dezember 2011.

Welche Vollmacht "ne varietur" von der Bevollmächtigten und dem Notar unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Ur-

kunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihr zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital

Art. 1. Unter der Bezeichnung NOVA TECHNOLOGIES S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Akti-

engesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Betei-

ligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften und Unternehmen, mit
der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unter-

6851

L

U X E M B O U R G

nehmen,  zum  Erwerb  durch  Einbringung,  Zeichnung,  Übernahme  oder  Kaufoption  oder  anderweitig  von  jeglichen
Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung
von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-), eingeteilt in ein hundert

(100) Aktien mit einem Nennwert von je DREI HUNDERT ZEHN EURO (€ 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 6. Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern

verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Im Falle eines alleinigen Anteilhabers, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf einen herabgesetzt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzu-

nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem

anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlussfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist;  die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fern-
schriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die  Beschlüsse  des  Verwaltungsrates  werden  mit  Stimmenmehrheit  gefaßt;  bei  Stimmengleichheit  entscheidet  die

Stimme des Vorsitzenden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Generalversammlung.

Art. 10. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in allen Fällen wie folgt vertreten:
- im Falle eines alleinigen Verwalters, durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Verwalters, oder
- durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder
- durch die alleinige Unterschrift des/der Delegierten des Verwaltungsrates im Rahmen der täglichen Geschäftsführung

der Gesellschaft; oder

- durch die gemeinsamen Unterschriften der Personen oder die alleinige Unterschrift der Person welchen/welcher

solche Zeichnungsbefugnisse durch den Verwaltungsrat oder durch den alleinigen Verwalter erteilt wurden.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.

6852

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von den ge-

setzlichen Erfordernissen können abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Die rechtmäßige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen
Beschlüsse gutzuheißen.

Im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz der Versammlung

der Aktionäre verliehen sind.

Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat nach Maßgabe des Gesetzes (insb. Des Artikels 72-2 des Ge-

setzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften) ausgeschüttet werden.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 17. Juli um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder

an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestimmungen

des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen, einschließlich der Än-
derungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2012
2) Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2013.
3) Ausnahmsweise kann/können der/die ersten Delegierte(n) des Verwaltungsrates und der erste Vorsitzende des

Verwaltungsrates bei der ersten Aktionärsversammlung ernannt werden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach  Feststellung  der  Satzung  wie  vorstehend  erwähnt,  wurden  alle  ein  hundert  (100)  Aktien  durch  die  alleinige

Gesellschafterin gezeichnet

Sämtliche  Aktien  wurden  voll  in  bar  eingezahlt,  so  dass  der  Betrag  von  EINUNDDREISSIG  TAUSEND  EURO  (€

31.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung
ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend vier hundert Euro (€ 1.400,-).

<i>Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterin

Alsdann hat die vorgenannte Komparentin, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als alleinige Gesellschafterin

folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
-  Herr  Nico  HANSEN,  Privatangestellter,  geboren  am  31.  März  1969  in  Differdange,  beruflich  ansässig  in  L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur,

- Frau Sophie BATARDY, Juristin, geboren am 22. Januar 1963 in Lille (Frankreich), beruflich ansässig in L-2311 Lu-

xembourg, 55-57, avenue Pasteur,

- Herr Alain BARTHOLME, Privatangestellter, geboren am 25. August 1972 in Ettelbrück, beruflich ansässig in L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

3) Herr Nico HANSEN, vorgenannt, wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.
4) Zum Delegierten des Verwaltungsrates wurde ernannt:
Herr Nico HANSEN, vorgenannt, welcher die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch seine

alleinige Unterschrift vertreten kann.

6853

L

U X E M B O U R G

5) Zum Kommisssar wird ernannt:
Die Gesellschaft MGI FISOGEST S.à r.l., mit Sitz in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen beim

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 20.114.

6) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, der Vorsitzenden des Verwaltungsrates, des Delegierten des Verwal-

tungsrates und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2016.

7) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Auftrag der Komparentin, dass

diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der Kompa-
rentin und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes ist die englische Fassung massgebend.

Woraufhin, diese notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde der Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, vorgelesen worden war, wurde sie von der

Komparentin und dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: S. BATARDY, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 08 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2126. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels-und Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 13. Dezember 2011.

Référence de publication: 2011170883/280.
(110198125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Fordale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 139.005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171646/9.
(110199851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Fordale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 139.005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171647/9.
(110199852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Fortyfifty Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.807.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171649/9.
(110199401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

RE Coatings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.775.850,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.245.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société adoptées le 7 décembre 2011

L'associé unique de la Société a décidé de révoquer Monsieur Volker Schmidt de son mandat de gérant de catégorie

B de la Société avec effet au 30 novembre 2011.

6854

L

U X E M B O U R G

L'associé unique de la Société a décidé de nommer M. Lars Thomas Blomqvist, né à Umeä (Suède) le 24 mars 1968,

demeurant professionnellement à Blasieholmsgatan 4A, 11148 Stockholm (Suède), en tant que nouveau gérant de caté-
gorie B de la Société avec effet au 30 novembre 2011 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RE Coatings S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011172630/17.
(110200992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

American European Alliance for Education S.A., Société Anonyme,

(anc. Mediterranean Investments S.A.).

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 55.322.

In the year two thousand and eleven, on the second day of November.
Before Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme")

"Mediterranean Investments S.A.", (the "Company"), with registered office in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse
Munchen, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 55.322, incor-
porated pursuant to a deed of Me Frank BADEN, then notary residing in Luxembourg, on the 11 

th

 of June 1996, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 466 of the 19 

th

 , September 1996.

The articles of incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary:
- on September 30 

th

 , 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2647 of 2

nd

 December 2010 and

- on April 1 

st

 , 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1361 of 22 

nd

 of June

2011.

The meeting is presided by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Christian ZOIS, director, residing pro-

fessionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the

following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change the name of the company to "AMERICAN EUROPEAN ALLIANCE FOR EDUCATION S.A."
2. Change the social purpose of the company in order to give it and article 2 of the articles of incorporation the

following wording:

Art. 2. The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form either in Luxembourg

or foreign organizations and companies with particular reference to educational ones and the management control and
development of such participating interests.

The company may also enter into franchise agreements of any kind or form to license the right to use trademarks that

belong to the company or that third-parties have assigned to the company to use.

The company may also design, develop, implement, deliver, acquire digital content, instructional platforms, learning

applications, smart learning environments, patents, trademarks and other rights deriving from the above and manage them
by sale, transfer, licensing and otherwise.

The company may also participate in the certification and accreditation of educational services including administration

and promotion of certification examinations in different skills including but not limited to English language competency,
information technology and company management.

The company may participate in the provision of educational services and products for life-long learning, vocational

and professional training, on-site training and e-learning,

The company may participate in the design, construction and maintenance of expert systems, knowledge repositories

and  other  databases.  It  may  also  participate  in  the  provision  of  consulting  and  advisory  management  services  in  the
educational domain and human resources, publications of books, learning material and their promotion and distribution.

The company may participate in research programs initiated by the European Union, the European Investment Bank,

the European Central Bank, the European Regional Development Fund, Europeaid and other organizations and agencies.

6855

L

U X E M B O U R G

The  company  can  participate  in  the  design,  organization  and  realization  of  cultural  events,  conferences,  visual  art

exhibitions,  workshops  and  seminars,  as  well  as  in  the  design  and  implementation  of  plans  and  programs  for  media
development.

The company may participate in the design, implementation and assessment of research studies, strategic and opera-

tional plans, institutional, regional and national policy guidelines, and systems for the development and management of
human resources.

The company may participate in the design, implementation and assessment of educational policies and strategic and

operational plans in the area of life-long learning and vocational counseling.

The company may participate in the design and assessment of policies and strategic and operational plans for promoting

employment, reducing social exclusion, managing diversity, and addressing youth unemployment as well as providing
technical support to local public state employment agencies.

The company may participate in the design and execution of studies, plans and programs for the organization, structure,

delivery and management of health care services.

The company may participate in the design, implementation and assessment of policies, plans and programs for im-

proving the effectiveness of public administration, training the public sector workforce, and furthering e-government.

The company may participate in the design and implementation of programs for local and regional development, and

of policies and programs for the enhancement of competitiveness and entrepreneurship at a local, regional and national
level.

The company may participate in the design and implementation of programs for the advancement of the less spoken

European languages.

The company may participate in the organization and implementation of educational tours, school trips, study abroad

experiences, skill-enhancement vacations, cultural tours, international practicum programs, senior-citizen tours, educa-
tional cruises and any and all other types of tourism packages and programs.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, wether by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange, or otherwise.

The company may borrow in any form and may issue bonds, debentures, or other security instruments. It may grant

assistance, loan advance or guarantee to companies in which it has an interest.

In general the company may adopt any control and supervisory measures and carry out any commercial, industrial and

financial activity which it might deem useful for the accomplishment of its purposes."

3. Statutory Appointments
4. Miscellaneous
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on

an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the company into AMERICAN EUROPEAN ALLIANCE FOR EDUCA-

TION S.A. and amend subsequently the first paragraph of article 1 

st

 of the articles of incorporation to give them the

following wording:

«  Art. 1 

st

 . (1 

st

 paragraph).  There exists a public limited company ("société anonyme") under the name of AMERICAN

EUROPEAN ALLIANCE FOR EDUCATION S.A., (hereafter referred as to the "Company").»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the corporate purpose of the company and to give article 2 of the articles of incor-

poration the following wording:

“ Art. 2. The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form either in Luxembourg

or foreign organizations and companies with particular reference to educational ones and the management control and
development of such participating interests.

6856

L

U X E M B O U R G

The company may also enter into franchise agreements of any kind or form to license the right to use trademarks that

belong to the company or that third-parties have assigned to the company to use.

The company may also design, develop, implement, deliver, acquire digital content, instructional platforms, learning

applications, smart learning environments, patents, trademarks and other rights deriving from the above and manage them
by sale, transfer, licensing and otherwise.

The company may also participate in the certification and accreditation of educational services including administration

and promotion of certification examinations in different skills including but not limited to English language competency,
information technology and company management.

The company may participate in the provision of educational services and products for life-long learning, vocational

and professional training, on-site training and e-learning,

The company may participate in the design, construction and maintenance of expert systems, knowledge repositories

and  other  databases.  It  may  also  participate  in  the  provision  of  consulting  and  advisory  management  services  in  the
educational domain and human resources, publications of books, learning material and their promotion and distribution.

The company may participate in research programs initiated by the European Union, the European Investment Bank,

the European Central Bank, the European Regional Development Fund, Europe aid and other organizations and agencies.

The  company  can  participate  in  the  design,  organization  and  realization  of  cultural  events,  conferences,  visual  art

exhibitions,  workshops  and  seminars,  as  well  as  in  the  design  and  implementation  of  plans  and  programs  for  media
development.

The company may participate in the design, implementation and assessment of research studies, strategic and opera-

tional plans, institutional, regional and national policy guidelines, and systems for the development and management of
human resources.

The company may participate in the design, implementation and assessment of educational policies and strategic and

operational plans in the area of life-long learning and vocational counseling.

The company may participate in the design and assessment of policies and strategic and operational plans for promoting

employment, reducing social exclusion, managing diversity, and addressing youth unemployment as well as providing
technical support to local public state employment agencies.

The company may participate in the design and execution of studies, plans and programs for the organization, structure,

delivery and management of health care services.

The company may participate in the design, implementation and assessment of policies, plans and programs for im-

proving the effectiveness of public administration, training the public sector workforce, and furthering egovernment.

The company may participate in the design and implementation of programs for local and regional development, and

of policies and programs for the enhancement of competitiveness and entrepreneurship at a local, regional and national
level.

The company may participate in the design and implementation of programs for the advancement of the less spoken

European languages.

The company may participate in the organization and implementation of educational tours, school trips, study abroad

experiences, skill-enhancement vacations, cultural tours, international practicum programs, senior-citizen tours, educa-
tional cruises and any and all other types of tourism packages and programs.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, wether by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange, or otherwise.

The company may borrow in any form and may issue bonds, debentures, or other security instruments. It may grant

assistance, loan advance or guarantee to companies in which it has an interest.

In general the company may adopt any control and supervisory measures and carry out any commercial, industrial and

financial activity which it might deem useful for the accomplishment of its purposes.”

<i>Third resolution

The general meeting revokes Salah SALHAB as member of the board of directors and the statutory auditor and
a.- appoints as new Member of the Board of Directors:
- Mr Jean Bernard ZEIMET, director, residing professionally in L1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
b.- confirms as Members of the Board of Directors:
(i) Bearn Holdings S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office

in Road Town, Wickhams Cay 1, Lake Building, Tortola, represented by Mr. Dimitrios ZOIS, Economist, residing pro-
fessionally at L-2172, Luxembourg, 29 Rue Alphonse Munchen.

(i) Mr. Marius KASKAS, Economist, residing at, 15, Rue de Carrefours L-8124 Bridel.
- appoints as new Statutory Auditor:
- MORATINA SERVICES Ltd having its registered office at, 30 Karpenisiou Street, P.C. 1660, Nicosia, Cyprus (HE

230792)

Their mandates will expire at the end of the annual general meeting of 2017.

6857

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at nine hundred fifty Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le deux novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Mediterranean Investments

S.A.", (ci-après dénommée la "Société"), avec siège social à L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 55.322, constituée suivant acte reçu
par Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 466 du 19 septembre 1996.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du
- 30 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2647 du 2 décembre 2010.
- 1 

er

 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1361 du 22 juin 2011.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian ZOIS, adminis-

trateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la denomination de la Société "AMERICAN EUROPEAN ALLIANCE FOR EDUCATION S.A."
2.- Modification de l'objet social et en conséquence de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés et

organisations luxembourgeoises ou étrangères avec référence particulaire dans la domaine de l'éducation, ainsi que la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également conclure des accords de franchises de toutes natures ou sous forme de licences, le droit

d'utiliser les marques qui appartiennent à la société ou celles que des tiers ont attribué à la Société.

La société peut également concevoir, développer, mettre en oeuvre, livrer, acquérir des contenus numériques, des

plates-formes pédagogiques, des applications d'apprentissage, des environnements d'apprentissage intelligents, des bre-
vets, des marques et autres droits découlant de ce qui précède, les gérer par vente, transfert, permis et autres.

La société peut également participer à la certification et l'accréditation des services éducatifs, y compris l'administration

et la promotion des examens de certification des compétences différentes, y compris mais non limité, à la compétence
linguistique en anglais, en technologie de l'information et en gestion des sociétés.

La société peut participer à la fourniture de services et de produits éducatifs pour l'apprentissage continu, la formation

technique et professionnelle, la formation sur site et sur internet.

La société peut participer à la conception, la construction et l'entretien des systèmes experts, les référentiels de

connaissances et d'autres bases de données. Elle peut également participer à la fourniture de services de conseil en gestion
et de conseil dans le domaine de l'éducation et les ressources humaines, des publications de livres, de matériel d'appren-
tissage et de promotion et de distribution.

La société peut participer à des programmes de recherche initiés par l'Union Européenne, la Banque Européenne

d'Investissement, la Banque Centrale Européenne, le Fonds Européen de Développement Régional, l'Aide en Europe et
d'autres organisations et agences.

La société peut participer à la conception, l'organisation et la réalisation des événements culturels, des conférences,

des expositions d'arts visuels, des ateliers et des séminaires, ainsi que dans la conception et la mise en oeuvre des plans
et des programmes de développement des médias.

6858

L

U X E M B O U R G

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des études de recherche, de plans straté-

giques  et  opérationnels,  d'orientations  politiques  institutionnelles,  régionales  et  nationales,  et  de  systèmes  pour  le
développement et la gestion des ressources humaines.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques éducatives et des plans

stratégiques et opérationnels dans le domaine de l'apprentissage continu et d'orientation professionnelle.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques éducatives et des plans

stratégiques et opérationnels pour la promotion de l'emploi, réduire les inégalités sociales, l'exclusion, la gestion de la
diversité et lutter contre le chômage des jeunes ainsi que l'appui technique aux agences publiques locales de l'emploi.

La société peut participer à la conception et l'exécution des études, des plans et des programmes de l'organisation,

de la structure, de la prestation et de la gestion des services de soins de santé.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques, des plans et des programmes

pour améliorer l'efficacité de l'administration publique, la formation des effectifs du secteur public, et promouvoir l'e-
gouvernement.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre des programmes et politiques de développement local et

régional pour améliorer la compétitivité et l'entreprenariat au niveau local, régional et national.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre de programmes pour la promotion des langues euro-

péennes moins parlées.

La société peut participer à l'organisation et la mise en oeuvre des visites éducatives, des voyages scolaires, des ex-

périences d'étude à l'étranger, des vacances pour améliorer les compétences, des visites culturelles, des programmes de
stage internationaux, des circuits pour les seniors, des croisières éducatives et tous les autres types de packages et les
programmes touristiques.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également
acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société
peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts,
avances ou garanties. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement
quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent.»

3. Nominations statutaires
4. Divers
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en AMERICAN EUROPEAN ALLIANCE FOR EDUCA-

TION S.A. et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . (1 

er

 alinéa).  Il existe une société anonyme sous la dénomination de AMERICAN EUROPEAN ALLIANCE

FOR EDUCATION S.A., (ci-après dénommée la "Société")»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 2 des statuts la teneur suivante:

« Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés et

organisations luxembourgeoises ou étrangères avec référence particulaire dans la domaine de l'éducation, ainsi que la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également conclure des accords de franchises de toutes natures ou sous forme de licences, le droit

d'utiliser les marques qui appartiennent à la société ou celles que des tiers ont attribué à la Société.

La société peut également concevoir, développer, mettre en oeuvre, livrer, acquérir des contenus numériques, des

plates-formes pédagogiques, des applications d'apprentissage, des environnements d'apprentissage intelligents, des bre-
vets, des marques et autres droits découlant de ce qui précède, les gérer par vente, transfert, permis et autres.

6859

L

U X E M B O U R G

La société peut également participer à la certification et l'accréditation des services éducatifs, y compris l'administration

et la promotion des examens de certification des compétences différentes, y compris mais non limité, à la compétence
linguistique en anglais, en technologie de l'information et en gestion des sociétés.

La société peut participer à la fourniture de services et de produits éducatifs pour l'apprentissage continu, la formation

technique et professionnelle, la formation sur site et sur internet.

La société peut participer à la conception, la construction et l'entretien des systèmes experts, les référentiels de

connaissances et d'autres bases de données. Elle peut également participer à la fourniture de services de conseil en gestion
et de conseil dans le domaine de l'éducation et les ressources humaines, des publications de livres, de matériel d'appren-
tissage et de promotion et de distribution.

La société peut participer à des programmes de recherche initiés par l'Union Européenne, la Banque Européenne

d'Investissement, la Banque Centrale Européenne, le Fonds Européen de Développement Régional, l'Aide en Europe et
d'autres organisations et agences.

La société peut participer à la conception, l'organisation et la réalisation des événements culturels, des conférences,

des expositions d'arts visuels, des ateliers et des séminaires, ainsi que dans la conception et la mise en oeuvre des plans
et des programmes de développement des médias.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des études de recherche, de plans straté-

giques  et  opérationnels,  d'orientations  politiques  institutionnelles,  régionales  et  nationales,  et  de  systèmes  pour  le
développement et la gestion des ressources humaines.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques éducatives et des plans

stratégiques et opérationnels dans le domaine de l'apprentissage continu et d'orientation professionnelle.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques éducatives et des plans

stratégiques et opérationnels pour la promotion de l'emploi, réduire les inégalités sociales, l'exclusion, la gestion de la
diversité et lutter contre le chômage des jeunes ainsi que l'appui technique aux agences publiques locales de l'emploi.

La société peut participer à la conception et l'exécution des études, des plans et des programmes de l'organisation,

de la structure, de la prestation et de la gestion des services de soins de santé.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques, des plans et des programmes

pour améliorer l'efficacité de l'administration publique, la formation des effectifs du secteur public, et promouvoir l'e-
gouvernement.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre des programmes et politiques de développement local et

régional pour améliorer la compétitivité et l'entreprenariat au niveau local, régional et national.

La société peut participer à la conception, la mise en oeuvre de programmes pour la promotion des langues euro-

péennes moins parlées.

La société peut participer à l'organisation et la mise en oeuvre des visites éducatives, des voyages scolaires, des ex-

périences d'étude à l'étranger, des vacances pour améliorer les compétences, des visites culturelles, des programmes de
stage internationaux, des circuits pour les seniors, des croisières éducatives et tous les autres types de packages et les
programmes touristiques.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également
acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société
peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts,
avances ou garanties. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement
quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale révoque Salah SALHAB de sa fonctions de membre du Conseil d'administration et le commissaire

aux comptes et

a.- nomme comme nouveau Membre du Conseil d'Administration:
- Mr Jean Bernard ZEIMET, directeur, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince

Henri.

b.- confirme aux fonctions de Membres du Conseil d'Administration:
(i) Bearn Holdings S.A., une société existant et gouvernée par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à Road Town, Wickhams Cay 1, Lake Building, Tortola, représentée par Mr. Dimitrios ZOIS, économiste, demeu-
rant professionnellement à L-2172, Luxembourg, 29, Rue Alphonse Munchen.

(i) Mr. Marius KASKAS, économiste, demeurant au 15, Rue de Carrefours à L-8124 Bridel.
- nomme à la fonctions de Commissaire aux Comptes:
- MORATINA SERVICES Ltd, ayant son siège social à 30, Karpenisiou Street, P.C. 1660, Nicosia, Cyprus (HE 230792)
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

6860

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 novembre 2011. Relation GRE/2011/3986. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 18 novembre 2011.

Référence de publication: 2011170857/341.
(110198042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Frecolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 17.329.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171651/9.
(110199406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Future Brands Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 117.185.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011171655/10.
(110200247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Halliba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 70.450.

EXTRAIT

Avec effet au 1 

er

 janvier 2011, la société FGS Consulting LLC. a donné sa démission en tant que commissaire aux

comptes de la société HALLIBA S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 70450.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

FGS Consulting LLC
Signature

Référence de publication: 2011172478/15.
(110200845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

6861

L

U X E M B O U R G

GeMoBa, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7463 Pettingen, 8, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 100.725.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011171658/10.
(110200274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Gläsener Transports S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

R.C.S. Luxembourg B 139.944.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Stadtbredimus, 15.11.2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011171659/10.
(110199675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Goreway Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.084.600,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 113.425.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171662/10.
(110200204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Greenwich Data (Rochester) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 151.986.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2011171663/11.
(110199425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Gasherbrun 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.989.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011171665/13.
(110200065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

6862

L

U X E M B O U R G

ProLogis UK XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.894.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 13 decembre 2011 sept cents cinquante (750) parts sociales détenues dans la

Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis European Finance XVI Sàrl ont étés transférées à ProLogis UK XXXVII
Sàrl ayant son siège social à 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Cette cession des parts sociales a été
approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:
Repartitions des parts sociales:

ProLogis UK XXXVII Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts sociales

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gerrit Jan Meerkerk
<i>Gérant

Référence de publication: 2011172891/20.
(110200864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Gateway Telecom, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 108.584.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011171666/10.
(110199823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Gelustok SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue J.-P. Michels.

R.C.S. Luxembourg B 108.551.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011171667/10.
(110199014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Halliba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 70.450.

EXTRAIT

Avec effet au 1 

er

 janvier 2011, la société Luxembourg Management Services S.à.r.l. a donné sa démission en tant

qu'administrateur de la société HALLIBA S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 70450.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Luxembourg Management Services S.à.r.l
Signature

Référence de publication: 2011172479/15.
(110200846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

6863

L

U X E M B O U R G

Gestion pour Décharges et Carrières S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7738 Colmar-Berg, rue de Cruchten.

R.C.S. Luxembourg B 100.401.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le gérant

Référence de publication: 2011171669/10.
(110199682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Gimo Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 92.690.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171670/9.
(110200088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Global Assurance S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 39, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 56.209.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2011.

Natacha Hainaux.

Référence de publication: 2011171671/10.
(110199460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

GM Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 152.285.

Les comptes annuels pour la période du 9 mars 2010 (date d’incorporation) au 31 décembre 2010 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171673/11.
(110200096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Gravilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 136.976.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GRAVILUX S.A.

Référence de publication: 2011171675/10.
(110199371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

6864


Document Outline

ABH Holdings S.A.

Allianz Finance VIII Luxembourg S.à r.l.

American European Alliance for Education S.A.

Boscolo International S.A.

Cerac Finance I S.à r.l.

DIH/HMD Investco S.à r.l.

Ferges S.A.

Festivo International S.à r.l.

Fideurope

Financière de Vauban S.A.

Financière Dube S.A.

Financière Leka S.A.

F.Int. S.A.

Finzels Reach Capital S.à r.l.

Floreanville Investholding S.à r.l.

Foncière de l'Europe S.A.

Fordale S.A.

Fordale S.A.

Fordale S.A.

Form &amp; Design S.à r.l.

Fortyfifty Investholding S.à r.l.

Frecolux S.A.

Future Brands Sàrl

Gasherbrun 2 S.A.

Gateway Telecom

Gecomat S.A.

Gelustok SA

GeMoBa

Gestion pour Décharges et Carrières S.à r.l.

Gimo Invest S.A.

Gläsener Transports S. à r. l.

Global Assurance S.A.

Global Metall, S.à r.l.

Global Metall, S.à r.l.

GM Management S.à r.l.

Goreway Luxembourg Holdings S.à r.l.

Gosdorf S.à r.l.

Gravilux S.A.

Greenwich Data (Rochester) S.à r.l.

Halliba S.A.

Halliba S.A.

Heart (Luxembourg) S.à r.l.

King Charter S.A.

L'Orchidea S.à.r.l.

Luxon S.A.

Mediterranean Investments S.A.

Merlin Entertainments Group Luxembourg 3 S.à r.l.

NDX Market S.A.

Neo Invest Sàrl

Nova Technologies S.A.

OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) S.à r.l.

ProLogis UK X S.àr.l.

ProLogis UK XV S.à r.l.

RE Car Parts S.à r.l.

RE Coatings S.à r.l.

San José Immobilien S.A.

Stores Concept S.à r.l.

Sun Life (Luxembourg) Finance No. 2 Sàrl

THEOLIA Utilities Investment Company S.A.

Winsway Coking Coal Holdings