logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1557

30 juillet 2010

SOMMAIRE

Air Terminal Publicity Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74718

A Klosen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74724

Atraxis Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

74725

Atrio S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74726

Avestus Real Estate (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74724

Axel Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74725

AxoGlia Therapeutics S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

74732

Belrose Properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74717

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74705

Cargill International Luxembourg 7 S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74705

Carnaz Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

74725

Cheval Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

74719

ChipPAC Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

74719

CMH Vertriebs Service I GmbH  . . . . . . . . .

74690

CMH Vertriebs Service I GmbH & Co KG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74694

Cobelfret Waterways S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

74713

Colux Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

74713

cominvest Best-in-One  . . . . . . . . . . . . . . . . .

74710

Dexia Banque Internationale à Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74721

Euro Floor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74705

Eurotruck (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .

74728

FBP Funds Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74720

F&C Management Luxembourg S.A. . . . . .

74723

FHFA Center II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74724

Financière E2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74698

Financière Figaro S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

74698

FinSole S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74714

Gebi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74720

Inhalux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74735

Kalos International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

74721

Kaupthing Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74713

Kerafin Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74722

KNEIP Fund Distribution Support S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74733

Kronospan Luxembourg Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74721

Lola Luxembourg Manager S.à r.l.  . . . . . . .

74718

Lombard Fund Services S.à r.l.  . . . . . . . . . .

74733

Mare Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74730

Mediapart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74716

Mediterranean Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

74719

Metro Investment Luxembourg S.à r.l. . . .

74711

Novalis Real Estate Holding  . . . . . . . . . . . . .

74730

Paramédical et Sécurité en abrégé P.E.S.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74715

Pecundria S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74726

Pimco Emerging Markets Funds  . . . . . . . . .

74722

Portalis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74716

Presto Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74722

Pygmalux Development S.A.  . . . . . . . . . . . .

74727

QSpace SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74731

Quinlan Private Golub (Luxembourg) S.à.

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74724

Recherche et Investissements Internatio-

naux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74717

Remora Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

74720

Resma (Restaurant Management) S.A.  . . .

74730

RINNEN Constructions Générales S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74730

Rossa Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74736

R.S. Construction s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

74714

Smart Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74717

Sun Sea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74723

Threadneedle Asset Management Hol-

dings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74718

TMCZ Holdco II (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

74722

Top Tone Media S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74723

VSP Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74701

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l.  . . . . . .

74723

Zopal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74724

74689

L

U X E M B O U R G

CMH Vertriebs Service I GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.850.

In the year two thousand and ten, on the nineteenth day of July.
Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

VSP Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée – Gesellschaft mit beschränkter Haftung governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with
registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 93.751 (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Me Marc LOESCH, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 19 July 2010

annexed to the present deed.

Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, shall be annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of "CMH Vertriebs Service I GmbH", a société à responsabilité limitée –

Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
with a share capital of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-), having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,
under number B 93.850 and incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand
Duchy of Luxembourg, of 14 May 2003, published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, number 694
of 2 July 2003 (the "Company").

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the under-

signed notary, on 20 May 2010, published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, number 1433 of 13
July 2010.

(i) The appearing party, represented as mentioned above, has recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To hear an explanatory report from the board of managers of the Company concerning the proposed merger of

the Company.

2. To approve the joint merger proposal between the Company, CMH Vertriebs Service I GmbH &amp; Co KG, a société

en commandite simple – Kommanditgesellschaft governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 93.763 (“CMH VS I GmbH &amp; Co KG”), as absorbed companies
and VSP Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée – Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500.-), having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 93.751, as absorbing com-
pany (the “Absorbing Company”), pursuant to which the Company and CMH VS I GmbH &amp; Co KG will be absorbed by
the Absorbing Company by contribution from the Company and CMH VS I GmbH &amp; Co KG to the Absorbing Company
of the universality of their current assets and liabilities, without any restriction or limitation, for no consideration and
with effect as of the date on which the merger will be effective and pursuant to which the Absorbing Company will assume
all of the liabilities of the Company and of CMH VS I GmbH &amp; Co KG, perform all of their commitments and obligations,
pay and bear all of the costs, taxes and expenses of any kind resulting from the merger.

3. To delegate powers.
4. To acknowledge that the Company is dissolved without liquidation.
5. Miscellaneous.
(ii) The undersigned notary confirms that:
(a) a joint merger proposal has been drawn up by the board of managers of the Company, the General Partner of

CMH VS I GmbH &amp; Co KG and the sole manager of the Absorbing Company on 31 May 2010; such merger proposal has
been published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations number 1251 of 16 June 2010, i.e. at least one
month before the date of the present resolutions of the Sole Shareholder.

(b) an explanatory report (the “Company Explanatory Report”) has been drawn up by the board of managers of the

Company on 31 May 2010 describing the reasons for the merger, the anticipated consequences for the respective activities
of the Company, CMH VS I GmbH &amp; Co KG and of the Absorbing Company and any legal, economic and social related
implications of the merger.

74690

L

U X E M B O U R G

(c) an explanatory report has also been drawn up by the General Partner of CMH VS I GmbH &amp; Co KG and the sole

manager of the Absorbing Company on 31 May 2010.

(d) on 20 May 2010, the Sole Shareholder of the Company and the shareholders of CMH VS I GmbH &amp; Co KG and

of the Company resolved to waive, pursuant to article 266(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (“LCC”), the written auditors' report (rapport écrit destiné aux associés).

(e) the respective documents required pursuant to article 267 of the LCC have been deposited at the registered office

of the Company, CMH VS I GmbH &amp; Co KG and of the Absorbing Company for inspection by the shareholders and
those persons having special rights against the Company, CMH VS I GmbH &amp; Co KG and the Absorbing Company, at
least one month prior to the date of the present resolutions and the general meeting of shareholders of CMH VS I GmbH
&amp; Co KG and of the Absorbing Company.

(f) the merger will become effective vis-à-vis third parties as at the date of publication of the resolutions of the Sole

Shareholder of the Company approving the merger in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, which
publication shall take place on 30 July 2010. For accounting purposes, the assets and liabilities of the Company shall be
deemed transferred to the Absorbing Company as from the 31 May 2010.

(iii) The appearing person mentioned above, presented the Company Explanatory Report to the undersigned notary.
A copy of the Company Explanatory Report after having been signed «ne varietur» by the appearing person and the

undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

(iv) Thereupon, the appearing person requested the notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to acknowledge the explanatory report of the board of managers of the Company

concerning the proposed merger of the Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to approve the joint merger proposal between the Company, CMH VS I GmbH &amp; Co

KG, as absorbed companies, and the Absorbing Company, pursuant to which the Company and CMH VS I GmbH &amp; Co
KG will be absorbed by the Absorbing Company by contribution from the Company and CMH VS I GmbH &amp; Co KG to
the Absorbing Company of the universality of their current assets and liabilities, without any restriction or limitation, for
no consideration and with effect as of the date on which the merger will be effective and pursuant to which the Absorbing
Company will assume all of the liabilities of the Company and CMH VS I GmbH &amp; Co KG, perform all of their commitments
and obligations, pay and bear all of the costs, taxes and expenses of any kind resulting from the merger.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to delegate the power to Mrs Victoria Karran, corporate secretary, with professional

address at Clerical Medical House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM99 1LT, acting and signing individually, with full
power of substitution, on behalf and in the name of the Company, to do all acts and things as she in her absolute and
unfettered discretion deems necessary or advisable for the purpose of implementing the foregoing resolutions and to (i)
transfer to the Absorbing Company the universality of the assets and liabilities of the Company (ii) file the merger of the
Company with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and (iii) carry out any other formalities or other
actions, including tax filings, that would be necessary in relation to the merger of the Company.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to acknowledge that the Company is dissolved without liquidation.

<i>Declaration

In  accordance  with  Article  271  (2)  of  the  LCC,  the  undersigned  notary  declares  having  verified  and  certifies  the

existence and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to
render the merger effective.

The merger of the Company into the Absorbing Company will become effective vis-à-vis third parties as at the date

of publication of the present deed in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations which publication shall take
place on 30 July 2010. For accounting purposes, the assets and liabilities of the Company shall be deemed transferred to
the Absorbing Company as from the 31 May 2010.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated

approximately at two thousand four hundred euro (EUR 2,400.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the English text and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

74691

L

U X E M B O U R G

This deed having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their name, surname,

occupation and residence, said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzehn, am neunzehnten Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Edouard Delosch, mit dem Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

VSP Holdings S.à r.l., eine société à responsabilité limitée – Gesellschaft mit beschränkter Haftung, luxemburgischem

Recht unterworfen, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) mit Sitz in 40, Avenue
Monterey,  L-2163  Luxemburg,  Großherzogtum  Luxemburg,  eingetragen  beim  Handelsregister  Luxemburg  unter  der
Nummer B 93.751 (der „Alleinige Gesellschafter“).

vertreten durch Maître Marc LOESCH, Rechtsanwalt mit Wohnsitz in Luxemburg, kraft der am 19. Juli 2010 erteilten

Vollmacht.

Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet

wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei ist die Alleingesellschafterin von „CMH Vertriebs Service I GmbH“, einer société à responsa-

bilité limitée - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000),-, mit Sitz in 40, Avenue Monterey,
L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer
B 93.850, und gegründet durch Urkunde von Notar Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sanem, Großherzogtum
Luxemburg, vom 14. Mai 2003, veröffentlicht im Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 694 vom
2. Juli 2003 (die „Gesellschaft“).

Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des amtierenden Notars vom

20. Mai 2010, veröffentlicht im Memorial C - Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1433 vom 13. Juli 2010.

(i) Die erschienen Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärt, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der

folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

<i>Tagesordnung

1. Anhörung des erklärenden Berichts der Geschäftsführung der Gesellschaft über die vorgeschlagene Verschmelzung

der Gesellschaft;

2. Genehmigung des gemeinsamen Verschmelzungsplans zwischen der Gesellschaft, CMH Vertriebs Service I GmbH

&amp; CoKG, eine société en commandite simple (Kommanditgesellschaft), gegründet und bestehend nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und
eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.763 als übernommene Gesellschaften (die „Über-
nommenen Gesellschaften“), und VSP Holdings S.à r.l., eine société à responsabilité limité - Gesellschaft mit beschränkter
Haftung - gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500),-, mit Sitz in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, und eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.751, als übernehmender Gesell-
schaft (die „Übernehmende Gesellschaft“) wonach die Gesellschaft und CMH VS I GmbH &amp; CoKG durch die Überneh-
mende Gesellschaft absorbiert werden, durch Einbringung von der Gesellschaft und CMH VS I GmbH &amp; CoKG an die
Übernehmende  Gesellschaft von der  Gesamtheit ihrer  derzeitigen Aktiva  und  Passiva,  ohne  Einschränkung  oder  Be-
schränkung, ohne Gegenleistung und mit Wirkung ab dem Datum ab dem die Verschmelzung wirksam sein wird und
wonach die Übernehmende Gesellschaft alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft und von CMH VS I GmbH &amp; CoKG
übernehmen, alle ihre Verpflichtungen und Obligationen und alle Kosten, Steuern und Ausgaben jedweder Art die sich
aus der Verschmelzung ergeben, begleichen wird.

3. Erteilung von Vollmacht.
4. Anerkennung, dass die Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst wird.
5. Verschiedenes.
(ii) Der Notar bestätigt dass:
(a) ein gemeinsamer Verschmelzungsplan wurde von der Geschäftsführung der Gesellschaft, dem geschäftsführenden

Komplementär von CMH VS I GmbH &amp; CoKG und dem einzigen Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft am
31. Mai 2010 erstellt; dieser Verschmelzungsplan wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer
1251 vom 16. Juni 2010, d.h. mindestens einen Monat vor dem Datum dieser Beschlüsse, veröffentlicht.

(b) Ein erklärender Bericht (der „Erklärende Bericht“) wurde am 31. Mai 2010 durch die Geschäftsführung der Ge-

sellschaft  erstellt,  der  die  Gründe  für  die  Verschmelzung,  die  voraussichtlichen  Folgen  für  die  Geschäftstätigkeit  der
Gesellschaft, CMH VS I GmbH &amp; CoKG und der Übernehmen Gesellschaft und alle juristischen, ökonomischen und
sozialen Auswirkungen der Verschmelzung beschrieben hat.

(c) Ein erklärender Bericht wurde ebenfalls vom geschäftsführenden Komplementär von CMH VS I GmbH &amp; CoKG

und dem alleinigen Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft am 31. Mai 2010 erstellt.

74692

L

U X E M B O U R G

(d) Am 20. Mai 2010 haben der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft und die Gesellschafter von CMH VS I GmbH

&amp; CoKG und der Gesellschaft beschlossen, gemäß Artikel 266 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften, in seiner geltenden Fassung („GüH“) auf den schriftlichen Prüfbericht (rapport écrit destiné aux associés) zu
verzichten.

(e) Die jeweils gemäß Artikel 267 GüH benötigten Dokumente wurden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, CMH

VS I GmbH &amp; CoKG und der Übernehmenden Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Gesellschafter und durch Per-
sonen, die spezielle Rechte gegen die Gesellschaft, CMH VS I GmbH &amp; CoKG und die Übernehmende Gesellschaft haben,
mindestens einen Monat vor dem Datum dieser Beschlüsse und der Generalversammlung der Gesellschafter von CMH
VS I GmbH &amp; CoKG und der Übernehmenden Gesellschaft.

(f) Die Verschmelzung wird Dritten gegenüber wirksam am Tag der Veröffentlichung der Beschlüsse des Alleinigen

Gesellschafters im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, die am 30. Juli 2010 erfolgen soll. Aus buchhalteri-
scher  Sicht  gelten  die  Aktiva  und  Passiva  der  Gesellschaft  mit  Wirkung  zum  31.  Mai  2010,  als  auf  die  Gesellschaft
übertragen.

(h) Die oben erwähnte erschienene Person hat den Erklärenden Bericht dem Notar vorgelegt.
Eine Kopie des Erklärenden Berichts, nach Unterschrift „ne varietur“ durch die erschienene Person und den unter-

zeichneten Notar, wird dieser Urkunde beigefügt um mit dieser einregistriert zu werden.

(i) Daraufhin hat die erschienene Person den unterzeichneten Notar gebeten, folgende Beschlüsse aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, den erklärenden Berichts der Geschäftsführung über die vorgeschlagene

Verschmelzung der Gesellschaft anzuerkennen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, den gemeinsamen Verschmelzungsplan zwischen der Gesellschaft, CMH

VS I GmbH &amp; CoKG, als Übernommenen Gesellschaften, zu genehmigen, wonach die Gesellschaft und CMH VS I GmbH
&amp; CoKG durch die Übernehmende Gesellschaft absorbiert werden, durch Einbringung durch die Gesellschaft und CMH
VS I GmbH &amp; CoKG der Gesamtheit ihrer derzeitigen Aktiva und Passiva, ohne Einschränkung oder Beschränkung, ohne
Gegenleistung und mit Wirkung ab dem Datum ab dem die Verschmelzung wirksam sein wird und wonach die Überneh-
mende Gesellschaft alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft und CMH VS I GmbH &amp; CoKG, übernehmen und alle ihre
Verpflichtungen und Obligationen und alle Kosten, Steuern und Ausgaben jedweder Art die sich aus der Verschmelzung
ergeben, begleichen wird.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, Vollmacht zu erteilen an Frau Victoria Karran, Corporate Secretary, mit

beruflicher Anschrift in Clerical Medical House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM99 1LT, allein handelnd und zeich-
nend, mit Berechtigung zur Substitution, für und im Namen der Gesellschaft alle Maßnahmen zu treffen, die sie nach ihrem
alleinigen Ermessen für notwendig oder ratsam hält um die obenstehenden Beschlüsse umzusetzen und (i) auf die Über-
nehmende Gesellschaft die Gesamtheit aller Aktiva und Passiva zu übertragen, (ii) die Verschmelzung der Gesellschaft
beim luxemburgischen Handelsregister einzutragen und (iii) alle sonstigen Formalitäten oder Maßnahmen durchzuführen,
einschließlich Steuererklärungen, die im Zusammenhang mit der Verschmelzung notwendig sind.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt anzuerkennen, dass die Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst wird.

<i>Erklärung

In Übereinstimmung mit Artikel 271 (2) des GüH erklärt der unterzeichnete Notar, dass er die Existenz und Wirk-

samkeit, nach Luxemburgischem Recht, aller rechtlichen Maßnahmen und Formalitäten, die der Gesellschaft obliegen, um
die Verschmelzung wirksam werden zu lassen.

Die Verschmelzung der Gesellschaft in die Übernehmende Gesellschaft wird Dritten gegenüber wirksam am Tag der

Veröffentlichung der Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, die
am 30. Juli 2010 erfolgen soll. Aus buchhalterischer Sicht gelten die Aktiva und Passiva der Gesellschaft mit Wirkung zum
31. Mai 2010, als auf die Übernehmende Gesellschaft übertragen.

<i>Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf zwei tausend vier hundert Euro (EUR 2.400.-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten

Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

74693

L

U X E M B O U R G

Woraufhin, vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-

nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Loesch, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 20 juillet 2010. Relation: RED/2010/953. Reçu soixante-quinze (75,-) euros

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 21. Juli 2010.

Référence de publication: 2010097275/234.
(100109500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.

CMH Vertriebs Service I GmbH &amp; Co KG, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.763.

In the year two thousand and ten, on the nineteenth day of July.
Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

VSP Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée – Gesellschaft mit beschränkter Haftung governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with
registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 93.751 (the “Shareholder”),

hereby represented by Me Marc LOESCH, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 19 July 2010

annexed to the present deed.

Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, shall be annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is, following the merger of the Company's general partner CMH Vertriebs Service I GmbH, a

société à responsabilité limitée – Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-), having its registered office at
40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 93.850 (“CMH VS I GmbH”) with the Shareholder on the 19 July 2010, the
owner of the parts d'associé commandité and the parts d'associé commanditaire of the Company and consequently the
sole shareholder of "CMH Vertriebs Service I GmbH &amp; Co KG", a société en commandite simple – Kommanditgesellschaft
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies, under number B 93.763 and incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing
in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 14 May 2003, published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 675 of 27 June 2003 (the "Company").

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the under-

signed notary, on 20 May 2010, not yet published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations.

(i) The appearing party, represented as mentioned above, has recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To hear an explanatory report from the General Partner of the Company concerning the proposed merger of the

Company.

2. To approve the joint merger proposal between the Company, CMH Vertriebs Service I GmbH, as absorbed com-

panies and VSP Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée – Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 93.751, as absorbing
company (the “Absorbing Company”), pursuant to which the Company and CMH VS I GmbH will be absorbed by the
Absorbing Company by contribution from the Company and CMH VS I GmbH to the Absorbing Company of the uni-
versality of their current assets and liabilities, without any restriction or limitation, for no consideration and with effect
as of the date on which the merger will be effective and pursuant to which the Absorbing Company will assume all of the

74694

L

U X E M B O U R G

liabilities of the Company and of CMH VS I GmbH, perform all of their commitments and obligations, pay and bear all of
the costs, taxes and expenses of any kind resulting from the merger.

3. To delegate powers.
4. To acknowledge that the Company is dissolved without liquidation.
5. Miscellaneous.
(ii) The undersigned notary confirms that:
(a) a joint merger proposal has been drawn up by the General Partner of the Company, the board of managers of

CMH VS I GmbH and the sole manager of the Absorbing Company on 31 May 2010; such merger proposal has been
published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations number 1251 of 16 June 2010, i.e. at least one month
before the date of the present resolutions of the Shareholder.

(b) an explanatory report (the “Company's Explanatory Report”) has been drawn up by the General Partner of the

Company on 31 May 2010 describing the reasons for the merger, the anticipated consequences for the respective activities
of the Company, CMH VS I GmbH and of the Absorbing Company and any legal, economic and social related implications
of the merger.

(c) an explanatory report has also been drawn up by the board of managers of CMH VS I GmbH and the sole manager

of the Absorbing Company on 31 May 2010.

(d) on 20 May 2010, the shareholders of the Company, CMH VS I GmbH &amp; Co KG and of the Company resolved to

waive, pursuant to article 266(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (“LCC”), the
written auditors' report (rapport écrit destiné aux associés).

(e) the respective documents required pursuant to article 267 of the LCC have been deposited at the registered office

of the Company, CMH VS I GmbH and of the Absorbing Company for inspection by the shareholders and those persons
having special rights against the Company, CMH VS I GmbH and the Absorbing Company, at least one month prior to
the date of the present resolutions and the general meeting of shareholders of CMH VS I GmbH and of the Absorbing
Company.

(f) the merger will become effective vis-à-vis third parties as at the date of publication of the resolutions of the Sha-

reholder of the Company approving the merger in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, which publication
shall take place on 30 July 2010. For accounting purposes, the assets and liabilities of the Company shall be deemed
transferred to the Absorbing Company as from the 31 May 2010.

(iii) The appearing person mentioned above, presented the Company Explanatory Report to the undersigned notary.
A copy of the Company Explanatory Report after having been signed «ne varietur» by the appearing person and the

undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

(iv) Thereupon, the appearing person requested the notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to acknowledge the explanatory report of the General Partner of the Company concerning

the proposed merger of the Company.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to approve the joint merger proposal between the Company, CMH VS I GmbH, as absorbed

companies, and the Absorbing Company, pursuant to which the Company and CMH VS I GmbH will be absorbed by the
Absorbing Company by contribution from the Company and CMH VS I GmbH to the Absorbing Company of the uni-
versality of their current assets and liabilities, without any restriction or limitation, for no consideration and with effect
as of the date on which the merger will be effective and pursuant to which the Absorbing Company will assume all of the
liabilities of the Company and CMH VS I GmbH, perform all of their commitments and obligations, pay and bear all of
the costs, taxes and expenses of any kind resulting from the merger.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to delegate the power to Mrs Victoria Karran, corporate secretary, with professional ad-

dress at Clerical Medical House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM99 1LT, acting and signing individually, with full
power of substitution, on behalf and in the name of the Company, to do all acts and things as she in her absolute and
unfettered discretion deems necessary or advisable for the purpose of implementing the foregoing resolutions and to (i)
transfer to the Absorbing Company the universality of the assets and liabilities of the Company (ii) file the merger of the
Company with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and (iii) carry out any other formalities or other
actions, including tax filings, that would be necessary in relation to the merger of the Company.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to acknowledge that the Company is dissolved without liquidation.

74695

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

In  accordance  with  Article  271  (2)  of  the  LCC,  the  undersigned  notary  declares  having  verified  and  certifies  the

existence and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to
render the merger effective.

The merger of the Company into the Absorbing Company will become effective vis-à-vis third parties as at the date

of publication of the present deed in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations which publication shall take
place on 30 July 2010. For accounting purposes, the assets and liabilities of the Company shall be deemed transferred to
the Absorbing Company as from the 31 May 2010.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated

approximately at two thousand four hundred euro (EUR 2,400.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the English text and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their name, surname,

occupation and residence, said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzehn, am neunzehnten Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Edouard Delosch, mit dem Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

VSP Holdings S.à r.l., eine société à responsabilité limitee – Gesellschaft mit beschränkter Haftung, luxemburgischem

Recht unterworfen, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) mit Sitz in 40, Avenue
Monterey,  L-2163  Luxemburg,  Großherzogtum  Luxemburg,  eingetragen  beim  Handelsregister  Luxemburg  unter  der
Nummer B 93.751 (der „Gesellschafter“).

vertreten durch Maître Marc LOESCH, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in Luxemburg, kraft der am 19. Juli 2010 erteilten

Vollmacht.

Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet

wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei ist, in Folge der Verschmelzung des geschäftsführenden Komplementärs der Gesellschaft, CMH

Vertriebs Service I GmbH“, einer société à responsabilité limité - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von fünfzehntausend Euro
(EUR 15.000),-, mit Sitz in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen beim
Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.850 („CMH VS I GmbH“) mit dem Gesellschafter am 19. Juli 2010
Eigentümerin der Komplementäranteile und der Kommanditanteile der Gesellschaft und folglich der alleinige Gesell-
schafter von „CMH Vertriebs Service I GmbH &amp; CoKG“, einer Kommanditgesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz
in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg
unter der Nummer B 93.763 und gegründet durch Urkunde von Notar Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sanem,
Großherzogtum Luxemburg, vom 14. Mai 2003, veröffentlicht im Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 675 vom 27. Juni 2003 (die „Gesellschaft“).

Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des amtierenden Notars vom

20 Mai 2010, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(i) Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärt, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der

folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

<i>Tagesordnung

1. Anhörung des erklärenden Berichts des geschäftsführenden Komplementärs der Gesellschaft über die vorgeschla-

gene Verschmelzung der Gesellschaft;

2. Genehmigung des gemeinsamen Verschmelzungsplans zwischen der Gesellschaft, CMH Vertriebs Service I GmbH

&amp; CoKG, als übernommene Gesellschaften (die „Übernommenen Gesellschaften“), und VSP Holdings S.à r.l., eine société
à responsabilité limitée - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - gegründet und bestehend nach dem Recht des Groß-
herzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500),-, mit Sitz in 40,
Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen beim Handelsregister Luxemburg
unter der Nummer B 93.751, als übernehmender Gesellschaft (die „Übernehmende Gesellschaft“) wonach die Gesell-
schaft  und  CMH  VS  I  GmbH  durch  die  Übernehmende  Gesellschaft  absorbiert  werden,  durch  Einbringung  von  der
Gesellschaft und CMH VS I GmbH an die Übernehmende Gesellschaft von der Gesamtheit ihrer derzeitigen Aktiva und
Passiva, ohne Einschränkung oder Beschränkung, ohne Gegenleistung und mit Wirkung ab dem Datum ab dem die Ver-

74696

L

U X E M B O U R G

schmelzung wirksam sein wird und wonach die Übernehmende Gesellschaft alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft und
von CMH VS I GmbH übernehmen, alle ihre Verpflichtungen und Obligationen und alle Kosten, Steuern und Ausgaben
jedweder Art die sich aus der Verschmelzung ergeben, begleichen wird.

3. Erteilung von Vollmacht.
4. Anerkennung, dass die Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst wird.
5. Verschiedenes.
(ii) Der Notar bestätigt dass:
(a) ein gemeinsamer Verschmelzungsplan wurde von dem geschäftsführenden Komplementär der Gesellschaft, der

Geschäftsführung von CMH VS I GmbH und dem einzigen Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft am 31. Mai
2010 erstellt; dieser Verschmelzungsplan wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1251 vom
16. Juni 2010, d.h. mindestens einen Monat vor dem Datum dieser Beschlüsse, veröffentlicht.

(b) Ein erklärender Bericht (der „Erklärende Bericht“) wurde am 31. Mai 2010 durch den geschäftsführenden Kom-

plementär  der  Gesellschaft  erstellt,  der  die  Gründe  für  die  Verschmelzung,  die  voraussichtlichen  Folgen  für  die  Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft, CMH VS I GmbH und der Übernehmen Gesellschaft und alle juristischen, ökonomischen
und sozialen Auswirkungen der Verschmelzung beschrieben hat.

(c) Ein erklärender Bericht wurde ebenfalls von der Geschäftsführung der CMH VS I GmbH und dem alleinigen Ge-

schäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft am 31. Mai 2010 erstellt.

(d) Am 20. Mai 2010 haben die Gesellschafter der Gesellschaft und die Gesellschafter von CMH VS I GmbH und der

Gesellschaft beschlossen, gemäß Artikel 266 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner
geltenden Fassung („GüH“) auf den schriftlichen Prüfbericht (rapport écrit destiné aux associés) zu verzichten.

(e) Die jeweils gemäß Artikel 267 GüH benötigten Dokumente wurden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, CMH

VS I GmbH und der Übernehmenden Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Gesellschafter und durch Personen, die
spezielle Rechte gegen die Gesellschaft, CMH VS I GmbH und die Übernehmende Gesellschaft haben, mindestens einen
Monat vor dem Datum dieser Beschlüsse und der Generalversammlung der Gesellschafter von CMH VS I GmbH und
der Übernehmenden Gesellschaft.

(f) Die Verschmelzung wird Dritten gegenüber wirksam am Tag der Veröffentlichung der Beschlüsse des Gesellschaf-

ters im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, die am 30. Juli 2010 erfolgen soll. Aus buchhalterischer Sicht
gelten die Aktiva und Passiva der Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Mai 2010, als auf die Gesellschaft übertragen.

(h) Die oben erwähnte erschienene Person hat den Erklärenden Bericht dem Notar vorgelegt.
Eine Kopie des Erklärenden Berichts, nach Unterschrift „ne varietur“ durch die erschienene Person und den unter-

zeichneten Notar, wird dieser Urkunde beigefügt um mit dieser einregistriert zu werden.

(i) Daraufhin hat die erschienene Person den unterzeichneten Notar gebeten, folgende Beschlüsse aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, den erklärenden Bericht des geschäftsführenden Komplementärs über die vor-

geschlagene Verschmelzung der Gesellschaft anzuerkennen.

<i>Zweiter Beschluss

Der  Gesellschafter  hat  beschlossen,  den  gemeinsamen  Verschmelzungsplan  zwischen  der  Gesellschaft,  CMH  VS  I

GmbH, als Übernommenen Gesellschaften, zu genehmigen, wonach die Gesellschaft und CMH VS I GmbH durch die
Übernehmende Gesellschaft absorbiert werden, durch Einbringung durch die Gesellschaft und CMH VS I GmbH der
Gesamtheit ihrer derzeitigen Aktiva und Passiva, ohne Einschränkung oder Beschränkung, ohne Gegenleistung und mit
Wirkung ab dem Datum ab dem die Verschmelzung wirksam sein wird und wonach die Übernehmende Gesellschaft alle
Verbindlichkeiten der Gesellschaft und CMH VS I GmbH, übernehmen und alle ihre Verpflichtungen und Obligationen
und alle Kosten, Steuern und Ausgaben jedweder Art die sich aus der Verschmelzung ergeben, begleichen wird.

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, Vollmacht zu erteilen an Frau Victoria Karran, Corporate Secretary, mit berufli-

cher Anschrift in Clerical Medical House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM99 1LT, allein handelnd und zeichnend,
mit Berechtigung zur Substitution, für und im Namen der Gesellschaft alle Maßnahmen zu treffen, die sie nach ihrem
alleinigen Ermessen für notwendig oder ratsam hält um die obenstehenden Beschlüsse umzusetzen und (i) auf die Über-
nehmende Gesellschaft die Gesamtheit aller Aktiva und Passiva zu übertragen, (ii) die Verschmelzung der Gesellschaft
beim luxemburgischen Handelsregister einzutragen und (iii) alle sonstigen Formalitäten oder Maßnahmen durchzuführen,
einschließlich Steuererklärungen, die im Zusammenhang mit der Verschmelzung notwendig sind.

<i>Vierter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt anzuerkennen, dass die Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst wird.

74697

L

U X E M B O U R G

<i>Erklärung

In Übereinstimmung mit Artikel 271 (2) des GüH erklärt der unterzeichnete Notar, dass er die Existenz und Wirk-

samkeit, nach Luxemburgischem Recht, aller rechtlichen Maßnahmen und Formalitäten, die der Gesellschaft obliegen, um
die Verschmelzung wirksam werden zu lassen.

Die Verschmelzung der Gesellschaft in die Übernehmende Gesellschaft wird Dritten gegenüber wirksam am Tag der

Veröffentlichung der Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, die
am 30. Juli 2010 erfolgen soll. Aus buchhalterischer Sicht gelten die Aktiva und Passiva der Gesellschaft mit Wirkung zum
31. Mai 2010, als auf die Übernehmende Gesellschaft übertragen.

<i>Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf zwei tausend vier hundert Euro (EUR 2.400.-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten

Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Woraufhin, vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-

nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Loesch, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 20 juillet 2010. Relation: RED/2010/954. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 21. Juli 2010.

Référence de publication: 2010097276/232.
(100109501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.

Financière Figaro S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Financière E2 S.à r.l.).

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 136.234.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth day of July.
In front of Maître Francis Kesseler, notary public residing in Eschsur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AXA Secondary Fund IV L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Jersey, having its registered office

at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX, registered under number LP 823, acting through its
General Partner AXA Private Equity Secondaries Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, having its
registered office at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX, registered under number 87242, here
represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette,
5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been initialled “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party hereby represented as described above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearer is the sole shareholder of Financière E2 S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having

its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed enacted
by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 21 January 2008, published in the “Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations” (the “Mémorial C”) number 631 of 13 March 2008, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 136.234 (the “Company”).

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted by the undersigned

notary, on 22 June 2010, in process of publication in the Mémorial C.

II.- That the 1,250 (one thousand two hundred fifty) ordinary shares, the 185 (one hundred eighty-five) class A shares,

the 185 (one hundred eighty-five) class B shares, the 185 (one hundred eighty-five) class C shares, the 185 (one hundred
eighty-five) class D shares, the 185 (one hundred eighty-five) class E shares, the 185 (one hundred eightyfive) class F

74698

L

U X E M B O U R G

shares, the 185 (one hundred eighty-five) class G shares, the 185 (one hundred eighty-five) class H shares, the 185 (one
hundred eighty-five) class I shares and the 185 (one hundred eighty-five) class J shares, all having a nominal value of EUR
10 (ten Euro) each and representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can
validly decide on all the items of the agenda, of which the sole shareholder expressly states having been duly informed
beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Change of name of the Company to Financière Figaro S.à r.l.;
3. Subsequent amendment of article 2. of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow him to examine carefully
each document.

<i>Second resolution

It is resolved to change the name of the Company to Financière Figaro S.à r.l.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 2. of the Company’s articles of association

so that to read as follows:

“ Art. 2. The Company’s name is “Financière Figaro S.à r.l.”.”

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand euro (€ 1.000,-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le quinzième jour de juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Eschsur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AXA Secondary Fund IV L.P., un limited partnership constitué selon le droit de Jersey, ayant son siège social sis au 22

Grenville Street, St. Helier, Jersey, Les Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX, enregistré sous le numéro LP 823, agissant par
son General Partner AXA Private Equity Secondaries Limited, une société constituée selon le droit de Jersey, ayant son
siège social sis au 22 Grenville Street, St. Helier, Les Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX, enregistré sous le numéro 87242,
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante

et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’en-
registrement.

La partie ici représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- Le comparant est l’associé unique de Financière E2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise

ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié
reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, le 21 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des

74699

L

U X E M B O U R G

Sociétés et Associations (le “Mémorial C”) numéro 631 du 13 mars 2008, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.234 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié reçu par le notaire instrumentant,

en date du 22 juin 2010, publié au Mémorial C, pas encore publié au Mémorial C.

II.- Que les 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales ordinaires, les 185 (cent quatre-vingt-cinq) parts sociales

de classe A, les 185 parts sociales de classe B, les 185 (cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe C, les 185 (cent
quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe D, les 185 (cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe E, les 185 (cent
quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe F, les 185 (cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe G, les 185 (cent
quatre-vingtcinq) parts sociales de classe H, les 185 (cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe I et les 185 (cent
quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe J, ayant toutes une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) chacune et repré-
sentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer
sur tous les points de l’ordre du jour sur lesquels l’associé unique reconnaît expressément avoir été dûment et préala-
blement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation à la convocation préalable;
2. Changement de la dénomination de la Société en Financière Figaro S.à r.l.;
3. Modification subséquente de l’article 2. des statuts de la Société; et
4. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’associé unique de la Société, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé que l’associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée

générale; l’associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement
convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre
décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’associé unique dans
un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution

Il est décidé de modifier la dénomination de la Société en Financière Figaro S.à r.l.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, il est décidé de modifier l’article 2. des statuts de la Société pour lui

donner la teneur suivante:

“ Art. 2. La dénomination de la Société est «Financière Figaro S.à r.l.»."

<i>Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ mille euros (€ 1.000,-).

Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch/Alzette, au jour qu’en tête.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte. Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 juillet 2010. Relation: EAC/2010/8722. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010101616/128.
(100114577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2010.

74700

L

U X E M B O U R G

VSP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.751.

In the year two thousand and ten, on the nineteenth day of July.
Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Clerical Medical Europe Financial Services B.V. Luxembourg Branch, with registered office at 40, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 93.191 (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Me Marc LOESCH, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 19 July 2010

annexed to the present deed.

Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, shall be annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of "VSP Holdings S. à r.l.", a société à responsabilité limitée – Gesellschaft

mit beschränkter Haftung incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share
capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,
under number B 93.751 and incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand
Duchy of Luxembourg, of 14 May 2003, published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, number 664
of 24 June 2003 (the "Company").

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the under-

signed notary, on 20 May 2010, published in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, number 1433 of 13
July 2010.

(i) The appearing party, represented as mentioned above, has recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To hear an explanatory report from the sole manager of the Company concerning the proposed merger of the

Company.

2. To approve the joint merger proposal between the Company, as absorbing company, and (i) CMH Vertriebs Service

I GmbH, a société à responsabilité limitée – Gesellschaft mit beschränkter Haftung governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-), with registered office at 40, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 93.850 and (ii) CMH Vertriebs Service I GmbH &amp; Co KG, a société en commandite
simple – Kommanditgesellschaft governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40,
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 93.763, as absorbed companies (the “Absorbed Companies”), pursuant to
which the Absorbed Companies will be absorbed by the Company, in its capacity as absorbing company, by contribution
from the Absorbed Companies to the Company, of the universality of their current assets and liabilities, without any
restriction or limitation, for no consideration and with effect as of the date on which the merger will be effective and
pursuant to which the Absorbing Company will assume all of the liabilities of the Absorbed Companies, performing all of
its commitments and obligations, paying and bearing all of the costs, taxes and expenses of any kind resulting from the
merger.

3. To delegate powers.
4. Miscellaneous.
(ii) The undersigned notary confirms that:
(a) a joint merger proposal has been drawn up by the board of managers, respectively the General Partner of the

Absorbed Companies and the sole manager of the Company on 31 May 2010; such merger proposal has been published
in the Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations number 1251 of 16 June 2010, i.e. at least one month before
the date of the present resolutions of the Sole Shareholder.

(b) an explanatory report (the “Company Explanatory Report”) has been drawn up by the sole manager of the Company

on 31 May 2010 describing the reasons for the merger, the anticipated consequences for the respective activities of each
of the Absorbed Companies and the Company and any legal, economic and social related implications of the merger.

(c) an explanatory report has also been drawn up by the board of managers, respectively the General Partner of the

Absorbed Companies on 31 May 2010.

74701

L

U X E M B O U R G

(d) on 20 May 2010, the Sole Shareholder of the Company and the shareholders of the Absorbed Companies resolved

to waive, pursuant to article 266(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (“LCC”), the
written auditors' report (rapport écrit destiné aux associés).

(e) the respective documents required pursuant to article 267 of the LCC have been deposited at the registered office

of each of the Absorbed Companies and the Company, for inspection by the shareholders and those persons having
special rights against any of the Absorbed Companies or the Company, at least one month prior to the date of the present
resolutions and the general meeting of shareholders of the Absorbed Companies.

(f) on 19 July 2010, the general meeting of shareholders of the Absorbed Companies, which were held in Luxembourg,

approved the proposal to effect the merger as contemplated by the joint merger proposal.

(g) the merger will become effective vis-à-vis third parties as at the date of publication of the resolutions of the Sole

Shareholder of the Company approving the merger in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, which
publication shall take place on 30 July 2010. For accounting purposes, the assets and liabilities of the Absorbed Companies
shall be deemed transferred to the Company as from the 31 May 2010.

(iii) The appearing person mentioned above, presented the Company Explanatory Report to the undersigned notary.
A copy of the Company Explanatory Report after having been signed «ne varietur» by the appearing person and the

undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

(iv) Thereupon, the appearing person requested the notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to acknowledge the explanatory report of the sole manager of the Company concerning

the proposed merger of the Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to approve the joint merger proposal between the Company, as absorbing company,

and the Absorbed Companies, pursuant to which the Absorbed Companies will be absorbed by the Company, in its
capacity as absorbing company, by contribution from the Absorbed Companies to the Company, of the universality of
their current assets and liabilities, without any restriction or limitation, for no consideration, and to assume all of the
liabilities of the Absorbed Companies, performing all of their commitments and obligations, paying and bearing all of the
costs, taxes, and expenses of any kind resulting from the merger.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to delegate the power to Mrs Victoria Karran, corporate secretary, with professional

address at Clerical Medical House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM99 1LT, acting and signing individually, with full
power of substitution, on behalf and in the name of the Company, to do all acts and things as she in her absolute and
unfettered discretion deems necessary or advisable for the purpose of implementing the foregoing resolutions and to (i)
transfer to the Absorbing Company the universality of the assets and liabilities of the Company (ii) file the merger of the
Company with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and (iii) carry out any other formalities or other
actions, including tax filings, that would be necessary in relation to the merger of the Company.

<i>Declaration

In  accordance  with  Article  271  (2)  of  the  LCC,  the  undersigned  notary  declares  having  verified  and  certifies  the

existence and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to
render the merger effective.

The merger of the Absorbed Companies into the Company will become effective vis-à-vis third parties as at the date

of publication of the present deed in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations which publication shall take
place on 30 July 2010. For accounting purposes, the assets and liabilities of the Absorbed Companies shall be deemed
acquired by the Company as from the 31 May 2010.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated

approximately at two thousand four hundred euro (EUR 2,400.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the English text and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their name, surname,

occupation and residence, said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzehn, am neunzehnten Juli.

74702

L

U X E M B O U R G

Vor dem unterzeichnenden Notar Edouard Delosch, mit dem Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Clerical Medical Europe Financial Services B.V. Luxembourg Branch, mit Sitz in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxem-

burg,  Grossherzogtum  Luxemburg,  eingetragen  beim  Handelsregister  Luxemburg  unter  der  Nummer  B  93.191  (der
„Alleinige Gesellschafter“).

vertreten durch Maître Marc LOESCH, Rechtsanwalt mit Wohnsitz in Luxemburg, kraft der am 19. Juli 2010 erteilten

Vollmacht.

Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet

wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei ist die Alleingesellschafterin von „VSP Holdings S. à r.l.“, einer société à responsabilité limité -

Gesellschaft mit beschränkter Haftung - gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), mit Sitz in 40, Avenue Monterey, L-2163
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.751,
und gegründet durch Urkunde von Notar Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sanem, Großherzogtum Luxemburg,
vom 14. Mai 2003, veröffentlicht im Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 664 vom 24. Juni 2003
(die „Gesellschaft“).

Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des amtierenden Notars vom

20. Mai 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1433 vom 13. Juli 2010.

(i) Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärt, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der

folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

<i>Tagesordnung

1. Anhörung des erklärenden Berichts des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft über die vorgeschlagene Ver-

schmelzung der Gesellschaft;

2. Genehmigung des gemeinsamen Verschmelzungsplans zwischen der Gesellschaft, als der übernehmenden Gesell-

schaft,  und  (i)  CMH  Vertriebs  Service  I  GmbH,  eine  société  à  responsabilité  limitée  (Gesellschaft  mit  beschränkter
Haftung), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von
fünfzehntausend Euro (EUR 15.000,-), mit Sitz in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
und eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.850 und (ii) CMH Vertriebs Service I GmbH
&amp; CoKG, eine société en commandite simple (Kommanditgesellschaft), gegründet und bestehend nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und
eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.763 als übernommene Gesellschaften (die „Über-
nommenen Gesellschaften“), wonach die Übernommenen Gesellschaften durch die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als
übernehmende  Gesellschaft  absorbiert  werden,  durch  Einbringung  durch  die  Übernommenen  Gesellschaften  an  die
Übernehmende  Gesellschaft  von der  Gesamtheit  ihrer  derzeitigen Aktiva  und Passiva,  ohne  Einschränkung oder  Be-
schränkung, ohne Gegenleistung und mit Wirkung ab dem Datum ab dem die Verschmelzung wirksam sein wird und
wonach die Übernehmende Gesellschaft alle Verbindlichkeiten der Übernommenen Gesellschaften übernehmen, alle ihre
Verpflichtungen und Obligationen und alle Kosten, Steuern und Ausgaben jedweder Art die sich aus der Verschmelzung
ergeben, begleichen wird.

3. Erteilung von Vollmacht.
4. Verschiedenes.
(ii) Der Notar bestätigt dass:
(a) ein gemeinsamer Verschmelzungsplan wurde von der Geschäftsführung, beziehungsweise dem geschäftsführenden

Komplementär der Übernommenen Gesellschaften und dem einzigen Geschäftsführer am 31. Mai 2010 erstellt; dieser
Verschmelzungsplan wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1251 vom 16. Juni 2010, d.h.
mindestens einen Monat vor dem Datum dieser Beschlüsse, veröffentlicht.

(b) Ein erklärender Bericht (der „Erklärende Bericht“) wurde am 31. Mai 2010 durch den alleinigen Geschäftsführer

der Gesellschaft erstellt, der die Gründe für die Verschmelzung, die voraussichtlichen Folgen für die Geschäftstätigkeit
jeder der Übernommenen Gesellschaften und die Gesellschaft und alle juristischen, ökonomischen und sozialen Auswir-
kungen der Verschmelzung beschrieben hat.

(c) Ein erklärender Bericht wurde ebenfalls von der Geschäftsführung, beziehungsweise dem geschäftsführenden Kom-

plementär der Übernommenen Gesellschaften am 31. Mai 2010 erstellt.

(d) Am 20. Mai 2010 haben der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft und die Gesellschafter der Übernommenen

Gesellschaften beschlossen, gemäß Artikel 266 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in
seiner geltenden Fassung („GüH“) auf den schriftlichen Prüfbericht (rapport écrit destiné aux associés) zu verzichten.

(e) Die jeweils gemäß Artikel 267 GüH benötigten Dokumente wurden am Gesellschaftssitz der Übernommenen

Gesellschaften und der Gesellschaft hinterlegt zur Einsichtnahme durch die Gesellschafter und durch Personen, die spe-
zielle Rechte gegen die Übernommenen Gesellschaften und die Gesellschaft haben, mindestens einen Monat vor dem
Datum dieser Beschlüsse und der Generalversammlung der Gesellschafter der Übernommenen Gesellschaft.

74703

L

U X E M B O U R G

(f) Am 19. Juli 2010 hat die Generalversammlung der Übernommenen Gesellschaften, die in Luxemburg abgehalten

wurde, den Vorschlag, die Verschmelzung wie vom gemeinsamen Verschmelzungsplan beabsichtigt, genehmigt.

(g) Die Verschmelzung wird Dritten gegenüber wirksam am Tag der Veröffentlichung der Beschlüsse des Alleinigen

Gesellschafters im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, die am 30. Juli 2010 erfolgen soll. Aus buchhalteri-
scher Sicht gelten die Aktiva und Passiva der Übernommenen Gesellschaften mit Wirkung zum 31. Mai 2010, als auf die
Gesellschaft übertragen.

(h) Die oben erwähnte erschienene Person hat den Erklärenden Bericht dem Notar vorgelegt.
Eine Kopie des Erklärenden Berichts, nach Unterschrift „ne varietur“ durch die erschienene Person und den unter-

zeichneten Notar, wird dieser Urkunde beigefügt um mit dieser einregistriert zu werden.

(i) Daraufhin hat die erschienene Person den unterzeichneten Notar gebeten, folgende Beschlüsse aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, den erklärenden Berichts des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft

über die vorgeschlagene Verschmelzung der Gesellschaft anzuerkennen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, den gemeinsamen Verschmelzungsplan zwischen der Gesellschaft, als der

übernehmenden Gesellschaft, und den Übernommenen Gesellschaften, wonach die Übernommenen Gesellschaften durch
die  Gesellschaft  in  ihrer  Eigenschaft  als  übernehmende  Gesellschaft  absorbiert  werden,  durch  Einbringung  durch  die
Übernommenen Gesellschaften an die Übernehmende Gesellschaft von der Gesamtheit ihrer derzeitigen Aktiva und
Passiva, ohne Einschränkung oder Beschränkung, ohne Gegenleistung und mit Wirkung ab dem Datum ab dem die Ver-
schmelzung wirksam sein wird und wonach die Übernehmende Gesellschaft alle Verbindlichkeiten der Übernommenen
Gesellschaften übernehmen wird, alle ihre Verpflichtungen und Obligationen und alle Kosten, Steuern und Ausgaben
jedweder Art die sich aus der Verschmelzung ergeben, begleichen wird.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, Vollmacht zu erteilen an Frau Victoria Karran, Corporate Secretary, mit

beruflicher Anschrift in Clerical Medical House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM99 1LT, allein handelnd und zeich-
nend, mit Berechtigung zur Substitution, für und im Namen der Gesellschaft alle Maßnahmen zu treffen, die sie nach ihrem
alleinigen Ermessen für notwendig oder ratsam hält um die obenstehenden Beschlüsse umzusetzen und (i) auf die Über-
nehmende Gesellschaft die Gesamtheit aller Aktiva und Passiva zu übertragen, (ii) die Verschmelzung der Gesellschaft
beim luxemburgischen Handelsregister einzutragen und (iii) alle sonstigen Formalitäten oder Maßnahmen durchzuführen,
einschließlich Steuererklärungen, die im Zusammenhang mit der Verschmelzung notwendig sind.

<i>Erklärung

In Übereinstimmung mit Artikel 271 (2) des GüH erklärt der unterzeichnete Notar, dass er die Existenz und Wirk-

samkeit, nach Luxemburgischem Recht, aller rechtlichen Maßnahmen und Formalitäten, die der Gesellschaft obliegen, um
die Verschmelzung wirksam werden zu lassen.

Die Verschmelzung der Übernommenen Gesellschaften in die Gesellschaft wird Dritten gegenüber wirksam am Tag

der Veröffentlichung der Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
die am 30. Juli 2010 erfolgen soll. Aus buchhalterischer Sicht gelten die Aktiva und Passiva der Übernommenen Gesell-
schaften mit Wirkung zum 31 Mai 2010, als auf die Gesellschaft übertragen.

<i>Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf zwei tausend vier hundert Euro (EUR 2.400.-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten

Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten, Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-

nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Loesch, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 20. Juli 2010. Relation: RED/2010/955. Reçu soixante-quinze (75,-) euros

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

74704

L

U X E M B O U R G

Rambrouch, den 21. Juli 2010.

Référence de publication: 2010097684/225.
(100109502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.

Euro Floor, Fonds Commun de Placement.

Le Règlement de Gestion consolidé du Fonds Commun de Placement Euro Floor a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2010.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (Part II) LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010101170/11.
(100113437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.967.

Cargill International Luxembourg 7 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.973.

MERGER PLAN

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of July.
1) the board of managers of Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under Section B, number 150.967,
and

2) the board of managers of Cargill international Luxembourg 7 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under Section B, number 150.973,

have, with regard to the Absorbing Company, by the meeting of its board of managers held on 27 July, 2010 and with

regard to the Absorbed Company, by the meeting of its board of managers held on 27 July, 2010, decided to submit to
the approval by the shareholders of the Absorbing Company and the Absorbed Company this:

<i>Plan of reorganization and merger

1) Merging Parties.
- Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 150.967, as absorbing company (herei-
nafter referred to as the "Absorbing Company"); and

- Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 150.973, as absorbed company (herei-
nafter referred to as the "Absorbed Company"),

the Absorbing Company and the Absorbed Company being collectively referred to as "Merging Companies".
2) The Absorbing Company holds ninety-one million eight hundred and sixty-four thousand seven hundred and thirty

(91,864,730) shares of the Absorbed Company, representing the entire share capital and all of the voting rights of the
Absorbed Company, the latter having issued no other shares and/or other securities.

3) The Absorbed Company does not have employees.
4) The Absorbed Company does not own any intellectual property rights or real estate property.
5) The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company by way of a merger by acquisition pursuant

to the provisions of articles 278 through 283 of the law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the
"Law").

6)  As  from  the  Effective  Date  (as  defined  below),  all  operations  and  transactions  of  the  Absorbed  Company  are

considered for accounting and tax purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.

74705

L

U X E M B O U R G

7) As of the Effective Date, all rights and obligations of the Absorbed Company vis-à-vis third parties shall be taken

over by the Absorbing Company by way of a universal transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company. The
Absorbing Company will in particular take over debts as its own debts and all payment obligations of the Absorbed
Company. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing
Company with ail securities, either in rem or personal, attached thereto on the Effective Date.

8) The Absorbing Company shall from the Effective Date carry out the business of the Absorbed Company including

all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Company such as these agreements and obligations exist
on the Effective Date and in particular carry out all agreements existing with the creditors of the Absorbed Company
and shall be subrogated to all rights and obligations from such agreements.

9) No special rights or advantages have been granted to the managers of the Merging Companies.
10) All shareholders of respectively, the Absorbing Company and the Absorbed Company have, within one month

from the publication of this merger plan in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, access at the registered
office of respectively the Absorbing Company and the Absorbed Company to all available documents listed in article 267
paragraph (1) a), b) and c) of the Law and may obtain copies thereof, free of charge.

11) One or more shareholders of the Absorbing Company holding a(least 5% of the subscribed share capital of the

Absorbing Company may within the time period set out in 10) above request the convening of a shareholders' meeting
of the Absorbing Company to decide whether to approve the proposed merger.

12) The merger between the Merging Companies shall become effective and final between the Merging Companies on

the date on which the extraordinary general meeting of the shareholders of respectively the Absorbing Company and
the Absorbed Company unanimously approve the merger (the "Effective Date"). The merger will lead simultaneously to
the effects set out in article 274 of the Law.

13) The merger between the Merging Companies shall become effective and final vis-à-vis third parties on the date on

which such extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbing Company and the Absorbed Company
approving the merger are published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

14) The Absorbing Company shall itself carry out ail formalities, including such announcements as are prescribed by

law, which are necessary or useful to carry into effect the merger and the transfer and assignment of the assets and
liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.

15) The books and records of the Absorbed Company will be held at the registered office of the Absorbing Company

for the period legally prescribed.

16) As a result of the merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares shall be cancelled.
17) The Absorbing Company and the Absorbed Company intend that the merger constitutes a reorganization pursuant

to section 368(a)(1)(A) of the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended.

This merger plan is worded in English followed by a French translation; and in case of divergences between the English

and the French text, the English version will prevail.

Signed in Minnetonka, Minnesota and in Luxembourg.

Board of managers of Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l. / Board of managers of Cargill International Lu-
xembourg 3 S.à r.l.
Represented by Daryl L. Wikstrom, Florence Gérardy / Represented by Daryl L. Wikslrom, Florence Gérardy
<i>Class A manager, Class B manager / Class A manager, Class B manager

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-septième jour du mois de juillet.
1) le conseil de gérance de Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro
150.967, et

2) le conseil de gérance de Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro
150.973,

ont, concernant la Société Absorbante, par la réunion de son conseil de gérance tenue le 27 juillet 2010 et concernant

la Société Absorbée, par la réunion de son conseil de gérance tenue le 27 juillet 2010, décidé de soumettre à l'approbation
des associés de la Société Absorbante et de fa Société Absorbée le présent:

<i>Plan de réorganisation et de fusion

1) Parties à la fusion
- Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès

74706

L

U X E M B O U R G

du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 150.967, en qualité de société
absorbante (ci-après la "Société Absorbante"); et

- Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 150.973, en qualité de société
absorbée (ci-après la "Société Absorbée"),

la Société Absorbante et la Société Absorbée étant collectivement désignées comme les "Sociétés Parties à la Fusion".
2)  La  Société  Absorbante  détient  quatre-vingt-onze  millions  huit  cent  soixante-quatre  mille  sept  cent  trente

(91.864.730) parts sociales de la Société Absorbée, représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la
Société Absorbée, celte dernière n'ayant émis aucune autre part sociale et/ou autre titre.

3) La Société Absorbée n'emploie pas de salariés.
4) La Société Absorbée ne possède aucun droit de propriété intellectuelle ou aucune propriété immobilière.
5) La Société Absorbante propose d'absorber la Société Absorbée au moyen d'une fusion par absorption conformé-

ment aux dispositions des articles 278 à 283 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la "Loi").

6) A compter de la Date Effective (comme définie ci-dessous), toutes les opérations et transactions de la Société

Absorbée sont réputées pour des considérations comptables et fiscales comme étant conduites pour le compte de la
Société Absorbante.

7) A la Date Effective, tous les droits et obligations de la Société Absorbée à l'égard des tiers seront repris par la

Société Absorbante par voie d'un transfert universel de l'intégralité des actifs et passifs de la Société Absorbée. La Société
Absorbante reprendra en particulier les dettes comme les siennes ainsi que l'ensemble des obligations de paiement de la
Société Absorbée. Les droits et créances compris dans les actifs de la Société Absorbée seront transférés à fa Société
Absorbante avec toutes les sûretés, qu'elles soient réelles ou personnelles, qui y sont attachées à la Date Effective.

8) La Société Absorbante exécutera à la Date Effective les affaires de la Société Absorbée en ce comprenant l'ensemble

des engagements et obligations, de toute nature, de la Société Absorbée, pour autant que ces engagements et obligations
existent à la Date Effective, et en particulier l'ensemble des engagements existant au bénéfice des créanciers de la Société
Absorbée et sera subrogée dans tous les droits et obligations découlant de ces engagements.

9) Aucun droit particulier ou avantage n'a été accordé aux gérants des Sociétés Parties à la Fusion.
10) Tous les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, respectivement, ont, dans le délai d'un mois

à compter de la publication de ce plan de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, accès au siège social
de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, respectivement, à l'ensemble des documents disponibles listés à
l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la Loi et peuvent gratuitement en obtenir copie sur place.

11) Un ou plusieurs associés de la Société Absorbante détenant au moins 5% du capital social souscrit de la Société

Absorbante peuvent dans le délai prévu dans le 10) ci-dessus demander la convocation d'une assemblée générale des
associés de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion proposée.

12) La fusion entre les Sociétés Parties à la Fusion deviendra effective et définitive entre les Sociétés Parties à la Fusion

à la date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante et de fa Société Absorbée,
respectivement, approuve à l'unanimité la fusion (la "Date Effective"). La fusion conduira simultanément aux effets prévus
à l'article 274 de la Loi,

13) La fusion entre les Sociétés Parties à la Fusion deviendra effective et définitive à l'égard des tiers à la date à laquelle

cette assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée approuvant la
fusion est publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

14) La Société Absorbante effectuera elle-même toutes les formalités, y compris les publications prescrites par la loi,

qui sont nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion ainsi qu'aux transfert et cession des actifs et passifs de la
Société Absorbée à la Société Absorbante.

15) Les livres et registres de la Société Absorbée seront tenus au siège social de la Société Absorbante pendant la

période prescrite par la loi.

16) En conséquence de la fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et l'intégralité des parts sociales émises sera

annulée.

17) La Société Absorbée et la Société Absorbante entendent que la fusion soit considérée comme une réorganisation

conformément à la Section 368(a)(1){A) du United States Internal Revenue Code de 1986, tel que modifié.

Ce plan de fusion est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; et en cas de divergences entre le texte anglais

et le texte français, la version anglaise fait foi.

Signé à Minnetonka, Minnesota et à Luxembourg.

Conseil de gérance de Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l. / Conseil de gérance de Cargill International
Luxembourg 3 S.à r.l.
Représenté par Daryl L. Wikstrom, Florence Gérardy / Représenté par Daryl L. Wikstrom, Florence Gérardy
<i>Gérant de Classe A, Gérante de classe B / Gérant de Classe A, Gérante de classe B

74707

L

U X E M B O U R G

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of July.
1) the board of managers of Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under Section B, number 150.967,
and

2) the board of managers of Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having Its registered office at 5 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under Section B, number 150.973,

have, with regard to the Absorbing Company, by the meeting of Its board of managers held on 27 July, 2010 and with

regard to the Absorbed Company, by the meeting of its board of managers held on 27 July, 2010, decided to submit to
the approval by the shareholders of the Absorbing Company and the Absorbed Company this:

<i>Plan of reorganization and merger

1) Merging Parties
- Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 150.967, as absorbing company (herein-
after referred to as the "Absorbing Company"); and

- Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 150.973, as absorbed company (herein-
after referred to as the "Absorbed Company"),

the Absorbing Company and the Absorbed Company being collectively referred to as "Merging Companies".
2) The Absorbing Company holds ninety-one million eight hundred and sixty-four thousand seven hundred and thirty

(91,864,730) shares of the Absorbed Company, representing the entire share capital and all of the voting rights of the
Absorbed Company, the latter having issued no other shares and/or other securities.

3) The Absorbed Company does not have employees.
4) The Absorbed Company does not own any intellectual property rights or real estate property.
5) The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company by way of a merger by acquisition pursuant

to the provisions of articles 278 through 283 of the law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the
"Law").

6)  As  from  the  Effective  Date  (as  defined  below),  all  operations  and  transactions  of  the  Absorbed  Company  are

considered for accounting and tax purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.

7) As of the Effective Date, all rights and obligations of the Absorbed Company vis-à-vis third parties shall be taken

over by the Absorbing Company by way of a universal transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company. The
Absorbing Company will in particular take over debts as its own debts and all payment obligations of the Absorbed
Company. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing
Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto on the Effective Date.

8) The Absorbing Company shall from the Effective Date carry out the business of the Absorbed Company including

all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Company such as these agreements and obligations exist
on the Effective Date and in particular carry out all agreements existing with the creditors of the Absorbed Company
and shall be subrogated to all rights and obligations from such agreements.

9) No special rights or advantages have been granted to the managers of the Merging Companies.
10) All shareholders of respectively, the Absorbing Company and the Absorbed Company have, within one month

from the publication of this merger plan in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, access at the registered
office of respectively the Absorbing Company and the Absorbed Company to all available documents listed in article 267
paragraph (1) a), b) and c) of the Law and may obtain copies thereof, free of charge.

11) One or more shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the subscribed share capital of the

Absorbing Company may within the time period set out in 10) above request the convening of a shareholders' meeting
of the Absorbing Company to decide whether to approve the proposed merger.

12) The merger between the Merging Companies shall become effective and final between the Merging Companies on

the date on which the extraordinary general meeting of the shareholders of respectively the Absorbing Company and
the Absorbed Company unanimously approve the merger (the "Effective Date"). The merger will lead simultaneously to
the effects set out in article 274 of the Law.

13) The merger between the Merging Companies shall become effective and final vis-à-vis third parties on the date on

which such extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbing Company and the Absorbed Company
approving the merger are published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

74708

L

U X E M B O U R G

14) The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by

law, which are necessary or useful to carry into effect the merger and the transfer and assignment of the assets and
liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.

15) The books and records of the Absorbed Company will be held at the registered office of the Absorbing Company

for the period legally prescribed.

16) As a result of the merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares shall be cancelled.
17) The Absorbing Company and the Absorbed Company intend that the merger constitutes a reorganization pursuant

to section 368(a)(1)(A) of the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended.

This merger plan is worded in English followed by a French translation; and in case of divergences between the English

and the French text, the English version will prevail.

Signed in Luxembourg.

Board of managers of Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l. / Board of managers of Cargill International Lux-
embourg 3 S.à r.l.
Represented by Florence Gérardy / Represented by Florence Gérardy
<i>Class B manager / Class B manager

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-septième jour du mois de juillet.
1) le conseil de gérance de Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro
150.967, et

2) le conseil de gérance de Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

et  existant  selon  les  lois  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  5  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro
150.973,

ont, concernant la Société Absorbante, par la réunion de son conseil de gérance tenue le 27 juillet 2010 et concernant

la Société Absorbée, par la réunion de son conseil de gérance tenue le 27 juillet 2010, décidé de soumettre à l'approbation
des associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée le présent:

<i>Plan de réorganisation et de fusion

1) Parties à la fusion
- Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 150.967, en qualité de société
absorbante (ci-après la "Société Absorbante"); et

- Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 150.973, en qualité de société
absorbée (ci-après la "Société Absorbée"),

la Société Absorbante et la Société Absorbée étant collectivement désignées comme les "Sociétés Parties à la Fusion".
2)  La  Société  Absorbante  détient  quatre-vingt-onze  millions  huit  cent  soixante-quatre  mille  sept  cent  trente

(91.864.730) parts sociales de la Société Absorbée, représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la
Société Absorbée, cette dernière n'ayant émis aucune autre part sociale et/ou autre titre.

3) La Société Absorbée n'emploie pas de salariés.
4) La Société Absorbée ne possède aucun droit de propriété intellectuelle ou aucune propriété immobilière.
5) La Société Absorbante propose d'absorber la Société Absorbée au moyen d'une fusion par absorption conformé-

ment aux dispositions des articles 278 à 283 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la "Loi").

6) A compter de la Date Effective (comme définie ci-dessous), toutes les opérations et transactions de la Société

Absorbée sont réputées pour des considérations comptables et fiscales comme étant conduites pour le compte de la
Société Absorbante.

7) A la Date Effective, tous les droits et obligations de la Société Absorbée à l'égard des tiers seront repris par la

Société Absorbante par voie d'un transfert universel de l'intégralité des actifs et passifs de la Société Absorbée.

La Société Absorbante reprendra en particulier les dettes comme les siennes ainsi que l'ensemble des obligations de

paiement de la Société Absorbée. Les droits et créances compris dans les actifs de la Société Absorbée seront transférés
à la Société Absorbante avec toutes les sûretés, qu'elles soient réelles ou personnelles, qui y sont attachées à la Date
Effective.

74709

L

U X E M B O U R G

8) La Société Absorbante exécutera à la Date Effective les affaires de la Société Absorbée en ce comprenant l'ensemble

des engagements et obligations, de toute nature, de la Société Absorbée, pour autant que ces engagements et obligations
existent à la Date Effective, et en particulier l'ensemble des engagements existant au bénéfice des créanciers de la Société
Absorbée et sera subrogée dans tous les droits et obligations découlant de ces engagements.

9) Aucun droit particulier ou avantage n'a été accordé aux gérants des Sociétés Parties à la Fusion.

10) Tous les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, respectivement, ont, dans le délai d'un mois

à compter de la publication de ce plan de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, accès au siège social
de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, respectivement, à l'ensemble des documents disponibles listés à
l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la Loi et peuvent gratuitement en obtenir copie sur place.

11) Un ou plusieurs associés de la Société Absorbante détenant au moins 5% du capital social souscrit de la Société

Absorbante peuvent dans le délai prévu dans le 10) ci-dessus demander la convocation d'une assemblée générale des
associés de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion proposée.

12) La fusion entre les Sociétés Parties à la Fusion deviendra effective et définitive entre les Sociétés Parties à la Fusion

à la date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée,
respectivement, approuve à l'unanimité la fusion (la "Date Effective"). La fusion conduira simultanément aux effets prévus
à l'article 274 de la Loi.

13) La fusion entre les Sociétés Parties à la Fusion deviendra effective et définitive à l'égard des tiers à la date à laquelle

cette assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée approuvant la
fusion est publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

14) La Société Absorbante effectuera elle-même toutes les formalités, y compris les publications prescrites par la loi,

qui sont nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion ainsi qu'aux transfert et cession des actifs et passifs de la
Société Absorbée à la Société Absorbante.

15) Les livres et registres de la Société Absorbée seront tenus au siège social de la Société Absorbante pendant la

période prescrite par la loi.

16) En conséquence de la fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et l'intégralité des parts sociales émises sera

annulée.

17) La Société Absorbée et la Société Absorbante entendent que la fusion soit considérée comme une réorganisation

conformément à la Section 368(a)(1)(A) du United States internal Revenue Code de 1986, tel que modifié.

Ce plan de fusion est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; et en cas de divergences entre le texte anglais

et le texte français, la version anglaise fait foi.

Signé à Luxembourg.

Conseil de gérance de Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l. / Conseil de gérance de Cargill International
Luxembourg 3 S.à r.l.
Représenté par Florence Gérardy / Représenté par Florence Gérardy
<i>Gérante de classe B / Gérante de classe B

Référence de publication: 2010102006/304.

(100114135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2010.

cominvest Best-in-One, Fonds Commun de Placement.

Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") hat mit Zustimmung der State Street

Bank Luxembourg S.A. (die "Depotbank") den Beschluss gefasst, die Teilfonds cominvest Best-in-One Konservativ und
cominvest Best-in-One Wachstum des Umbrellas cominvest Best-in-One (die "untergehenden Fonds") mit den Teilfonds
Allianz  Horizont  Defensiv  und  Allianz  Horizont  Balance  des  Umbrellas  Allianz  Horizont  Fonds  (die  "aufnehmenden
Fonds"), wie in der folgenden Tabelle beschrieben, mit Ablauf des 8. September 2010 (der "Stichtag") zu verschmelzen.

Anteilklasse des untergehenden Fonds

Anteilklasse des aufnehmenden Fonds

cominvest Best-in-One Konservativ (EUR)

Allianz Horizont Defensiv A (EUR)

cominvest Best-in-One Wachstum (EUR)

Allianz Horizont Balance A (EUR)

Aufgrund der Verschmelzung werden die untergehenden Fonds cominvest Best-in-One Konservativ und cominvest

Best-in-One Wachstum aufgelöst.

Senningerberg, 30. Juli 2010.

<i>Die Verwaltungsgesellschaft.

Luxemburg, 30. Juli 2010.

<i>Die Depotbank.

Référence de publication: 2010102912/755/16.

74710

L

U X E M B O U R G

Metro Investment Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8008 Strassen, 2, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 85.271.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the seventh of July.
Before US Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, a company incorporated under and governed by the laws of the Federal

Republic of Germany, having its registered office at Schlüterstraße 1, D-40235 Düsseldorf, Federal Republic of Germany
and registered with the trade register at the court of Düsseldorf under trade register number HRB 41013 (the “Sole
Shareholder”),

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on July 2010.

Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. The appearing party is currently the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilitié

limitée) existing in Luxembourg under the name of Metro Investment Luxembourg S.à r.l., having its registered office at
2, route d’Arlon, L-8008 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 85.271 and incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
on 12 December 2001, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 597 on 17 April 2002
(the “Company”).

The Company’s articles of association have been lastly amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary

then residing in Mersch, on 12 December 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1517 on 20 July 2007.

II. The share capital of the Company currently amounts to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) repre-

sented by 500 (five hundred) shares with a nominal value for each share of EUR 25 (twenty-five Euro).

III. The appearing person, as Sole Shareholder, expressly declares to proceed with the dissolution of the Company

with immediate effect.

IV. The appearing person, as liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have been

settled and that provisions have been set up to cover the payment of (i) a future liability for the establishment of the tax
returns for the year 2009,(ii) a future liability for legal services in connection with the dissolution of the Company, (iii) a
future liability for the membership fee of the Luxembourg Chamber of Commerce and (iv) a future liability for the payment
of the net wealth tax for the year 2010; the Sole Shareholder acknowledges that these provisions will be taken on by it.

V. The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the Sole Shareholder, who

is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those currently unknown; accordingly, the
liquidation of the Company is considered to be done and closed.

VI. The Sole Shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company for the performance of

their mandate as of today.

VII. The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the

following address: Metro AG, Schlüterstraße 1, D-40235 Düsseldorf, Federal Republic of Germany.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated without prejudice at approximately one thousand euro (€ 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

74711

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le septième jour de juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, une société constituée selon et régie par les lois de la République Fédérale

d’Allemagne, ayant son siège social au Schlüterstraße 1, D-40235 Düsseldorf, République Fédérale d’Allemagne et enre-
gistrée auprès de du registre de commerce du tribunal de Düsseldorf sous le numéro de registre du commerce HRB
41013 (l’«Associé Unique»)

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement au 5, rue

Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée en juillet
2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant représenté par son mandataire a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Le comparant est actuellement l’Associé Unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la

dénomination de Metro Investment Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 2, route d’Arlon, L-8008 Strassen,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
85.271 et constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 12 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 597 en date du 17 avril 2002 (la
«Société»).

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de

résidence à Mersch, en date du 12 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1517
en date du 20 juillet 2007.

II. La Société a actuellement un capital social de 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros) représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune.

III. Le comparant, en qualité d’Associé Unique, déclare expressément la dissolution de la Société avec effet immédiat.
IV. Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que le passif connu de la Société est réglé et que

des provisions ont été constituées pour assurer le règlement (i) d’une dette future pour l’établissement de la déclaration
d’impôts pour l’année 2009, (ii) d’une dette future pour des services juridiques relatifs à la dissolution de la Société, (iii)
d’une dette future pour la cotisation à la Chambre de Commerce de Luxembourg et (iv) d’une dette future pour le
paiement de l’impôt sur la fortune pour l’année 2010; l’Associé Unique reconnaît qu’il devra prendre en charge ces
provisions.

V. L’activité de la Société a cessé et l’Associé Unique est investi de tout l’actif et il répondra personnellement de tous

les engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer
comme faite et clôturée.

VI. L’associé Unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société dissoute pour l’exécution de leur

mandat jusqu’à ce jour.

VII. Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l’adresse suivante:

Metro AG, Schlüterstraße 1, D-40235 Düsseldorf, République Fédérale d’Allemagne.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’environ mille euros (€ 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 juillet 2010. Relation: EAC/2010/8308. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010101786/109.
(100114534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2010.

74712

L

U X E M B O U R G

Kaupthing Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.002.

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE SUB-FUNDS

"KAUPTHING FUND - GLOBAL EQUITIES"

"KAUPTHING FUND - NORDIC GROWTH"

"KAUPTHING FUND - SWEDISH GROWTH"

Shareholders  of  the  Sub-Funds  "KAUPTHING  FUND  -  GLOBAL  EQUITIES",  "KAUPTHING  FUND  -  NORDIC

GROWTH" and "KAUPTHING FUND - SWEDISH GROWTH" (the "Sub-Funds") are hereby informed that the board
of directors (the "Directors") of the Fund has decided with effect as of 31st August 2010 to merge the Sub-Funds with
newly created sub-funds (the "Transferee Sub-Funds") of the undertaking for collective investment in transferable secu-
rities ("UCITS") Alandsbanken SICAV (the "Transferee Fund") as follows:

Kaupthing Fund to be merged into

Alandsbanken SICAV (Transferee Fund)

Class A (EUR) Kaupthing Fund - Global Equities

Class A (EUR) Alandsbanken SICAV - Global Growth

Class A (SEK) Kaupthing Fund - Global Equities

Class A (SEK) Alandsbanken SICAV - Global Growth

Class B (EUR) Kaupthing Fund - Global Equities

Class B (EUR) Alandsbanken SICAV - Global Growth

Class B (SEK) Kaupthing Fund - Global Equities

Class B (SEK) Alandsbanken SICAV - Global Growth

Class A (EUR) Kaupthing Fund - Nordic Growth

Class A (EUR) Alandsbanken SICAV - Nordic Growth

Class A (SEK) Kaupthing Fund - Nordic Growth

Class A (SEK) Alandsbanken SICAV - Nordic Growth

Class B (EUR) Kaupthing Fund - Nordic Growth

Class B (EUR) Alandsbanken SICAV - Nordic Growth

Class B (SEK) Kaupthing Fund - Nordic Growth

Class B (SEK) Alandsbanken SICAV - Nordic Growth

Class A Kaupthing Fund - Swedish Growth

Class A Alandsbanken SICAV - Swedish Growth

Class B Kaupthing Fund - Swedish Growth

Class B Alandsbanken SICAV - Swedish Growth

Luxembourg, 30 July 2010.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010102917/7/27.

Cobelfret Waterways S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 92.721.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2010.

Référence de publication: 2010072100/10.
(100084694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Colux Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.012.500,00.

Siège social: L-4384 Ehlerange, ZARE Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 133.582.

EXTRAIT

Il ressort d'un contrat de cession de parts sociales exécuté en date du 15 octobre 2009 entre Cogel S.A. et Gedial

S.A. que les soixante mille cent vingt cinq (60.125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (100,00 Euros)
chacune, représentant cent pour cent (100 %) du capital de la Société ont été transférées à la société Gedial S.A., ayant
son siège social au 23, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87002.

A compter du 15 octobre 2009, l'associé unique de la Société est Gedial S.A., ayant son siège social au 23, Avenue de

la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et enregistré au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87002.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

74713

L

U X E M B O U R G

Senningerberg, le 15 juin 2010.

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

Référence de publication: 2010070975/22.
(100084256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

FinSole S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 85.437.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 14 juin 2010.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010 comme suit:

<i>Conseil d'administration

MM. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-

xembourg, administrateur;

Benoit Dessy, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

administrateur;

Attilio Brambilla, demeurant Via Cascina Soldone n° 8, 1-20065 Inzago (Italie) administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

ComCo S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010071053/24.
(100084257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

R.S. Construction s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 17A, Gruuss-strooss.

R.C.S. Luxembourg B 131.254.

Im Jahre zweitausendzehn, den einunddreissigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine WEINANDY, mit dem Amtssitz zu Clerf,

ist erschienen

Herr Elmar Robert RÖHL, Bauunternehmer, geboren in Waimes,(Belgien), am 15.Mai 1962, wohnhaft in B-4761 Bül-

lingen, Rocherath Messeweg 11,

Welcher Komparent den handelnden Notar folgendes zu beurkunden:
Gemäss privatschriftlicher Abtretungserklärung vom 15. Januar 2010, hat Herr Erich Franz RÖHL, Rentner, geboren

in Rocherath, (Belgien), am 14.September 1936,wohnhaft in B-4761 Büllingen, Rocherath Nr. 109, ein Anteil der nach-
genannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „RS. CONSTRUCTION s.är.l." an den vorgenannten Herr Elmar RÖHL,
abgetreten.

Diese Abtretung unter Privatschrift bleibt bei dieser Urkunde beigebogen um mit ihr einregistriert zu werden
Diese Abtretung wird von dem einzigen Gesellschafter angenommen.
Herr Elmar RÖHL, vorgenannt, wird Eigentümer der ihnen somit abgetretenen Geschäftsanteile vom heutigen Tage

an und er hat Recht auf die Erträge und gewinne, welche dieser Anteil produziert, vom heutigen angerechnet.

Herr Elmar RÖHL, vorgenannt, wird in alle Rechte und Pflichten, welche mit den abgetretenen Anteilen zusammen-

hängen, eingesetzt.

Herr Elmar RÖHL, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft R.S. CONSTRUC-

TION s.àr.l. erklärt, die vorgenannten Abtretungen anzunehmen, gemäss Artikel 1690 des Code Civil.

Somit  ist  Herr  Elmar  RÖHL,  vorgenannt,  einziger  Gesellschafter  der  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  "R.S.

CONSTRUCTION s.àr.l." mit Sitz zu L - 9964 Huldange, 105, Duarrefstrooss, RCS B131254,

74714

L

U X E M B O U R G

welche Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 04. Sep-

tember 2007, veröffentlicht im Memorial C N0 2248 vom 09. Oktober 2007, Seite 107.881.

Nach dieser Abtretung stehen noch folgende Punkte auf der Tagesordnung:
1.- Abänderung von Artikel 6 Absatz 2.
2.- Verlegung des Sitzes der Gesellschaft und Anpassung des 1 Absatzes von Artikel 2 der Statuten.
3.- Verschiedenes.
Und der einzige Gesellschafter trifft folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Infolge der vorstehenden Abtretungen hat Artikel 6 Absatz 2 folgenden Wortlaut:

"Die Geschäftsanteile sind wie folgt gezeichnet: Herr Elmar RÖHL, vorbenannt, ein hundert fünfundzwanzig
Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: ein hundert fünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

<i>Zweiter und Letzter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L -9964 Huldange, Duarrefstrooss 105 nach L- 9991

Weiswampach, 17A, Grussstrooss zu verlegen und dementsprechend Artikel 2 Absatz 1 der Statuten wie folgt, umzuän-
dern:

Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach."
Die genaue Anschrift lautet "L-9991 Weiswampach, 17A, Grussstrooss".
Die Kosten dieser Urkunde gehen zu Lasten der Gesellschaft R.S. CONSTRUCTION s.àr.l.
Somit ist die Tagesordnung erschöpft.

WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, Am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Röhl, Martine Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 03 juin 2010. Relation: CLE/2010/520. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Folgt Abschrift der Annexe:
„Hiermit trete ich, Erich Röhl. geb. am 14.9.36 meinen Anteil (1) der Gesellschaft R.S. Construction Sàrl gegründet

am 04.09.07 an meinen Sohn Elmar Röhl, geb. Am 15.05.62 ab. 15.01.2010„

Gezeichnet: Röhl.

Gezeichnet: ne varietur: Röhl, Martine Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 03 juin 2010. Relation: CLE/2010/520. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Rodenbour C.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Eintragung im Firmenregister.

Clerf, den 04. Juni 2010.

Martine WEINANDY.

Référence de publication: 2010073270/62.
(100084837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Paramédical et Sécurité en abrégé P.E.S., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3238 Bettembourg, 2, rue de l'Indépendance.

R.C.S. Luxembourg B 147.419.

L'an deux mille dix, Le huit juin,
Pardevant Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,

Ont comparu:

1) Monsieur Michel BOURGEOIS, commerçant, époux de Nicole PULL, né à Orly (F) le 21 juin 1948 (n° d'identité

19480621 118), demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 15, Allée des Mérisiers,

2) Madame Nicole PULL, retraitée, épouse de Michel BOURGEOIS, née à Amnéville (F) le 15 mars 1948 (n° d'identité

19480315 149), demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 15, Allée des Mérisiers,

3)  Monsieur  Sébastien  BOURGEOIS,  responsable  commercial,  célibataire,  né  à  Thionville  (F)  le  20  mai  1973  (n°

d'identité 19730520 134), demeurant à L-3569 Dudelange, 40, rue Tattenberg,

74715

L

U X E M B O U R G

4) Monsieur Olivier BOURGEOIS, responsable technique, célibataire, né à Luxembourg le 19 novembre 1981 (n°

d'identité 19811119 213), demeurant à L-1638 Senningerberg, 4-6, rue du Golf,

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PARAMÉDICAL ET SÉCURITÉ en abrégé

P.E.S.. ayant son siège social à L-1638 Senningerberg, 4-6, rue du Golf, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro
B 147.419,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 1637 du 25 août 2009.

Les comparants agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée "PARAMÉDICAL

ET SÉCURITÉ en abrégé P.E.S.". ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution.

Les associés décident de transférer le siège social de la société "PARAMÉDICAL ET SÉCURITÉ en abrégé P.E.S.". de

L-1638 Senningerberg, 4-6, rue du Golf à L-3238 Bettembourg, 2, rue de l'Indépendance.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la

teneur suivante:

Art. 5. Premier paragraphe. Le siège social de la société est établi à Bettembourg."

<i>Frais.

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des

comparants et de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Grevenmacher, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. BOURGEOIS, N. PULL, S. BOURGEOIS, O. BOURGEOIS, J. GLODEN.

Enregistré à Grevenmacher, le 09 juin 2010. Relation: GRE/2010/1936. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier timbré aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Grevenmacher, le 15 juin 2010.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2010073255/45.
(100085055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Mediapart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 53.473.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010071167/9.
(100084255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Portalis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.082.

<i>Décision unanime de l'assemblée générale des actionnaire dûment convoquée et tenue à Luxembourg le 14 juin 2010 à 17 heures

L'Assemblée Générale DECIDE, dans le cadre des élections statutaires, de renouveler les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes comme suit:

<i>Conseil d'Administration:

4. Stephan LE GOUEFF, né le 14/12/1958 à Montréal, Canada, avec adresse professionnelle au 124, Boulevard de la

Pétrusse, L - 2330 Luxembourg

74716

L

U X E M B O U R G

5. Sabine PERRIER, née le 22/04/1959 à Thionville, France, avec adresse au 5, chemin du Colombier, F - 57100 Thionville

et

6. Maunder Investments Corporation, IBC N° 451.957 auprès du Companies' Register des Iles Britanniques Vierges,

avec siège social à Road Town, Tortola, B.V.I. et dont le représentant mandaté est Stephan LE GOUEFF sus-nommé.

<i>Commissaire Aux Comptes:

- Stéphanie BARTOLOZZI-CATTANEO, née le 3 juin 1971 à Metz, avec adresse 12, Rue Salvador Allende à F - 54650

Saulnes.

Les mandats des administrateurs composant le conseil d'administration et du commissaire aux comptes prendront fin

à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2015 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2014.

Pour Extrait sincère et conforme
<i>Signature
Le Conseil l'Administration

Référence de publication: 2010071203/25.
(100084275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Recherche et Investissements Internationaux, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 32.561.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour "RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX", en abrégé "R.I.I. S.A."
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010071216/11.
(100084273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Belrose Properties, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 84.183.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société BELROSE PROPERTIES qui s'est tenue en

date du 3 mai 2010 que:

1. Mr. Miguel MUNOZ, avec adresse professionnelle au 4 avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, a été nommé comme

Administrateur de la société avec effet à ce jour, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016, en
remplacement de Mademoiselle Nadine HIRTZ, démissionnaire.

2. Mme Rita ISRAM, avec adresse professionnelle au 24 avenue de Grande Bretagne, MC 98000 Monaco, a été nommée

comme Administrateur additionnel de la société avec effet à ce jour, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra
en 2016.

Luxembourg, le 3 mai 2010.

Pour Extrait conforme

Référence de publication: 2010072052/18.
(100085491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Smart Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.967.

Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

74717

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 juin 2010.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2010071251/13.
(100084219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 884.247.079,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 143.975.

La société RBC cees Nominees Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 3PB JERSEY, 19-21 Broad Street, St.

Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 83756 a transféré, en date
du 26 mars 2010 en vertu de deux contrats de cessions de parts sociales:

- 217.392 parts sociales D de la Société à la société RBC Trustees (Cl) Limited dont le siège social est situé à GB - JE1

1PB JERSEY, La Motte Chambers, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le
numéro 11033;

- 36.232 parts sociales D de la Société à la société RBC Trustees (CI) Limited dont le siège social est situé à GB - JE1

1PB JERSEY, La Motte Chambers, St. Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le
numéro 11033;

Soit au total : 253.624 parts sociales D
A la suite des cessions décrites ci-dessus:
- la société RBC cees Nominees Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 3PB JERSEY, 19-21 Broad Street, St.

Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 83756 détient désormais
8.949.105 parts sociales D; et

- la société RBC Trustees (CI) Limited dont le siège social est situé à GB - JE1 1PB JERSEY, La Motte Chambers, St.

Helier, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Jersey sous le numéro 11033 détient 297.973 parts
sociales D et 1 part sociale T de la Société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 15 Juin 2010.

Référence de publication: 2010071266/27.
(100084164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Lola Luxembourg Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.014.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanvern, en date

du 25 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1534 du 20 juin 2008.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lola Luxembourg Manager S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010072220/14.
(100085501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Air Terminal Publicity Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Luxembourg-Findel, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 98.952.

<i>Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie de manière anticipée en date du 3 juin 2010

L'an deux mille dix, le trois juin, à onze heures, les actionnaires de la société AIR TERMINAL PUBLICITY LUXEM-

BOURG  S.A.  se  sont  réunis  en  assemblée  générale  ordinaire,  réunie  extraordinairement  de  manière  anticipée  sur
demande du conseil d'administration, au siège social et ont pris les décisions suivantes:

74718

L

U X E M B O U R G

L'assemblée prend note de la démission de Madame REGOUT Anita de son poste d'administrateur à dater de ce jour.
Est nommé en remplacement de Madame REGOUT Anita, Monsieur THIBOU Philippe, consultant, domicilié Avenue

Jules Gathy, 15 B-1390 Grez-Doiceau.

Monsieur THIBOU Philippe reprend et poursuit le mandat de l'administrateur démissionnaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

Luxembourg, le 3 juin 2010.

Les actionnaires:
Philippe Vastapane / Marc van Canneyt / Philippe Thibou
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2010071759/20.
(100084074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Cheval Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 121.087.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2010.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010071783/12.
(100084201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Mediterranean Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 133.299.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 07 juin 2010

que:

1. A démissionné de son poste de Commissaire aux comptes avec effet immédiat:
- Montbrun Révision Sàrl, immatriculée au RCS sous le N° B 67.501, sise «Le Dôme», Espace Pétrusse, 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

2. A été élue au poste de Commissaire aux comptes:
- CHESTER &amp; JONES Sàrl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le N° B 120.602, sise au 165A route de Longwy,

L-4751 Pétange.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2012.
3. Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat:
Du 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
Au: 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2010072237/22.
(100084668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

ChipPAC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 69.052.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

74719

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010071784/12.
(100084227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

FBP Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 97.405.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2010.

<i>Pour FBP FUNDS SICAV
Banque Degroof Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Jean-Michel GELHAY / Martine VERMEERSCH
<i>Directeur / Sous-Directeur

Référence de publication: 2010071831/15.
(100084075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Remora Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 79.644.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 11 juin 2010 sur l'exercice 2009 à Luxem-

<i>bourg

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à

échéance.

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année

2016 comme suit:

Monsieur Guillaume Nogacki, administrateur, avec adresse à L-1459 Luxembourg, 4, Côte d'Eich.
Monsieur Patrice Silverio, administrateur, avec adresse à L-6919 Roodt-sur-Syre, 32, A Millesch.
Monsieur Raymond Henschen, administrateur, avec adresse à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs-délégués jusqu'à l'assemblée générale de

l'année 2016 comme suit:

Monsieur Guillaume Nogacki, administrateur-délégué, avec adresse à L-1459 Luxembourg, 4, Côte d'Eich.
Monsieur Patrice Silverio, administrateur-délégué, avec adresse à L-6919 Roodt-sur-Syre, 32, A Millesch.
Les administrateurs-délégués peuvent engager la société par leur seule signature.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale de

l'année 2016 comme suit:

Fiduplan S.A., RCS B-44.563, avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2010071946/27.
(100084160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Gebi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 108.844.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

74720

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010071840/12.
(100084245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Kronospan Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 110.195.900,00.

Siège social: L-4902 Sanem, Z.I. Gadderscheier.

R.C.S. Luxembourg B 116.516.

Le bilan consolidé ainsi que le rapport de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises au 30 septembre 2009 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010071868/12.
(100084233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Dexia Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.307.

Le Conseil d'administration du 1 

er

 juin 2010 a nommé M. Philippe Rucheton comme administrateur de Dexia Banque

Internationale à Luxembourg en remplacement de M. Jean-Luc Dehaene, administrateur démissionnaire au 10 mai 2010.

La composition du Conseil d'administration de Dexia BIL se présente comme suit:

Nom

Fonction

Adresse professionnelle

François Narmon

Président

11 place Rogier B-1210 Bruxelles

Gaston Schwertzer

Vice-président

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Frank Wagener

Administrateur

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Stefaan Decraene

Administrateur

44 boulevard Pachéco B-1000 Bruxelles

Jean Duschène

Administrateur

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Fernand Fischer

Administrateur

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Pierre Mariani

Administrateur

11 place Rogier B-1210 Bruxelles

Joseph Mertz

Administrateur

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Luc Onclin

Administrateur

44 Suikerbergstraat B-1700 Sint-Martens-Bodegem

Philippe Rucheton

Administrateur

11 place Rogier B-1210 Bruxelles

Serge Schimoff

Administrateur

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

René Steichen

Administrateur

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Donny Wagner

Administrateur

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2010.

Dexia Banque Internationale à Luxembourg
Société anonyme
Jean-Paul Putz / Simone Wallers
<i>Attaché de direction / Manager

Référence de publication: 2010074475/30.
(100085514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Kalos International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 115.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

74721

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010071870/12.
(100084246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Kerafin Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 89.253.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010071871/12.
(100084252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Pimco Emerging Markets Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 147.952.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

À Luxembourg, le 14 juin 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010071932/11.
(100084240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

TMCZ Holdco II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: CZK 379.764,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 121.872.

<i>Extrait de résolution écrite prise par l'associé unique en date du 4 juin 2010.

<i>Résolution:

Le mandat du reviseur d'entreprises venant à échéance, l'associe unique décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010:

<i>Réviseur d'entreprises:

KPMG Audit S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour extrait conforme
TMCZ Holdco II (Lux) S.à r.I.
Société à responsabilité limitée
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2010072326/19.
(100084661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Presto Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 33, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 98.769.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

74722

L

U X E M B O U R G

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
Signature

Référence de publication: 2010071935/11.
(100084279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Sun Sea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 87.046.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010071972/12.
(100084247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Top Tone Media S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.257.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2010.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010071991/12.
(100084209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

F&amp;C Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 122.163.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2010, les actionnaires de la société F&amp;C Management Luxembourg

S.A. ont pris les résolutions suivantes:

- Réélection des membres du conseil d'administration de la société. Désormais, le conseil d'administration de la société

est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2010:

* Ben Kramer
* Hugh Cameron Moir
* Joäo Santos
- Renouvellement du mandat de KPMG Audit en leur fonction de réviseur d'entreprise de la société pour une durée

d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 15 juin 2010.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2010073107/19.
(100085463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.793.243.400,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 90.028.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

74723

L

U X E M B O U R G

Thierry Lenders / Lennart Stenke
<i>Manager-Gérant / Manager

Référence de publication: 2010072003/12.
(100084220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

Zopal, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.431.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2010.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010072007/12.
(100084211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2010.

A Klosen, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6170 Godbrange, 4, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 146.136.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010072009/9.
(100085545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Avestus Real Estate (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Quinlan Private Golub (Luxembourg) S.à. r.l.).

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 102.423.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 16 juin 2010.

Référence de publication: 2010072014/11.
(100085552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

FHFA Center II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 148.036.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1 

<i>er

<i> mars 2010

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 01 mars 2010, que:
Après avoir constaté que Monsieur Edouard GEORGES s'est démis de ses fonctions d'administrateur, en date du 1

er

 mars 2010, les administrateurs restants ont décidé, conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, de coopter Monsieur Jérôme WUNSCH, employé privé, né le 14 juillet 1959 à Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte, comme administrateur de la Société, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Edouard
GEORGES, administrateur démissionnaire, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

74724

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 2 mars 2010.

FHFA CENTER II S.A.
Dr. Peter HAMACHER / Jérôme WUNSCH
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010072154/21.

(100085469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Atraxis Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 87.687.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue annuelle au siège social de la société le 1 

<i>er

<i> juin 2010 à 10.30 heures

L'Assemblée ratifie la démission de Mr. Kamarowsky, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371

Luxembourg, de son mandat d'Administrateur.

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Picco Edoardo, entrepreneur, né le 17/05/1961 à Vercelli (Italie), et

résidant au 23, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg en tant que nouvel administrateur. Le nouvel Administrateur
terminera le mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'assemblé générale statutaire qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2010.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2010072043/17.

(100084648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Axel Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 52, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 71.746.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010072048/9.

(100085536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Carnaz Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 119.006.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 28 mai 2010

L'Assemblée ratifie la démission de Mr. Kamarowsky, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371

Luxembourg, de son mandat d'Administrateur.

L'assemblée ratifie la cooptation de Madame Angelina Scarcelli, née le 13/09/1975 à Thionville, France, avec adresse

professionnelle au 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg en tant que nouvel administrateur. Le nouvel Administrateur
terminera le mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'assemblé générale statutaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 28/05/2010.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2010072083/17.

(100084649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

74725

L

U X E M B O U R G

Atrio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 51.442.

EXTRAIT

Il résulte de la cession de parts intervenue en date du 1 

er

 avril 2010 que:

Monsieur Patrick VAN CAUTER, demeurant au 23, Pieter Gorusstraat, B - 9240 Zele, a cédé 1 (une) part sociale qu'il

détenait dans la société ATRIO S. à r. l., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg à
BDO Tax &amp; Accounting, Société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 147 571, ayant son siège social au 2, avenue Charles de
Gaulle, L - 1653 Luxembourg.

Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société ATRIO S. à r. I. en date du 1 

er

 avril 2010 conformément

à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, le capital social de la société ATRIO S. à r. I. est détenu comme suit:
BDO Tax &amp; Accounting, Société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 147 571, ayant son siège social au 2, avenue Charles

de Gaulle, L -1653 Luxembourg: 597 parts sociales

Monsieur Michel GRIGNARD, demeurant au 31, rue Jean Gome, B - 4802 Heusy: 1 part sociale
Monsieur André KILESSE, demeurant au 22, Croix Henes, B - 4630 Soumagne: 1 part sociale
Monsieur Félix FANK, demeurant au 104A, route de la Ferme Modèle, B - 4800 Verviers: 1 part sociale

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010072046/24.
(100085563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Pecundria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 139.417.

L'an deux mil dix, le six mai.
Pardevant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société Severgnini Family Office Srl en sa qualité de trustee de THE SCHIGHERA TRUST, établie et ayant son siège

social à i-20123 Milano, Via Camperio 9,

Ici représentée par Mr Xavier MANGIULLO, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg,5, Avenue

Gaston Diderich en vertu d’une procuration datée du 6 mai 2010, jointe en annexe au présent acte.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être l’actionnaire unique de la société dénommée PE-

CUNDRIA S.A. une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diederich, inscrite au R.C.S.
à Luxembourg sous la section B et le n°139.417, constituée suivant acte reçu par le nota ire soussigné en date du 23 mai
2008, publié au Mémorial C n°1688 du 9 juillet 2008, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date
du 16 novembre 2009, publié au Mémorial C n°75 du 19 janvier 2010.

Ensuite le comparant, es-qualité qu’il agit, déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l’actionnaire unique, détenant l'intégralité du capital social de EUR 32.000 (trente-deux mille euros), est dûment

représentée à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant
1. To resolve on starting the procedure of the winding up of the company;
2. To resolve in order to appoint Mr Marco Sterzi as liquidator of the company and to determine his powers;
3. Miscellaneous.
L’actionnaire unique a ensuite pris les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'actionnaire unique décide la dissolution et la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

74726

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, Monsieur Marco STERZI, conseil économique, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 5, Avenue Gaston Diderich.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.
Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous
sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale
des associés

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 1.500.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu au comparant en langue française, connue du comparant, ce dernier, connu du notaire

par nom, prénom, état et demeure, a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: X. MANGIULLO, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 12 mai 2010, LAC/2010/21329: Reçu douze Euros (EUR 12.-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme  délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Com-

merce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 17 juin 2010.

Référence de publication: 2010073622/53.
(100085952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2010.

Pygmalux Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 82.414.

DISSOLUTION

L'an deux mil dix, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Frédéric SICCHIA, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard

Emmanuel Servais,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de LOGIN CONSULTANTS LTD, ayant son siège à Suite 13, First Floor,

Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, République des Seychelles,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 16 avril 2010.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société PYGMALUX DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, Boulevard Em-

manuel Servais, a été constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1163 du 14 décembre 2001 et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce
jour;

- que le capital social de la société PYGMALUX DEVELOPMENT S.A. s'élève actuellement à trente-et-un mille euros

(31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (100,- EUR) chacune entièrement libérées;

- que LOGIN CONSULTANTS LTD précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution

anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 16 avril 2010,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

74727

L

U X E M B O U R G

- l’activité de la Société a cessé;
- l’actionnaire unique est investie de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du

passif de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 16 avril 2010 étant seulement
un des éléments d’information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société PYGMALUX DEVELOPMENT S.A. est à considérer comme

accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L2535 Luxembourg,

16, Boulevard Emmanuel Servais.

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,

état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. SICCHIA, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 avril 2010. Relation: LAC/2010/18482. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2010.

Référence de publication: 2010073634/53.
(100085816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2010.

Eurotruck (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 43.204.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix.
Le dix-huit mai.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU

Monsieur Wawrzyniec WAWRZYNOWSKI, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 29, avenue

des Papalins,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange, agissant

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes.

La prédite mandataire, agissant ès-qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:
- que son mandant est seul propriétaire de toutes les actions de la société anonyme holding EUROTRUCK (LUXEM-

BOURG) S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, Avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 43.204,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 mars 1993, publié au Mémorial C

numéro 255 du 29 mai 1993,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 décembre

1995, publié au Mémorial C numéro 88 du 20 février 1996,

dont le capital social a été converti en euros aux termes d'une assemblée générale sous seing privé en date du 12 avril

2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 14 du 03 janvier 2002.

Que  le  capital  social  est  fixé  à  TROIS  CENT  SOIXANTE-QUINZE  MILLE  EUROS  (€  375.000,-),  représenté  par

QUINZE MILLE (15.000) ACTIONS d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune,

- que son mandant décide de dissoudre ladite société;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique, son mandant reprend tout l'actif à son compte;

74728

L

U X E M B O U R G

- que son mandant reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu'il assume pour autant

que de besoin, la qualité de liquidateur;

- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite

société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire de la

personne  comparante,  le  présent  acte  est  rédigé  en  française  suivi  d’une  version  anglaise.  A  la  requête  de  la  même
personne et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et

prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and ten, on the eighteenth day of May.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

M. Wawrzyniec WAWRZYNOWSKI, "the mandator", company director, residing in MC-98000 Monaco, 29, avenue

des  Papalins,  here  represented  by  Mrs  Sofia  AFONSO-DA  CHAO  CONDE,  ("the  proxyholder"),  private  employee,
residing in Differdange, by virtue of a proxy given under private seal, here annexed.

Such proxyholder, acting in that capacity, has requested the undersigned notary to state:
-That the mandator is the sole owner of all the issued shares of the public limited liability company (“société anonyme”)

EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 43,204,
incorporated by a deed of the undersigned notary, dated March 10 

th

 , 1993, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, under number 255 dated May 29 

th

 , 1993, and which bylaws have been amended by a deed of

the undersigned notary, dated December 20 

th

 , 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

under number 88 dated February 20 

th

 , 1996,

which the corporate capital was converted in euro by an extraordinary meeting held under private seal on April 12

th

 , 2000, an extract is published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 14 dated January

rd

 , 2002,

that the Company’s share capital is set at THREE HUNDRED SEVENTY-FIVE THOUSAND EURO (€ 375,000.-)

represented by FIFTEEN THOUSAND (15,000) SHARES with a par value of TWENTY-FIVE EURO (€ 25.-) each,

- that the mandator requested the dissolution of the company,
- that all the liabilities have been settled or duly provisioned;
- that as sole shareholder, the mandator takes over all the assets;
- that the mandator takes over all eventual liabilities, even if unknown at the time, and that he will act as liquidator if

required;

- that the liquidation of the company can be considered as definitely closed;
- that discharge is granted to the directors and the auditor,
- that the books, registers and documents of the company will be kept five years at the address of the registered office.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of

the above appearing person, the present deed is worded in French, followed by a English version. On request of the same
person and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevaile.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his full

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Signé: Conde, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 mai 2010. Relation: EAC/2010/6175. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

74729

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010073481/83.
(100086007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2010.

Resma (Restaurant Management) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 24.387.

Le Bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15/06/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010073279/10.
(100084801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

RINNEN Constructions Générales S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9946 Binsfeld, 25, Ëlwenterstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.657.

Statuts coordonné suivant acte du 17 novembre 2009, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Urbain THOLL
<i>Notaire

Référence de publication: 2010073282/12.
(100084730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Novalis Real Estate Holding, Société Anonyme,

(anc. Mare Holding S.A.).

Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 108.188.

L'an deux mille dix, le douze mai.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVALIS REAL ESTATE

HOLDING (anc. MARE HOLDING S.A.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B108.188,
avec siège social à L-5752 Frisange, 4b, um Hau, constituée suivant acte du notaire Henri HELLINCKX de Mersch du 11
mai 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 1005 du 7 octobre 2005, modifiée
suivant acte du notaire instrumentant en date du 20 septembre 2007, pubblié au dit Memorial C, numéro 2509 du 6
novembre 2007.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Wolfgang KITZ, dirigeant de société, demeurant professionnellement

à Remich,

qui désigne comme secrétaire Awais Habbibullah KHAN, commerçant, demeurant à Mannheim (Allemagne).
L'Assemblée choisit comme scrutateur Marc KERNEL, expert-comptable, demeurant à Remich.
Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de Frisange à Remich, et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des

statuts.

2. Fixation de l'adresse.
3. Révocation du conseil d'administration.
4. Nomination d'un nouveau conseil d'administration.
5. Révocation de l'administrateur-délégué.
6. Nomination d'un nouvel administrateur-délégué.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

74730

L

U X E M B O U R G

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Frisange à Remich, et par conséquent de modifier le premier alinéa

de l'article 2 des statuts comme suit:

Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Remich."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée fixe l'adresse à L-5532 Remich, 6, rue Enz.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de révoquer le conseil d'administration en fonction, à savoir les sociétés AGENDA ADVISORS

CORP., OVERCLEAR DEVELOPMENT INC, et Waldemar Ernst LUSTIG.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer administrateurs:
- Wolfgang KITZ, dirigeant de sociétés, demeurant professionnellement à L-5532 Remich, 6, rue Enz,
- Frank SIMON, comptable, demeurant professionnellement à L-5532 Remich, 6, rue Enz.
- Marc KERNEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-5532 Remich, 6, rue Enz.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de révoquer l'administrateur-délégué, Waldemar Ernst LUSTIG, retraité, demeurant à D-76287

Rheinstetten, Kriegstrasse 12.

<i>Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée nomme administrateur-délégué, Wolfgang KITZ, dirigeant de société,

demeurant professionnellement à L-5532 Remich, 6, rue Enz.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: KITZ, KHAN, KERNEL, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 18 mai 2010. REM 2010 / 665. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 17 juin 2010.

Référence de publication: 2010073600/69.
(100085853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2010.

QSpace SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 147.577.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010072278/9.
(100084678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

74731

L

U X E M B O U R G

AxoGlia Therapeutics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1316 Luxembourg, 2A, rue des Carrières.

R.C.S. Luxembourg B 114.310.

L'an deux mille dix, le dix-neuf juin.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AXOGLIA THERAPEUTICS

S.A.", avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 7 février 2006, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 932 du 12 mai 2006, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 20 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
1816 du 28 août 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul SCHEUREN, indépendant, demeurant à L-1316 Lu-

xembourg, 2a, rue des Carrières.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Djalil COOWAR, chercheur, demeurant à Zouftgen.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick MOES, salarié, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que sur 136.334 actions émises, 99.201 actions sont présentes ou repré-

sentées  à  la  présente  assemblée  générale  extraordinaire,  à  laquelle  tous  les  actionnaires  se  considèrent  valablement
convoqués par courrier recommandé envoyé à tous les actionnaires en date du 11 mai 2010. La présente assemblée,
représentant l'intégralité du capital social, peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital autorisé pour porter le capital social de EUR 186.334.- à EUR 280.000.- et pouvoirs au

Conseil d'Administration pour réaliser des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé et notamment le
pouvoir de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital autorisé pour porter le capital social autorisé de EUR 186.334.- (cent quatre-

vingt-six mille trois cent trente-quatre euros) à EUR 280.000.- (deux cent quatre-vingt-mille euros).

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration établi en conformité avec l'article 32-3(5) de la loi sur les

sociétés commerciales, l'Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser des augmentations
de capital dans le cadre du capital autorisé et notamment le pouvoir de supprimer ou limiter le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit:
"Le capital social est fixé à EUR 136.334.- (cent trente-six mille trois cent trente-quatre euros) représenté par 136.334

(cent trente-six mille trois cent trente-quatre) actions d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté à EUR 280.000.- (deux cent quatre-vingt mille euros) par la création

et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

74732

L

U X E M B O U R G

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

qu'avec l'agrément unanime des autres actionnaires.

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer les autres actionnaires par lettre recom-

mandée en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et domicile des
cessionnaires proposés.

Les actionnaires auront alors pendant le délai de trois mois un droit de préemption pour le rachat des actions dont

la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun des ac-
tionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires par lettre recom-

mandée dans les trois mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de
préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces actions sera déterminé, de commun accord entre l'actionnaire cédant et le

ou les actionnaire(s) acquéreur(s), et à défaut d'accord par un expert indépendant désigné par le tribunal de commerce.

En cas de refus des actionnaires d'acquérir les actions proposées ou en cas de non réponse de leur part dans le délai

imparti, l'actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. SCHEUREN, D. COOWAR, P. MOES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mai 2010. Relation: LAC/2010/23322. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 14 juin 2010.

Henri HELLINCK.

Référence de publication: 2010072992/92.
(100085025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

KFDS, KNEIP Fund Distribution Support S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Lombard Fund Services S.à r.l.).

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 47.094.

In the year two thousand and ten, on the twelfth day of May,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared

Kneip Communication S.A., a société anonyme having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, in Luxembourg under number B 45.747,

here represented by Mr Antonello Argenziano, private employee, residing professionally at 26-28, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 10 May 2010.
Said proxy, after ne varietur signature by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

74733

L

U X E M B O U R G

The appearing party is the sole shareholder of Lombard Fund Services S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité

limitée having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial
deed dated 24 March 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial")
of 7 July 1994, number 265 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number
B 47.094.

The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed

of the undersigned notary dated 23 March 2009, published in the Mémorial number 1136 of 9 June 2009.

The appearing party, represented as stated above, declared and requested the notary to record that:
1. The sole shareholder holds all one hundred and twenty-five (125) shares in issue in the Company, so that decisions

can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
1) Modification of the denomination of the Company into KNEIP Fund Distribution Support S.à r.l.;
2) Subsequent modification of article 4 of the articles of incorporation of the Company.
The sole shareholder then takes the following decisions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the denomination of the Company into KNEIP Fund Distribution Support S.à

r.l..

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder resolves to amend article 4 of the Articles which

shall henceforth read as follows:

Art. 4. La société prend la dénomination de KNEIP Fund Distribution Support S.à r.l., en abrégé "KFDS"."

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at one thousand euro (EUR 1,000).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

person, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French versions, the French version will prevail.

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date stated at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le douze mai,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

a comparu

Kneip Communication S.A., une société anonyme ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Lu-

xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 45.747,

ici représentée par Monsieur Antonello Argenziano, employé privé, demeurant professionnellement au 26-28, rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 mai 2010.
La procuration restera, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, annexée au présent acte

pour être enregistrée en même temps.

La comparante est l'associé unique de Lombard Fund Services S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 24
mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 7 juillet 1994, numéro
265 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 47.094.

Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 23 mars

2009, publié au Mémorial numéro 1136 du 9 juin 2009.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare et prie le notaire d'acter que:
- l'associé unique détient la totalité des cent vingt-cinq (125) parts sociales émises par la Société, si bien que des

décisions peuvent valablement être prises sur les points portés à l'ordre du jour.

- les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1) Changement de la dénomination de la Société en KNEIP Fund Distribution Support S.à r.l.;

74734

L

U X E M B O U R G

2) Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société. L'associé unique prend ensuite les décisions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société en KNEIP Fund Distribution Support S.à r.l..

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des Statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

Art. 4. La société prend la dénomination de KNEIP Fund Distribution Support S.à r.l., en abrégé "KFDS"."

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société en raison du

présent acte sont évalués à mille euros (EUR 1.000).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande du même comparant, et en cas de divergence
entre la version anglaise et la version française, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. ARGENZIANO et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2010. LAC/2010/22095. Reçu soixante quinze euros €75,-

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010073209/92.
(100084809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Inhalux, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 35.678.

L'an deux mille dix, le trente-et-un mai.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  "INHALUX",  (ci-après  la

"Société"), ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, Avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 35678, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 204 du 6 mai 1991, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant résolutions
des actionnaires prises en date du 02 juillet 2001, publié par extrait au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 107 du 21 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John WEBER, conseil fiscal, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guy LANNERS, expert-comptable, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc HILGER, employé privé demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

74735

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l'article 5 (Alinéa 6) des statuts pour lui donner la teneur suivante: "Les actions sont nominatives

ou au porteur, au choix de l'actionnaire".

2) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 6 de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire".

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire.

Signé: J. WEBER, G. LANNERS, L. HILGER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juin 2010. LAC/2010/24799. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au R.C.S. Luxembourg.

Luxembourg, le 11 juin 2010.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2010074702/55.
(100085871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2010.

Rossa Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.755.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 07 juin 2010

que:

1. A démissionné de son poste de Commissaire aux comptes avec effet immédiat:
- Montbrun Révision Sàrl, immatriculée au RCS sous le N° B 67.501, sise «Le Dôme», Espace Pétrusse, 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

2. A été élue au poste de Commissaire aux comptes:
- CHESTER &amp; JONES Sàrl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le N° B 120.602, sise au 165A route de Longwy,

L-4751 Pétange.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2012.
3. Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat:
Du 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
Au: 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2010072294/22.
(100084673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

74736


Document Outline

Air Terminal Publicity Luxembourg S.A.

A Klosen

Atraxis Immobilière S.A.

Atrio S.à r.l.

Avestus Real Estate (Luxembourg) S.à r.l.

Axel Finance S.A.

AxoGlia Therapeutics S.A.

Belrose Properties

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.

Cargill International Luxembourg 7 S. à r.l.

Carnaz Luxembourg S.A.

Cheval Luxembourg S.à r.l.

ChipPAC Luxembourg S.à r.l.

CMH Vertriebs Service I GmbH

CMH Vertriebs Service I GmbH &amp; Co KG

Cobelfret Waterways S.A.

Colux Real Estate S.à r.l.

cominvest Best-in-One

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

Euro Floor

Eurotruck (Luxembourg) S.A.

FBP Funds Sicav

F&amp;C Management Luxembourg S.A.

FHFA Center II S.A.

Financière E2 S.à r.l.

Financière Figaro S.à r.l.

FinSole S.A.

Gebi S.A.

Inhalux

Kalos International S.A.

Kaupthing Fund

Kerafin Group S.A.

KNEIP Fund Distribution Support S.à r.l.

Kronospan Luxembourg Holdings S.à r.l.

Lola Luxembourg Manager S.à r.l.

Lombard Fund Services S.à r.l.

Mare Holding S.A.

Mediapart S.A.

Mediterranean Estate S.A.

Metro Investment Luxembourg S.à r.l.

Novalis Real Estate Holding

Paramédical et Sécurité en abrégé P.E.S.

Pecundria S.A.

Pimco Emerging Markets Funds

Portalis S.A.

Presto Consulting S.A.

Pygmalux Development S.A.

QSpace SPF

Quinlan Private Golub (Luxembourg) S.à. r.l.

Recherche et Investissements Internationaux

Remora Investment S.A.

Resma (Restaurant Management) S.A.

RINNEN Constructions Générales S.àr.l.

Rossa Real Estate S.A.

R.S. Construction s.à r.l.

Smart Fund

Sun Sea S.A.

Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl

TMCZ Holdco II (Lux) S.à r.l.

Top Tone Media S.A.

VSP Holdings S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l.

Zopal