This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1918
2 octobre 2009
SOMMAIRE
agri.capital Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
92056
Beltaj Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92020
Biodev S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92018
Brossia Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
92023
Clavadel Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92023
Clavadel Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92027
CTS Coating Technology System S.A. . . .
92043
Dancing de la Place S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
92020
Downshire Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . . .
92025
Emerald S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92024
EPI - European Property Investment S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92026
Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
92024
Eridanus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92025
Euro-Getränke A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92026
European Media Ventures S.A. . . . . . . . . . .
92023
Fiduciaire Denis Bossicart S.à r.l. . . . . . . . .
92028
Fifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92019
Fortunae S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92033
Francap S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92027
Fullmotion Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
92057
Fullmotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92057
Grouwen-A-Feldbunn S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
92021
Haken Lighthouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92019
HAZ Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92036
International Terry Company S.à.r.l. . . . . .
92018
Jing Tai S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92022
Kaiserkarree S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92045
KBC Financial Indemnity Insurance . . . . . .
92063
KC Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92018
Labeo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92018
Lagfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92023
LDR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92019
Luxdiam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92055
Maison Rideaux Thibeau, S.à r.l. . . . . . . . . .
92021
Martin Pecheur Investments Limited . . . .
92030
Maxilly Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92019
New CV Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92056
Nexia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92064
NG Luxembourg 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
92047
Notola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92019
Opportunity Fund III (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92024
Pepsi-Cola Belgium S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
92026
P.R. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92022
Réidener Spënnchen S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
92021
Restaurant Chinois YONG-HONG S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92022
RREP Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
92036
S.A.F. Services Anti-Feu . . . . . . . . . . . . . . . .
92027
Schneppelstuff s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92021
S.E.F. Luxemburg Holding S.A. . . . . . . . . . .
92026
Sigma Capital Hospitality, Leisure and
Tourism Holding Company S.A. . . . . . . . .
92050
Soluxcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92018
Stratus Packaging Europe . . . . . . . . . . . . . . .
92020
Strongbow Capital Holdings S.A. . . . . . . . .
92025
Tarinech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92025
Topglas Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
92064
Trading Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92020
Unicapital Investments V (Management)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92027
VAN-Electronic A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92026
Waasserkraaft Wampach, s.à r.l. . . . . . . . .
92027
Westbridge S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92024
Z Alpha S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92022
92017
Biodev S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 116.536.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009114388/10.
(090137799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.
International Terry Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 19.739.
Le bilan au 30 juin 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009114389/10.
(090137438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.
Soluxcom, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.169.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009114382/10.
(090137441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.
Labeo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 87.032.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009114381/10.
(090137792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.
KC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 498.186,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 135.906.
Les comptes annuels pour la période du 28 décembre 2007 au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KC Lux S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009116115/14.
(090139294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
92018
Haken Lighthouse, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 80.659.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04.09.09.
Signature.
Référence de publication: 2009116124/10.
(090139315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Maxilly Estate S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 138.473.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009116125/10.
(090139316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Fifin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 66.050.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009116126/10.
(090139258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Notola S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 104.369.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/09/09.
Signature.
Référence de publication: 2009116123/10.
(090139312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
LDR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 51.524.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 juillet 2009 que:
- Monsieur Thierry JACOB, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy (F), demeurant professionnellement 25, avenue
de la Liberté, L-1931 à Luxembourg.
Est coopté, avec effet au 30 juillet 2009, en tant qu'Administrateur, pour achever le mandat de Monsieur Armando
CESA, Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 28 juillet 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009116140/14.
(090139504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
92019
Beltaj Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 51.882.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2009.
Beltaj Finance S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Référence de publication: 2009116127/15.
(090139264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Trading Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 101.824.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116121/10.
(090139309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Dancing de la Place S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 223, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 21.040.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2009116112/10.
(090139292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Stratus Packaging Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 56.657.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 juillet 2009 que:
1. L'Assemblée accepte la démission de la société F.G.S. Consulting LLC de son poste de Commissaire.
2. L'Assemblée décide de nommer en remplacement du Commissaire démissionnaire, la société BF Consulting S.à r.l.,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B 125.757 et ayant son siège social au 1, Val
Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le mandat du nouveau Commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au
31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2009.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2009116116/19.
(090139363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
92020
Grouwen-A-Feldbunn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5318 Contern, 10, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 99.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2009116157/14.
(090139411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Maison Rideaux Thibeau, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9205 Diekirch, 15, rue Saint Antoine.
R.C.S. Luxembourg B 100.512.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2009116156/14.
(090139414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Schneppelstuff s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9150 Eschdorf, 6, An der Huuscht.
R.C.S. Luxembourg B 105.884.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2009116154/14.
(090139419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Réidener Spënnchen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 59, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 104.631.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 7 septembre 2009.
<i>Pour la société
i>KIEFFER Romain
Référence de publication: 2009116158/12.
(090139378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
92021
Jing Tai S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4742 Pétange, 59, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 94.924.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116106/10.
(090139281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Z Alpha S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 120.935.
RECTIFICATIF
Suite à une erreur matérielle survenue dans l'assemblée générale annuelle datée du 29 octobre 2009, déposée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 5 février 2009, sous la référence L090019935, les actionnaires
ont pris les décisions suivantes:
- acceptation de la cooptation de Julian Huxtable, avec adresse professionnelle 45, Pall Mall, SW1Y 5JG Londres,
Royaume-Uni, au mandat d'administrateur DH, avec effet au 22 septembre 2008, pour une période arrivant à échéance
lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011
et qui se tiendra en 2012.
- acceptation de la cooptation de Claus Felder, avec adresse professionnelle au 2, Platz der Einheit, 60327 Francfort,
Allemagne au mandat d'administrateur DH, avec effet au 25 septembre 2008, pour une période arrivant à échéance lors
de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et
qui se tiendra en 2012
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009116111/21.
(090139329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Restaurant Chinois YONG-HONG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 2, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 40.548.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116105/10.
(090139276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
P.R. International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 56.664.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue en date du 4 juin 2009 a approuvé la résolution suivante:
Les mandats de Monsieur Eric Di Duca en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué sont renouvelés pour
une période de cinq ans.
Ceux-ci prendront fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2014.
Luxembourg, le 4 juin 2009.
Anne Compère.
Référence de publication: 2009116144/13.
(090139280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
92022
Clavadel Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 60.099.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009116152/10.
(090139232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
European Media Ventures S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 46.560,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 75.524.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle Ajournée datée du 24 août 2009 que:
- Le mandat des administrateurs actuels, M. Peter E. Gerwe, M. Jan Obrman, M. Bart Zech et M. George E. Collins est
renouvelé pour une période de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2009.
Frank Walenta.
Référence de publication: 2009116146/13.
(090139261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Lagfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 51.599.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 juillet 2009 que:
- Monsieur Thierry JACOB, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy (F), demeurant professionnellement 25, avenue
de la Liberté, L-1931 à Luxembourg.
Est coopté, avec effet au 30 juillet 2009, en tant qu'Administrateur, pour achever le mandat de Monsieur Armando
CESA, Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 28 juillet 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009116141/14.
(090139502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Brossia Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 99.387.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 17 août 2009i>
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique accepte la démission de Eddy DÔME de son poste de gérant de la Société avec effet au 31 août 2009.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique nomme Alan DUNDON né le 18 Avril 1966 à Dublin (Irlande), résidant professionnellement au 67,
rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au poste de gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au 31 août 2009.
92023
Pour extrait
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2009116097/17.
(090139266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Emerald S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 56.560.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EMERALD S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009116180/12.
(090139447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Opportunity Fund III (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 116.180.
Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Opportunity Fund III (Luxembourg) S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009116188/12.
(090139459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 93.421.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3/9/2009.
Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l.
Nicholas Hayes
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009116175/14.
(090139551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Westbridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 98.280.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 17 juin 2009i>
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale des actionnaires nomme Monsieur Maciej DROZD, né le 31 mars 1965 à Varsovie (Pologne),
résidant au ul Szamocin 9A, 02-003 Varsovie, Pologne, au poste de Gérant de la société pour une durée illimitée avec
effet au 1
er
juillet 2009.
92024
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2009116093/16.
(090139255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Tarinech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 119.282.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009116092/11.
(090139519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Strongbow Capital Holdings S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 92.914.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
L'affectation du résultat au 31 décembre a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009116095/12.
(090139517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Eridanus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 212.500,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 110.484.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116118/11.
(090139296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Downshire Enterprises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.580.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2009i>
- L'Assemblée ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2008, qui se tiendra en 2010.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Peter van Opstal, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Alter
Audit Sàrl, ayant son siège social 69, rue de la Semois à L-2533 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'as-
semblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008, qui se tiendra en 2010.
92025
Luxembourg, le 31 août 2009.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009116103/20.
(090139304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
VAN-Electronic A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 37, Gruuss Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 105.839.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116160/10.
(090139604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
S.E.F. Luxemburg Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 95.440.
Le comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116161/10.
(090139601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
EPI - European Property Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 27, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 94.525.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116162/10.
(090139596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Euro-Getränke A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tanneurs.
R.C.S. Luxembourg B 91.919.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116163/10.
(090139593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Pepsi-Cola Belgium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 100.587.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
92026
Luxembourg, le 2 septembre 2009.
Pepsi-Cola Belgium S.à r.l.
Patrick van Denzen / Signature
<i>Gérant / -i>
Référence de publication: 2009116192/14.
(090139509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Waasserkraaft Wampach, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 23, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 111.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116164/10.
(090139475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Clavadel Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 60.099.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009116165/10.
(090139233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
S.A.F. Services Anti-Feu, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6691 Moersdorf, 4, Um Kiesel.
R.C.S. Luxembourg B 128.243.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116159/10.
(090139606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Francap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 110.670.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009116170/10.
(090139237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.
Unicapital Investments V (Management) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 124.018.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
92027
Luxembourg, le 8 septembre 2009.
<i>Pour Unicapital Investments V Management S.A.
i>Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Patrice Gilson / Steve David
<i>Director / Managing Directori>
Référence de publication: 2009116931/14.
(090140595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.
FDB S.à r.l., Fiduciaire Denis Bossicart S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8372 Hobscheid, 23, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 148.039.
STATUTS
L'an deux mil neuf, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Denis Jacques Ghislain BOSSICART, expert-comptable, né à Libramont-Chevigny (Belgique) le 19 janvier
1971, célibataire, demeurant à L-8372 Hobscheid, 23, Grand-rue.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'il déclare constituer:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La Société prend la dénomination de "Fiduciaire Denis Bossicart S.à r.l.", en abrégé "FDB S.à r.l."
Art. 3. La Société a pour objet l'exercice, à titre indépendant, de toutes activités relevant directement ou indirectement
de la profession d'expert-comptable telles qu'elles sont définies à l'article 1
er
de la loi du 10 juin 1999 portant organisation
de la profession d'expert-comptable, et de toutes activités relevant directement ou indirectement de la profession d'ex-
pert-fiscal.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobi-
lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet sous réserve du respect des dispositions législatives et
déontologiques de la profession d'expert-comptable.
Elle a également pour objet la domiciliation de sociétés. Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés ayant un objet identique similaire ou complémentaire, ou de nature à favoriser son développement.
Elle pourra contracter des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionne-
ments à d'autres personnes physiques ou morales du groupe.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Hobscheid.
Il pourra être transféré en toute autre localité de la municipalité par simple décision du gérant, qui aura tous pouvoirs
d'adapter le présent article.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,- EUR), représenté par CENT
(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
Les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Denis BOSSICART, prénommé.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE
QUATRE CENTS EUROS (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
92028
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2010.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ HUIT CENTS EUROS (800,-
EUR)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqué,
s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi L-8372 Hobscheid, 23, Grand-rue.
2.- L'assemblée désigne comme gérant de la Société:
Monsieur Denis Jacques Ghislain BOSSICART, expert-comptable, né à Libramont-Chevigny (Belgique) le 19 janvier
1971, célibataire, demeurant à L-8372 Hobscheid, 23, Grand-rue.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité de la Société présentement fondée,
celle-ci doit être en possession d'une autorisation en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est
expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Bossicart, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 août 2009. Relation: LAC/2009/34935. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Fr. Sandt.
92029
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009119251/100.
(090143455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
Martin Pecheur Investments Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège de direction effectif: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 147.757.
In the year two thousand and nine, on the fourth of August.
Before Us, M
e
Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Kingfisher International Holdings Limited, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales,
having its registered office at 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6PX, registered at Companies House under
number 02558762, acting through its Luxembourg branch Kingfisher International Holdings Limited - Luxembourg Branch,
having its address at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of being
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (the "Sole Shareholder") represented by Mr.
Eric ISAAC, director, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal, such proxy, being initialed
"ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be registered
with it, being the Sole Shareholder of and holding all the shares in issue in "Martin Pecheur Investments Limited" (the
"Company"), a company incorporated under the laws of Jersey on 21 July 2009, having its registered office at Whiteley
Chambers, Don Street, St Helier, Jersey JE4 9WG and its central administration (head office) at 99, Grand-rue, L-1661
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as recorded by a notarial deed of the undersigned notary, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
I. The Company is a private company with limited liability incorporated under the laws of Jersey with its central
administration (head office) in Luxembourg.
II. The Sole Shareholder holds all twelve thousand (12,000) shares in issue in the Company, so that decisions can validly
be taken on the items of the agenda.
III. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
A. Increase of the authorised and issued share capital of the Company from twelve thousand Pound Sterling (£ 12,000)
to three hundred million twelve thousand Pound Sterling (£300,012,000) by the issue to the Sole Shareholder of three
hundred million (300,000,000) shares, having a par value of one Pound Sterling (£ 1) each and a total subscription price
of three hundred million Pound Sterling (£ 300,000,000), by acceptance of a contribution in kind from the Sole Shareholder
consisting of a loan receivable in an amount of three hundred million Pound Sterling (£ 300,000,000) held by the Sole
Shareholder (the "Contribution in Kind");
- subscription to, and payment of, all new three hundred million (300,000,000) shares by the Sole Shareholder by
transfer of the Contribution in Kind to the Company for a total subscription price of three hundred million Pound Sterling
(£ 300,000,000);
- acknowledgement of a report by the board of directors of the Company on the value of the Contribution in Kind,
approval of the valuation of the Contribution in Kind at three hundred million Pound Sterling (£ 300,000,000);
- allocation of an amount of three hundred million Pound Sterling (£ 300,000,000) to the Company's share capital
account;
B. Consequential amendments (i) of article 6 of the memorandum of association of the Company as follows:
"The company's share capital is £ 300,012,000 divided into 300,012,000 ordinary shares of £1.00 each";
and (ii) of article 3 of the articles of association of the Company as follows:
"The fully paid up and issued share capital of the company at the date of adoption of this article is £ 300,012,000 divided
into 300,012,000 ordinary shares of £1.00 each".
The decisions taken by the Sole Shareholder are as follows:
<i>First resolutioni>
It is irrevocably resolved to increase the share capital of the Company from twelve thousand Pound Sterling (£ 12,000)
to three hundred million twelve thousand Pound Sterling (£300,012,000) by the issue to the Sole Shareholder of three
hundred million (300,000,000) shares, having a par value of one Pound Sterling (£ 1) each and a total subscription price
of three hundred million Pound Sterling (£ 300,000,000), by the approval of a contribution in kind from the Sole Share-
holder consisting in the contribution of a loan receivable in an amount of three hundred million Pound Sterling (£
92030
300,000,000) held by the Sole Shareholder (the "Contribution in Kind"). The appearing party subscribed to, and fully paid,
the new shares as set out in the Agenda by the transfer of the Contribution in Kind to the Company. Consequently the
amount of three hundred million Pound Sterling (£300,000,000) is allocated to the share capital. The above Contribution
in Kind has been the subject of a valuation report of the board of managers of the Company dated 4 August 2009. The
conclusion of such report reads as follows:
"In view of the above, the board of directors believes that the value of the contribution in kind, being the principal
amount of a loan receivable held by the sole shareholder of the Company, amounts to GBP 300,000,000 and thus is at
least equal to the nominal value of the 300,000,000 shares to be issued by the Company."
In view of the above, it is resolved to value the Contribution in Kind at three hundred million Pound Sterling (£
300,000,000). Proof of the transfer of the Contribution in Kind to the Company was shown to the undersigned notary.
It is further resolved to allocate an amount of three hundred million Pound Sterling (£ 300,000,000) to the share capital.
<i>Second resolutioni>
Consequential to the preceding resolution, it is resolved to amend (i) article 6 of the memorandum of association of
the Company and (ii) article 3 of the articles of association of the Company each to be read as set forth in the agenda.
There being no further item on the agenda, the decision of the Sole Shareholder was thereupon closed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at six thousand eight
hundred Euros (6,800.- €).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by his
name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le quatre août.
Par-devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Kingfisher International Holdings Limited, une limited company constituée et existant sous les lois d'Angleterre et du
Pays de Galles, ayant son siège social au 3 Sheldon Square, Paddington, Londres, W2 6PX, inscrite auprès du Companies
House sous le numéro 02558762, agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise Kingfisher International
Holdings Limited - Luxembourg Branch, ayant son adresse au 99, Grand'rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (l'"Associé
Unique"), représentée par Monsieur Eric ISAAC, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, étant l'Associé Unique détenant toutes les
parts sociales émises dans "Martin Pecheur Investments Limited" (la "Société"), une société constituée selon les lois de
Jersey en date du 21 juillet 2009, ayant son siège social à Whiteley Chambers, Don Street, St Helier, Jersey, JE4 9WG, et
son administration centrale au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'enregistré dans
un acte notarié du notaire soussigné, demeurant à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. La Société est une private company (société à responsabilité limitée) constituée selon les lois de Jersey ayant son
administration centrale (bureau principal) à Luxembourg.
II. L'Associé Unique détient toutes les douze mille (12.000) parts sociales émises dans la Société de sorte que des
décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:
A. Augmentation du capital social autorisé et émis de la Société de douze mille Livres Sterling (£ 12.000) à trois cent
millions douze mille Livres Sterling (£300.012.000) par l'émission à l'Associé Unique de trois cent millions (300.000.000)
parts sociales d'une valeur d'une Livre Sterling (£ 1) chacune et un prix de souscription total de trois cent millions Livres
Sterling (£300.000.000), par acceptation d'un apport en nature de l'Associé Unique consistant en une créance d'un mon-
tant de trois cent millions Livres Sterling (£300.000.000) détenue par l'Associé Unique (l'"Apport en Nature");
92031
- souscription et libération de toutes les trois cent millions (300.000.000) nouvelles parts sociales par l'Associé Unique
par le transfert de l'Apport en Nature à la Société pour un prix de souscription total de trois cent millions Livres Sterling
(£300.000.000);
- constat d'un rapport du conseil de gérance de la Société sur la valeur de l'Apport en Nature, approbation de l'Apport
en Nature à trois cent millions Livres Sterling (£300.000.000);
- allocation d'un montant de trois cent millions Livres Sterling (£300.000.000) au compte de capital social de la Société;
B. Modification subséquente (i) de l'article 6 des statuts de la Société comme suit:
"Le capital social de la société est de £300.012.000, représenté par 300.012.000 parts sociales ordinaires de £ 1,00
chacune."
et (ii) de l'article 3 des statuts de la Société comme suit:
"Le capital social émis et entièrement libéré de la société à la date d'adoption des présents statuts est de £300.012.000,
représenté par 300.012.000 parts sociales ordinaire de £ 1,00 chacune."
Les décisions prises par l'Associé Unique sont les suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé irrévocablement d'augmenter le capital social de la Société de douze mille Livres Sterling (£ 12.000) à
trois cent millions douze mille Livres Sterling (£300.012.000) par l'émission à l'Associé Unique de trois cent millions
(300.000.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (£ 1) chacune et un prix de souscription total
d'une Livre Sterling (£ 1), par l'approbation d'un apport en nature de l'Associé Unique consistant en un apport d'une
créance d'un montant de trois cent millions Livres Sterling (£300.000.000) détenue par l'Associé Unique (l'"Apport en
Nature"). La partie comparante a souscrit et entièrement libéré les nouvelles parts sociales tel que décrit dans l'ordre
du jour par le transfert de l'Apport en Nature à la Société. Par conséquent, le montant de trois cent millions Livres Sterling
(£300.000.000) est alloué au capital social. L'Apport en Nature qui précède a fait l'objet d'un rapport d'évaluation du
conseil de gérance de la Société daté 4 août 2009.
La conclusion de ce rapport est la suivante:
"Au vu de ce qui précède, le conseil de gérance est d'avis que la valeur de l'apport en nature, composé du montant
principal sous une créance détenue par l'associé unique de la Société, est égale à 300.000.000 Livres Sterling et est donc
au moins égale à la valeur nominale des 300.000.000 parts sociales à émettre par la Société."
Au vu de ce qui précède, il est décidé d'évaluer l'Apport en Nature à trois cent millions Livres Sterling (£300.000.000).
Preuve du transfert de l'Apport en Nature à la Société a été montrée au notaire soussigné.
Il est décidé d'allouer un montant de trois cent millions Livres Sterling (£300.000.000) au capital social.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier les articles 6 et 3 des statuts de la Société afin
qu'il ait la teneur reprise dans l'ordre du jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision de l'Associé Unique a été clôturée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à six mille huit cents euros
(6.800,- €).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par ses nom, prénom, état civil et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: ISAAC - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 août 2009. Relation GRE/2009/2902. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
Junglinster, le 2 septembre 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009119280/158.
(090143333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
92032
Fortunae S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 148.051.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendneun, den zwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, im Amtssitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1° Herr Manfred MÜLLER, Diplom-Betriebswirt, geboren in Saarbrücken (Deutschland), am 2. Juli 1951, wohnhaft in
D-66571 Eppelborn, Flurweg 14 (Deutschland);
2° Herr Patrick MÜLLER, Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, geboren in Neunkirchen (Deuts-
chland), am 13. August 1975, wohnhaft in D-66117 Saarbrücken, Dornierstrasse 8 (Deutschland).
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird eine Familienvermögensverwaltungsgesellschaft in Form einer anonymen Aktiengesellschaft gegründet,
welche dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie abgeändert, dem Gesetz vom 11. Mai
2007 über die Familienvermögensverwaltungsgesellschaften und den vorliegenden Satzungen unterliegt.
Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „FORTUNAE S.P.F.".
Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesell-
schafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu
sein braucht.
Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Gesellschafters
lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen,
Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede
andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses
Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzaktiva im
Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Schaffung einer Société de gestion de patrimoine familial
("SPF").
Die Gesellschaft wird keine kommerzielle Tätigkeit ausüben.
Die Gesellschaft wird jegliche Massnahmen treffen um ihre Rechte zu erhalten und kann jede Tätigkeit, welche mit
dem Gesellschaftszweck in Verbindung steht oder welche diesen fördern kann, ausüben, jedoch nur im Bereich des
Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Familienvermögensverwaltungsgesellschaften (SPF).
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in eintausend
(1.000) Aktien mit einem Nominalwert von einunddreissig Euro (EUR 31,-) pro Aktie.
Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs, mit Ausnahme der Aktien, für welche das
Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
92033
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalver-
sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen
einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter" genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus
mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die Generalversammlung
zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die
Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.
Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die
Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.
Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher
die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie
dies abgeändert wurde, vertritt.
Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl
der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können
die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalver-
sammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine
Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwal-
tungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.
Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vor-
behalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.
Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden
ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschrift-
lich, telegraphisch oder per Telefax geben.
In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch
oder per Telefax abgeben.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist
die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.
Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen,
die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Ver-
walter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.
Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.
Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Ver-
tretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann ausserdem jedwelcher Person, die nicht Verwalter
sein muss, jedwelche Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Angestellte ernennen und abberufen und ihren Lohn
festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet wie dies durch die folgenden Generalversammlungen beschlos-
sen wird.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Geschäftsjahr - Generalversammlung
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 13. Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungs-
gemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.
92034
Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle
Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung
Kenntnis genommen zu haben.
Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Generalversammlung zugelassen werden, die fünf Ka-
lendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 14. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,
wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.
Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu
tätigen oder zu ratifizieren.
Art. 15. Die Generalversammlung bestimmt über Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt Zwischendividenden auszuschütten gemäss
den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar
am dritten Freitag des Monates Juni um 11.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen sowie das Gesetz vom
11. Mai 2007 über Familienvermögensverwaltungsgesellschaften.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
1° Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.
2° Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2010 statt.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).
<i>Kapitalzeichnungi>
Die gesamten eintausend (1.000) Aktien werden wie folgt gezeichnet:
- Herr Manfred MÜLLER, vorgenannt, fünfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Aktien
- Herr Patrick MÜLLER, vorgenannt, fünfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Aktien
Insgesamt: eintausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Aktien
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe
von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3), diejenige der Kommissare wird festgelegt auf
einen.
2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-
sammlung des Jahres 2015.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Manfred MÜLLER, vorgenannt;
- Herr Patrick MÜLLER, vorgenannt;
- Frau Stephanie MÜLLER, Reiseverkehrskauffrau, geboren in Dudweiler (Deutschland), am 1. November 1965, wohn-
haft in D-66571 Eppelborn, Flurweg 14 (Deutschland).
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie, RCS Luxemburg B
25.797.
92035
5.- Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
erforderlich.
6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-2530 Luxemburg, 4A, rue Henri Schnadt.
<i>Erklärungi>
Die Herren Manfred und Patrick MÜLLER, vorgenannt, erklären, dass sie "INVESTISSEUR ELIGIBLE" (wählbarer An-
leger) im Sinne des vorgenannten Gesetzes vom 11. Mai 2007 sind.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Erschienenen zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Manfred Müller, Patrick Müller, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 25 août 2009. LAC/2009/34587. Reçu 75,-.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis Sandt.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 9. September 2009.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2009119241/174.
(090143701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
HAZ Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 132.645.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2009.
<i>Pour: HAZ HOLDING S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2009119191/15.
(090143414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
RREP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 148.029.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twelfth of August.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX,
notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
PICTET PRIVATE EQUITY INVESTORS S.A., a corporation incorporated under the laws of the Republic of Panama
on November 22
nd
2000, having its registered office at 53
rd
Street, Urbanizacion Obarrio Swiss Tower, 16
th
Floor
Panama, Republic of Panama, registered with the Public Registry of Panama under number 391168, here represented by
Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 11
th
August,
2009.
Which proxy shall be signed "ne varietur" by the attorney of the above named person and the undersigned notary and
shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.
The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed
a single member limited liability company and to draw up its Articles of Association as follows:
Title I. - Name - Registered office - Purpose - Duration
Art. 1. There is hereby established a single member limited liability company which will be governed by the laws in
effect and especially by those of August 10
th
, 1915 referring to commercial companies, as amended from time to time,
92036
September 18
th
, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28
th
, 1992 on single member limited
liability companies (hereafter the "Law") as well as by the present articles (hereafter the "Articles").
Art. 2. The name of the company is "RREP LUXEMBOURG S.a R.L.".
Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Luxembourg. It can be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner
provided for amendments to the Articles.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The object of the company is the holding of interests, in any form whatsoever both directly and indirectly, in
Luxembourg and foreign companies; the acquisition by purchase, subscription or in any other manner, and the transfer
by sale, exchange or otherwise of real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind; and the
ownership, administration, development and management of its portfolio.
The company will in particular invest in properties in Germany. Investment may be in residential, commercial, retail,
development, land or mixed-use real estate assets either directly or through special purpose vehicles.
The company may participate in the establishment and development of any industrial and commercial enterprises.
The company may borrow money in any form, issue bonds and other debt instruments, including without limitation
convertible participating equity certificates (the "CPECs") which may or may not bear interest, and lend the proceeds of
such borrowings to its subsidiaries and investee companies and may give security for any borrowings.
In general, the company may carry out any other transaction it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.
Art. 5. The company is established for an unlimited term.
Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the company.
Title II. - Capital - Parts
Art. 7. The capital of the company is fixed at FOUR HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 450,000.-)
divided into FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED (4,500) parts of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each.
The company shall have an authorised share capital of FIFTY MILLION EURO (EUR 50,000,000.-) divided into FIVE
HUNDRED THOUSAND (500,000) parts having a nominal value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each.
The board of managers of the company is hereby authorised to issue further parts, with or without issue premium,
so as to bring the total capital of the company up to the amount of the authorised share capital. The board of managers
is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for such parts from time to time, to accept
subscriptions for such parts, and to accept contributions in cash or in kind as payment of the issue price for such parts.
This authorisation is granted for a period of three (3) years from the date of publication of the present articles, for
the purposes of financing the acquisition of real estate property mainly in Germany or to discharge any liability incurred
in or amount due as a result of its formation. The period of this authority may be extended by resolution of the sole
participant or, as the case may be, of the general meeting of participants, in the manner required for amendment of these
articles of association.
The board of managers is further authorised to issue convertible bonds or other bonds, with or without subscription
rights, or any other bond which is convertible into parts, but only on condition that such bonds are not offered to the
public.
When the board of managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the above provisions, it shall be
obliged to take steps to amend this article in order to record the change. The board of managers is hereby authorised
to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment.
Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter
vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing
at least three quarters (3/4) of the share capital of the company.
For all other matters, reference is made to Articles 189 and 190 of the Law.
Art. 9. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any
circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any
way in its administration.
92037
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III. - Management
Art. 10. The company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) may be revoked ad
nutum.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to
perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those
expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of participants.
Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by
the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for this
purpose.
In case of plurality of managers, the company shall be bound by the joint signature of any two members of the board
of managers. If only one manager exists, the company will be bound by the signature of this manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its
members is present either in person or by proxy.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either
in person or by proxy.
All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.
In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of
managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.
If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg
if the call is initiated from Luxembourg.
Title IV. - General meeting of participants
Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under
section XII of the law of August 10
th
, 1915.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall
be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.
In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing
more than fifty per cent (50%) of the capital.
However, resolutions to alter the Articles of the company may only be adopted by a quorum of at least fifty per cent
(50%) of the existing participants and the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the company's votes present or
represented at the general meeting amending the Articles, further subject to the provisions of the Law.
All general meetings of participants shall take place in Luxembourg.
Each part carries one vote at all meetings of participants.
Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him
at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 12. The financial year of the company starts on the first day of October of each year and ends on the last day of
September of the following year.
Art. 13. Each year on the last day of September an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as
a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the pro-
visions and taxes constitute the net profit.
92038
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The remainder of the net profit is at the disposal of the general meeting of participants.
Title VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by the Law. The liquidator(s) shall
be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.
The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse
the contribution made by the participants on the parts of the company.
The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective participation in the company.
Title VII. - Varia
Art. 15. The parties refer to the existing Law and regulations for all matters not mentioned in the present Articles.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the company and shall end on the 30th of September
2010.
<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:
PICTET PRIVATE EQUITY INVESTORS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500 parts
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500 parts
The parts have been fully paid up to the amount of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) per part by a contribution
in cash of FOUR HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 450,000.-).
As a result, the amount of FOUR HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 450,000.-) is as of now at the
disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its organization, are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an
extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:
1) The registered office of the company is fixed at 73, Cote d'Eich, L-1450 Luxembourg;
2) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined term:
<i>Board of Managers:i>
a) Erik VANDERKERKEN, company director, born on January 27
th
, 1964 in Esch-sur-Alzette, and having his profes-
sional residence at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
b) Pascal BRUZZESE, company director, born on April 7
th
, 1966 in Esch-sur-Alzette, having his professional residence
at 73, Cote d'Eich, L-1450 Luxembourg; and
c) Fabien WANNIER, company director, born on July 18
t
h
, 1977 in Bern (Switzerland), with professional residence
at 11 Cours De Rive, CH-1204 Geneva, Switzerland.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English followed by a German version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and German text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.
Follows the German Version:
Im Jahre zweitausendneun, am zwölften August.
Vor Maître Carlo WERSANDT, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung seines verhinderten
Kollegen Maître Henri HELLINCKX, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterer Verwahrer vorliegender
Urkunde bleibt.
92039
ERSCHIEN:
PICTET PRIVATE EQUITY INVESTORS S.A., eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Republik Panama am
22. November 2000, mit Sitz in 53, Street, Urbanizacion Obarrio Swiss Tower, 16. Etage, Panama, Republik Panama,
registriert bei dem Öffentlichen Register von Panama unter der Nummer 391168, wirksam vertreten durch Natalie
O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, mit Wohnsitz in Luxemburg, im Wege einer am 11. August erteilten Voll-
macht.
Welche Vollmacht, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar "ne varietur"
gezeichnet wurde, dieser Urkunde beigefügt wird, um zusammen mit ihr registriert zu werden.
Die vorgenannte Partei, vertreten wie vorerwähnt, erklärt ihre Absicht, mit dieser Urkunde eine unipersonale Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen und die folgende Satzung festzulegen:
Titel I. - Firma - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-
schen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen
Abänderungen, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie abgeändert, und
dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung (hiernach die "Ge-
setze") und der hiernach folgenden Satzung (die "Satzung") unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft führt die Firma "RREP LUXEMBOURG S.à R.l.".
Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Luxemburg. Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter,
welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort
innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Im Falle außergewöhnlicher politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse, welche auftreten oder sich dringlich ergeben
und die normale Aktivität oder Kommunikation am Gesellschaftssitz mit dem Ausland erschweren, kann der Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis diese Ereignisse oder Umstände nicht mehr vorhanden sind.
Eine solche Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Entscheidung wird durch das
Organ der Gesellschaft an Drittparteien bekannt gemacht, welches am besten dafür in der Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen, in jeder bestehenden Form, an luxemburgischen und
ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung, oder auf andere Art, sowie der Übertragung durch
Verkauf, Tausch oder auf andere Art, von Grundeigentum, Aktien, Schuldverschreibungen, Pfandbriefen, Schuldscheinen
oder anderen Wertpapieren jeglicher Art, und der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung sowie das Management seines
Portfolios.
Das Kerngeschäft der Gesellschaft umfasst Investitionen in Grundstücke und Immobilien in Deutschland. Investitionen
können in Mietwohnungen, Gewerbeobjekte, Einzelhandelsobjekte, Grundeigentum oder Mischnutzungsobjekte entwe-
der direkt oder indirekt durch Spezialvehikel erfolgen.
Die Gesellschaft kann an der Gründung und der Fortführung jeglicher Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen
teilnehmen.
Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen, Schuldscheine und andere Schuldtitel ausgeben - eingeschlossen ohne
es darauf zu begrenzen -Wandelschuldanleihen („CPECS") mit oder ohne Zins. Die Gesellschaft kann des weiteren die
Erträge, welche sie aufgrund der Ausgabe dieser Schuldtitel erhält, nutzen, um diese den Tochtergesellschaften und In-
vestmentvehikel der Gesellschaft zukommen zu lassen und die Gesellschaft kann Sicherheiten für jede Art der Geldleihe
begeben.
Generell kann die Gesellschaft alle Maßnahmen ergreifen, welche sie für notwendig erachtet, um den Gesellschafts-
zweck zu erreichen und zu fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines
Gesellschafters aufgelöst.
Titel II. - Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt VIERHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (EUR 450.000,-), eingeteilt in
VIERTAUSENDFÜNFHUNDERT (4.500) Anteile von je EINHUNDERT EURO (EUR 100,-).
Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Kapital in Höhe von FÜNFZIG MILLIONEN EURO (EUR 50.000.000,-) eingeteilt
in FÜNFHUNDERTTAUSEND (500.000) Anteile mit einem Nominalwert je Anteil von EINHUNDERT EURO (EUR
100,-).
Die Geschäftsführung ist autorisiert, weitere Anteile auszugeben, mit oder ohne Aktienagio, um das Gesamtkapital
der Gesellschaft bis auf den Wert des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Die Geschäftsführung ist autorisiert, die Bedin-
gungen zu bestimmen, welche mit der Zeichnung solcher neuen Anteile zusammenhängen von Zeit zu Zeit, Zeichnungen
für diese Anteile zu akzeptieren, und die Einzahlungen in bar oder als Sacheinlage in Höhe des Ausgabepreises entgegen-
zunehmen.
92040
Diese Autorisierung ist auf eine Zeitperiode von drei (3) Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung dieser
Satzung und nur für die Zwecke der Finanzierung des Aufkaufes von Immobilien und Grundstücken in Deutschland sowie
für die Einlösung von Verpflichtungen der Gesellschaft im Rahmen der Gründung der Gesellschaft beschränkt. Die Zeit-
periode kann durch den Beschluss des einzigen Gesellschafters oder, im gegebenen Falle, durch Beschluss der General-
versammlung der Gesellschafter, in der Art und Weise wie für die Änderung der Satzung vorgesehen, verlängert werden.
Die Geschäftsführung ist des Weiteren befugt, Wandelschuldanleihen und sonstige Schuldverschreibungen, mit oder
ohne Zeichnungsrechte oder sonstige Schuldinstrumente, welche in Aktien umwandelbar sind, auszugeben, vorausgesetzt,
diese Instrumente werden nicht öffentlich angeboten.
Sofern die Geschäftsführung eine teilweise oder vollständige Kapitalerhöhung beschließt im Rahmen der oben ausge-
führten Absätze, so ist die Geschäftsführung verpflichtet, alle Schritte zu unternehmen, um diesen Artikel entsprechend
abzuändern. Die Geschäftsführung ist hierbei autorisiert, alle Schritte zu unternehmen, um eine solche Änderung auszu-
führen und zu veröffentlichen.
Art. 8. Die Anteile können, solange es nur einen Gesellschafter gibt, von diesem Gesellschafter ohne Beschränkungen
übertragen werden.
Im Falle, dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Über-
tragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindes-
tens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-
gesellschaften verwiesen.
Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-
gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-
ziehen.
Titel III. - Geschäftsführung
Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine
unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand.
Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.
Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen
ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesell-
schaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder
diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.
Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder
im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.
Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet. Sollte lediglich ein Geschäftsführer existieren, wird die Gesell-
schaft durch die Unterschrift des Geschäftsführers rechtlich wirksam gebunden.
Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle
Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
Alle Treffen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen,
als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären.
Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie
können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.
Außerdem soll jedes Vorstandsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe
(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe)
anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und
selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und
mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.
Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst
gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.
92041
Titel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 11. Der einzige Gesellschafter ist mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung nach
Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 eingeräumt werden.
Alle Entscheidungen, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder des Vorstands fallen, können
vom Gesellschafter getroffen werden. Jede solcher Entscheidungen muss schriftlich verfasst, in einem Protokoll festge-
halten und in einem speziellen Register registriert werden.
Sollte mehr als ein Gesellschafter existieren, so werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterver-
sammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als ange-
nommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung nur wirksam gefasst werden, wenn ein solcher Beschluss von zwei Dritteln
(2/3) der anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst wird, wobei mindestens fünfzig Prozent (50%) des existier-
enden Gesellschaftskapitals bei der Generalversammlung anwesend sein muss, ergänzt durch die Vorschriften des
Gesetzes.
Alle Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.
Jeder Gesellschafter kann im Wege einer schriftlichen Vollmacht eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss,
autorisieren, ihn auf einer Gesellschafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen und auf seine Rechnung abzu-
stimmen.
Titel V. - Geschäftsjahr - Gewinn - Reserven
Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober eines Jahres und endet am letzten Septembertag
des darauffolgenden Jahres.
Art. 13. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats September, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der
Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und
der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-
ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter zur Verfügung.
Titel VI. - Liquidation - Auflösung
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit den in den Gesetzen be-
stimmten Mehrheiten, ernannt werden. Der (die) Liquidator(en) verfüg(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur
Realisierung des existierenden Vermögens und Begleichung der Verpflichtungen.
Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Ver-
fügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Gesellschaftsanteile eingezahlten
Beträge zurückzuzahlen.
Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung aus-
gezahlt.
Titel VII. - Verschiedenes
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2010.
<i>Zeichnungi>
Nachdem diese Satzung wie obenstehend verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, wie folgt Anteile der Gesell-
schaft zu zeichnen:
PICTET PRIVATE EQUITY INVESTORS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 Anteile
GESAMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 Anteile
Die Anteile wurden vollständig bis zu einem Betrag von EINHUNDERT EURO (EUR 100,-) je Anteil durch Barzahlung
in Höhe von VIERHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (EUR 450.000,-) eingezahlt.
92042
Als Ergebnis steht ab dem jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft der Betrag von VIERHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND
EURO (EUR 450.000,-) zur Verfügung, was von dem Notar, welcher diese Urkunde unterzeichnet, bestätigt wird.
<i>Kosteni>
Die aufgrund dieser Gründung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form, welche
durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr EUR 1.800,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Nachdem diese Satzung soeben verabschiedet wurde, entscheidet der oben erwähnte einzige Gesellschafter, eine
Gesellschafterversammlung abzuhalten. Nachdem festgestellt wurde, dass die Gesellschafterversammlung wirksam kon-
stitutiert wurde, hat diese die folgenden Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;
2) Als Geschäftsführer (gérants) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer werden folgende Personen ernannt:
<i>Vorstand:i>
a) Erik VANDERKERKEN, Company director, geboren am 27. Januar 1964 in Esch-sur-Alzette, mit professioneller
Adresse in 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg;
b) Pascal BRUZZESE, Company director, geboren am 7. April 1966 in Esch-sur-Alzette, mit professioneller Adresse
in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg; und
c) Fabien WANNIER, Company director, geboren am 18. Juli 1977 in Bern, Schweiz, mit professioneller Adresse in
11 Cours De Rive, CH-1204 Genf, Schweiz.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung
der oben erschienenen Partei die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst
ist, und dass auf Hinweis derselben erschienenen Partei im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen
Versionen, die englische Version massgebend sein soll.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-
milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: N. O'SULLIVAN-GALLAGHER - C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 août 2009. Relation: LAC/2009/33731. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations erteilt.
Luxemburg, den zwanzigsten August zweitausendneun.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009119237/375.
(090143332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
CTS Coating Technology System S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 148.041.
STATUTS
L'an deux mil neuf, le premier septembre.
Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.
ONT COMPARU:
1) La société anonyme "R.M.S. Fiduciaria SA" (CH-514.3.013.385-7 Registre de Commerce du canton Tessin) avec
siège à CH-6900 Lugano, 2 Via Greina, ici représentée par Monsieur Marc VAN HOEK, expert-comptable, né à Berchem,
le 28 janvier 1965, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16 rue de Nassau,
en vertu d'une procuration annexée au présent acte.
2) La société à responsabilité limitée "MANAGEMENT S.àr.l.", (RC B No 95.489) avec siège à L-2213 Luxembourg,
16 rue de Nassau, ici représentée par Monsieur Marc VAN HOEK, préqualifié,
en vertu d'une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme, qu'ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "CTS Coating Technology System S.A.".
92043
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.
La société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en
valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements
à d'autres personnes physiques ou morales.
La société pourra également créer des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000.-€), divisé en trois cent dix (310) actions de cent
euros (100.-€) chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société "R.M.S. Fiduciaria SA", préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 actions
2) La société "MANAGEMENT S.àr.l.", préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
et-un mille euros (31.000.-€) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit et téléfax, étant admis, les décisions prises
lors de réunions tenues par voie circulaire étant également admises. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-
teur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la signature individuelle d'un
administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne
peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2009.
Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 3
e
jeudi de mai de chaque année à 13.30 heures, sauf jour férié le
lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2010.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où
il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
92044
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cent cinq
euros (1.505.-€).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unani-
mité des voix, prix les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un pour une durée de 6 ans;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marzio GUGGIARI, expert-comptable, né à Sorengo (CH), le 18 décembre 1964, demeurant profession-
nellement à CH-6900 Lugano, 2 Via Greina, (administrateur)
b) Monsieur Marc VAN HOEK, préqualifié (administrateur)
c) La société à responsabilité limitée MANAGER S.àr.l.", (RC B No 95.614) avec siège à L-2213 Luxembourg, 16 rue
de Nassau (administrateur)
d) Madame Oriana ROSSI, employée privée, née à Lugano (CH), le 27 mai 1977, demeurant professionnellement à
CH-6900 Lugano, 2 Via Greina (administrateur)
3. est appelé aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée "LUXFIDUCIA S.àr.l." (RC B 71.529) avec siège à L-2213 Luxembourg, 16 rue de
Nassau.
4. le siège social de la société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16 rue de Nassau.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: VAN HOEK, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 04 septembre 2009. Relation: EAC/2009/10455. Reçu: soixante-quinze euros EUR
75.-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): KIRCHEN.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 08 septembre 2009.
Georges d'HUART.
Référence de publication: 2009119257/104.
(090143504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
Kaiserkarree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.677.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 135.140.
In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appear:
TS Kaiserkarree Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 132.440, and
CR KaiserKarree Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25, rue Edward Steichen, L-2546 Luxembourg, and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 132.783,
both here represented by Ms. Suzana Fuia, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of two (2) proxies established on August 19, 2009 and August 20, 2009.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholders of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholders, have requested the undersigned notary to state that:
92045
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
existing in Luxembourg under the name of "Kaiserkarree S.à r.l." (the "Company") with registered office at 34-38, Avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under
number 135.140, incorporated by a deed of the undersigned notary of December 18
th
, 2007, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 294 of February 5
th
, 2008, which bylaws have been lastly amended pursuant
to a deed of the undersigned notary of June 4
th
, 2009 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 1304 of July 7
th
, 2009.
II. The Company's share capital is currently fixed at two million fifty-seven thousand five hundred Euro (€ 2,057,500.-)
represented by eighty-two thousand three hundred (82,300) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-)
each.
III. The shareholders resolve to increase the Company's share capital to the extent of six hundred twenty thousand
Euro (€ 620,000.-) in order to raise it from its present amount of two million fifty-seven thousand five hundred Euro (€
2,057,500.-) to two million six hundred seventy-seven thousand five hundred Euro (€ 2,677,500.-) by the creation and
issuance of twenty-four thousand eight hundred (24,800) new shares, with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-)
each (the "New Shares").
<i>Subscription - Paymenti>
- TS Kaiserkarree Holdings S.à r.l., prenamed, resolves to subscribe for twelve thousand four hundred (12,400) New
Shares, with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and fully pays them up in the amount of three hundred
ten thousand Euro (€ 310,000.-) by contribution in cash in the same amount.
- CR KaiserKarree Holding S.à r.l., prenamed, resolves to subscribe for twelve thousand four hundred (12,400) New
Shares, with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and fully pays them up in the amount of three hundred
ten thousand Euro (€ 310,000.-) by contribution in cash in the same amount.
The total amount of six hundred twenty thousand Euro (€ 620,000.-) has been fully paid up in cash and is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the notary, who expressly acknowledges it.
IV. Pursuant to the above increase of capital, article 5.1 of the Company's articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
" Art. 5.1. The share capital is fixed at two million six hundred seventy-seven thousand five hundred Euro (€ 2,677,500.-)
represented by one hundred seven thousand one hundred (107,100) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (€
25.-) each".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately two thousand Euro (€ 2,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholders of the persons appearing, who is known to the notary by his/her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille neuf, le vingt-quatre août.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
TS Kaiserkarree Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 132.440, et CR KaiserKarree Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social à 25, rue Edward Steichen, L-2546 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 132.783,
toutes les deux ici représentées par Mademoiselle Suzana Fuia, employée privée, ayant son adresse professionnelle au
1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu de deux (2) procurations données les 19 et 20 août 2009.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps. Lesquels comparantes, par leur
mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
92046
I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
"Kaiserkarree S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 135.140, constituée suivant
acte du notaire soussigné reçu en date du 18 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 294 du 5 février 2008, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné reçu
en date du 4 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1304 du 7 juillet 2009.
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à deux millions cinquante-sept mille cinq cents Euro (€ 2.057.500,-)
divisé en quatre-vingt-deux mille trois cents (82.300) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-)
chacune.
III. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent vingt mille Euro (€
620.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinquante-sept mille cinq cents Euro (€ 2.057.500,-) à
deux millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cents Euro (€ 2.677.500,-) par la création et l'émission de vingt-quatre
mille huit cents (24.800) nouvelles parts sociales (les "Nouvelles Parts"), d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-)
chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
- TS Kaiserkarree Holdings S.à r.l., précité, déclare souscrire à douze mille quatre cents (12.400) Nouvelles Parts, d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune et les libérer intégralement pour un montant de trois cent dix mille
Euro (€ 310.000,-) par apport en numéraire du même montant.
- CR KaiserKarree Holding S.à r.l., précité, déclare souscrire à douze mille quatre cents (12.400) Nouvelles Parts,
d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune et les libérer intégralement pour un montant de trois cent dix
mille Euro (€ 310.000,-) par apport en numéraire du même montant.
Un montant de six cent vingt mille Euro (€ 620.000,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le reconnaît expressément.
IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5.1. des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais
la teneur suivante:
" Art. 5.1. Le capital social est fixé à deux millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cents Euro (€ 2.677.500,-)
représenté par cent sept mille cent (107.100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille Euro (€ 2.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connu(e) du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: S. FUIA, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 août 2009. Relation: LAC/2009/35028. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, 07 SEP. 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009119289/121.
(090143250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
NG Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 5.084.606.720,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 120.899.
In the year two thousand and nine, on the eighteenth day of August.
92047
Before M
e
Marc Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of M
e
Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who shall remain the depositary of the
present deed.
There appeared:
National Grid (US) Holdings Limited, a company governed by the laws of England, having its registered office at 1-3
Strand, London WC2N 5EH, United Kingdom and registered under number 2630496,
hereby represented by M
e
Tom Loesch lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
14 August 2009 (the "Sole Shareholder").
The said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Sole Shareholder is the sole sha-
reholder of NG Luxembourg 3 S.à r.l., a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) governed by
the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365, Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 120.899,
incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
dated 12 October 2006, published on 28 November 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2221 (the "Company"). The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed dated 31
March 2009 of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on 8 May
2009 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 966.
The Sole Shareholder represented as above mentioned has recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To amend the starting date and the ending date of the Company's financial year and to amend article 21 of the
articles of incorporation of the Company, so that said article shall read as follows:
"The Company's financial year begins on the twenty-second day of August of each year and ends on the twenty-first
day of August of the following year."
2. To resolve that the current financial year which began on 26 March 2009 shall end on 21 August 2009.
3. Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the starting date and the ending date of the Company's financial year and
resolved to consequently amend article 21 of the articles of incorporation of the Company, so that said article shall read
as follows:
"The Company's financial year begins on the twenty-second day of August of each year and ends on the twenty-first
day of August of the following year."
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved resolve that the current financial year which began on 26 March 2009 shall end on 21
August 2009.
<i>Costsi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of the present deed amount to nine hundred Euro (900.- EUR).
Nothing else being in the agenda, the meeting was closed.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le dix-huit août,
Par-devant, Maître Marc Lecuit notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg agissant en rem-
placement de Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier
restera dépositaire de la présente minute.
92048
A comparu:
National Grid (US) Holdings Limited, une société de droit anglais, ayant son siège social au 1-3 Strand, London WC2N
5EH, Royaume-Uni et enregistrée sous le numéro 2630496,
représentée aux fins des présentes par M
e
Tom Loesch, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux
termes d'une procuration donnée le 14 août 2009 ("l'Associé Unique").
La prédite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée
aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé Unique est le seul associé de NG Luxembourg
3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365, Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 120.899, constituée suivant acte reçu par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 12 octobre 2006, publié le 28 novembre 2006 au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2221 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois le 31 mars 2009 suivant acte reçu par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, publié le 8 mai 2009 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 966.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à inter-
venir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Modification de la date d'ouverture et de la date de clôture de l'année sociale de la Société et modification de l'article
21 des statuts de la Société, de sorte que ledit article soit lu comme suit:
"L'année sociale de la Société commence le vingt-deuxième jour du mois d'août de chaque année et finit le vingt-et-
unième jour du mois d'août de l'année suivante."
2 Décision de clôturer l'année sociale en cours, commencée le 26 mars 2009, au 21 août 2009.
3 Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier la date d'ouverture et la date de clôture de l'année sociale de la Société et, par
conséquent, de modifier l'article 21 des statuts de la Société, de sorte que ledit article soit lu comme suit:
"L'année sociale de la Société commence le vingt-deuxième jour du mois d'août de chaque année et finit le vingt et
unième jour du mois d'août de l'année suivante."
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de clôturer l'année sociale en cours, commencée le 26 mars 2009 au 21 août 2009.
<i>Coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte
sont estimés à environ neuf cents Euros (900,- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. LOESCH, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 août 2009. Relation: LAC/2009/34076. Reçu: soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009119291/110.
(090143228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
92049
Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 90.334.
In the year two thousand nine, the second day of April.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of the public limited liability company
(société anonyme) Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A., organized and existing under
the laws of Luxembourg, with its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg (the "Company"), incor-
porated pursuant to a deed of Maitre Gerard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated November 15, 2002, published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 84 dated January 28, 2003.
The articles of association of the Company have been amended and fully restated for the last time on May 4, 2006 by
a deed of Maitre Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 1679 on August 8, 2007.
The Meeting is presided by Mrs. Françoise PFEIFFER, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Mrs. Solange WOLTER-SCHIERES, private employee, professionally residing in Luxem-
bourg.
The Meeting elected as Scrutineer Mrs Silvia FONSECA, lawyer, professionally residing in Luxembourg.
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the "Bureau".
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Declaration by the shareholders that they have received and accepted the special report of the board of directors
foreseen by Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, on the authorisation
to be given to the board of directors by the shareholders to limit or cancel the preferential rights to subscription of the
existing shareholders with respect to future increases of the subscribed share capital of the Company subsequent to the
issue of shares, pursuant to the amended article 5.1. of the Company's articles of association.
2. Introduction into the Company's articles of association of an authorised (but non issued) capital of an amount of
nine million euro (EUR 9,000,000) to be divided into nine hundred thousand (900,000) shares all with a par value of ten
euro (EUR 10) per share, authorising the board of directors, during a period of five years starting at the date of the
extraordinary general meeting, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorised
capital without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued; this authorised
capital may only be used in connection with the conversion of any outstanding options issued by the Company and for
the issue of shares to Sigma Capital International Management Ltd. (the "Manager"), and will require the subsequent
amendment and restatement of article 5 of the articles of association of the Company.
3. Amendment of article 10 of the Company's articles of association regarding daily management of the Company.
4. Amendment of article 13 of the Company's articles of association regarding the majority requirements applicable
to shareholders' meetings.
II. The extraordinary general meeting has been duly convened by courier sent to all the shareholders, all the shares
being under registered form.
III. The shareholders present or represented, the proxy-holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on the attendance list. This attendance list signed by the shareholders, the proxy-holders of the
represented shareholders, the Bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. It appears from an attendance list established, and certified by the members of the Bureau that two hundred and
seventy six thousand (276,000) shares with a par value of ten euro (EUR 10) each, representing one hundred percent
(100%) of the Company's share capital are duly represented at this Meeting so that the present Meeting is regularly
constituted and may validly deliberate and resolve on the agenda.
After deliberation, the Meeting unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
The Meeting declares that the shareholders have received and accepted the special report of the board of directors
required pursuant to Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, on the
authorisation to be given to the board of directors by the shareholders to limit or cancel the preferential rights to
subscription of the existing shareholders with respect to future increases of the subscribed share capital of the Company
subsequent to the issue of shares, pursuant to the amended article 5 of the Company's articles of association (the "Re-
port").
92050
<i>Second resolutioni>
The Meeting declares that on the view of the Report and after having acknowledged that the notice of the present
meeting expressly mentions that the authorization given to the board of directors includes the possibility to limit or to
suppress the preferential subscription rights of the shareholders, the Meeting decides unanimously to introduce an au-
thorised but non issued capital of an amount of nine million euro (EUR 9,000,000) to be divided into nine hundred thousand
(900,000) shares, all with a par value of ten euro (EUR 10) per share, authorising the board of directors, during a period
of five years ending on 2 April 2014, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the
authorised (but non issued) capital without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the
shares issued; this authorised capital may only be used by conversion of any outstanding options issued by the Company
and for the issue of shares to the Manager.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend and restate article 5 of the articles of association of the Company as follows:
" Art. 5.
5.1. The subscribed capital of the company is fixed at two million seven hundred and sixty thousand euro (EUR
2,760,000), divided into two hundred and seventy six thousand (276,000) shares with a par value of ten euro (EUR 10.-)
each.
The total unissued (unsubscribed) but authorised capital of the company is set at nine million euro (EUR 9,000,000)
divided into nine hundred thousand (900,000) shares with a par value of ten euro (EUR 10) each. Such authorised capital
shall be reserved for the issue of new shares upon conversion of any outstanding options issued by the company and for
the issue of shares to the manager (as defined in article 10).
The authorisation granted to the board of directors shall be valid for a period of 5 (five) years starting at the date of
the extraordinary general meeting of 2 April 2009 and may be renewed from time to time by resolutions of an extraor-
dinary general meeting of shareholders deliberating in accordance with the requirements for amendments to these
Articles, for a period which, for each renewal, may not exceed 5 (five) years.
The board of directors may suppress the statutory preferential subscription right of the existing shareholders in the
company to subscribe to any new shares issued within the limits of the authorized share capital. Any shares resulting
from the increase of the share capital pursuant to this article 5 may be issued with or without issue premium and paid
up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims or in any other way to be determined by the board of
directors.
The board of directors is authorised to do all things necessary to amend article 5 in order to record the change of
share capital following the issuance of additional shares pursuant to this article 5; the board of directors is empowered
to take or authorize the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with the
Luxembourg Act dated 10
th
August, 1915 on commercial companies, as amended. Furthermore the board of directors
may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorised person, the
duties of accepting subscriptions and receiving payments for shares representing part or all of such increased amounts of
capital.
5.2. Shares may be evidenced at the owners' option, in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
Shares shall be issued and shall remain in registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Bonds issued by the company must be in a registered form and holders of bonds may not request the conversion of
their registered bonds into bearer bonds.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbur-
sement and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
All bonds shall bear a "Restricted" stamp and can be transferred only in connection with the transfer of shares in the
ratio of nine bonds to one share. If any consent of the company to the transfer of bonds is required pursuant to the terms
and conditions of the issuing documents of the bonds, the board of directors shall be required to grant such consent if
the relevant shares are being transferred by a shareholder simultaneously with the bonds as provided herein. The shares
in the company and any share unit certificates are freely transferable, provided, however, that shares cannot be transferred
unless accompanied by a simultaneous transfer of nine bonds per share to the transferee."
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to add a paragraph at the end of article 10 of the articles of association of the Company which
shall read as follows:
"Any delegation of the day-to-day management to a managing director or manager shall terminate automatically upon
issue of any new shares with an aggregate par value of EUR 20,000 by the company's board of directors within the limits
92051
of the authorized share capital so that the share capital of the company amounts to at least EUR 2,780,000. Following the
termination of such delegation, a new managing director or manager may be appointed in accordance with the provisions
set forth above."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend and restate article 13 of the articles of association of the Company as follows:
" Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held on the thirtieth day of June of each year at 10.00
a.m.
All meetings of the shareholders shall be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the day and at a time specified in such notice. If all the shareholders are present or represented and
if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening
of notices. Each share gives the right to one vote.
Shareholders holding a majority of at least 86% of the outstanding shares in the company, either present in person or
represented by proxy, shall constitute a quorum at all meetings of the shareholders for the transaction of business.
Shareholders may also participate in a meeting by means of telephone conference or similar communications equipment
that permits all shareholders present to hear each other. Such quorum shall cease to apply once the share capital of the
Company has been increased up to EUR 2,780,000.
Unless otherwise provided herein the vote of the shareholders holding a majority of at least 86% of the outstanding
shares in the company present in person or represented by proxy shall decide any question brought before such meeting,
including when the matter for consideration is an amendment to these articles, except when the vote of a greater number
or higher percentage is required by law. Such majority requirement shall cease to apply once the share capital of the
Company has been increased up to EUR 2,780,000 following which the majority requirements set forth by law shall
become applicable.
Except with the approval of the shareholders, acting by a majority of at least 86% of the outstanding shares in the
company, (i) the company shall not make any investments or issue any new shares or bonds; (ii) the company shall not
engage in lending of capital to any person; (iii) the manager shall not, and shall make sure that its affiliates shall not, enter
into any transactions with the company (no investment, contract or arrangement may be made by the company, which
may involve any actual or potential conflict of interest with the manager or any of its affiliates without approval by the
shareholders, acting by a majority of at least 86% of the outstanding shares in the company); or (iv) the manager shall not
take actions contrary to or inconsistent with the obligations of the company to the shareholders, specified in an agreement
to which the company and the shareholders are parties, or otherwise. The above shareholders' approval requirement
shall cease to apply once the share capital of the Company has been increased up to EUR 2,780,000."
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a German translation and that in case of any divergences between
the English and the German text, the English version shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original
deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausendundneun, am zweiten April.
Vor dem unterzeichneten Maître Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtssiitz in Luxemburg.
Fand statt eine außerordentliche Generalversammlung (die Versammlung) der Sigma Capital Hospitality, Leisure and
Tourism Holding Company S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Lu-
xemburg mit Sitz unter der Anschrift 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg (die Gesellschaft), welche gegründet wurde
gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Gerard Lecuit, Notar mit dem damaligen Amtssitz in Hesperange am 15.
November 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C-Nummer 84 vom 28. Januar 2003.
Die Gesellschaftssatzung wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar mit
dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 4. Mai 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
C-Nummer 1679 vom 8. August 2007, geändert und vollkommen neu gefasst.
Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Frau Françoise PFEIFFER, Juristin, beruflich ansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zur Schriftführerin Frau Solange WOLTERSCHIERES, Privatbeamtin, berufsmäßig ansässig in
Luxemburg.
Zur Stimmenzählerin der Versammlung wählt die Versammlung Frau Silvia FONSECA, Juristin, berufsmäßig ansässig in
Luxemburg.
Die Vorsitzende, die Schriftführerin und die Stimmenzählerin werden nachstehend gemeinsam das Bureau genannt.
92052
Nachdem das Bureau somit gebildet wurde, erklärte und bat der Vorsitzende den Notar, wie folgt festzustellen:
I. Die Tagesordnung hat den folgenden Wortlaut:
1. Die Aktionäre erklären den Erhalt und die Annahme des Sonderberichts des Verwaltungsrates gemäß Artikel 32-3
(5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung bezüglich der von den
Aktionären dem Verwaltungsrat erteilten Genehmigung, die bevorzugten Zeichnungsrechte der bestehenden Aktionäre
im Hinblick auf zukünftige Kapitalerhöhungen des gezeichneten Aktienkapitals der Gesellschaft nach einer Ausgabe von
Aktien gemäß dem geänderten Artikel 5.1 der Gesellschaftssatzung zu begrenzen oder zu streichen.
2. Einschiebung eines genehmigten (aber nicht ausgegebenen) Kapitals in Höhe von neun Millionen Euro (EUR
9.000.000) in die Gesellschaftssatzung, eingeteilt in neunhunderttausend (900.000) Aktien mit einem Nennwert von je
zehn Euro (EUR 10) pro Aktie und Ermächtigung des Verwaltungsrats für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum
der außerordentlichen Hauptversammlung, das gezeichnete Kapital einmalig oder mehrmals innerhalb der Grenzen dieses
genehmigten Kapitals zu erhöhen, ohne den bestehenden Aktionären ein bevorzugtes Zeichnungsrecht zu reservieren;
dieses genehmigte Kapital darf nur in Verbindung mit der Umwandlung ausstehender, von der Gesellschaft ausgegebener
Optionsscheine sowie für die Ausgabe von Aktien an Sigma Capital International Management Ltd. (Manager) verwendet
werden und erfordert die nachstehende Änderung und Neufassung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung der Gesell-
schaft.
3. Änderung des Artikels 10 der Gesellschaftssatzung bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft.
4. Änderung des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung bezüglich der Mehrheitserfordernisse bei den Aktionärsver-
sammlungen.
II. Die außerordentliche Hauptversammlung wurde ordnungsgemäß per Schreiben auf dem Postweg an alle Aktionäre
einberufen, wobei es sich bei allen Aktien um Namensaktien handelt.
III. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Stimmrechtsinhaber der vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl
ihrer Aktien sind auf der Anwesenheitsliste vermerkt. Diese von den Aktionären, den Stimmrechtsinhabern der vertre-
tenen Aktionäre, dem Bureau und dem unterzeichneten Notar unterzeichnete Anwesenheitsliste wird dieser Urkunde
als Anlage beigefügt.
Des Weiteren werden die Vollmachten der vertretenen Aktionäre der vorliegenden Urkunde als Anhang beigefügt.
IV. Aus einer von den Bureau-Mitgliedern erstellten und bestätigten Anwesenheitsliste geht hervor, dass zweihun-
dertsechsundsiebzigtausend (276.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10), die einhundert Prozent
(100 %), also die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bilden, bei dieser Versammlung ordnungsgemäß vertreten sind, so
dass die Versammlung ordnungsgemäß konstituiert ist und wirksam über die Tagesordnung beraten sowie beschließen
kann.
Nach einer Beratung fasst die Versammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung erklärt, dass die Aktionäre den Sonderbericht des Verwaltungsrates, erforderlich gemäß Artikel
32-3 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung, bezüglich der von
den Aktionären dem Verwaltungsrat erteilten Genehmigung, die bevorzugten Zeichnungsrechte der bestehenden Akti-
onäre im Hinblick auf zukünftige Kapitalerhöhungen des gezeichneten Aktienkapitals der Gesellschaft nach einer Ausgabe
von Aktien gemäß dem geänderten Artikel 5 der Gesellschaftssatzung zu begrenzen oder zu streichen (Bericht), erhalten
und angenommen haben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung erklärt im Sinne des Berichts und nach Bestätigung, dass die Mitteilung über die Versammlung aus-
drücklich erwähnt, dass die dem Verwaltungsrat erteilte Genehmigung die Möglichkeit beinhaltet, die bevorzugten
Zeichnungsrechte der Aktionäre zu begrenzen oder zu unterdrücken; die Versammlung beschließt einstimmig die Ein-
schiebung eines genehmigten (aber nicht ausgegebenen) Kapitals in Höhe von neun Millionen Euro (EUR 9.000.000) in die
Gesellschaftssatzung, eingeteilt in neunhunderttausend (900.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10)
pro Aktie, sie ermächtigt den Verwaltungsrat, für einen Zeitraum von fünf Jahren, also bis zum 2. April 2014, das ge-
zeichnete Kapital einmalig oder mehrmals innerhalb der Grenzen dieses genehmigten (aber nicht ausgegeben) Kapitals zu
erhöhen, ohne den bestehenden Aktionären ein bevorzugtes Zeichnungsrecht zu reservieren; dieses genehmigte Kapital
darf nur in Verbindung mit der Umwandlung ausstehender, von der Gesellschaft ausgegebener Optionsscheine sowie für
die Ausgabe von Aktien an den Manager verwendet werden.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die Änderung und Neufassung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung der Gesellschaft
wie folgt:
" Art. 5.
5.1. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wird auf zwei Millionen und siebenhundertsechzigtausend Euro (EUR
2.760.000), eingeteilt in zweihundertsechsundsiebzigtausend (276.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro
(EUR 10,-) festgesetzt.
92053
Das gesamte nicht ausgegebene (nicht gezeichnete) Kapital der Gesellschaft wird auf neun Millionen Euro (EUR
9.000.000), eingeteilt in neunhunderttausend (900.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-) festge-
setzt. Dieses genehmigte Kapital ist für die Ausgabe neuer Aktien nach der Umwandlung ausstehender, von der
Gesellschaft ausgegebener Optionsscheine sowie für die Ausgabe von Aktien an den Manager (wie in Artikel 10 festgelegt)
vorbehalten.
Die dem Verwaltungsrat erteilte Ermächtigung gilt für einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren ab dem Datum der außer-
ordentlichen Hauptversammlung vom 2 April 2009 und kann von Zeit zu Zeit durch Beschlüsse einer außerordentlichen
Hauptversammlung der Aktionäre, die gemäß den Erfordernissen für Veränderungen dieser Artikel berät, verlängert
werden, wobei eine Verlängerung höchstens 5 (fünf) Jahre betragen kann.
Der Verwaltungsrat kann das bevorzugte Zeichnungsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft für die Zeich-
nung neuer Aktien, die innerhalb der Grenzen dieses genehmigten Aktienkapitals ausgegeben werden, unterdrücken. Alle
Aktien, die aus der Erhöhung des Aktienkapitals gemäß diesem Artikel 5 hervorgehen, können mit oder ohne Ausga-
beaufschlag ausgegeben und mittels einer Sach- oder Bareinlage, mittels einer Umwandlung von Forderungen oder in einer
anderen, vom Verwaltungsrat festzulegenden Form bezahlt werden.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alles Notwendige zur Änderung von Artikel 5 zu veranlassen, um die Änderung
des Aktienkapitals nach der Ausgabe zusätzlicher Aktien gemäß diesem Artikel 5 eintragen zu lassen; der Verwaltungsrat
ist bevollmächtigt, die Handlungen durchzuführen oder zu genehmigen, die für die Ausführung und Veröffentlichung einer
solchen Änderung gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten
Fassung erforderlich sind. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat an einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Direktor
oder Angestellten des Unternehmens oder an jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person die Aufgabe übertra-
gen, Zeichnungen anzunehmen und Zahlungen für Aktien zu erhalten, die einen Teil oder die Gesamtheit einer solchen
Kapitalerhöhung bilden.
5.2. Auf Wunsch des Inhabers können die Aktien als Zertifikate für einzelne Aktien oder für zwei oder mehr Aktien
verbrieft werden.
Die Aktien werden als Namensaktien und ausgegeben und bleiben auch als solche bestehen.
Die Gesellschaft kann in dem gesetzlich zulässigen Umfang und unter den gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen
ihre eigenen Aktien kaufen.
Bei den von der Gesellschaft ausgegebenen Obligationen muss es sich um Namensobligationen handeln, und die Ob-
ligationen dürfen keine Umwandlung der Namensobligationen in Inhaberobligationen erfordern.
Der Verwaltungsrat legt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Bedingungen für Ausgabe und Erstattung sowie die anderen
Bedingungen in Verbindung mit der Ausgabe von Obligationen fest.
Ein Verzeichnis der eingetragenen Obligationeninhaber wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft gepflegt.
Alle Obligationen werden mit dem Stempel „beschränkt" versehen und können nur mit der Übertragung von Aktien
im Verhältnis neun Obligationen zu einer Aktie übertragen werden. Ist für eine Übertragung von Obligationen gemäß den
Ausgabedokumenten der Obligationen eine Zustimmung der Gesellschaft zu der Übertragung erforderlich, muss der
Verwaltungsrat eine derartige Zustimmung erteilen, wenn die entsprechenden Aktien wie hierin festgelegt von einem
Aktionär gleichzeitig mit den Obligationen übertragen werden. Die Aktien der Gesellschaft sowie alle Zertifikate über
Aktieneinheiten sind frei übertragbar, jedoch unter dem Vorbehalt, dass Aktien nur übertragen werden dürfen, wenn es
gleichzeitig zu einer Übertragung von neun Obligationen pro Aktie an den Erwerber kommt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die Hinzufügung eines Absatzes am Ende von Artikel 10 der Gesellschaftssatzung der
Gesellschaft mit dem folgenden Wortlaut:
„Jegliche Übertragung der täglichen Geschäftsführung an einen geschäftsführenden Direktor oder Manager endet au-
tomatisch mit der Ausgabe neuer Aktien mit einem Gesamtnennwert von EUR 20.000 durch den Verwaltungsrat der
Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Aktienkapitals, so dass sich das Aktienkapital der Gesellschaft min-
destens auf EUR 2.780.000 beläuft. Nach dem Ende einer solchen Übertragung kann gemäß den oben festgelegten
Bestimmungen ein neuer geschäftsführender Direktor oder Manager benannt werden.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die Änderung und Neufassung von Artikel 13 der Gesellschaftssatzung der Gesellschaft
wie folgt:
" Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet jedes Jahr am dreizehnten Tag des Monats Juni um
10.00 Uhr statt.
Alle Versammlungen der Aktionäre werden im Stadtbezirk des eingetragenen Sitzes an dem in der Einberufungseinla-
dung genannten Ort an dem Tag und zu der in dieser Einladung angegebenen Uhrzeit abgehalten. Wenn alle Aktionäre
anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, dass sie Kenntnis von der Tagesordnung haben, kann die Ver-
sammlung ohne eine vorherige Einberufungseinladung stattfinden. Jede Aktie verleiht das Recht auf eine Stimme.
92054
Aktionäre, die eine Mehrheit von mindestens 86 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens halten und entweder
persönlich anwesend oder durch einen Bevollmächtigten vertreten sind, bilden bei allen Versammlungen der Aktionäre
ein Quorum (eine beschlussfähige Mehrheit) für die geschäftlichen Transaktionen. Aktionäre können auch per Telefon-
konferenz oder ähnliche Kommunikationsausrüstungen, mit denen sich alle anwesenden Aktionäre hören können, an
einer Versammlung teilnehmen. Ein solches Quorum ist nicht mehr gültig, sobald das Aktienkapital der Gesellschaft auf
EUR 2.780.000 aufgestockt wurde.
Sofern hierin nichts Gegenteiliges festgelegt ist, entscheiden die Stimmen der Aktionäre, die eine Mehrheit von min-
destens 86 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens halten und entweder persönlich anwesend oder durch einen
Bevollmächtigten vertreten sind, in jeder Frage, die der Versammlung vorgetragen wird, auch wenn es dabei um eine
Änderung dieser Artikel geht, es sei denn, das Gesetz erfordert die Abstimmung durch eine höhere Anzahl oder einen
höheren Prozentsatz. Ein solches Mehrheitserfordernis verliert seine Gültigkeit, sobald das Aktienkapital der Gesellschaft
auf EUR 2.780.000 aufgestockt wurde; in diesem Fall finden die gesetzlich festgelegten Mehrheitserfordernisse Anwen-
dung.
Ohne eine Zustimmung der Aktionäre, die mit einer Mehrheit von mindestens 86 % der ausgegebenen Aktien der
Gesellschaft entscheiden müssen, (i) tätigt die Gesellschaft keine Investitionen oder Ausgaben neuer Aktien oder Obli-
gationen, (ii) leiht die Gesellschaft keiner Person irgendwelches Kapital, (iii) darf der Manager keine Transaktionen mit
der Gesellschaft tätigen und muss sicherstellen, dass auch seine Mitarbeiter keine Transaktionen mit der Gesellschaft
tätigen (es darf ohne eine Zustimmung der Aktionäre, die mit einer Mehrheit von mindestens 86 % der ausgegebenen
Aktien des Unternehmens handeln, keine Anlagen, Verträge oder Vereinbarungen geben, die zu einem tatsächlichen oder
möglichen Interessenkonflikt beim Manager oder seinen Mitarbeitern führen können), oder (iv) darf der Manager keine
Maßnahmen ergreifen, die den Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber ihren Aktionären, die in einer Vereinbarung
spezifiziert werden, zu deren Parteien die Gesellschaft und die Aktionäre gehören, oder anderweitig zuwiderlaufen. Das
oben genannte Erfordernis der Zustimmung der Aktionäre ist nicht mehr gültig, sobald das Gesellschaftskapital auf EUR
2.780.000 aufgestockt wurde.
Da keine weiteren Tagesordnungsangelegenheiten zu besprechen sind, wird die Versammlung beendet.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende
Urkunde auf Verlangen der Parteien in englischer Sprache, gefolgt von einer deutsche Übersetzung, verfasst wurde. Die
Parteien legen fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die englische Version Vorrang hat.
Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde den erschienenden Personen, welche Personen dem Notar durch Vorname, Name, Stand
und Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, haben diese Personen zusammen mit dem Notar die Urkunde unter-
zeichnet.
Gezeichnet: F. PFEIFFER, S. WOLTER-SCHIERES, S. FONSECA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 avril 2009. Relation: LAC/2009/13624. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
erteilt.
Luxemburg, den 20. April 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009119329/321.
(090143130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
Luxdiam, Société Anonyme.
Siège social: L-7264 Walferdange, 2, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 26.870.
L'an deux mille neuf, le dix-sept août.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LUXDIAM" (numéro d'iden-
tité 1987 22 02 172), avec siège social à L-1221 Luxembourg, 233-241, route de Beggen, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 26.870, constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien SCHUMAN, alors de résidence à Luxembourg, en
date du 13 novembre 1987, publié au Mémorial C, numéro 24 du 27 janvier 1988 et dont les statuts ont été modifiés à
différentes reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue en date du 17 décembre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C, numéro 816 du 29 mai 2002.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Michèle ADAM, employée privée, demeurant à Heisdorf.
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-
gique).
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Liliane ALBERTY, employée privée, demeurant à Schouweiler.
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
92055
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-1221 Luxembourg, 233-241, route de Beggen à L-7264 Walferdange, 2, rue des Romains
et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1221 Luxembourg, 233-241, route de Beggen à L-7264 Walfer-
dange, 2, rue des Romains et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur
suivante.
"Le siège de la société est établi dans la Commune de Walferdange."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: ADAM, J.M. WEBER, ALBERTY, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 20 août 2009. Relation: CAP/2009/2868. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 7 septembre 2009.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2009119377/51.
(090143263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
New CV Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.396.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2009.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009119440/12.
(090143044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
agri.capital Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 132.659.
Suite aux résolutions du directoire en date du 9 septembre 2009 de la société agri.capital S.A. les décisions suivantes
ont été prises:
- Démission du membre B du directoire suivant en date du 9 septembre 2009:
92056
Monsieur Frank Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, Pays-Bas, demeurant au 46A, avenue J. F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, en qualité de member B du directoire de la Société
- Nomination du membre B du directoire suivant en date du 9 septembre 2009:
Monsieur Robert van't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam, Pays-Bas, demeurant au 46A, avenue J. F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, en qualité de membre du directoire de la Société et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra
en l'année 2014.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil du directoire de la société est comme suit:
- Monsieur Marco Dijkerman, Membre de catégorie B;
- Monsieur Robert van't Hoeft, Membre de catégorie B;
- Monsieur Bernd Hugenroth, Membre de catégorie A;
- Monsieur Martin Löffler, Membre de catégorie A;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
agri.capital Group S.A.
Marco Dijkerman
<i>Membre B du directoirei>
Référence de publication: 2009119448/25.
(090143262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
Fullmotion S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Fullmotion Holding S.A.).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 69.686.
In the year two thousand and nine, on the nineteenth day of August.
Before us, Maître Marc LECUIT, notary, residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacing Maître
Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg, to whom remains the present deed
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company FULLMOTION HOLDING S.A., with
registered office at L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg N° B. 69.686 (hereafter referred
to as the "Corporation").
The Corporation has been incorporated by deed of notary Léon Thomas, called Tom METZLER, residing in Luxem-
bourg, Bonnevoie, of May 10, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 539 dated
July 14, 1999.
The meeting of shareholders was presided over by Maître Nathalie HOULLE, lawyer, residing professionally in Lu-
xembourg. The chairman then designated as secretary Mr. Mustafa NEZAR, lawyer, residing in Russange (F).
The meeting of shareholders then duly designated as scrutineer, Maître Patricia THILL, lawyer, professionally residing
in Luxembourg.
The board of the meeting thus composed as above, then drew up the attendance list, which, having been signed "ne
varietur" by the representative of the sole shareholder, as well as by the members of the board of the meeting and the
notary, will be attached to the present minutes, together with the proxy, to be filed together with the present deed with
the registration authorities.
The chairman then declared and requested the notary to acknowledge the following:
I. The sole shareholder representing the entire share capital of 50.000,- USD (fifty thousand Dollars of the Unites
States) is duly present or rightfully represented at the present meeting and may as such, effectively deliberate and resolves
upon all the items of the agenda, even those without prior convening notice; he recognizes having received the agenda
beforehand.
II. The agenda of the meeting is as follows:
1 ) Conversion of the Corporation into a société de participations financières ("SOPARFI") and subsequent amendment
to the first paragraph of article 1, articles 2 and 15 of the articles in accordance with the following:
a) Art. 1
st
. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
thereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of "FULLMOTION S.A.".
b) Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other
enterprises or companies either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such
participating interests.
The purpose of the corporation is, in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not,
stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international,
national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option
92057
or in any other manner. The corporation may proceed to the acquisition and development of connected patents and
licences and other intellectual property rights. The corporation may also sell, transfer, exchange or otherwise develop
such securities and other financial investments and patents and licences and other intellectual property rights, and grant
to other enterprises or companies or natural persons, any support, loans, advances or guarantees.
For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without
having obtained the required authorisation
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures.
In general, the corporation may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful
to enhance or to supplement its purpose.
c) "Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the
law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto."
2) Amendment of article 5 which will have the following wording:
" Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of the
corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
corporation.
If the corporation has only a sole shareholder, then this sole shareholder has all the powers of the meeting of share-
holders.
The resolutions which will be taken by the sole shareholder in accordance with paragraph 2 will be recorded by
minutes."
3) Insertion of a new paragraph 2 between paragraphs 1 and 3 of article 7 of the articles with the following wording:
"If however the corporation has only a sole shareholder, or if at a general meeting of shareholders it would appear
that the corporation has only one sole shareholder, then the board of directors may be composed of only one member
until the ordinary general annual meeting of shareholders following the establishment of the existence of more than one
shareholder."
4) Insertion of a new paragraph 2 between paragraphs 1 and 3 of article 8 of the articles with the following wording:
"If the board of directors is composed of only one member, then this sole director will the chairman of the board."
5) Amendment of article 10 which will have the following wording:
" Art. 10. The joint signature of two directors will bind the corporation or the single signature of the sole director or
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors."
6) Amendment of article 11 which will have the following wording:
" Art. 11. One or several statutory auditors or independent auditors, according to the legal provisions, shall supervise
the operations of the corporation. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors or the in-
dependent auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years."
7) Miscellaneous
III. The general meeting of shareholders having approved the declarations of the Chairman and considering itself being
duly constituted and convened, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to convert the Corporation into a société de participations financières
("SOPARFI").
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend paragraph 1 of article 1 of the articles of incorporation of the
Corporation in order to reflect the foregoing resolution.
The first paragraph of article 1 of the articles of incorporation will read as follows:
"There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares thereafter
issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of "FULLMOTION S.A.".
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend article 2 of the articles of incorporation in order to reflect the
first resolution.
Article 2 of the articles of incorporation will read as follows:
" Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other enter-
prises or companies either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such
participating interests.
92058
The purpose of the corporation is, in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not,
stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international,
national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option
or in any other manner. The corporation may proceed to the acquisition and development of connected patents and
licences and other intellectual property rights. The corporation may also sell, transfer, exchange or otherwise develop
such securities and other financial investments and patents and licences and other intellectual property rights, and grant
to other enterprises or companies or natural persons any support, loans, advances or guarantees.
For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without
having obtained the required authorisation
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures.
In general, the corporation may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful
to enhance or to supplement its purpose."
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend article 15 of the articles of incorporation in order to reflect the
first resolution.
Article 15 of the articles of incorporation will read as follows:
" Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto."
<i>Fifth resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation.
Article 5 of the articles of incorporation will read as follows:
" Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of the
corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
corporation. If the corporation has only a sole shareholder, then this sole shareholder has all the powers of the meeting
of shareholders.
The resolutions which will be taken by the sole shareholder in accordance with paragraph 2 will be recorded by
minutes."
<i>Sixth resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to insert a new paragraph 2 between paragraphs 1 and 3 of article 7 the
articles of incorporation with the following wording:
"If however the corporation has only a sole shareholder, or if at a general meeting of shareholders it would appear
that the corporation has only one sole shareholder, then the board of directors may be composed of only one member
until the ordinary general annual meeting of shareholders following the establishment of the existence of more than one
shareholder."
<i>Seventh resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to insert a new paragraph 2 between paragraphs 1 and 3 of article 8 the
articles of incorporation with the following wording:
"If the board of directors is composed of only one member, then this sole director will the chairman of the board."
<i>Eighth resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend article 10 of the articles of incorporation which will have the
following wording:
" Art. 10. The joint signature of two directors will bind the corporation or the single signature of the sole director or
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors."
<i>Ninth resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend article 11 of the articles which will have the following wording:
" Art. 11. One or several statutory auditors or independent auditors, according to the legal provisions, shall supervise
the operations of the corporation. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors or the in-
dependent auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Corporation, as a result of the presently
stated, are valued at approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200).
92059
The undersigned notary who understand and speaks English states that upon request of the above appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing person, it is
specified that in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The present deed having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary
by her surname, Christian name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, the
present deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le dix-neuf août,
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rempla-
cement de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente
minute;
s'est réunie à son siège social une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FULLMOTION
HOLDING S.A. ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse (ci-après dénommée "la So-
ciété").
La Société a été constituée pardevant Maître Léon Thomas, dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie suivant acte du 10 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 539 du 14
juillet 1999.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.686.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte par Me Nathalie HOULLE, avocat, demeurant professionnellement à
Luxembourg, agissant comme Président et désignant Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F), comme
secrétaire de l'assemblée.
L'assemblée nomme scrutateur Maître Patricia THILL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.
Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée "ne varietur" par le
mandataire représentant l'actionnaire unique et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent
procès-verbal ensemble avec la procuration et sera soumise ensemble avec le présent acte aux formalités d'enregistre-
ment.
Le Président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. L'intégralité du capital social de cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-), représenté par cinq cents (500)
actions d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) étant présente ou représentée à la présente as-
semblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire unique présent ou représenté se reconnaît
dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour.
II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Transformation de la société en société de participations financières ("SOPARFI") et modification subséquente du
1
er
paragraphe de l'article 1, et des articles 2 et 15 des statuts comme suit:
a) Art. 1
er
. Paragraphe 1
er
. "Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires d'actions
par après, une société sous la forme d'une société anonyme portant la dénomination de "FULLMOTION S.A."."
b) "Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la détention, la gestion et le développement de ces participations.
L'objet de la société sera, en particulier, l'acquisition de tous types de valeurs, négociables ou non, valeurs mobilières,
obligations, titres de créance, effets de commerce et tous autres titres, y compris des valeurs émises par un Gouverne-
ment, quel qu'il soit, ou par toute autre autorité internationale, nationale ou locale, et de tous autres droits s'y rattachant,
que ce soit par achat, apport, souscription, option, ou par tout autre moyen. La société est en droit de procéder à
l'acquisition et au développement de brevets, licences ou autres droits de propriété intellectuelle s'y rapportant. La société
pourra également procéder au transfert par vente, transfert ou échange ou par tout autre moyen, de ces valeurs et autres
instruments financiers et brevets, licences ou autres droits de propriété intellectuelle, et accorder toute assistance, prêt,
avance ou garantie à d'autres entreprises ou sociétés ou à des personnes physiques.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.
La société pourra contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations ou d'obligations
convertibles en actions et de titres de créance.
D'une manière générale, la Société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles et financières qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
92060
c) "Art. 15. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance
avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée."
2) Modification de l'article 5 qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. Toute assemblée générale des actionnaires de la société représente l'entièreté des actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la société.
Si la société a seulement un actionnaire, cet actionnaire unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.
Les décisions de l'actionnaire unique qui sont prises dans le cadre du deuxième paragraphe sont inscrites dans un
procès-verbal."
3) Insertion d'un nouveau paragraphe 2 entre le 1
er
et le 3e paragraphe de l'article 7 des statuts avec la teneur suivante:
"Toutefois, si la société a été constituée par un actionnaire unique, ou si à une assemblée générale des actionnaires il
est constaté que la société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire."
4) Insertion d'un nouveau paragraphe 2 entre le 1
er
et le 3
e
paragraphe de l'article
8 avec la teneur suivante:
"En cas d'un conseil d'administration composé d'un membre, cet administrateur unique sera le président du conseil
d'administration."
5) Modification de l'article 10 lequel aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 10. La société sera engagée par la signature de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'admi-
nistrateur unique ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué
par le conseil d'administration."
6) Modification de l'article 11 lequel aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou réviseurs
d'entreprise selon les exigences légales. L'assemblée des actionnaires procédera à la nomination des commissaires ou
réviseurs d'entreprise, déterminera leur nombre, leur rémunération et la période pour laquelle ils sont nommés, période
qui ne peut pas excéder six années."
7) Questions diverses.
III. L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment con-
stituée et convoquée, a délibéré et pris par les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la Société en société de participations financières ("SO-
PARFI").
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le paragraphe 1
er
de l'article 1
er
des statuts de la Société afin
de refléter la résolution précédente. Le paragraphe 1
er
de l'article 1
er
des statuts se lit dès lors comme suit:
"Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires d'actions par après, une société sous
la forme d'une société anonyme portant la dénomination de "FULLMOTION S.A."."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 2 des statuts afin de refléter la première résolution.
L'article 2 des statuts se lit dès lors comme suit:
" Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la détention, la gestion et le développement de ces participations.
L'objet de la société sera, en particulier, l'acquisition de tous types de valeurs, négociables ou non, valeurs mobilières,
obligations, titres de créance, effets de commerce et tous autres titres, y compris des valeurs émises par un Gouverne-
ment, quel qu'il soit, ou par toute autre autorité internationale, nationale ou locale, et de tous autres droits s'y rattachant,
que ce soit par achat, apport, souscription, option, ou par tout autre moyen. La société est en droit de procéder à
l'acquisition et au développement de brevets, licences ou autres droits de propriété intellectuelle s'y rapportant. La société
pourra également procéder au transfert par vente, transfert ou échange ou par tout autre moyen, de ces valeurs et autres
instruments financiers et brevets, licences ou autres droits de propriété intellectuelle, et accorder toute assistance, prêt,
avance ou garantie à d'autres entreprises ou sociétés ou à des personnes physiques.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise
92061
La société pourra contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations ou d'obligations
convertibles en actions et de titres de créance.
D'une manière générale, la Société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles et financières qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 15 des statuts afin de refléter la première résolution.
L'article 15 des statuts se lit dès lors comme suit:
" Art. 15. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec
la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée."
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. Toute assemblée générale des actionnaires de la société représente l'entièreté des actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la société.
Si la société a seulement un actionnaire, cet actionnaire unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.
Les décisions de l'actionnaire unique qui sont prises dans le cadre du deuxième paragraphe sont inscrites dans un
procès-verbal."
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide d'insérer un nouveau paragraphe 2 entre l'actuel paragraphe premier et
l'actuel paragraphe trois de l'article 7 des statuts, avec la teneur suivante:
"Toutefois, si la société a été constituée par un actionnaire unique, ou si à une assemblée générale des actionnaires il
est constaté que la société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire."
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide d'insérer un nouveau paragraphe 2 entre l'actuel paragraphe premier et
l'actuel paragraphe trois de l'article 8 des statuts, avec la teneur suivante:
"En cas d'un conseil d'administration composé d'un membre, cet administrateur unique sera le président du conseil
d'administration."
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 10 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 10. La société sera engagée par la signature de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'admi-
nistrateur unique ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué
par le conseil d'administration."
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 11 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou réviseurs
d'entreprise selon les exigences légales. L'assemblée des actionnaires procédera à la nomination des commissaires ou
réviseurs d'entreprise, déterminera leur nombre, leur rémunération et la période pour laquelle ils sont nommés, période
qui ne peut pas excéder six années."
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant ci-dessus, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de la même personne comparante,
il est spécifié qu'en case de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, le présent acte notarié est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et traduction donnée en une langue connue à la personne comparante, connue du notaire par
nom, prénom, état et demeure, ladite personne comparante a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. HOULLE, M. NEZAR, P. THILL, G. LECUIT.
92062
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 août 2009. Relation: LAC/2009/34924. Reçu: soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009119346/306.
(090143573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.
KBC FII, KBC Financial Indemnity Insurance, Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 75.878.
L'an deux mille neuf, le quatre août.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
la société anonyme ASSURISK, avec siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 30.328 (ci-après "l'Actionnaire Unique"),
ici représentée par Monsieur Ivo Bauwens, managing director, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles, Belgique, le 17 juillet 2009.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'actionnaire unique de KBC Financial Indemnity Insurance, en abrégé "KBC FII", une société ano-
nyme, ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, inscrite auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 75.878, constituée sous la dénomination ALMA REINSURANCE S.A.
suivant acte notarié en date du 15 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 668 du
18 septembre 2000.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 19 décembre 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 915 du 18 mai 2007 (ci-après la "Société").
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) pour le porter de son
montant actuel de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000) à quinze millions d'euros (EUR 15.000.000), par la création et
l'émission de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles actions ayant une valeur nominale de quatre mille euros (EUR 4.000)
chacune;
2. Souscription et libération en espèces;
3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société;
4. Divers.
L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix millions d'euros (EUR 10.000.000)
pour le porter de son montant actuel de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000) à quinze millions d'euros (EUR 15.000.000),
par la création et l'émission de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles actions ayant une valeur nominale de quatre mille
euros (EUR 4.000) chacune.
Les deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles sont toutes souscrites par l'Actionnaire Unique, prénommée,
représentée comme indiqué ci-dessus, pour un montant total de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) intégralement
affecté au capital social de la Société.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire par l'Actionnaire Unique, de sorte que le montant
total de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) est à la disposition de la Société, tel qu'il a été démontré au notaire
soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Actionnaire Unique décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts de la
Société qui aura désormais la teneur suivante:
"Le capital social est fixé à quinze millions d'euros (EUR 15.000.000) représenté par trois mille sept cent cinquante
(3.750) actions d'une valeur nominale de quatre mille euros (EUR 4.000) chacune."
92063
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: I. BAUWENS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2009. LAC/2009/32467. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 4 septembre 2009.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2009118522/59.
(090142798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.
Nexia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 105.358.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NEXIA S.A.
i>SGG S.A.
<i>Mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009118459/13.
(090142726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.
Topglas Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 101.712.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 25 août 2009:i>
<i>1. Administrateursi>
1.1 Les mandats de John Broadhurst Mills ainsi que celui de Solon Director Limited, comme étant administrateurs, ont
été renouvelés avec effet au 28 avril 2009. Leur échéance arrivera en date du 25 août 2009.
1.2 Le mandat de Montblanc (Directors) Limited, comme étant administrateur, a été renouvelé avec effet au 28 avril
2009. Son échéance arrivera lors de l'assemblée générale statutaire de 2014.
1.3 La société a pris acte que Christopher Crosby, né le 27 octobre 1961, East London, demeurant à Clairmont, Le
rue de Bas, St Lawrence, JE3 1JG, Jersey, a été nommé par Montblanc (Directors) Limited comme étant son représentant
permanent en relation avec son mandat d'administrateur de la société en date 25 août 2009. Son mandat arrivera à
échéance lors de l'assemblée générale statutaire 2014.
1.4 Kai Hennen, né le 27 mai 1975, Cochem, Allemagne et Kathryn Bergkoetter, née le 25 mars 1964, Illinois, Etats-
Unis d'Amérique, tous deux demeurant professionnellement au 58, rue Charles Martel, L-2134, Luxembourg, ont été
nommés comme administrateur de la société avec effet au 25 août 2009. Leur mandat arrivera à échéance lors de l'as-
semblé générale statutaire de 2014.
<i>2. Commissaire aux comptesi>
Le mandat de Dirk Oppelaar, comme étant commissaire aux comptes, a été renouvelé avec effet au 28 avril 2009. Son
échéance arrivera lors de l'assemblée générale statutaire de 2014.
Luxembourg, le 9 septembre 2009.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009118092/29.
(090142007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
92064
agri.capital Group S.A.
Beltaj Finance S.A.
Biodev S.A.
Brossia Investments S.à r.l.
Clavadel Finance S.A.
Clavadel Finance S.A.
CTS Coating Technology System S.A.
Dancing de la Place S.à r.l.
Downshire Enterprises S.A.
Emerald S.A.
EPI - European Property Investment S.A.
Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l.
Eridanus S.à r.l.
Euro-Getränke A.G.
European Media Ventures S.A.
Fiduciaire Denis Bossicart S.à r.l.
Fifin S.A.
Fortunae S.P.F.
Francap S.à r.l.
Fullmotion Holding S.A.
Fullmotion S.A.
Grouwen-A-Feldbunn S.à r.l.
Haken Lighthouse
HAZ Holding S.A.
International Terry Company S.à.r.l.
Jing Tai S.àr.l.
Kaiserkarree S.à r.l.
KBC Financial Indemnity Insurance
KC Lux S.à r.l.
Labeo S.A.
Lagfin S.A.
LDR S.A.
Luxdiam
Maison Rideaux Thibeau, S.à r.l.
Martin Pecheur Investments Limited
Maxilly Estate S.A.
New CV Luxco S.à r.l.
Nexia S.A.
NG Luxembourg 3 S.à r.l.
Notola S.A.
Opportunity Fund III (Luxembourg) S.à r.l.
Pepsi-Cola Belgium S.à r.l.
P.R. International S.A.
Réidener Spënnchen S.A.
Restaurant Chinois YONG-HONG S.à r.l.
RREP Luxembourg S.à r.l.
S.A.F. Services Anti-Feu
Schneppelstuff s.à r.l.
S.E.F. Luxemburg Holding S.A.
Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A.
Soluxcom
Stratus Packaging Europe
Strongbow Capital Holdings S.A.
Tarinech S.à r.l.
Topglas Investments S.A.
Trading Invest S.A.
Unicapital Investments V (Management) S.A.
VAN-Electronic A.G.
Waasserkraaft Wampach, s.à r.l.
Westbridge S.à r.l.
Z Alpha S.A.