logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1919

2 octobre 2009

SOMMAIRE

Acmar Financial Luxembourg S.A.  . . . . . .

92068

ACS Dobfar Generics S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

92066

Agnes Constructions Succ. S.A.  . . . . . . . . .

92112

Air 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92077

Alamos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92080

Allmende S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92074

Alpina Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

92071

Amesbury Property Group S.à r.l.  . . . . . . .

92074

AMO Holding 16 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92100

Amot Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92067

Ampala S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92071

ÄVWL Real Asset Trust Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92073

ÄVWL Real Asset Trust S.à r.l. . . . . . . . . . .

92072

Beryss S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92066

Braga Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

92075

Building The Future S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

92073

Building The Future S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

92077

CHURCHILL.HUI International S.A.  . . . .

92067

Close World S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92069

Coast Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92099

CORSAIR (Luxembourg) N°20 S.A.  . . . . .

92079

CORSAIR (Luxembourg) N°21 S.A.  . . . . .

92079

Credit Suisse International & Compagnie

SNC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92107

Dana International Luxembourg S.à r.l.  . .

92099

Ex Pluribus Unum S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

92078

Fabergé S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92100

Farmachen S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92098

Ferrum Fund Management Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92075

Ferrum Pension Management S. à r.l.  . . . .

92073

Finance et Développement  . . . . . . . . . . . . .

92066

Freisler Schumann Holding AG . . . . . . . . . .

92066

Holding Klege S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92071

Industrial Buildings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

92069

Infinitinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92078

International Business Services & Partners

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92067

Location de Voiture Internationale S.A. in

Kurzform L.V.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92095

Maguro II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92072

Manzoni International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

92074

MaxInvest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92075

MB Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92079

MezzVest Luxembourg II S. à r.l . . . . . . . . .

92069

MezzVest Luxembourg I S.à.r.l.  . . . . . . . . .

92070

Montferrand Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

92077

Novopar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92107

Opera Masters Management S.à r.l. . . . . . .

92080

Pasadena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92079

Prickley Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

92076

Private Trust Management Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92072

ProLogis Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

92070

Restab S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92068

Russian Consumer Finance No.1 S.A.  . . . .

92078

Samtora (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

92076

Sanacomp S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92067

SDG Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

92099

Société Financière d'Investissement  . . . . .

92066

Socket Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92076

Socket Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92076

SportInvest International S.A. . . . . . . . . . . .

92068

Stevenage Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

92067

Swisscanto (Lu) Bond Invest Management

Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92112

Taronga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92070

TMK Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92078

Tottenham Hale S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . .

92081

92065

ACS Dobfar Generics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 65.912.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009114393/12.
(090137540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Freisler Schumann Holding AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 91.816.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114386/10.
(090137796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Beryss S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 67.023.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114380/10.
(090137789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Société Financière d'Investissement, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.534.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114394/10.
(090137431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Finance et Développement, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 73.425.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINANCE ET DEVELOPPEMENT
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009114367/12.
(090137368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

92066

Stevenage Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 33.080.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114375/10.
(090137446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Amot Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 44.255.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114374/10.
(090137447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

International Business Services &amp; Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 35.973.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114397/10.
(090137457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

CHURCHILL.HUI International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 4, avenue du Docteur Ernest Feltgen.

R.C.S. Luxembourg B 76.539.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114373/10.
(090137787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Sanacomp S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 130.125.

In der Hauptversammlung der Sanacomp S.à r.l. am 11. August 2008 wurde die Fiduciaire Joseph Treis S.à r.l. RCS

Luxembourg B 70910

57, avenue de la Faïencerie
L-1510 Luxembourg,
für das Geschäftsjahr 2008 zum Abschlussprüfer bestimmt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2009.

Bodo Demisch.

Référence de publication: 2009115900/14.
(090139234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

92067

SportInvest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.542.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société SportInvest International S.A. qui s'est

tenue extraordinairement en date du 10 août 2009 que:

GEFCO CONSULTING SARL établie et ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg est nommé

Commissaire aux Comptes avec effet immédiat jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010, en rem-
placement de European Audit Sàrl.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2009115921/16.
(090139441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Restab S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 86.490.

<i>Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 23 juillet 2009

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivé à leur terme, l'Assemblée a décidé de

nommer jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014:

- M. Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en

qualité d'Administrateur,

- Director Sàrl, une société ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en qualité d'Adminis-

trateur,

- Manager Sàrl, une société ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en qualité d'Administra-

teur,

- Luxfiducia Sàrl, une société ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en qualité de Com-

missaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009115934/23.
(090139585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Acmar Financial Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 88.204.

Suite au Conseil d'Administration tenu en date du 1 

er

 septembre 2009, il a été décidé de reconduire avec effet immédiat

Madame Polyxeni Kotoula en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société. Son mandat prendra fin à
l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Pour avis conforme
Polyxeni Kotoula / Jorge Pérez Lozano
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009115817/15.
(090139143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

92068

Close World S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.011.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 juin 2009

<i>Résolutions

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2009 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009115866/19.
(090139299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Industrial Buildings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 68.343.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 juillet 2009

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2009:

<i>Commissaire aux comptes:

Fiduciaria MEVEA SARL, 4 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009115868/17.
(090139303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

MezzVest Luxembourg II S. à r.l ., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 110.227.

Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société MezzVest Luxembourg II S.à r.l. datées du 7 septembre 2009,

les décisions suivantes ont été prises:

- Démission de M. Jacques Barbier de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 7 septembre 2009
- Nomination de M. William A. Obenshain, né le 18 avril 1940 à Cincinnati, Ohio, Etats-Unis d'Amérique, résidant à

2236 N. Lincoln Park West, Chicago, Illinois, 60614, Ohio, Etats-Unis d'Amérique, à la fonction de gérant avec effet au 7
septembre 2009 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>MezzVest Luxembourg II S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2009118068/18.
(090142158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

92069

Taronga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 96.405.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2009 que:
- La société AUSTIN EQUITIES SA, société de Panama, ayant son siège social à Arango-Orillac Building, Second Floor,

East 54th Street, Rep. of Panama, a été nommée Commissaire aux Compte en remplacement de Mayfair Trust Sàrl,
démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de rassemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
- Monsieur Riccardo MORALDI, administrateur actuel, a été nomme Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 09/09/09.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009118070/17.
(090142126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

MezzVest Luxembourg I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 78.731.

Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société MezzVest Luxembourg I S.à r.l. datées du 7 septembre 2009,

les décisions suivantes ont été prises:

- Démission de M. Jacques Barbier de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 7 septembre 2009
- Nomination de M. William A. Obenshain, né le 18 avril 1940 à Cincinnati, Ohio, Etats-Unis d'Amérique, résidant à

2236 N. Lincoln Park West, Chicago, Illinois, 60614, Ohio, Etats-Unis d'Amérique, à la fonction de gérant avec effet au 7
septembre 2009 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>MezzVest Luxembourg I S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009118067/19.
(090142161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

ProLogis Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.940.

<i>Extrait pour dépôt

<i>Cession de parts

Il résulte d'un acte notarié en date du 9 mai 2008, enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2008, LAC / 2008 / 19480,

que les parts sociales de la société ProLogis Management S.à r.l. (la Société) ont été apportées en nature par PLD Inter-
national Incorporated (le cédant) à ProLogis Management Services S.à r.l. (le cessionnaire).

Par conséquent, ProLogis Management Services S.à r.l. est propriétaire de toutes les parts sociales émises par ProLogis

Management S.à r.l..

Le présent extrait vaut mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Peter Cassells
<i>Gérant

Référence de publication: 2009118045/18.
(090142303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

92070

Alpina Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 105.829.

<i>Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique qui s'est tenue le 4 septembre 2009

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de la Société qui s'est tenue le 4 septembre 2009, il a été décidé

comme suit:

- D'accepter la démission de Mr Doeke van der Molen résidant au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

comme Gérant de la société avec effet immédiat.

- De nommer Mme Christelle Ferry, résidant au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme Gérant

de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009118036/18.
(090141690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Holding Klege S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.508.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2009

Résolutions:
1- Acceptation de la démission de Monsieur Michel Clair de son poste de Gérant de catégorie A de la Société en date

du 15 avril 2009.

2- Nomination de Monsieur Laurent Morel, 21, avenue Kléber, F75016 Paris en remplacement de Monsieur Michel

Clair au poste de gérant de catégorie A de la Société.

3- Nomination de Monsieur Olivier Terrenoire, 5, allée Scheffer, L-2420 Luxembourg comme premier gérant délégué

à la gestion quotidienne pour une période de 3 ans.

Pour extrait
FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2009118040/18.
(090141821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Ampala S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 143.241.

Par décision du Conseil de gérance du 11 août 2009 Monsieur Patrick FERY, demeurant à 24 rue Carnot, F-10100

Romilly-sur-Seine, France a été nommé délégué du conseil de gérance, et pourra engager la société sous sa seule signature
pour la gestion journalière.

Luxembourg, le 03 SEP. 2009.

<i>Pour AMPALA S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
Cathérine Day-Royemans / Mireille Wagner
<i>Vice-président / -

Référence de publication: 2009118042/18.
(090141806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

92071

Maguro II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 136.575.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2009 à 11.00 heures à Luxembourg 23,

<i>avenue de la Porte-Neuve

- Les mandats des Gérants viennent à échéance à la présente Assemblée.
-  L'Assemblée  Générale  Ordinaire  décide  à  l'unanimité  de  renouveler  le  mandat  de  Gérants  de  Monsieur  Joseph

Winandy et de la société Cosafin S.A., 23 avenue de la Porte Neuve-L-2227 Luxembourg, représentée par Monsieur
Jacques Bordet, 10 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de nom-
mer Monsieur Koen Lozie, 18 rue des Sacrifiés L-8356 Garnich, au poste de gérant en remplacement de Monsieur Jean
Quintus.

- Les mandats des Gérants viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes

clôturés au 31 décembre 2009.

Pour extrait
Signatures
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009118039/20.
(090141759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

ÄVWL Real Asset Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 141.577.

Suite au transfert du siège social de la Société, le 1 

er

 septembre 2009, il y a lieu de lire l'adresse professionnelle de

Monsieur Dieter NÖLKEL et Monsieur Thomas ZIMMER comme suit:

- 1, rue Nicolas Adames
L-1114 Luxembourg

Par ailleurs, il y lieu de corriger les données relatives à l'associé unique de la Société:
- ÄVWL Real Asset Trust Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 1, rue Nicolas

Adames, L-1114 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 143233, est l'associé unique de la Société (et non "Ferrum Pension Management S.à r.l.")

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

ÄVWL Real Asset Trust S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009118049/19.
(090142291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Private Trust Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 123.203.

Suite au transfert du siège social de la Société, le 1 

er

 septembre 2009, il y a lieu de lire l'adresse professionnelle de

Monsieur Dieter NÖLKEL et Monsieur Thomas ZIMMER comme suit:

- 1, rue Nicolas Adames
L-1114 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Private Trust Management Company S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009118050/15.
(090142276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

92072

Ferrum Pension Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 122.594.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

Il y a lieu de lire l'adresse de Monsieur Dieter NÖLKEL et Monsieur Thomas ZIMMER comme suit:
- 1, rue Nicolas Adames
L-1114 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Ferrum Pension Management S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009118048/16.
(090142280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

ÄVWL Real Asset Trust Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 143.233.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

Le siège social de Ferrum Pension Management S.à r.l. a changé comme suit:
- 1, rue Nicolas Adames
L-1114 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

ÄVWL Real Asset Trust Holding S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009118047/16.
(090142293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Building The Future S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 120.853.

Suite au transfert de siège de la société BUILDING THE FUTURE S.A. avec prise d'effet au 28 janvier 2008, il est porté

à la connaissance de tous que l'adresse professionnelle de Madame Nathalie Mager et de Madame Tonini-Di Vito Helena,
agissant en tant que administrateur, a été modifié et se situe à compter de cette date au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg.

Le Conseil d'administration se compose dès lors comme suit:
- Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180

Luxembourg, administrateur,

- Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Lu-

xembourg, administrateur,

- Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180

Luxembourg, administrateur.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009118065/22.
(090142172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

92073

Allmende S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 21.902.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 août 2009

Est nommé commissaire aux comptes en remplacement de BDO Compagnie Fiduciaire, son mandat prenant fin lors

de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- BDO Audit, Société Anonyme, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009118061/14.
(090142242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Manzoni International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 71.820.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 août 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Auguste BETSCHART, administrateur de sociétés, demeurant à 19 chemin du Chamoliet, 1226 Thônex,

Genève (Suisse), Président;

- Monsieur Nikolaus ZENS, administrateur de sociétés, demeurant à 161 A route d'Hermance, 1245 Collonge, Genève

(Suisse).

- LEMAN CAPITAL S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce de Genève sous le numéro CH-660-0498998-4, ayant

son siège social au 65, rue du Rhône, CH-1204 Genève, représentée par Monsieur Auguste BETSCHART, représentant
permanent, demeurant à 19 chemin du Chamoliet, 1226 Thônex, Genève (Suisse).

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- EWA Révision S.A. inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 38.937, sise

au 45, avenue JF Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009118063/23.
(090142190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Amesbury Property Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 76.869.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 2 septembre 2009

1. M. Benoît NASR a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée. La société se trouve engagée par la signature du gérant.

Luxembourg, le 10 SEP. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AMESBURY PROPERTY GROUP S.A R.L.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009118055/17.
(090142304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

92074

MaxInvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 412.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.125.

L'adresse de l'associé unique Monsieur Michael PAWLOWSKI est dorénavant la suivante:
Monsieur Michael PAWLOWSKI, demeurant au 154, Les Cheseaux-Dessus, CH-1264 St-Cergue, Suisse: 16.500 parts

sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2009118064/15.
(090142181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Braga Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.785.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 2 septembre 2009

1. M. Benoît NASR a démissionné de son mandat de gérant.
2. Le nombre des gérants a été augmenté de 1 (un) à 3 (trois).
3. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée.

4. M. Georges SCHEUER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), le 5 juin 1967,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
gérant pour une durée indéterminée.

5. M. Ruth BRAND, administrateur de sociétés, née à Sarnen (Suisse), le 21 juillet 1954, demeurant professionnellement

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une durée indé-
terminée.

Luxembourg, le 10 SEP. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BRAGA INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009118057/24.
(090142299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Ferrum Fund Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 108.559.

Suite au transfert du siège social de la Société, le 1 

er

 septembre 2009, il y a lieu de lire l'adresse professionnelle de

Monsieur Dieter NÖLKEL et Monsieur Thomas ZIMMER comme suit:

- 1, rue Nicolas Adames
L-1114 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Ferrum Fund Management Company S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009118053/15.
(090142240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

92075

Socket Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 29.885.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009118075/10.
(090141697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Socket Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 29.885.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009118076/10.
(090141698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Prickley Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 76.023.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009118074/10.
(090141696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Samtora (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.257.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 2 septembre 2009

1. M. Benoît NASR a démissionné de son mandat de gérant.
2. Le nombre des gérants a été augmenté de 1 (un) à 3 (trois).
3. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée.

4. M. Georges SCHEUER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), le 5 juin 1967,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
gérant pour une durée indéterminée.

5. M. Ruth BRAND, administrateur de sociétés, née à Sarnen (Suisse), le 21 juillet 1954, demeurant professionnellement

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une durée indé-
terminée.

Luxembourg, le 10 SEP. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Samtora (Luxembourg) S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009118056/24.
(090142302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

92076

Air 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 81.112.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 9 septembre 2009 que les

modifications suivantes ont été apportées:

<i>- Commissaire aux comptes:

La société MRM Consulting S.A., 5, rue de l'Ecole, L-4394 Pontpierre, a été nommée commissaire aux comptes en lieu

et place de M. Luis Velasco avec effet immédiat.

Le mandat susvisé prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>AIR 1 SA
Patrick Houbert
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009118077/18.
(090142077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Building The Future S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 120.853.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 août 2009

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, et de Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, avec
adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

L'Assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg au poste d'administrateur. Ce mandat se terminera lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de ALTER AUDIT S.à r.l., ayant son siège social au

69, rue de la Semois à L-2533 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2014.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009118066/23.
(090142167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Montferrand Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 85.063.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.09.2009.

MONTFERRAND HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009118899/13.
(090142587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

92077

Ex Pluribus Unum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 86.374.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009118898/10.
(090142584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

TMK Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 119.081.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2009:

- Est nommée administrateur de la société Mme. Rachel Aguirre, employée privée, résidant professionnellement au 2,

boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement de l'administrateur démissionnaire M. Marco Hirth
avec effet du 9 septembre 2009.

- Le nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 statuant sur les comptes

annuels de 2009.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2009118902/16.
(090142669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Russian Consumer Finance No.1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 114.369.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2009:

- Est nommée administrateur de la société Mme. Rachel Aguirre, employée privée, résidant professionnellement au 2.

boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement de l'administrateur démissionnaire M. Marco Hirth
avec effet du 9 septembre 2009.

- Le nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 statuant sur les comptes

annuels de 2009.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2009118903/16.
(090142667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Infinitinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 63.934.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009118913/12.
(090142399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

92078

CORSAIR (Luxembourg) N°21 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 95.222.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2009:

- Est nommée administrateur de la société Mme. Rachel Aguirre, employée privée, résidant professionnellement au 2,

boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Rolf Caspers
avec effet du 4 septembre 2009.

- Le nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 statuant sur les comptes

annuels de 2009.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2009118895/16.
(090142638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

MB Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 114.660.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2009:

- Est nommée administrateur de la société Mme. Rachel Aguirre, employée privée, résidant professionnellement au 2,

boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Rolf Caspers
avec effet du 4 septembre 2009.

- Le nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 statuant sur les comptes

annuels de 2009.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2009118897/16.
(090142648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

CORSAIR (Luxembourg) N°20 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 95.221.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2009:

- Est nommée administrateur de la société Mme. Rachel Aguirre, employée privée, résidant professionnellement au 2,

boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Rolf Caspers
avec effet du 4 septembre 2009.

- Le nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 statuant sur les comptes

annuels de 2009.

Luxembourg, le 4 septembre 2009.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2009118893/16.
(090142629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Pasadena S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 92.584.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2009:

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

92079

- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

- Monsieur Marco NEUEN, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur;

- Monsieur René SCHLIM, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2014.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

Luxembourg.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009118912/25.
(090142684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Alamos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 92.650.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 août 2009:

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

- Monsieur Marco NEUEN, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur;

- Monsieur René SCHLIM, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2014.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009118914/24.
(090142682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Opera Masters Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 115.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009118917/11.
(090142402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

92080

Tottenham Hale S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.760.

In the year two thousand and nine,
on the second day of the month of September.
Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-

cement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain
depositary of the present original deed,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "Tottenham Hale S.à r.l.", a société

à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Me
Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg, on 17 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 2354 of 19 October 2007, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under B-131.760 (the "Company"). The Company's articles of association have not been amended yet.

The meeting was declared open and was presided by Mrs Caroline WEIRAUCH, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed Mrs Rebecca UNVERZAGT, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
The meeting elected as scrutineer Mr Cedric BLESS, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1 To create two classes of shares, the class A shares (the "Class A Shares"), the class B shares (the "Class B Shares"),

and to reclassify the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares of one Cent (EUR 0.01) each into
eight-hundred seventy-five thousand (875,000) Class A Shares of one Cent (EUR 0.01) each and three-hundred seventy-
five thousand (375,000) Class B Shares of one Cent (EUR 0.01) each.

2 To fully restate the articles of incorporation of the Company, which restatement, next to reflecting the above changes

to the issued capital, shall consist inter alia in adopting the following corporate object:

"The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of interests in

Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such assets and/or
interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation
or which are members of its group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object."

3 Miscellaneous.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list

signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of
the meeting; such attendance list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with
this deed.

III. It appears from the said attendance list that out of the issued share capital of the Company all shares are present

or represented at the meeting. The Meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all
the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present
Meeting.

IV. The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the chairman, by unanimous vote adopted

the following resolution:

<i>First resolution

The Meeting RESOLVED to create two (2) classes of shares, the class A shares (the "Class A Shares") and the class B

shares (the "Class B Shares"), and RESOLVED to reclassify the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000)

92081

shares of one Cent (EUR 0.01) each into eight-hundred seventy-five thousand (875,000) Class A Shares of one Cent (EUR
0.01) each and three-hundred seventy-five thousand (375,000) Class B Shares of one Cent (EUR 0.01) each.

As a result, FCP Anlage AG, a company incorporated and organised under the laws of Germany, with registered office

at Freihamer Straße 2, 82166 Gräfelfing, Germany and registered with the commercial register of the Local Court of
Munich under HRB 164206 is holding all of the Class A Shares and one hundred twenty-five thousand (125,000) Class B
Shares, Benecura S.à r.l., a private limited liability company (Société à responsabilité limitée), having a share capital of EUR
12,500.-, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under B-138.251 is
holding one hundred twenty-five thousand (125,000) Class B Shares, and InvestOpp S.à r.l., a private limited liability
company (Société à responsabilité limitée), having a share capital of EUR 12,500.-, incorporated and existing under the
laws of Luxembourg, with registered office at 2, rue Joseph Hackin, L- 1746 Luxembourg, and registered with the Lu-
xembourg  Register  of  Commerce  and  Companies  under  B-139.667,  is  holding  one  hundred  twenty-five  thousand
(125,000) Class B Shares.

<i>Second resolution

The Meeting RESOLVED that the articles of association of the Company shall be entirely restated to inter alia reflect

the above resolution, so that these articles shall forthwith read as follows:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time
to time (the "Law"), and by the present articles of incorporation (the "Articles of Association").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "Tottenham Hale S.à r.l.".

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s).

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the

Manager(s).

In the event that in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of

interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such
assets and/or interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds
a participation or which are members of its group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
It may be dissolved by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the applicable

laws or by these Articles of Association, as the case may be, for any amendment of these Articles of Association.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (Eur 12,500.-), represented

by eight-hundred seventy-five thousand (875,000) fully paid class A shares (the "Class A Shares") and three-hundred
seventy-five thousand (375,000) fully paid class B shares (the "Class B Shares"), each of such Class A Shares and Class B

92082

Shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) (the Class A Shares and the Class B Shares are collectively referred
to as the "Shares" and individually as a "Share").

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each Share entitles to one vote. Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of

Association of the Company and the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

Each Share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of Shares must be represented towards the

Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its Shares. When

the Company is composed of several shareholders, the shares may, always subject to the following paragraph below, be
transferred (i) freely amongst shareholders and (ii) to non-shareholders only with the authorisation of a majority of the
shareholders as further set out in article 21 of these Articles of Association.

The precise terms and conditions in relation to the transfer of Shares issued by the Company may be agreed in writing

by the shareholders. Transfers shall be made in compliance with any such terms and conditions and with these Articles
of Association. The Company is entitled to refuse to register any transfer of Shares unless transferred in accordance with
these Articles of Association or in accordance with any agreement relating to the transfer of Shares to which the Company
is a party. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract.

Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law, in view of their immediate

cancellation.

Art. 7. Increase and Reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a reso-

lution of the shareholder(s) voting with the quorum and majority rules set by the applicable laws or by these Articles of
Association, as the case may be, for any amendment of these Articles of Association.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed and administered by one or several managers who need not be

shareholders themselves (the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Manager(s) will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of his (their) mandate and

their number. The Manager(s) are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") and

class B Managers (the "Class B Managers").

At general meetings of the shareholders resolving on statutory elections, the holder(s) of Class B Shares are entitled

to propose the qualification of the appointed Managers (if two (2) or more Manager(s) have been appointed) into Class
A Managers and Class B Managers.

The holder(s) of Class B Shares are further entitled to propose the Class B Managers for election or removal, whereas

such Class B Managers will be chosen from a list of candidates presented by the holder(s) of Class B Shares, being
understood that there will be one (1) Class B Manager if two (2) Managers are appointed and not less than one third
(1/3) of the Managers will be Class B Managers if at least three (3) Managers are appointed.

Art. 10. Powers of the managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles of Association to shareholder(s) are in the competence

of the Managers.

The Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, shall require the prior written consent of the share-

holders in order to effect the following legal transactions and measures:

(i) the purchase or other acquisition by the Company of any real estate assets or any real estate owning legal entity

and the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the purchase or other acquisition of any real estate
assets or any real estate owning legal entity by any of its direct or indirect subsidiaries (if existing);

92083

(ii) any creation of, pledge, sale or other disposal of shares in the Company's direct or indirect subsidiaries (if existent),

or the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the liquidation of the Company's direct or indirect
subsidiaries;

(iii) any sale or disposal of any real estate asset or portfolio of real estate - either by asset or share deal type of

transaction - or any other material fixed asset held by the Company or the exercise of the Company's shareholder rights
in case the real estate asset, portfolio of real estate or other material fixed asset is held by any of the Company's direct
or indirect subsidiaries (if existing);

(iv) the entering into, amending, prepaying or terminating of any third party loan or shareholder loan and the creation

of any pledge or other encumbrance on such loans;

(v) the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the adoption of or changes to the articles of

association of any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing);

(vi) the establishment or closure of branch offices;
(vii) the acquisition, disposal or encumbrance of participations in other enterprises, including silent participations, the

exercise of the Company's shareholder rights with respect to acquisition, disposal or encumbrance of participations in
other enterprises, including silent participations by any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing);

(viii) the acquisition or disposal of businesses or parts of businesses; and
(ix) the exercise of the Company's shareholders rights with respect to the execution, termination or amendment of

any center management or other material service agreement by the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing).

For the avoidance of doubt, all other acts necessary or useful for accomplishing the Company's object will not be

subject to shareholders' consent.

Art. 11. Meetings of the board of managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) days written

notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place and the agenda of the
meeting. Any Manager may waive his right to be convened as set out above. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office or at such other place as the Board of

Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of half of the Managers holding office,

provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, such quorum
shall only be met if at least one Class A Manager and one Class B Manager are present.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 12. Recording of the resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by any two Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 13. Management fees and Expenses. Subject to the approval of the shareholder(s), the Managers may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by him/them in relation with such management of the Company or the pursuit
of the Company's corporate object.

Art. 14. Managers' liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any Manager is only liable for the performance
of his duties.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason

92084

of his being or having been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the relevant
Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Any person
related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that one or more of the Managers of the Company have or may have any

personal interest in any transaction of the Company, they shall make known to the other Manager(s) such personal
interest. The conflicted Manager(s) shall not consider or vote on any such transaction and such transaction and such
Managers' interest therein shall be reported to the shareholder(s).

The foregoing provisions do not apply if and when the relevant transaction is entered into under fair market conditions

and falls within the ordinary course of business of the Company.

Art. 16. Representation of the company - Delegation of powers. The Company will be bound towards third parties

by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two (2) Manager(s) if more than one
Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers and Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or committees chosen by them.

The Company will also be bound by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory

power has been delegated, but only within the limits of such power

Art. 17. Auditors. Except where according to the laws the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.

The auditors, if any, will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of their mandate. The

auditors are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the
shareholder(s).

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises

the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not
applicable to that situation.

If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions

of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions can be documented in a single document or in several
separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholder(s). Should the
resolutions to be adopted, be sent by the Manager(s) to the shareholders, the shareholders are under the obligation to,
within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolutions, cast their written vote and
return it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum
and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis
mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

issuance of a convening notice sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting by the Manager(s), the
auditors or shareholders representing half of the corporate capital. The convening notice will specify the time and place
and the agenda of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting should be held in the Grand Duchy of Lu-

xembourg. They may be held abroad if circumstances of force majeure so require.

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

92085

Art. 19. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to

the Law and these Articles of Association.

Art. 20. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders to be held in case the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such
other place in the Grand Duchy of Luxembourg, as may be specified in the notice convening the meeting, at the latest
within six (6) months after the close of the financial year.

If such day is a day on which banks are not open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next

following business day.

Art. 21. Procedure and Vote at meetings. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder, as his
proxy.

The following measures shall always require a resolution by a majority of the shareholders representing at least ninety

percent (90%) of the voting rights in the Company:

(i) any transfer of Shares, other than to Affiliates (as defined from time to time in agreements between the shareholders

to which the Company is a party) and/or among Executive Shareholders (as defined from time to time in agreements
between the shareholders to which the Company is a party);

(ii)the increase or decrease of the Company's share capital;
(iii) the appointment or removal of a Manager or a member of the Board of Managers;
(iv) any act or omission by the Manager(s) or the Board of Managers (including but not limited to the exercise of the

Company's shareholder rights) relating to (a) the sale, transfer, pledge or other disposal or encumbrance of shares in the
Company or the Company's direct or indirect subsidiaries (if existent); or (b) the liquidation of the Company and/or the
Company's direct or indirect subsidiaries; and

(v) the designation of a new Executive Shareholder (as defined from time to time in agreements between the share-

holders to which the Company is a party).

Any resolution (other than the resolution to increase or decrease the Company's share capital) the purpose of which

is to amend the present Articles of Association or the adoption of which is subject by virtue of the applicable laws or
these Articles of Association, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles
of Association, will be taken by (i) a majority of shareholders in number (ii) representing at least three quarters (3/4) of
the capital, except where agreements between the shareholders to which the Company is a party provide for more
stringent quorum and majority rules.

Except as otherwise required by the applicable laws, agreements between the shareholders to which the Company is

a party or by the present Articles of Association, all other resolutions will be taken by shareholders representing more
than half of the capital. If such majority is not reached at the first meeting or consultation in writing, the shareholders
shall be convened or consulted a second time and resolutions will then be taken by a majority of the votes cast not-
withstanding the proportion of the capital represented.

The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present or their proxy holders

or by the chairman, the secretary and the scrutineer of the meeting if such a bureau has been appointed.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s), as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 22. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 23. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s)

draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
applicable laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 24. Appropriation of profits. From the net profits of the Company, five per cent (5%) shall each year be allocated

to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

92086

The shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to

allocate the whole or part of the remainder to a reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute  it  together  with  carried  forward  profits,  distributable  reserves  or  share  premium  to  the  shareholders)  as
dividend, always in accordance with the following rules:

(i) all Class A Shares shall entitle pro rata among themselves to sixty-one point five percent (61.5%) of the Company's

annual net profits (the "Class A Shares Participation"), whereas such Class A Participation shall be allocated to a reserve
unless the shareholders decide otherwise by shareholders' resolution passed with a majority of at least seventy-five
percent (75%) of the share capital; and

(ii) all Class B Shares shall entitle pro rata among themselves to thirty-eight point five percent (38.5%) of the Company's

annual net profits (the "Class B Shares Participation"), whereas four point five percent (4.5%) of the annual net profits
shall be payable and distributable on a pro rata basis to the Executive Shareholders (as defined from time to time in
agreements between the shareholders to which the Company is a party) as dividend (the "Preferred Return", as adjusted
from time to time according to agreements between the shareholders to which the Company is a party), the remaining
Class B Participation upon payment of such Preferred Return being allocated to a reserve unless the shareholders decide
otherwise by shareholders' resolution passed with a majority representing the sum of at least seventy-five percent (75%)
of the share capital and the shares held by the affected Executive Shareholder(s).

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s), voting with the

same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Association, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the managers or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company including the expenses of liquidation, the remainder

of the Company's net assets shall be distributed to the shareholder(s) in conformity with and so as to achieve on an
aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out in Article 24 of the present Articles of Asso-
ciation.

Chapter VII. Applicable law

Art. 26. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance

with the Law.

There being no other business on the agenda, the meeting was closed.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residences, said persons signed together with Us notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendneun,
am zweiten September.
vor Uns, Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg), in Vertretung

von Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar, mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), in dessen Besitz
und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt.

fand eine außerordentlicher Gesellschafterversammlung (die „Versammlung") der Gesellschaft „Tottenham Hale S.à

r.l.", einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 46A, Avenue J. F. Ken-
nedy,  L-1855  Luxemburg,  Großherzogtum  Luxemburg,  gegründet  durch  notarielle  Urkunde  vom  17  August  2007
aufgenommen durch Maître Jacques Delvaux, Notar, mit Amtssitz in Luxembourg, und veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, vom 19. Oktober 2007 unter der Nummer 2354, und eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-131.760 (die „Gesellschaft"), statt. Der Gesellschaftsvertrag
wurde bis dato noch nicht abgeändert.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Frau Caroline WEIRAUCH, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, er-

öffnet.

Der Vorsitzende ernennt Frau Rebecca UNVERZAGT, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer der Ver-

sammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmenzähler Herrn Cedric BLESS, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

92087

<i>Tagesordnung

1 Schaffung von zwei Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Gesellschaftsanteile der Klasse A (die „Gesellschaftsanteile

der Klasse A"), die Gesellschaftsanteile der Klasse B (die „Gesellschaftsanteile der Klasse B") und die Neueinteilung der
existierenden eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von einem
Euro-Cent (EUR 0,01), in achthundertfünfundsiebzigtausend (875.000) Gesellschaftsanteile der Klasse A mit einem Nenn-
wert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) und dreihundertfünfundsiebzigtausend (375.000) Gesellschaftsanteile der
Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01).

2 Vollständige Neuformulierung der Gesellschaftssatzung um die oben erwähnten Abänderungen des Gesellschafts-

kapitals wiederzugeben und um, inter alia, folgenden Gesellschaftszweck festzulegen:

„Der Gesellschaftszweck umfasst (i) die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Vermögenswerten und/oder

Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung
solcher Vermögenswerte und/oder Beteiligungen sowie (iii) die unmittelbare und/oder mittelbare finanzielle Unterstüt-
zung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder die Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind.

Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere (i) den Erwerb mittels Zeichnung, Kauf, Tausch oder auf jegliche

andere  Weise  von  Aktien,  Anteilen  oder  anderen  Anspruch  auf  Dividende  vermittelnden  Wertpapieren,  Schuldver-
schreibungen, Anleihen, Einlagenzertifikaten und anderen Schuldinstrumenten und, ganz allgemein, von Wertpapieren und
Finanzinstrumenten, die Eigentumsrechte, Forderungen oder übertragbare Instrumente verbriefen, die von einem privaten
oder öffentlichen Emittenten ausgegeben wurden; (ii) die Ausübung aller mit diesen Wertpapieren und Finanzinstrumen-
ten verbundenen Rechte; (iii) die direkte und/oder indirekte finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist oder welche Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind, und zwar insbesondere mittels der Gewährung
von Darlehen, Finanzhilfen und Sicherheiten jeglicher Form und Laufzeit sowie jegliche sonstige Unterstützung, beispiels-
weise durch Beratung; (iv) die Gewährung von Darlehen und/oder die private Ausgabe von Schuldtiteln in jeglicher Form;
und (v) die Vornahme von Geschäften jeglicher Art, ob kommerzieller, industrieller oder finanzieller Natur, betreffend
bewegliche oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen."

3 Sonstiges.
II. Die Namen der Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile sind in einer Anwesenheitsliste

aufgeführt, welche von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter sowie von
den Mitgliedern des Versammlungsvorstands unterzeichnet wird; die vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die jeweiligen
Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser einregistriert zu werden.

III. Aus der vorliegenden Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesell-

schaftskapital repräsentieren, anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammenge-
treten  und  kann  rechtsgültig  über  sämtliche  Punkte  der  Tagesordnung,  über  die  die  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter in Kenntnis gesetzt worden sind, abstimmen.

IV. Nach Einführung durch den Vorsitzenden fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST die Schaffung von zwei (2) Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Gesellschaftsanteile

der Klasse A (die „Gesellschaftsanteile der Klasse A"), die Gesellschaftsanteile der Klasse B (die „Gesellschaftsanteile der
Klasse B") und die Neueinteilung der existierenden eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsan-
teile  mit  einem  Nennwert  von  einem  Euro-Cent  (EUR  0,01),  in  achthundertfünfundsiebzigtausend  (875.000)  Gesell-
schaftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) und dreihundertfünfundsieb-
zigtausend (375.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01).

Folglich hält FCP Anlage AG, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in Freihamerstrasse

2, D-82166 Gräfelfing, Deutschland, und im Handelsregister des Münchner Amtsgerichtes unter HRB 164206 eingetragen,
alle Gesellschaftsanteile der Klasse A und einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B,
Bencura S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts,
mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12,500, mit Sitz in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen
beim  Handels-  und  Gesellschaftsregister  Luxemburg  unter  Nummer  B-138.251  einhundertfünfundzwanzigtausend
(125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B und InvestOpp S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12,500, mit Sitz in 2, rue Joseph
Hackin, L-1746 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B-139.667,
hält einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST die Abänderung der Gesellschaftssatzung um, inter alia, den oben genannten Beschluss

wiederzugeben. Der Wortlaut der Gesellschaftssatzung ist fortan folgender:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft") gegründet, die

den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10 August 1915 über Handelsgesell-

92088

schaften (das „Gesetz") und den Bestimmungen der vorliegenden Gesellschaftssatzung unterliegt (die „Gesellschaftssat-
zung").

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren

Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Der Name der Gesellschaft ist „Tottenham Hale S.à. r.l.".

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der registrierte Gesellschaftssitz befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des/der Geschäftsführer/s oder des Geschäftsführungsrats an jeden ande-

ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  einen  Beschluss  des/der  Geschäftsführer/s  im

Großherzogtum Luxemburg gegründet werden.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-

scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung
der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vo-
rübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von dem/den Geschäftsführer/n durchzuführen und interessier-
ten Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst (i) die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von

Vermögenswerten und/oder Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung,
Entwicklung und Betreuung solcher Vermögenswerte und/oder Beteiligungen sowie (iii) die unmittelbare und/oder mit-
telbare finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder die Teil ihrer
Gesellschaftsgruppe sind.

Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere (i) den Erwerb mittels Zeichnung, Kauf, Tausch oder auf jegliche

andere  Weise  von  Aktien,  Anteilen  oder  anderen  Anspruch  auf  Dividende  vermittelnden  Wertpapieren,  Schuldver-
schreibungen, Anleihen, Einlagenzertifikaten und anderen Schuldinstrumenten und, ganz allgemein, von Wertpapieren und
Finanzinstrumenten, die Eigentumsrechte, Forderungen oder übertragbare Instrumente verbriefen, die von einem privaten
oder öffentlichen Emittenten ausgegeben wurden; (ii) die Ausübung aller mit diesen Wertpapieren und Finanzinstrumen-
ten verbundenen Rechte; (iii) die direkte und/oder indirekte finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist oder welche Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind, und zwar insbesondere mittels der Gewährung
von Darlehen, Finanzhilfen und Sicherheiten jeglicher Form und Laufzeit sowie jegliche sonstige Unterstützung, beispiels-
weise durch Beratung; (iv) die Gewährung von Darlehen und/oder die private Ausgabe von Schuldtiteln in jeglicher Form;
und (v) die Vornahme von Geschäften jeglicher Art, ob kommerzieller, industrieller oder finanzieller Natur, betreffend
beweglicher oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des (der) Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit

dem nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird.

Kapitel II. Kapital, Gesellschaftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt,

eingeteilt  in  achthundertfünfundsiebzigtausend  (875.000)  voll  eingezahlte  Gesellschaftsanteile  der  Klasse  A  („Gesell-
schaftsanteile der Klasse A") und dreihundertfünfundsiebzigtausend (375.000) voll eingezahlte Gesellschaftsanteile der
Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B"); alle Gesellschaftsanteile der Klasse A und Gesellschaftsanteile der Klasse
B haben einen Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) (Gesellschaftsanteile der Klasse A und Gesellschafts-
anteile der Klasse B werden gemeinsam als „Gesellschaftsanteile" bezeichnet und einzeln als „Gesellschaftsanteil").

Zusätzlich zu dem genannten Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emis-

sionsaufgelder, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag
dieses internen Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurück-
erwirbt, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die jeweilige Anteilsklasse oder zur Einbringung
in die gesetzlichen Rücklagen verwendet werden.

Art. 6. Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschaftsanteil verleiht Anrecht auf eine (1) Stimme. Das Eigentum eines Ge-

sellschaftsanteils  bewirkt  automatisch  die  implizite  Annahme  der  Gesellschaftssatzung  und  der  regulär  gefassten  Be-
schlüsse der Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschafts-

anteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen (1) einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein
Dritter sein kann, vertreten lassen.

92089

Hat die Gesellschaft nur einen (1) Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft

mehrere Gesellschafter, können die Gesellschaftsanteile unter Beachtung der im nächsten Absatz genannten Bedingungen
(i) frei zwischen den Gesellschaftern übertragen werden und (ii) Nicht-Gesellschaftern können Gesellschaftsanteile nur
mit Erlaubnis einer Mehrheit von Gesellschaftern wie sie in Artikel 21 dieser Satzung dargestellt ist, zugeteilt werden.

Die genauen Bedingungen betreffend die Übertragung der Gesellschaftsanteile können schriftlich von den Gesellschaf-

tern festgelegt werden. Alle Übertragungen erfolgen im Einklang mit diesen Bedingungen sowie der Gesellschaftssatzung.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Übertragung von Gesellschaftsanteilen zu verweigern, es sei denn, die
Übertragung erfolgt im Einklang mit der Gesellschaftssatzung oder anderen vertraglichen Regelungen bezüglich der Über-
tragung  von  Gesellschaftsanteilen,  zu  denen  die  Gesellschaft  eine  Partei  ist.  Der  Nachweis  der  Übertragung  von
Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß

Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder
von dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.

Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Zur Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschaftska-

pitals sind die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit zu erfüllen, die in der vorliegenden Gesell-
schaftssatzung oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung der vorliegenden Gesellschaftssatzung
vorgesehen sind.

Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird weder durch die

Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das die Gesellschafter
betrifft, aufgelöst.

Kapitel III. Geschäftsführer, Kommissare

Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Gesellschaftsführern, die nicht

notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die „Geschäftsführer").

Wenn zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen zu verwalten.
Wenn mehr als zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft als Geschäftsfüh-

rungsrat (der „Geschäftsführungsrat") zu führen.

Der/die  Geschäftsführer  wird/werden  von  der  Gesellschafterversammlung,  die  deren  Anzahl  festlegt,  für  eine  be-

stimmte oder unbestimmte Dauer bestellt. Er/sie ist/sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Der/die Gesellschafter können die Geschäftsführer in Geschäftsführer der Klasse A (die „Geschäftsführer der Klasse

A") und Geschäftsführer der Klasse B (die „Geschäftsführer der Klasse B") einteilen.

An einer Gesellschafterversammlung, welche über satzungsmäßige Bestellungen zu befinden hat, ist/sind der/die Ei-

gentümer der Gesellschaftsanteile der Klasse B befugt, die Einteilung der Geschäftsführer (wenn zwei (2) oder mehr als
zwei (2) Geschäftsführer bestellt wurden) in Geschäftsführer der Klasse A und Geschäftsführer der Klasse B vorzuschla-
gen.

Der/die Eigentümer der Gesellschaftsanteile der Klasse B ist/sind weiterhin befugt, Geschäftsführer der Klasse B zur

Wahl oder Entlassung vorzuschlagen, wobei die Geschäftsführer der Klasse B von einer Kandidatenliste, welche von dem/
den Eigentümern der Gesellschaftsanteile der Klasse B vorgelegt wurde, bestellt werden; hierbei ist sicherzustellen, dass
ein (1) Geschäftsführer der Klasse B ernannt wird wenn insgesamt zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden, und nicht
weniger als ein Drittel (1/3) der Geschäftsführer der Klasse B sind, wenn insgesamt mindestens drei (3) Geschäftsführer
ernannt werden.

Art. 10. Befugnisse der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet,

um jedwede Handlung vorzunehmen, welche für die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist.

Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch die vorliegende Gesellschaftssatzung ausdrücklich dem

Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des/der Geschäfts-
führer(s).

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat benötigen eine vorherige schriftliche Genehmigung der Ge-

sellschafter, um folgende Transaktionen und Maßnahmen durchzuführen:

(i) den Kauf oder Erwerb auf sonstige Weise von Immobilien oder von Beteiligungen an juristischen Personen, die

Immobilien besitzen, sowie die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft hinsichtlich des Kaufs oder
Erwerbs von Immobilien oder von Beteiligungen an juristischen Personen, die Immobilien besitzen, durch unmittelbare
oder mittelbare Tochtergesellschaften (sofern solche existieren);

(ii) die Ausgabe, die Verpfändung, der Verkauf oder die anderweitige Übertragung der Anteile an unmittelbaren oder

mittelbaren Tochtergesellschaften (sofern solche existieren), oder die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die
Gesellschaft im Rahmen der Abwicklung unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

92090

(iii) der Verkauf oder die anderweitige Übertragung, im Rahmen eines Asset- beziehungsweise Share-Deals, einer

Immobilie, eines Immobilienportfolios oder eines sonstigen Gegenstandes aus dem Anlagevermögen der Gesellschaft
beziehungsweise die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft wenn sich diese Immobilie, dieses Im-
mobilienportfolio oder dieser Gegenstand aus dem Anlagevermögen im Besitz einer unmittelbaren oder mittelbaren
Tochtergesellschaft der Gesellschaft befinden (sofern solche existieren);

(iv) der Abschluss, die Abänderung, Vorauszahlung oder Beendigung von Darlehensverträgen mit Dritten oder Ge-

sellschaftern und die Verpfändung oder Schaffung von anderen Sicherheiten hinsichtlich solcher Darlehensforderungen;

(v) die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft zwecks Annahme oder Abänderung der Satzungen

unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften der Gesellschaft (falls solche existieren);

(vi) die Errichtung oder Schließung von Zweigniederlassungen;
(vii) der Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, einschließlich stiller

Beteiligungen, die Ausübung der Gesellschafterrechte der Gesellschaft hinsichtlich des Erwerbs, der Veräußerung oder
der Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, einschließlich stiller Beteiligungen, durch unmittelbare oder
mittelbare Tochtergesellschaft der Gesellschaft (falls solche existieren);

(viii) der Erwerb oder die Schließung von Geschäftsbetrieben oder von Teilen solcher Geschäftsbetriebe;
(ix) die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft hinsichtlich des Abschlusses, der Beendigung oder

Änderung von Verträgen zur Hauptverwaltung oder anderer materieller Dienstleistungsverträge durch unmittelbare oder
mittelbare Tochtergesellschaft der Gesellschaft (falls solche existieren).

Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgestellt, dass alle anderen Maßnahmen, die für die Erfüllung des Gesellschafts-

zweckes notwendig oder nützlich sind, nicht der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen.

Art. 11. Sitzungen des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende

Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende") benennen. Er kann auch einen

Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Aufnahme der Sitzungspro-
tokolle des Geschäftsführungsrates sowie der Gesellschafterversammlungen zuständig ist (der „Schriftführer").

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen

des Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit
gewährleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung angeben. Jeder Geschäftsführer kann auf seine Einberufung wie oben ausgeführt verzichten. Für Sitz-
ungen, deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine
gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-

führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-

schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner am-

tierenden  Mitglieder,  wobei  im  Falle  einer  der  Qualifizierung  der  Geschäftsführer  als  Geschäftsführer  A  oder  als
Geschäftsführer B, außerdem mindestens ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B anwesend sein muss.

Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-

schäftsführungsrates gefasst.

Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung

oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellt, teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß

einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in
einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem oder
mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Art. 12. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse des/der Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.

Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-

weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr
als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.

Art. 13. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den/die Gesellschafter, kann/können der/die

Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus können
den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des Gesell-
schaftszweckes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

92091

Art. 14. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die Geschäftsführer trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich

der aufgrund ihrer Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen. Geschäftsführer sind für die Ausführung
ihrer Aufgaben verantwortlich.

Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-

lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses entstanden sind, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäfts-
führer, Angestellter oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft
für eine andere Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der
gegenüber er nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober
Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich
umfasste Fragen gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der
freizustellenden Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht
zur Freistellung schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

Art. 15. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner

anderen  Gesellschaft  oder  Firma  wird  durch  den  Umstand  beeinträchtigt  oder  ungültig,  dass  ein  oder  mehrere  Ge-
schäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt sind,
oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte oder Angestellte einer solchen Gesellschaft oder Firma sind. Keine
Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft
vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge
oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Gleichwohl, wenn ein Geschäftsführer der Gesellschaft oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches

Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäftsfüh-
rern anzeigen. Er darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen und das Rechtsgeschäft und das
Interesse des Geschäftsführers sind dem/den Gesellschafter(n) bei der nächsten Gesellschafterversammlung anzuzeigen.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Marktbe-

dingungen eingegangen wurde und in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Art. 16. Vertretung der Gesellschaft - Delegation von Befugnissen. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die

alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch
die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.

Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben

(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.

Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die

von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen

gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.

Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-

schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer, welche
nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

Die Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die Gesellschafter ernannt, die ihre Anzahl und die Dauer

ihres Mandats festlegen. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne
Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Kapitel IV. Gesellschafter

Art. 18. Generalversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem (1) Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse

aus, die per Gesetz der Generalversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes finden diesbezüglich
keine Anwendung.

Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, können die Be-

schlüsse  der  Gesellschafter  in  schriftlicher  Form  gefasst  werden.  Schriftliche  Beschlüsse  können  in  einem  einzigen
Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem (1) oder mehreren Ge-
sellschaftern unterzeichnet, festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern an die Gesell-
schafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen seit dem
Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes,
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Bestimmungen zur Beschlussfähig-
keit  und  den  erforderlichen  Mehrheiten  bei  Beschlüssen  der  Gesellschafterversammlung  sind  sinngemäß  auf  die  Be-
schlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

92092

Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die Gesellschafter auch auf ein Einberufungsschreiben hin

versammeln, das durch Einschreiben acht (8) Tage vor der Versammlung durch die Geschäftsführer, die Wirtschaftsprüfer
oder durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren, versandt wurde. Das an die
Gesellschafter  gesendete  Einberufungsschreiben  gibt  die  Zeit,  den  Ort  und  die  Tagesordnung  der  Gesellschafterver-
sammlung an.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über

die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, sollen in Luxemburg abgehalten werden.

Sie können im Ausland abgehalten werden, wenn Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

Jede regulär einberufene Gesellschafterversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter.

Art. 19. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz

zustehen.

Art. 20. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die abzuhalten ist wenn die Gesell-

schaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt, wird am Gesellschaftssitz der Gesellschaft oder einem anderen,
im Einberufungsschreiben benannten Ort des Großherzogtums Luxemburg binnen sechs (6) Monaten nach Ende des
Geschäftsjahres abgehalten.

Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-

genden Werktag abgehalten.

Art. 21. Verfahren, Wahl. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme- und Re-

derecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes

Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Die folgenden Maßnahmen bedürfen immer eines Beschlusses, der mit einer Mehrheit von Gesellschaftern, die Min-

destens 90% der Stimmrechte vertreten, gefasst wird:

(i) jede Übertragung von Anteilen, mit Ausnahme einer Übertragung an verbundene Unternehmen (wie dies von Zeit

zu Zeit in Gesellschafterverträgen, zu denen die Gesellschaft Partei ist, definiert wird) und/oder zwischen ausführenden
Gesellschaftern (wie dies von Zeit zu Zeit in Gesellschafterverträgen, zu denen die Gesellschaft Partei ist, definiert wird).

(ii) die Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschaftskapitals;
(iii) die Ernennung oder Abberufung eines Geschäftsführers oder eines Mitglieds des Geschäftsführungsrates;
(iv) die Vornahme oder Unterlassung durch den/die Geschäftsführer oder den Geschäftsführungsrat (einschließlich

aber nicht ausschließlich der Ausübung von Gesellschafterrechten der Gesellschaft) von Maßnahmen hinsichtlich (a) dem
Verkauf, der Übertragung, Verpfändung oder anderen Verfügung oder Belastung von Anteilen in der Gesellschaft oder in
direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft (falls vorhanden); oder (b) der Auflösung der Gesellschaft
und/oder der direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

(v) die Ernennung eines neuen ausführenden Gesellschafters (wie dies von Zeit zu Zeit in Gesellschafterverträgen, zu

denen die Gesellschaft Partei ist, definiert wird).

Jeder Beschluss (mit Ausnahme eines Beschlusses zur Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschaftskapitals) zum

Zwecke der Satzungsänderung oder dessen Feststellung aufgrund der vorliegenden Gesellschaftssatzung oder des Ge-
setzes den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegt, muss (i) von einer
Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des gesamten Gesellschaftskapitals
vertreten es sei denn Gesellschafterverträge, zu denen die Gesellschaft Partei ist, sehen strengere Präsenz- oder Mehr-
heitsbestimmungen vor.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der anwendbaren Gesetze, von Gesellschafterverträgen, zu denen die Ge-

sellschaft Partei ist, oder der vorliegenden Gesellschaftssatzung werden bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht
zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals repräsentieren.

Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-

schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Anteile, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern oder deren Bevollmächtigten

oder durch den Vorsitzenden, den Schriftführer und den Stimmenzähler der Gesellschafterversammlung, falls ein solches
Komitee vorgesehen wurde, unterzeichnet.

Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter

unterzeichnet.

92093

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls

der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Gewinnverteilung

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 23. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die

Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter oder dessen Bevollmächtigter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Be-

steht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne
von fünfzehn (15) Kalendertagen bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 24. Ausschüttung und Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent

(5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage
die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-

winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-
jahr  vortragen  oder,  zusammen  mit  vorgetragenen  Gewinnen,  ausschüttbaren  Rücklagen  oder  Aufgeldern  an  die
Gesellschafter gemäß den folgenden Regeln ausschütten:

(i)  alle  Gesellschaftsanteile  der  Klasse  A  berechtigen  pro  rata  zu  einundsechzig  Komma  fünf  Prozent  (61,5%)  des

jährlichen Reingewinns der Gesellschaft (die „Beteiligung der Gesellschaftsanteile der Klasse A") wobei diese Beteiligung
der Gesellschaftsanteile der Klasse A einer Reserve zugewiesen werden soll wenn nicht die Gesellschafter etwas anderes
durch Gesellschafterbeschluss, der mit einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschafts-
kapitals gefasst wird, beschließen.

(ii) alle Gesellschaftsanteile der Klasse B berechtigen pro rata zu achtunddreißig Komma fünf Prozent (38,5,5%) des

jährlichen Reingewinns der Gesellschaft (die „Beteiligung der Gesellschaftsanteile der Klasse B") wobei vier Komma fünf
Prozent (4,5%) des jährlichen Reingewinns pro rata an die ausführenden Gesellschafter (wie dies von Zeit zu Zeit in
Gesellschafterverträgen, zu denen die Gesellschaft Partei ist, definiert wird) als Dividende zu zahlen und auszuschütten
ist (die „Vorzugsdividende" wie dies von Zeit zu Zeit in Gesellschafterverträgen, zu denen die Gesellschaft Partei ist,
angepasst wird). Die nach Zahlung der Vorzugsdividende verbleibende Beteiligung der Gesellschaftsanteile der Klasse B
soll einer Reserve zugewiesen werden wenn nicht die Gesellschafter etwas anderes durch Gesellschafterbeschluss, der
mit einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals und mit der Zustimmung des
betroffenen ausführenden Gesellschafters gefasst wird, beschließen.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 25. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) aufgelöst werden. Die

Abstimmung über einen solchen Beschluss erfolgt vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen unter Be-
rücksichtigung des Quorums und der Mehrheit, wie sie für eine Satzungsänderung erforderlich sind.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche oder

juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-

quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Gesellschafter verteilt; hierbei ist das gleiche wirtschaft-
liche Gesamtergebnis zu erzielen, wie es sich aus Artikel 24 dieser Satzung, ergibt.

Kapitel VII. Geltendes recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-

stimmen sich nach dem Gesetz.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der obengenann-

ten erschienen Personen die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf
Anfrage der gleichen Personen und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird der
englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

92094

Gezeichnet: C. WEIRAUCH, R. UNVERZAGT, C. BLESS, C. WERSANDT.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 03. September 2009. Relation: EAC/2009/10443. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75.- EUR).

<i>Der Einnehmer (Gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Sondersammlung für Ge-

sellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 14 SEP. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009121171/796.
(090146165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Location de Voiture Internationale S.A. in Kurzform L.V.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

R.C.S. Luxembourg B 148.075.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun, am neunten September.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

MEDULUX S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-5450 Stadtbredimus, 7,

Lauthegaass und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 114.036, hier rechtsmässig ver-
treten durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates Herr Thomas JOHANNES, Buchhalter, mit beruflicher Anschrift in
Stadtbredimus.

Welche Komparentin, namens wie sie handelt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihr zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen dem Komparenten und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine

Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung "Location de Voiture Internationale S.A. in Kurzform L.V.I. S.A."

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist in Stadtbredimus.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die international Vermietung von PKWs sowie die Beteiligung unter irgendeiner

Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere
Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen,
Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung
und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industrieller oder kommerzieller Unternehmen teilneh-

men und ihnen Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien, jedoch ohne direkt das Gewerbe eines Immobilenmaklers auszuüben.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in

Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontroll-massnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise, nach Wahl der

Aktionäre, unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Eins-
chränkungen.

92095

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte, bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger
Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde, suspendieren.

Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre

der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder
zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angege-

benen Ort, am zweiten Freitag des Monats Juni um 15 Uhr statt.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen
feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Ge-

neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur General-

versammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär kann der Verwaltungsrat, in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 25. August

2006, aus nur einem Mitglied bestehen, welcher nicht Aktionär zu sein braucht.

Die  Verwaltungsratsmitglieder  werden  von  den  Aktionären  während  der  jährlichen  Generalversammlung  für  eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der

für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre verantwortlich sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsrats-mitglie-

dern, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden, einberufen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder tele-graphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungs-ratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vor-

zunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Haupt-versammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeits-
bereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der General-versammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen; dessen Befugnisse werden vom Verwaltungsrat fest-
gesetzt.

92096

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmit-

glieder oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des
Verwaltungsrats, verpflichtet. Sollte unter

Anwendung und gemäß Artikel 51 des Gesetzes vom 25. August 2006 der Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied

bestehen, so wird die Gesellschaft nach außen durch die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär

zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die  Generalversammlung  wird,  auf  Empfehlung  des  Verwaltungsrats,  über  die  Verwendung  des  Nettogewinns

beschließen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter

durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die die Auflösung
beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 sowie dessen Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2010 statt.
2. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der heutigen Gründung und endemt am 31. Dezember 2009.

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Der Komparent hat die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär

Gezeichnetes

Kapital

Einbezahltes

Kapital

Anzahl der

Aktien

EUR

EUR

MEDULUX S.A., vorbenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000.-

31.000.-

310

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000.-

31.000.-

310

Das Gesellschaftskapital wurde vollständig in Bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag von einunddreißig-

tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrüc-
klich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie

dessen Änderungsgesetze über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder

sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf eintausend dreihundert Euro (1.300,- EUR) abge-
schätzt.

<i>Anmerkung

Der amtierende Notar hat der Komparent darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft

vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftsz-
weck sein muss, was der Komparent ausdrücklich anerkannt haben.

92097

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig

folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf eins (1), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2. Zum Mitglied des Verwaltungsrats wird ernannt:

Herr Thomas JOHANNES, Steuerfachangestellter „comptable", geboren am 6. Februar 1963 in Merzig-Saar (Deuts-

chland), wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg, Im Brühl 6B.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

Herr  Erik  RISCHMANN,  Steuerberater  „expert  comptable",  geboren  am  8.  März  1964  in  Homburg-Saar  (Deuts-

chland), wohnhaft in D-66424 Homburg-Saar, Talstraße 39.

4. Die Mandate des Verwaltungsratsmitgliedes und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung vom Jahre 2015.

5. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: T. Johannes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2009. LAC/2009/36849. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009121125/176.

(090145201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2009.

Farmachen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.779.600,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 98.163.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 03 septembre 2009

<i>Première résolution

Les Associés acceptent la démission de Monsieur Jean-Pascal CARUSO de son poste de gérant C de la société avec

effet au 24 août 2009.

<i>Deuxième résolution

Les Associés nomment Monsieur José CORREIA, gérant de sociétés, né le 04.10.1971 à Braga (Portugal), résidant

professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au poste de gérant C de la société pour une durée illimitée
avec effet au 24 août 2009.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009120054/19.

(090143811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

92098

SDG Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 136.674.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique tenue en date du 31 août 2009

<i>Première résolution

L'Associé Unique accepte la démission de Eddy DÔME de son poste de gérant de la Société avec effet au 31 août 2009.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique nomme José CORREIA, né le 4 octobre 1971 à Braga (Portugal), résidant professionnellement au

67 rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au poste de gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au 31 août
2009.

Pour extrait
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009120053/18.
(090143804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Dana International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.442.604,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 124.210.

Par résolutions signées en date du 18 août 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Cornelia von Künsberg, avec adresse au 8, c/o Dana Europe S.A. Ifangstrasse, 8952

Schlieren, Suisse, de son mandat de gérant, avec effet au 31 août 2009.

- Nomination de Ralph Than, avec adresse professionnelle au 3939, Technology Drive, 45537-9194 Toledo, Ohio,

Etats Unis, au mandat de gérant, avec effet au 31 août 2009 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en
2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009120048/17.
(090143882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Coast Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 115.939.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale du 12 janvier 2009 de la société ZODIAC S.A., gérant de Coast Holding S.à r.l., que

ZODIAC S.A. a changé sa dénomination sociale en ZODIAC AEROSPACE.

Il ressort d'un contrat de cession et d'acquisition d'actions exécutée en date du 31 août 2009 entre Zodiac Aerospace

et CEP II Participations Sàrl SICAR, que 1.250 parts sociales ordinaires additionnelles sont détenues depuis cette date
par CEP II Participations Sàrl SICAR, 2 Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, enregistrée sous le numéro B
96.017.

Il ressort d'un contrat de cession et d'acquisition d'actions exécutée en date du 31 août 2009 entre Zodiac Aerospace

et CEP III Participations Sàrl SICAR, que 1.250 parts sociales ordinaires sont détenues depuis cette date par CEP III
Participations Sàrl SICAR, 2 Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 127.711.

Depuis cette date, les 12.500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

CEP II Participations Sàrl SICAR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.250 parts sociales
CEP III Participations Sàrl SICAR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

92099

Senningerberg, le 8 septembre 2009.

Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009120050/29.
(090143851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

AMO Holding 16 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.586.

<i>Changement dans la composition du Conseil d'administration

L'Assemblée générale du 10 septembre 2009 a pris acte de la démission de Messieurs Armand Gobber et Alain Gilniat,

administrateurs.

L'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Christian Quincke, avec adresse

professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Monsieur Quincke a été nommé pour une période de six (6) ans. Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée

générale statutaire à tenir en l'an 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Egbert Jansen / Javier Lasso Peña.

<i>Change in the composition of the Board of Directors

The Shareholder's meeting held on September 10, 2009 recorded the resignation of Mssrs. Armand Gobber and Alain

Gilniat, directors.

The Shareholder decided to appoint as new director Mr. Christian Quincke, with professional address at 24-26 bou-

levard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Mr. Quincke has been appointed for a term of six (6) years. His mandate will expire at the annual general meeting to

be held in 2015.

For mention with a view to publishing at the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 11, 2009.

Egbert Jansen / Javier Lasso Peña.

Référence de publication: 2009120063/25.
(090144324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Fabergé S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 148.063.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the thirteenth day of July.
Before Us, Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Fabergé Limited, a limited company incorporated and existing under the law of the Cayman Islands, with registered

office at Walker House, 87 Mary Street, Georgetown, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, registered with the
Registrar of companies of Cayman Islands, under number WK 178293,

here represented by Marc WINANDY, notary's clerk, with professional address at 6, rue de Schwiedelbrouch, L-8806

Rambrouch, by virtue of a proxy given on the sixth day of July 2009 in Paris (F).

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. Corporate form.  There  is  formed  a  private  limited  liability  company,  which  will  be  governed  by  the  laws

pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial

92100

companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles"),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one shareholder companies.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "Fabergé S.à r.l.".

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The share capital is fixed at twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) represented by twelve thousand four

hundred (12,400) shares of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2,
amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders'

meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

6.3 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of article 189 and 190 of the Law.

6.6 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in

accordance with article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder

(s) as a category A manager or a category B manager.

If at a time when there is a sole manager, a further manager is appointed, the shareholder(s) shall, at a such time, in

addition to designating the new managers as category A manager or category B manager, also designate the existing
manager, to the extend not already categorised, as a category A manager of a category B manager.

The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by

the shareholder(s) of the Company.

92101

7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and
provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of

plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers

for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures
The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of category A and managers of

category B is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or

represented at such meeting, with necessarily a simple majority in each category of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'

meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the text of the resolutions
or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual

general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 14 

th

 day of the

month of September. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meting shall be held on
the next following bank business day.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be su-

pervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a college and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company's accounting year starts on the 1 

st

 of April and ends on the 31

st

 of March of the following year, with the exception of the first year which shall begin on the date of the incorporation

of the Company and shall terminate on the 31 

st

 March 2010.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and

loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the
Law.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net

92102

profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including

during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available
for  distribution.  Any  manager  may  require,  at  its  sole  discretion,  to  have  this  interim  balance  sheet  reviewed  by  an
independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the
end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried
forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, Fabergé Limited, afore-mentioned, declared to subscribe the entire share

capital represented by twelve thousand four hundred shares (12,400) of one Euro (EUR 1.-) each.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-)

is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at EUR 1,500.-.

<i>Resolution of the sole shareholder

1. The Company will be managed by the following managers:

<i>Category A manager:

- Mr. Arne Frandsen, Director, CEO, Partner, born on December 22, 1966, in Naestved, Denmark and residing at

Mascan Japete, 66110 Le Bastide, France

<i>Category B manager:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., a limited company incorporated and existing under Luxembourg law, with

registered office at 13, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the companies register of Luxembourg,
under number B 103.336.

2. The registered office of the Company shall be established at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Rambrouch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le treize juillet.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Fabergé Limited, société soumise au droit des Iles Cayman, ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street,

Georgetown, Grand Cayman KY1-9002, Iles Cayman, inscrite au registre des sociétés des Iles Cayman, sous le numéro
WK 178293,

ici représentée par Monsieur Marc WINANDY, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 6, rue de Schwie-

delbrouch, L-8806 Rambrouch, en vertu d'une procuration donnée à Paris (F), le 6 juillet 2009.

92103

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec les autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une

telle entité (ci-après "la Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après "la Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en
leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans

d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs
de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, et procéder à l'émission d'obligations, sans offre publique,

qui pourront être convertibles, et à l'émission de titres d'emprunt.

D'une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination "Fabergé S.à r.l.".

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à la municipalité de Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par douze mille quatre cents

(12.400) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.

6.3 Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibl es que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.6 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associés conformément à l'article 185 de la Loi.

92104

Art. 7. Gérance.
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront

un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de catégorie B.

Dès sa nomination, tout gérant autre que le gérant unique devra être désigné par l'associé unique ou les associés

comme étant gérant de catégorie A ou de catégorie B.

Si la Société ne compte qu'un seul gérant au moment où un second gérant est nommé, l'associé unique ou les associés,

devra/ont en plus d'indiquer la catégorie à laquelle appartient ce nouveau gérant, indiquer celle du gérant existant.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués ad nutum

par le(s) associé(s) de la Société.

7.2 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représen-
tation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.4 Procédures
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants de catégorie A et

des gérants de catégorie B est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion, avec obligatoirement une majorité simple dans chaque catégorie de
gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

7.6 Responsabilité des gérants
Le(s) gérants ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu'il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un

vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée

générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le quatorzième jour du mois de septembre. Si
ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société

sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert

92105

pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 avril et se termine le 31

mars de l'année suivante, à l'exception de la première année qui débute à la date de la constitution de la Société et se
termine le 31 mars 2010.

A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire

(indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels
apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction

des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital

de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes

sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce
bilan intérimaire soit revu par un réviseur d'entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder
le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation
légale ou statutaire.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence

aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, Fabergé Limited, prénommée, déclare souscrire l'entièreté du capital social représenté par

douze mille quatre cents (12.400) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant
qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.500,-.

<i>Décisions de l'associé unique

1. La Société est administrée par les gérants suivants:

<i>Gérant de catégorie A:

- M. Arne Frandsen, Directeur, CEO, Partner, née le 22 décembre 1966, à Naestved, Danemark et demeurant à Mascan

Japete, 66110 Le Bastide, France,

<i>Gérant de catégorie B:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 13, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 103.336.

2. Le siège social de la Société est établi au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg.

92106

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Rambrouch, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: WINANDY, GRETHEN
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29465. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 12 août 2009.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2009120320/360.
(090144644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Novopar, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 73.465.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 31 août 2009

Il résulte d'une décisions prise par le Conseil d'Administration du 31 août 2009 que la société Free Haven Limited (nr

5025383), ayant son siège social à The Quadrangle, 180, Wardour Street London W IF 8LB et dont le représentant
permanent est M. Frank van Bellingen, Administrateur de sociétés, demeurant 95 Sint Amamdsstraat B-1853 Strombeerk-
Bever, a été coopté administrateur avec effet au 31 août 2009 en remplacement de l'administrateur démissionnaire M.
Frank van Bellingen. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'issue de l'Assemblée
Générale Statutaire de 2010.

La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Adriaens / F. Bracke
<i>Directeur / Administrateur

Référence de publication: 2009120334/18.
(090144663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Credit Suisse International &amp; Compagnie SNC, Société en nom collectif.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 148.070.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the fourth day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Credit Suisse International, a private unlimited company organised under the laws of England with its registered

address at One Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom, registered under number 2500199; and

2. Credit Suisse, a corporation incorporated under the laws of Switzerland and registered in Zurich operating by and

through its London Branch situated at One Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom, registered under number
FC007227; and

represented by Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 1 

st

 Sep-

tember 2009 which, signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to execute the deed

of  formation  of  a  general  partnership  (société  en  nom  collectif)  which  they  declare  to  establish  between  them,  the
constitution of which will read as follows:

92107

Agreed constitution

1. Form.
1.1 There is formed a general partnership (société en nom collectif) between the founders and all persons which could

become partner in the future (the "Partnership"), which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well
as by the present constitution (the "Constitution").

2. Name of partnership.
2.1 The Partnership will have the name "Credit Suisse International &amp; Compagnie SNC".

3. Registered office.
3.1 The registered office of the Partnership is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in

the Grand Duchy of Luxembourg by a unanimous decision from the Partners (as defined below).

3.2 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Partnership, the registered office of the Partnership may be
temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not
have any effect on this Partnership's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office,
will remain a Luxembourg Partnership. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the
Management Committee.

4. Purpose.
4.1 The purpose of the Partnership is to carry on the business of investing in, managing and disposing of any forms of

financial instruments, securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfil the above purpose
as well as operations directly or indirectly described in this clause, including any hedging arrangements.

4.2 The Partnership may incur borrowings needed to meet the purpose of the Partnership.
4.3 The Partnership may engage employees and perform all commercial, technical and financial operations, if these

operations are likely to enhance the above-mentioned objectives.

5. Duration.
5.1 Unless otherwise dissolved in accordance with the provisions hereof, the Partnership shall be dissolved on the

date falling 99 years after the date of formation of the Partnership.

6. Partnership capital.
6.1 The Partnership capital is established at one thousand Euro (€ 1,000.-) represented by one thousand (1,000)

partnership interests with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each.

6.2 The partnership interests have been subscribed as follows:
- Credit Suisse International: nine hundred ninety nine (999) partnership interests; and
- Credit Suisse, London Branch: one (1) partnership interest.
Total: one thousand (1,000) partnership interests.
The here-above subscribers are together hereafter referred as to the "Partners".
6.3 The partnership interests have been fully paid up in cash, so that the amount of one thousand Euro (€ 1,000.-) is

from now on at the disposal of the Partnership, evidence of which has been given to the undersigned notary.

6.4 A register of the partnership interests of the Partnership shall be maintained at the registered office of the Part-

nership.

7. Transfer of partnership interest.
7.1 The partnership interests may not be transferred inter vivos to non-Partners without the agreement of all the

Partners having an interest in the Partnership capital.

7.2 The partnership interests may not be transferred causa mortem to non-Partners without the agreement of all the

surviving Partners.

7.3 In case of transfer of a partnership interest by a Partner, the remaining Partners have a pre-emption right propor-

tional to the number of partnership interests belonging to them.

7.4 In case of transfer of a Partnership interest by a Partner to another Partner, the remaining Partners have no pre-

emption right.

8. Management.
8.1 The business of the Partnership is managed by a committee constituted by the Partners (the "Management Com-

mittee").

92108

9. Power of the management committee.
9.1 The Management Committee has, within the purpose of the Partnership, all powers to act in the name and on

behalf of the Partnership towards third parties in all circumstances and to carry out and approve all administration (actes
d'administration) and disposition acts (actes de disposition) and operations consistent with the Partnership's purpose.

10. Meeting and decisions of the management committee.
10.1 The Management Committee shall be convened by any Partner subject to a twenty-four (24) hours notice re-

quirement.

10.2 The Management Committee may validly debate and take decisions without prior notice if all the Partners are

present and have waived the convening requirements and formalities.

10.3 Decisions of the Management Committee shall be adopted by unanimity.
10.4 A written decision, signed by all the members of the Management Committee, is proper and valid as though it

had been adopted at a meeting of the Management Committee, which was duly convened and held. Such a decision can
be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
of the Management Committee.

11. Representation of the partnership.
11.1 The Partnership shall validly be bound by the joint signatures of the Partners or by the signature of any person

to whom such power shall be delegated by the joint signatures of the Partners.

12. Collective decisions of the partners.
12.1 In each general meeting of the Partners, each partnership interest entitles to one vote.
12.2 All decisions of the Partners shall be adopted by unanimous decision.

13. Business year.
13.1 The Partnership financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each

year.

14. Financial statements.
14.1 At the end of each financial year a balance sheet that will contain a record of its assets together with its debts

and liabilities as well as a profit and loss account will be drawn up for submission to the Partners.

14.2 The Partners will consider and approve such accounts.

15. Profits.
15.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, depreciations, charges

and provisions represents the net profit of the Partnership.

15.2 The net profit ascertained in the annual accounts shall accrue to the Partners and be distributed to the Partners

proportionally to the Partnership interests they hold.

16. Liquidation.
16.1 The liquidation of the Partnership shall be decided by the Partners, it being understood that in case of a sole

Partner, such sole Partner may decide to dissolve the Partnership and to proceed to its liquidation taking over all the
assets and liabilities, known or unknown of the Partnership.

17. Applicable law.
17.1 The provisions of Luxembourg law will apply in respect of all matters for which no specific provision is made in

the Constitution.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Partnership and shall terminate on the 31

December 2009.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Partnership or which shall

be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euros.

<i>Collective decision of the partners

Thereupon, the Partners, as owners of the entire contributed Partnership capital and considering themselves to have

duly come together, have immediately proceeded to hold a meeting and have passed the following resolution by unanimous
vote:

1. The registered office is established at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

92109

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quatre septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Credit Suisse International, une société à responsabilité illimitée de droit anglais, ayant son siège social à One Cabot

Square, Londres E14 4QJ, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 2500199; et

2. Credit Suisse, une entité de droit suisse, immatriculée à Zurich, opérant par et à travers sa branche Londonienne

située à One Cabot Square, Londres E14 4QJ, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro FC007227;

représentées par Rachel Uhl, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le

er

 septembre 2009, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la représentante des comparantes et le notaire

instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles auprès du Bureau de l'Enregistrement
compétent.

Lesquelles comparantes, représentées comme ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d'une société en nom collectif qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté l'acte de constitution
comme suit:

Constitution

1. Forme. Il est formé entre les constituants et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite, une société en

nom collectif (la "Société"), qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par la présente constitution (la "Constitution").

2. Dénomination de la société. La société prend la dénomination de "Credit Suisse International &amp; Compagnie SNC".

3. Siège social.
3.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit

du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération unanime des Associés (tel que défini ci-après).

3.2 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être  transféré  provisoirement  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Comité de Gestion.

4. Objet.
4.1 L'objet de la Société est de poursuivre une activité d'investissement, de gérer et disposer de toutes formes d'ins-

truments financiers, titres, droits et biens au travers de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option, de négociation
ou de toute autre manière et d'effectuer toutes transactions qui sont nécessaires ou utiles afin de poursuivre l'objet ainsi
que les opérations directes ou indirectes décrites dans cette clause, y compris toutes conventions de risques.

4.2 La Société pourra contracter les prêts nécessaires pour réaliser l'objet de la Société.
4.3 La Société pourra engager des employés et accomplir toutes opérations commerciales, techniques et financières,

si ces opérations peuvent améliorer les objectifs mentionnés ci-dessus.

5. Durée. A moins que la Société ne soit dissoute conformément aux dispositions suivantes, la Société devra être

dissoute le jour suivant la 99 

ème

 année après la date de constitution de la Société.

6. Capital social.
6.1 Le capital social est fixé à mille Euro (1.000,- €), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale

d'un (1,-) Euro, chacune.

6.2 Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Credit Suisse International: neuf cent quatre vingt dix-neuf (999) parts sociales; et
- Credit Suisse, Branche Londonienne: une (1) part sociale.
Total: mille (1.000) parts sociales.
Les souscripteurs susmentionnés sont ci-après dénommés les "Associés".

92110

6.3 Les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de mille Euro (1.000,- €) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate
expressément.

6.4 Il est tenu au siège social de la Société un registre des parts sociales de la Société.

7. Transfert de parts sociales.
7.1 Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés qu'avec l'agrément de tous les Associés

représentant l'intégralité du capital social.

7.2 Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-Associés sans l'agrément de tous les

Associés survivants.

7.3 En cas de cession de parts sociales par un Associé, les Associés restants ont un droit de préemption au prorata

des parts en leur possession.

7.4 En cas de cession de parts sociales par un Associé à un autre Associé, les Associés restant n'ont pas de droit de

préemption.

8. Gestion.
8.1 L'activité de la Société est gérée par un comité constitué par les Associés (le "Comité de Gestion").

9. Pouvoirs du Comité de Gestion. Le Comité de Gestion a, pour les besoins de l'objet de la Société, tous pouvoirs

pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes
d'administration et de disposition ainsi que toutes opérations conformes à l'objet de la Société.

10. Réunions et décisions du Comité de Gestion.
10.1 Tout Associé pourra convoquer le Comité de Gestion en respectant un délai de convocation de vingt-quatre (24)

heures.

10.2 Le Comité de Gestion peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

Associés sont présents et ont renoncé aux formalités de convocation.

10.3 Les décisions du Comité de Gestion seront adoptées à l'unanimité.
10.4 Une décision écrite, signée par tous les membres du Comite de Gestion est valide même si elle a été adoptée à

une réunion du Comité de Gestion, qui a été valablement convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
dans un seul document ou dans divers documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du
Comité de Gestion.

11. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par les signatures conjointes des Associés ou par

la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué conjointement par les Associés.

12. Décisions collectives des Associés.
12.1 Dans les assemblées générales des Associés, chaque part sociale donne droit à une voix.
12.2 Toutes les décisions des Associés sont prises à l'unanimité.

13. Exercice social.
13.1 L'année sociale commence le premier janvier et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.

14. Comptes sociaux.
14.1 A la fin de chaque année sociale, un bilan qui contient mention des avoirs et dettes ainsi qu'un compte de profits

et pertes seront préparés pour être soumis aux Associés.

14.2 Les Associés considéreront et approuveront ces comptes.

15. Bénéfices.
15.1 Après déduction des dépenses, coûts, amortissement, charges et provisions, le solde créditeur du compte de

profits et pertes constitue le bénéfice net de la Société.

15.2 Le bénéfice net constaté dans les comptes annuels devra revenir aux Associés et être distribué aux Associés en

proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

16. Liquidation.
16.1 La liquidation de la Société devra être décidée par les Associés, étant entendu qu'en cas d'Associé unique, un tel

Associé unique pourra décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en reprenant tous les avoirs et
dettes, connues ou inconnues de la Société.

17. Loi applicable.
17.1 Pour tout ce qui n'est pas réglé par la Constitution, les Associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2009.

92111

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille Euro.

<i>Décision collective des Associés

Et aussitôt les Associés, représentant l'intégralité du capital de la Société et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée et ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

1. Le siège social de la société est établi au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36429. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009120326/245.

(090144927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Agnes Constructions Succ. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 126, rue Michel Weber.

R.C.S. Luxembourg B 128.383.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2009120318/13.

(090144822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Swisscanto (Lu) Bond Invest Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 38.348.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SWISSCANTO (LU) BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009120330/12.

(090144839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

92112


Document Outline

Acmar Financial Luxembourg S.A.

ACS Dobfar Generics S.A.

Agnes Constructions Succ. S.A.

Air 1 S.A.

Alamos S.A.

Allmende S.A.

Alpina Investments S.à r.l.

Amesbury Property Group S.à r.l.

AMO Holding 16 S.A.

Amot Holding S.A.

Ampala S.àr.l.

ÄVWL Real Asset Trust Holding S.à r.l.

ÄVWL Real Asset Trust S.à r.l.

Beryss S.A.

Braga Investments S.à r.l.

Building The Future S.A.

Building The Future S.A.

CHURCHILL.HUI International S.A.

Close World S.A.

Coast Holding S.à r.l.

CORSAIR (Luxembourg) N°20 S.A.

CORSAIR (Luxembourg) N°21 S.A.

Credit Suisse International &amp; Compagnie SNC

Dana International Luxembourg S.à r.l.

Ex Pluribus Unum S.à r.l.

Fabergé S.à r.l.

Farmachen S.à.r.l.

Ferrum Fund Management Company S.à r.l.

Ferrum Pension Management S. à r.l.

Finance et Développement

Freisler Schumann Holding AG

Holding Klege S.à r.l.

Industrial Buildings S.A.

Infinitinvest S.A.

International Business Services &amp; Partners S.A.

Location de Voiture Internationale S.A. in Kurzform L.V.I. S.A.

Maguro II S.à r.l.

Manzoni International S.A.

MaxInvest S.à r.l.

MB Capital S.A.

MezzVest Luxembourg II S. à r.l .

MezzVest Luxembourg I S.à.r.l.

Montferrand Holding S.A.

Novopar

Opera Masters Management S.à r.l.

Pasadena S.A.

Prickley Investments S.A.

Private Trust Management Company S.à r.l.

ProLogis Management S.à r.l.

Restab S.A.

Russian Consumer Finance No.1 S.A.

Samtora (Luxembourg) S.à r.l.

Sanacomp S. à r.l.

SDG Investments S.à r.l.

Société Financière d'Investissement

Socket Holding S.A.

Socket Holding S.A.

SportInvest International S.A.

Stevenage Holding S.A.

Swisscanto (Lu) Bond Invest Management Company S.A.

Taronga S.A.

TMK Capital S.A.

Tottenham Hale S. à r. l.