logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

48289

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1007

23 mai 2006

S O M M A I R E

CODITEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.031.000,-.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 112.067. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société réunie en date du 2 février 2006

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société réunie en date du 2 février

2006 que:

1. Monsieur Bruno Moineville a démissionné, en date du 2 février 2006, de ses fonctions de gérant de la Société;
2. L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de nommer Monsieur Michel Matas, juriste, né le 30 mai

1972 à Dijon (France), demeurant à F-75007 Paris, 29, rue Surcouf, en qualité de gérant de la Société, en remplacement
du gérant démissionnaire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes clos au
31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023278/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Arcadie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48324

Lauriane Investissements Internationaux Holding 

Arcadie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48325

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48303

ATC Steuerberatungsgesellschaft, GmbH, Luxem- 

Lauriane Investissements Internationaux Holding 

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48332

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48303

Coditel, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48289

Lauriane Investissements Internationaux Holding 

Crystal Car Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

48294

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48303

Eurobeton Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . .

48290

OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A., Luxem-

Euroengineering, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . .

48325

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48305

Extensity, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

48329

Oniria Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

48335

Extensity, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

48330

Oniria Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

48336

Geula Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

48298

(Le) Ramoneur, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48334

Ivefi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48320

Restaurant Brasserie Chez Tony, S.à r.l., Wiltz  . . 

48290

Ivefi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48323

Société d’Assistance Technique et Ecologique S.A.,

J &amp; L Montana, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . .

48331

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48330

LAF S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48303

Stand’Inn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48323

Lauriane Investissements Internationaux Holding 

Wisdom Entertainment, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

48325

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48303

Signature
<i>Un mandataire

48290

RESTAURANT BRASSERIE CHEZ TONY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9455 Wiltz, 1, rue Hannelaanst.

R. C. Luxembourg B 102.694. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 25 janvier 2006.

(914651/238/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2006.

EUROBETON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 114.468. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt sept janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Luxembourg).

Ont comparu:

1. LBO LUXEMBOURG S.C., société civile de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis à 1B, Heienhaff, L-

1736 Senningerberg, et dont l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg est en cours;

2. LBO INVESTMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis à 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, et dont l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg est en cours;

Toutes deux ici représentées par M. Nicolas Cuisset, employé, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu de deux pouvoirs sous seing privé établis en janvier 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROBETON HOLDING S.A. (la «Société»),

soumise aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu’amendée ainsi qu’aux stipula-
tions des présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Senningerberg.
Il pourra être transféré à toute autre adresse dans le Grand Duché de Luxembourg par simple décision du conseil

d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4.- La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres, actions, actifs et droits par voie de participation, de souscription, de négocia-

tion ou de toute autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes Sociétés ou
entreprises.

Elle pourra accorder à toute société dans laquelle elle détient une participation ou intérêt, toute assistance, prêt,

avances ou garanties, prêter des fonds à ses filiales, ou à toute autre société y compris tout emprunt ou dette sous quel-
que forme que ce soit.

Elle pourra aussi accorder des garanties et garantir les obligations de toute filiale ou de toute autre société. La Société

pourra aussi nantir, donner en gage, transférer et donner en garantie tout ou partie des ses actifs et en général accomplir
tout acte ou opération en relation directe ou indirecte avec son objet, sans toutefois bénéficier des dispositions de la
loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés Holdings. 

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou de tout autre

instrument financier qui pourront être convertibles.

M. Weinandy
<i>Notaire 

48291

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante trois mille sept cent soixante-dix Euros (EUR 53.770,-) représenté par

cinq mille trois cent soixante-dix-sept (5.377) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, libérées
intégralement.

Toute prime d’émission payée lors de la libération d’actions sera remboursable exclusivement aux propriétaires des

actions sur lesquelles la prime d’émission a été payée.

Les titres seront nominatifs et la propriété des actions sera inscrite dans le registre des actionnaires.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Les cessions d’actions sont soumises aux stipulations suivantes:
Tout transfert d’actions de la Société à des non-actionnaires requiert un l’approbation préalable donné par les action-

naires représentant les deux tiers du capital social.

6.01. Pour les besoins de l’article 6:
(a) les termes «transfert» ou «cession» désignent tout acte de transfert, cession ou disposition, réalisé directement

ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, notamment par vente, donation, offre, apport en nature, échange, fusion
scission, création de privilèges ou transfert en usufruit.

 (b) Toutes ces stipulations s’appliqueront mutatis mutandis à tout transfert d’obligations convertibles ou tout autre

instrument convertible en actions émis par la Société.

6.02. Droit de préemption:
Les actionnaires ont un droit de préemption sur les actions cédées à l’exception (i) des actions cédées au profit de

LBO LUXEMBOURG S.C. et au profit de LBO INVESTMENTS S.A. et (ii) des actions cédées par LBO LUXEMBOURG
S.C. et par LBO INVESTMENTS S.A. lesquelles cessions d’actions ne seront pas soumises au droit de préemption tel
qu’organisé ci-dessous. 

6.02.01. Tout actionnaire qui entend transférer, ou céder ses actions détenues dans la Société (l’«Actionnaire Ven-

deur»), doit informer tous les autres actionnaires (les «Actionnaires Acheteurs») par écrit («l’Offre de Vente») qu’il
souhaite transférer ses actions en indiquant le nombre d’actions qu’il entend transférer suite à une offre formulée de
bonne foi (les «Actions à Vendre»), en leur indiquant le prix proposé, la date proposée pour le transfert et le paiement
du prix (en ce inclus, dans l’hypothèse d’une vente à tempérament, les garanties demandées par l’Actionnaire Vendeur)
l’identité de l’acquéreur (le «Tiers Acquéreur») et en fournissant copie de l’offre d’achat écrite. L’Actionnaire Vendeur
doit indiquer également toute information qui pourrait être raisonnablement nécessaire pour évaluer correctement la
valeur du transfert (en cas de donation notamment). Une Offre de Vente ne peut pas être retirée sauf lorsque l’ensemble
des Actionnaires Acheteurs a donné son consentement à un tel retrait.

6.02.02. A la réception de l’Offre de Vente, chacun des Actionnaires Acheteurs aura le droit d’acquérir proportion-

nellement à ses droits dans le capital social de la Société (leur «Droit Proportionnel»), les Actions à Vendre au prix fixé
dans l’Offre de Vente en donnant dans les trente (30) jours de la réception de l’Offre de Vente un avis indiquant:

(i) le nombre d’actions qu’il souhaite acquérir, ainsi que le nombre d’actions qu’il souhaite acheter dans l’hypothèse

où les autres Actionnaires Acheteurs exercent leur droit de préemption pour un nombre d’actions inférieur à celui de
leur Droit Proportionnel; et

(ii) leur acceptation des conditions générales figurant dans l’Offre de Vente (un «Droit de Premier Refus»).
6.02.03. Au cas où le droit de préemption n’a pas été exercé par les Actionnaires Acheteurs pour toutes les Actions

à Vendre, mais seulement pour une partie des Actions à Vendre, l’Actionnaire Vendeur devra répéter la procédure dé-
crite ci-dessus et notifier et offrir aux Actionnaires Acheteurs le reliquat des Actions à Vendre tant que toutes les Ac-
tions à Vendre n’auront pas été préemptées ou que les Actionnaires Acheteurs n’auront pas signifié leur intention de
ne pas préempter. 

6.02.04. Une fois la procédure de l’article 6.02.03 accomplie, l’Actionnaire Vendeur doit vendre les Actions à Vendre

aux Actionnaires Acheteurs le quinzième (15

ème

) jour suivant le notification d’un Droit de Premier Refus ou, le cas

échéant, le quinzième (15

ème

) jour suivant la date à laquelle une autorisation réglementaire est accordée (la «Date de

Transfert»).

A la Date de Transfert:
(i) l’Actionnaire Vendeur doit transférer aux Actionnaires Acheteurs la pleine propriété de son Droit Proportionnel;

et 

(ii) les Actionnaires Acheteurs doivent payer à l’Actionnaire Vendeur le prix de vente correspondant à son Droit

Proportionnel par virement immédiatement disponible sur un compte spécifique indiqué par l’Actionnaire Vendeur au
mois cinq (5) jours avant la Date de Transfert.

6.02.05. Dans l’hypothèse où:
(i) les Actionnaires Acheteurs ne donnent pas à l’Actionnaire Vendeur un Droit de Premier Refus dans le délai spé-

cifié; ou

(ii) les Actionnaires Acheteurs n’achètent pas, conformément aux termes de l’article 6.02.03. ci-dessus toutes les Ac-

tions à Vendre, mais seulement une partie des Actions à Vendre; ou

(iii) le droit de préemption n’a pas été exercé par les Actionnaires Acheteurs pour toutes les Actions à Vendre, mais

seulement pour une partie des Actions à Vendre; 

Et sous réserve que le transfert ait été préalablement autorisé par les actionnaires si requis par les stipulations de cet

article 6, alors les Actionnaires Vendeurs peuvent transférer les Actions à Vendre à un Tiers Acquéreur dans les quinze
(15) jours ouvrables suivant l’expiration du délai fixé aux articles 6.02.02. ou 6.02.03. ci-dessus, le cas échéant, pour un
prix et des conditions qui ne peuvent pas être moins favorables que celles qui figurent dans l’Offre de Vente. 

48292

Il est accepté que si l’Actionnaire Vendeur ne transfère pas ou ne cède pas les Actions à Vendre dans les quinze (15)

jours ouvrables fixés ci-dessus, la procédure prévue à l’Article 6.02. sera répétée pour tout transfert ou cession d’ac-
tions.

Titre III. Administration

Art. 7. La Société est administrée par un conseil composé de six membres au moins, associés ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Il sera donné à tous les administrateurs un avis écrit de toute réunion du conseil d’administration au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administration.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont pré-

sents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.
Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en
original, soit par courrier ou téléfax ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier élec-
tronique.

Seul un Administrateur peut représenter un autre Administrateur. Toutes les décisions doivent être prises à la ma-

jorité des votes des Administrateurs présents ou représentés. 

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée. Les décisions du conseil d’administration sont prises valablement à la majorité des voix des administra-
teurs présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par tous les
administrateurs présents ou représentés à la réunion.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration par téléphone ou vidéo conférence ou

par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre et se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les administrateurs seront considérées comme étant valablement adop-

tées comme si une réunion du conseil d’administration dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des adminis-
trateurs peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre, e-mail ou téléfax.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi ou les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Toutefois, la cession de participations détenues par la Société devra être préalablement autorisée par une résolution

des associés prise à la majorité.

Art. 9. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut créer des comités dont il fixe les pouvoirs, les attributions, le nombre de

membres et leur rémunération, il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11 . Les actions judiciaires, tant en demande qu’en défense, sont suivies au nom de la Société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur désigné à ces fins. 

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville du siège social de la Société, à l’endroit indiqué dans les

convocations, le premier jeudi d’avril à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le pre-
mier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pourcent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve

48293

avait été entamé. Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec
les dispositions légales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par versement en numéraire, de sorte que la somme de cinquante

trois mille sept cent soixante dix Euros (EUR 53.770,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ trois mille cinq cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs:
- M. Norbert Becker, cadre dirigeant, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg et demeurant 40, rue des genêts, L-8131

Bridel,

- M. Marc Assa, cadre dirigeant, né le 31 janvier 1941 à Luxembourg et demeurant 9, rue des noyers, L-7303 Steinsel,
- M. Robert Dennewald, cadre dirigeant, né le 11 novembre 1953 à Luxembourg et demeurant 8, Cité Rackenberg,

L-2409 Luxembourg,

- M. Christian Weiler, cadre dirigeant, né le 21 mars 1960 à Bettembourg, France, et demeurant 35, rue Bocksberg,

L-6614 Wasserbillig,

- M. Gaston Reinesch, Président de la SNCI, ayant pour adresse professionnelle le 7, rue du Saint Esprit, L-1475

Luxembourg, 

- M. Jean Pierre Vallée, Directeur des activités BPE et Fabrications Groupe Point P, né le 12 février 1952 à Laval,

France, et demeurant 3, allée Cassard, 44000 Nantes, France;

2. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes DELOITTE S.A., une société anonyme de droit Luxembour-

geois, ayant son siège au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

3. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2007.

4. Le siège social de la Société est établi 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire comparant susmentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: N. Cuisset, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1 février 2006, vol. 27CS, fol. 40, case 11. – Reçu 537,70 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(020517/211/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

LBO INVESTMENTs S.A., cinq mille trois cent soixante-seize actions

5.376

LBO LUXEMBOURG S.C., une action

1

Total

5.377

Luxembourg, le 15 février 2006.

J. Elvinger.

48294

CRYSTAL CAR PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 114.613. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty third of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared the following:

BLUE CRYSTAL SPRINGS INC., with registered office at Geneva Place 2nd Floor, 333 Waterfront Drive, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands registered at the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under
the number 1000677 duly represented by Ms Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.

SEA CRYSTAL INVESTMENTS INC., with registered office at Geneva Place 2nd Floor, 333 Waterfront Drive, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands registered at the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under
the number 1000678 duly represented by Ms Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.

The above proxies, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a limited

liability company (société à responsabilité limitée), which they, intend to organize among themselves.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant

legislation.

Art. 2. The purposes for which the company is established are to carry out all transactions pertaining directly or

indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the
management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may undertake, in Luxembourg and abroad, financing operations by granting loans to corporations be-

longing to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited
to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans. The company
may also undertake to guarantee obligations of other corporations belonging to the same international group to which
it belongs itself.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The company is expressly authorised to acquire and hold properties/real-estate.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is CRYSTAL CAR PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associates.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the manager(s).

Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500

(five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning

commercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. In case of a single associate, the Company’s shares held by the single associate are freely transferable.
In the case of plurality of associates, the shares held by each associate may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by a board of managers comprising at least two members who need not to

be associates and who are appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company will be validly committed by the individual signature of any of the managers.

48295

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the

company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. Each associate has a number of votes equal to the

number of shares the associate owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.

Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31 st of each year.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the manager.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company.

Art. 19. Out of the net profit at least five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate refers to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first year begins today and shall end on December 31, 2006.

<i>Subscription and payment

The 500 shares have been subscribed as follows: 

The 500 shares have been fully subscribed and paid up in cash each up to 100%, so that the company has now at its

disposal the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), as was certified to the notary executing this
deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately EUR 1,500.-.

<i>Extraordinary shareholders meeting of the associates

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

Are appointed managers of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation:
1.- Philippe Vanderhoven, born on July 2nd, 1971 in Rocourt (Belgium), professionally residing at 9B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2.- Géraldine Schmit, born on November 12th, 1969 in Messancy (Belgium), professionally residing at 9B, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 

3.- Carole Caspari, born on October 25th, 1970 in Wermelskirchen (Germany), professionally residing at 9B, boul-

evard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Second resolution

The company’s address is fixed at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the

notary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation.

Subscribers

 Number of

shares

Amount subscribed

in EUR

BLUE CRYSTAL SPRINGS INC., prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

650.-

SEA CRYSTAL INVESTMENTS INC., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

474

11,850.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500.-

48296

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the German text, the

English version will prevail.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundfünf, am neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

ACL HOLDINGS, S.à r.l., mit Sitz im L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, hier vertreten durch Frau

Flora Gibert, juristin, wohnhaft in Luxemburg auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift, 

welche Vollmachte, nach ne varietur Unterschreibung durch die Komparentin und den unterzeichneten Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorgenannte Person, handelnd in den vorgenannten Eigenschaften, hat die Satzung einer von ihr zu gründenden

Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die

diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck alle Operationen, die direkt oder indirekt zum Erwerb von Beteiligungen

unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen führen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich

aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, verwenden, des weiteren kann sie ihre Aktiva zum
Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere
Art und Weise verwenden. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder
sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann, in Luxemburg und im Ausland, Gesellschaften, die der gleichen internationalen Gruppe wie sie

selbst angehören, Kredite gewähren. Die Kredite werden unter anderem, aber nicht ausschließlich durch finanzielle Mit-
tel und Instrumente refinanziert, wie Aktionärsdarlehen, oder Darlehen, die durch Gesellschaften, die zur gleichen
Gruppe gehören gewährt wurden oder Bankdarlehen.

Des weiteren kann die Gesellschaft jegliche Geschäfte im Finanz-, Handels-, Industrie-, persönlichen sowie Immobi-

lienbereich tätigen. Sie kann alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlie-
ßen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Die Gesellschaft ist ausdrücklich berechtigt Immobilien zu erwerben und zu halten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen CRYSTAL CAR PROPERTIES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter

Haftung.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter

an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des/der Geschäftsführer kann/können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder

administrative Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 500

(fünfhundert) Anteile, zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Im Falle eines einzigen Gesellschafters sind die Anteile frei übertragbar.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile, die durch jeden Gesellschafter gehalten werden, durch

Anwendung des Artikels 189 des Gesetzes übertragbar.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen Rat der aus wenigstens zwei Geschäftsführer besteht, die Gesellschafter

sind oder nicht, und die von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

48297

Art. 17. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Zeichnung der Anteile und Einzahlung

Die 500 Anteile wurden folgendennassen gezeichnet:  

Die 500 Aktien wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR 12.500,-

(zwölftausendfünfhundert Euro) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrück-
lich bestätigt wird.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf eintausendfünfhundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei festgelegt. Zu Geschäftsführern, die die Befugnisse wie in Artikel 12 der

Statuten erwähnt, haben, werden ernannt:

1.- Philippe Vanderhoven, geboren am Juli 2., 1971 in Rocourt (Belgium), wohnhaft 9B, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg.

2.- Géraldine Schmit, geboren am November 12., 1969 in Messancy (Belgium), wohnhaft 9B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

3.- Carole Caspari, geboren am Oktober 25., 1970 in Wermelskirchen (Deutschland), wohnhaft 9B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäfts-

jahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Pour copie conforme à l’original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RECTIFICATIF

L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Aktionär

 Aktienanzahl

Gezeichnetes und eingezahltes

Kapital in EUR

BLUE CRYSTAL SPRINGS INC., vorgenannt   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26

650,-

SEA CRYSTAL INVESTMENTS INC., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . 

474

11.850,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500,-

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

J. Elvinger.

48298

Comparaît:

Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg,
Agissant pour et au nom de:
- BLUE CRYSTAL SPRINGS INC., avec siège social à Geneva Place 2nd Floor, 333 Waterfront Drive, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands numéro 1000677,

- SEA CRYSTAL INVESTMENTS INC., avec siège social à Geneva Place 2nd Floor, 333 Waterfront Drive, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands numéro 1000678.

En vertu de procurations sous seing privées demeurées annexées à l’acte de constitution de la dite société du 23

décembre 2005.

Laquelle a requis le notaire d’acter ce qui suit:
Par acte en date du 23 décembre 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2006, vol. 27CS, Fol. 11, Case 10

a été constituée une société à responsabilité limitée dénommée CRYSTAL CAR PROPERTIES, S.à r.l., avec siège social
à Luxembourg.

Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement que des erreurs matérielles ont été commises:
- Dans la version allemande non prépondérante concernant la comparution, qu’il convient de lire comme suit:
«Sind erschienen:
1.- BLUE CRYSTAL SPRINGS INC., mit Sitz Geneva Place 2nd Floor, 333 Waterfront Drive, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands nummer 1000677,

2.- SEA CRYSTAL INVESTMENTS INC., mit Sitz Geneva Place 2nd Floor, 333 Waterfront Drive, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands registered at the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands nummer 1000678».

- Dans les deux versions la souscription des parts sociales doit être lue comme suit, conformément aux procurations

sus indiquées:

«Die 500 Anteile wurden folgendermassen gezeichnet:
Gezeichnetes

«The 500 shares have been subscribed as follows: 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, vol. 152S, fol. 77, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022363/211/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

GEULA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 114.824. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twentieth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ESSEXWAY INVESTMENTS S.A., a public limited liability company incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
B number 100.113,

here represented by Mrs Lucinda Clifton-Bryant, with professional address at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy under private seal given on January 15, 2006.
Which, proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is hereby incorporated.

Aktionär

AktienanzahlKapital in

EUR

BLUE CRYSTAL SPRINGS INC., vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

1.250,-

SEA CRYSTAL INVESTMENTS INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

450 11.250,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 12.500,-»

Subscribers Number 

of

shares

Amount subscribed

in EUR

BLUE CRYSTAL SPRINGS INC., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

1,250.-

SEA CRYSTAL INVESTMENTS INC., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

450

11,250.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500.-»

Luxembourg, le 3 mars 2006.

J. Elvinger.

48299

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August 1915 on commercial companies, as
well as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and de-
velopment of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company can borrow in any form, except by way of public offer, and in particular by way of bond issue, convert-

ible or not, bank loan or shareholder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect par-
ticipating interests, any support, loans, advances or guarantees.

Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other

form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.

It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly

or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.

It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by

carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.

Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may

deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name GEULA FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

48300

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no persona lia-

bility in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by ESSEXWAY INVESTMENTS S.A., prenamed.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears
witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2006. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred Euro (EUR
1,800.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the sub-

scribed capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mrs Johanna Dirkje Martina Van Oort, private employee, born on February 28th, 1967 in Groningen (The Nether-

lands), with professional address at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Mr Benoît Georis, company director, born on January 13th, 1961 in Huy (Belgium), with professional address at 9B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2) The registered office of the Company is established at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, said prox-

yholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

ESSEXWAY INVESTMENTS S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, avec siège social au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 100.113,

48301

ici représentée par Madame Lucinda Clifton-Bryant, avec adresse professsionnelle au 29, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 janvier 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une so-

ciété à responsabilité limitée qu’elle déclare vouloir constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de

toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter sous toute forme, sauf par voie d’offre publique, et notamment par voie d’émission d’obli-

gations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans
lesquelles la Société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute

autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de GEULA FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté

par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

48302

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été

adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi modifiée du
10 août 1915.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pour-
ra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi

modifiée du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont toutes été souscrites par ESSEXWAY INVESTMENTS S.A., préqualifiée.
Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît
expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2006.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille huit cents euros
(EUR 1.800,-).

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Johanna Dirjke Martina Van Oort, employée privée, née le 28 février 1967 à Groningen (Les Pays-Bas),

avec adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Monsieur Benoît Georis, administrateur de sociétés, né le 13 janvier 1961 à Huy (Belgique), avec adresse profes-

sionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-

sent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: L. Clifton-Bryant, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, vol. 152S, fol. 38, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025031/230/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

A. Schwachtgen.

48303

LAURIANE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: CHF 250.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 42.097. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01243, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022255/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

LAURIANE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: CHF 250.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 42.097. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01244, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022268/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

LAURIANE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: CHF 250.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 42.097. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01245, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022270/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

LAURIANE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: CHF 250.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 42.097. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01246, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022280/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

LAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 21.192. 

L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAF S.A., ayant son siège

social à L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig, R.C.S. Luxembourg section B numéro 21.192.

Ladite société, constituée suivant acte reçu par Maître Giacinto Inselmini, notaire de résidence à Lugano (Suisse), en

date du 15 avril 1976, a été transférée au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux,
notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 décembre 1983, publié au Mémorial C numéro 40 du 11
février 1984.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à

Luxembourg:

- en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 949 du 11 décembre 1999;
- en date du 31 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 769 du 20 octobre 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

R.P. Pels.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

R.P. Pels.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

R.P. Pels.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

R.P. Pels.

48304

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Cindy Gabriele, maître en droit, demeurant professionnelle-

ment à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-

nellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assem-
blée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 1

er

 alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée.»
2. Suppression de la deuxième phrase du 1

er

 alinéa et les alinéas 2 et 3 de l’article 13 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Les administrateurs nommés par l’assemblée générale sont élus pour trois ans et sont toujours rééligibles.»
3. Modification de l’article 15 des statuts par ajout d’un dernier alinéa ayant la teneur suivante: «Le Conseil d’Admi-

nistration peut valablement délibérer par voie circulaire et par écrit.»

4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’adopter pour la société une durée illimitée et de modifier, également suite au transfert du siège

social de Luxembourg à Wasserbillig en date du 21 janvier 2002, l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme, qui est régie par les présents statuts et les dispositions de la loi luxembour-

geoise du 10 août 1915 et des lois modificatives subséquentes, sous la dénomination de LAF S.A. avec siège social à
Wasserbillig.

La durée de la société est illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la 2

e

 phrase du 1

er

 alinéa et les alinéas 2 et 3 de l’article 13 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 13. Les administrateurs nommés par l’assemblée générale sont élus pour trois ans et sont toujours rééligibles.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts par ajout d’un dernier alinéa ayant la teneur suivante:

«Art. 15. (dernier alinéa). Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer par voie circulaire et par écrit.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la présidente lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Gehlen, C. Gabriele, J.-H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 mars 2006, vol. 535, fol. 88, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022969/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

Junglinster, le 9 mars 2006.

J. Seckler.

48305

OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par actions. 

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 114.638. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of February.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, a Delaware limited partnership having its registered office at

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States,
registered with the Delaware Secretary of State under number 3725285,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles, on 20 February 2006;
2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, a Delaware limited partnership having its registered office at

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States,
registered with the Delaware Secretary of State under number 3794755,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles, on 20 February 2006;
3) OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., an exempted limited partnership organized under

the laws of the Cayman Islands, having its registered address at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

duly represented by Mr Carsten Opitz, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles, on 20 February 2006;
4) OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

duly represented by Mr Carsten Opitz, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 20 February 2006;
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain

attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société en commandite par actions, which they declare organised among themselves as follows:

Chapter I. - Name, Registered office, Duration, Object

Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a com-

pany in the form of a société en commandite par actions under the name of OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG
S.C.A. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within the same

municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Manager. Branches, subsidi-
aries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Man-
ager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political or military events have occurred or are immi-

nent, which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited term.

Art. 4. Purpose
The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, and any other form of investment, including the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of any such participations and the administration, voting and con-
trol of any such participations.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist any entity in which it holds a direct or indirect

participation, or which forms part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 5. Shareholders Liability
The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company.

The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the Manager), being the holder(s) of Ordinary Shares
shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as
shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

48306

Chapter II. - Share capital, Shares

Art. 6. Corporate Capital
6.1. Subscribed Capital
The Company has a subscribed capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by fully paid up shares,

consisting of twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»). All shares shall vote as a single class and, except
as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any separate class of shares shall not be entitled
to vote separately as a class on any matter.

6.2. The Class A Ordinary Shares
(a) All Class A Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A Ordinary Shares shall share ratably in the

payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an aggregate
basis to such Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company
may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the shareholders
held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class A Ordinary Shares will be reduced
accordingly.

(b) Voting Rights. Each Class A Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

6.3. Redemption; Convertibility
(a) Redeemable Shares. The Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 49-

8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Redeemable shares bear the same rights to
receive dividends and have the same voting rights as non-redeemable Ordinary Shares, if any. Subscribed and fully paid-
in redeemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares of each class held by each holder
upon request of the Company (i) in accordance with the provisions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended, and (ii) as may be provided for in a written agreement which may be entered into
among the Company and the relevant shareholders of the Company. The redemption of the redeemable shares can only
be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the
Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed
shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds. Redeemed shares may
be cancelled upon request of the Manager by a positive vote of the general meeting of shareholders held in accordance
with Article 12.

(b) Special Reserve. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of

all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the
event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed
share capital by capitalization of reserves.

(c) Redemption Price. Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be

entered into among the Company and the relevant shareholders, the redemption price of the redeemable shares shall
be determined by the Manager, or by such person appointed by the Manager, and shall be approved by holders of a
majority of the outstanding Ordinary Shares at a meeting of the shareholders convened in accordance with Article 12.
In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the redemption price by the Manager
that is approved by a majority of the shareholders of the Company shall be conclusive and binding on the Company and
on its present, past and future shareholders.

(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among

the Company and the relevant Shareholders at least 20 days prior to the redemption date, written notice shall be sent
by  registered  mail  (and  if  the  Manager  so  elects  by  internationally recognized overnight courier) to each registered
shareholder of the Ordinary Shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of
the Company, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the
redemption price, the procedures necessary to submit the Ordinary Shares to the Company for redemption and the
projected date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Ordinary Shares and the valuation
of the redemption price, as provided for in Articles 6.3(a) and 6.3(c). Each holder of Ordinary Shares to be redeemed
shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such Ordinary Shares to the Company. The
redemption price of such Ordinary Shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share
register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemp-
tion date.

(e) Convertibility. The Class A Ordinary Shares shall not be convertible into any other class of shares.
6.4. Distributions to Shareholders
If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company’s shareholders meeting and/or by

the Manager (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive dis-
tributions, when, as, and if approved and declared by the Company’s shareholders meeting and/or by the Manager out
of funds legally available therefore, in accordance with applicable law, pro rata among the shareholders based on the
number of Class A Ordinary Shares held by each shareholder.

6.5. Liquidation Rights
In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Com-

pany will be distributed to the shareholders in the manner set forth in Article 6.4 above. Neither a merger nor consol-
idation of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or
entities into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration)

48307

of all or any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article 6.5,
unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan
of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.

6.6. Authorized Capital
In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at one billion Euro (EUR

1,000,000,000.-) represented by eight hundred million (800,000,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share. During a period ending five (5) years after the date of publication
of the shareholders’ resolution to create the authorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by
causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed
for and issued under the terms and conditions as the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in
respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time
and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with
or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable
either by cash or by assets other than cash. Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the
authorized capital in full or in part, the Manager is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription
right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any duly authorized director or officer of the
Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the
new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital
performed in the legally required form by the Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

6.7. Amendment of the subscribed and of the authorized capital
The subscribed and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles.

Art. 7. Shares, Shareholders Register and Share Transfers
7.1. Shareholders Register
The shares will be and remain in the form of registered shares. A shareholders’ register which may be examined by

any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each sharehold-
er and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the
transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address
and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated. Certificates of
these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder.

7.2. Share Ownership
Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register. The Company rec-

ognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is dis-
puted, all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single representative to represent such share(s)
towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such
shares until such representative is appointed, at which time any suspended distributions with respect to such shares shall
be paid to such representative.

7.3. Share Transfer
(a) Declaration of Transfer. The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer registered into the

shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers
of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the
Luxembourg Civil code. Furthermore, the Company may accept and register into the shareholders’ register any transfer
referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

(b) Limitations on Transfer. Prior to the tenth anniversary of the Date of Issuance, or during such shorter period as

may be consistent with applicable law, the Secondary Investors may not validly transfer the shares issued by the Com-
pany without the prior written approval of the Manager or unless otherwise permitted pursuant to this Article 7.3.

(c) Permitted Transfers
Any Secondary Investor may Transfer any and all Securities held by any such Persons (where such Person is a natural

person) to each such Person’s spouse and/or descendants (whether natural or adopted) or to any trust solely for the
benefit of such Person and/or such Person’s spouse and/or descendants (a «Permitted Transferee»), pursuant to the
applicable laws of descent and distribution or otherwise (a «Permitted Transfer»).

(d) Drag Along Sale Procedures
In the event of a contemplated Transfer by the Primary Investors of the Company to any Third Party Purchaser, the

Primary Investors or the Manager may, prior to but in contemplation of such Transfer, elect to deem such Transfer a
«Drag-Along Sale», and in such case any Secondary Investors shall take all actions reasonably requested by the Primary
Investors and/or the Manager in connection with such Drag-Along Sale as set forth in this Article 7.3(d). In the event of
a Drag-Along Sale, the Manager may compel any Secondary Investors to participate on a pro rata basis (determined on
an As-Converted basis) in such Drag-Along Sale. The Manager shall provide notice of a Drag-Along Sale (the «Drag-
Along Sale Notice») to such Secondary Investors. Such Drag-Along Sale Notice shall disclose in reasonable detail the
proposed type and number (or percentage) of Ordinary Shares, CPECs and PECs held by the Secondary Investors to
be subject to the Drag-Along Sale (the «Drag-Along Securities»), the proposed price, the other proposed terms and
conditions of the proposed Drag-Along Sale, and the identity of the prospective purchaser, if known.

(ii) Cooperation. With respect to any Drag-Along Sale, any Secondary Investor shall effect such transactions as are

necessary or advisable, as determined by the Manager in the light of any business, taxation or marketability concerns
and agrees to use his or her best efforts to effect such Drag-Along Sale as expeditiously as practicable, including deliv-

48308

ering all documents and entering into any instrument, undertaking or obligation necessary or reasonably requested by
the Manager or the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale necessary or reasonably requested in
connection with such Drag-Along Sale (as specified in the applicable Drag-Along Sale Notice) and hereby consents to
the taking of any step by the Company and the Manager which is necessary or desirable as determined by the Manager
to effect any legal formalities in connection with the Transfer of the Securities subject to such Drag-Along Sale. In addi-
tion, the Secondary Investors shall (i) pay their pro rata share (based on the aggregate proceeds) of the reasonable ex-
penses (if any) incurred by the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale and (ii) join severally on a
pro rata basis (based on the inverse amount each Person concerned would be entitled to receive on a complete liqui-
dation of the Company) in any indemnification or other obligations that are specified in the Drag-Along Sale Notice.

(iii) Consideration. In the event of a Drag-Along Sale, each Secondary Investor shall Transfer such Securities held by

that Secondary Investor as are provided in the Drag-Along Sale Notice. The form and value of the consideration offered
in respect of any security in a Drag-Along Sale shall be the same for all Securities of the same type or class subject to
such Drag-Along Sale as set forth in the Drag-Along Sale Notice.

(e) Transfer. For the purposes of these Articles, «Transfer» or «transfer» shall mean any transaction, whether vol-

untary or involuntary or by operation of law, resulting in a transfer of the ownership, «nue-propriété», «usufruit» or
any rights of the shares issued by the Company (including any voting rights or dividend rights) to any person other than
the Company itself, whether a shareholder of the Company or not, by any means whatsoever (including, without limi-
tation, gifts, partial contributions of assets («apports partiels d’actifs»), mergers, splits («scissions»), sales, assignments,
pledges or any other form of transfer, conveyance or disposition of any legal or beneficial interest in the shares, as well
as any combination of such methods of transfer of ownership. The shares are and shall remain in registered form.

(f) Transfers in Violation of the Articles. Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any pro-

vision of these Articles shall be void and of no effect, and the Company shall not give effect to such Transfer nor record
such Transfer on its books or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any
purpose. 

Chapter III. - Management

Art. 8. Manager
The Company shall be managed by OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., a société anonyme organized under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole Manager (associé commandité) and manager of the
Company (referred to herein as the «Manager»). The other shareholders shall neither participate in nor interfere with
the management of the Company. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing
the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated,
provided the Supervisory Board, as provided for in Article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a
shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such
administrator shall convene within 15 days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint
a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles. Fail-
ing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

Art. 9. Powers of the Manager
9.1. General Powers
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Com-

pany’s stated object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of sharehold-
ers or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager. 

9.2. Enforcement of Rights
The Manager shall act, in its reasonable good faith judgment, in the best interests of the Company and its sharehold-

ers, shall use reasonable efforts to enforce any rights granted to the Company under the articles of association of any
company in which it holds participations or under any securityholders agreement or other agreement which may be
entered into among the Company and any of its securityholders from time to time.

9.3. Termination of the Manager by the holders of Ordinary Shares.
In the event that, in the reasonable opinion of the holders of Ordinary Shares, the Manager shall have failed to fulfill

its obligations to the Company and the shareholders under Article 9.2, then the shareholders may, acting pursuant to
an affirmative vote taken at a duly convened meeting of the shareholders in accordance with the quorum and majority
conditions required for the amendment of these Articles, revoke the appointment of the Manager and replace the Man-
ager with a new manager whose appointment shall be approved by an affirmative vote taken under the same quorum
and majority requirements as above mentioned. The Manager may not participate in any vote concerning the revocation
of its appointment as manager of the Company.

Art. 10. Third Parties
The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Manager, or by the signature(s) of any

other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion.

Chapter IV. - Supervision

Art. 11. Supervisory Board
11.1. Supervisory Board Members
The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a

Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising of at least three (3) members. The members of the Su-
pervisory Board need not be shareholders of the Company. For the carrying out of its supervisory duties, the Supervi-
sory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on

48309

commercial companies, as amended from time to time. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on
such matters as the Manager may determine and may authorize any actions taken by the Manager that may, pursuant to
law or regulation or under these Articles, exceed the powers of the Manager. The members of the Supervisory Board
shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one (1) year and shall hold office until
their successors are elected. The members of the Supervisory Board are re-eligible for election and may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders. The Supervisory
Board may elect one of its members as chairman.

11.2. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board

must be convened if any of its members so requests.

11.3. Notices
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least three (3) days prior

to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall
be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda there-
of. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile or any other similar means of commu-
nication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.

11.4. Chairman
The chairman of the supervisory board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory

Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.

11.5. Resolutions
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the members are present or repre-

sented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

11.6. Minutes
Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by (i) the chairman or (ii) by three

directors. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed
by the chairman of the meeting or any three members.

11.7. Written Resolutions - Conference Call
Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as

resolutions voted at a meeting of the Supervisory Board; each member shall approve such resolution in writing as evi-
denced by his, her or its signature, a copy thereof being sufficient. All such documents shall together form the document
which proves that such resolution has been taken. Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting
of the Supervisory Board by conference-call or by other similar means of communication initiated in the Grand Duchy
of Luxembourg and allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

11.8. Liability
No member of the Supervisory Board assumes, by reason of his membership thereof, any personal liability in relation

to commitments regularly made by the members of the Supervisory Board in the name of the Company. They are au-
thorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

11.9. Indemnity
(a) Indemnity. The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the Supervisory

Board and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the
Supervisory Board of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to mat-
ters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct;
in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of
duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

(b) Expenses. The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection

with any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding
undertaking by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not
entitled to indemnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction,
or a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did
not satisfy the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash
payment to such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an ob-
ligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably
require.

11.10. Conflicts
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any interest in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise

48310

engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from consid-
ering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Chapter V. General meeting of the shareholders

Art. 12. Shareholder Meetings
(a) Powers. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest

powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,
unless otherwise provided by the present Articles, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.
The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory
Board.

(b) Location, Time. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on 4 April. If such day is
a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day in
Luxembourg. Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective
convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent
by the Manager by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Com-
pany at the address indicated in the share register.

(c) Voting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing

another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.
The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Company,
unless otherwise provided herein. The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by sharehold-
ers for them to take part in any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a meet-
ing of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior notice or publication.

Chapter VI. - Accounting year, Balance sheet

Art. 13. Accounting Year
The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31 December of the same year.

Art. 14. Reserve
From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten percent (10%) of
the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, shall deter-
mine how the remainder of the annual net profit will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing
the terms and conditions provided for by law.

Chapter VII. - Liquidation, Amendment of the articles

Art. 15. Amendment
These Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of at least two-thirds of the

votes of the shareholders of the Company at a general meeting of the shareholders at which at least 50% of the capital
of the Company is represented in person or by proxy. In the event that the foregoing quorum requirement is not sat-
isfied, these Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of at least two-thirds of the
votes of the shareholders of the Company at a second general meeting of the shareholders with respect to which no
quorum requirement shall apply.

Art. 16. Dissolution
In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liqui-

dation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall deter-
mine their powers and compensation.

Chapter VIII. - Final dispositions

Art. 17. Miscellaneous
For all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the Luxembourg Law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended.

Art. 18. Definitions
For the purpose of these Articles:
«Affiliate» or «Affiliates» means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, Controls,

is Controlled by, or is under common Control with such first Person or any other Person who holds directly or indi-
rectly more than a fifty percent (50%) economic interest in such first Person or in whom such first Person holds directly
or indirectly or has a contractual right to acquire more than a fifty percent (50%) economic interest.

«Articles» means the articles of association of the Company as amended from time to time.
«As-Converted Basis» with respect to the outstanding securities of the Company, shall mean as if all such securities

convertible into or exercisable or exchangeable for Ordinary Shares outstanding were converted, exercised or ex-
changed into or for Ordinary Shares pursuant to the terms of such convertible, exercisable or exchangeable securities
(i.e., the number of Ordinary Shares outstanding, plus the additional number of Ordinary Shares that would be outstand-
ing assuming such conversion, exercise or exchange).

«Class A Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.
«Company» has the meaning provided in Article 1.

48311

«Control» means in respect of a Person, the power to manage or govern such Person, or to appoint the managing

and governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through
the ownership of voting securities, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership shall be deemed to
be Controlled by its Manager).

«CPECs» means the Series 1 CPECs which may be issued by the Company from time to time and, if applicable, any

additional series of convertible preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to
time.

«Drag-Along Sale» shall have the meaning set forth in Article 7.3(d)(i).
«Drag-Along Sale Notice» shall have the meaning set forth in Article 7.3(d)(i).
«Drag-Along Securities» shall have the meaning set forth in Article 7.3(d)(i).
«Manager» has the meaning provided in Article 8.
«Group» means the Company and its Subsidiaries and Group Company means any of them.
«Issuance» shall have the meaning set forth in Article 6.13.
«Managed Entity» means any entity Controlled by the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company or

in which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company has management or operating responsibilities or
of which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company is a partner or shareholder.

«Ordinary Shares» means the Class A Ordinary Shares issued by the Company.
«PECs» means the Series 1 PECs which may be issued by the Company from time to time and, if applicable, any ad-

ditional series of preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to time.

«Permitted Transfer» shall have the meaning set forth in Article 7.3(c) hereto.
«Permitted Transferee» shall have the meaning set forth in Article 7.3(c) hereto.
«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock

company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency
or political subdivision thereof.

«Primary Investors» means OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC or any Affiliate thereof which holds Ordinary

Shares or Securities of the Company or the Manager.

«Secondary Investors» means all holders of Ordinary Shares or Securities of the Company other than the Primary

Investors.

«Securities» means any duly authorized securities of the Company including, but not limited to, PECs and CPECs.
«Series 1 CPECs» means the Series 1 convertible preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Series 1 PECs» means the Series 1 preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Subsidiary» or «Subsidiaries» means, with respect to any Person, any or all other Person(s) of which a majority of

the total voting power of shares or other equity interests entitled (without regard to the occurrence of any contingency)
to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, directly or indi-
rectly, by such Person or one or more of its other Subsidiaries or a combination thereof. For purposes hereof, a Person
or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership, association
or other business entity if such Person or Persons shall be allocated a majority of limited liability company, partnership,
association or other business entity gains or losses or shall Control such entity.

«Supervisory Board» has the meaning provided in Article 11.1.
«Transfer» or «transfer» has the meaning provided in Article 7.3(e).

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31

December 2006.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, pre-named,
paid eighteen thousand two hundred fifty-two Euro and fifty cents (EUR 18,252.50) in subscription for fourteen thou-

sand six hundred two (14,602) shares; and

2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, pre-named,
paid three hundred forty-seven Euro and fifty cents (EUR 347.50) in subscription for two hundred seventy-eight (278)

shares; and

3) OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND, LP, pre-named,
paid twelve thousand three hundred ninety-eight Euro and seventy-five cents (EUR 12,398.75) in subscription for nine

thousand nine hundred nineteen (9,919) shares;

4) OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., pre-named,
paid one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) in subscription for one (1) share.
Total: thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) paid for twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as of now

available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been
fulfilled.

48312

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately four thousand (4,000.-) Euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of manager is fixed at one (1) and the number of statutory auditor at three (3).
2. The following persons are appointed as sole manager of the Company:
- OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A.
3. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company: 
- ERNST &amp; YOUNG S.A., with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
- COMPAGNIE DE REVISIONS S.A., with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach; and
- ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg.

4. The address of the company is set at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

5. The term of office of the members of the supervisory board of auditors shall end at the general meeting called to

approve the accounts of the accounting year 2006 or at any time prior to such time as the general meeting of share-
holders may determine.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholders

of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request
of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will
be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said persons appearing signed

together with the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahr zweitausendundsechs, den einundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen
Delaware Secretary of State unter der Nummer 3725285,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles, am 20. Februar 2006;
2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen
Delaware Secretary of State unter der Nummer 3794755,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles, am 20. Februar 2006;
3) OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., eine Gesellschaft Cayman Islands Rechts mit Ge-

schäftsadresse in Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles, am 20. Februar 2006; und
4) OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., eine Gesellschaft Luxemburg Rechts mit Geschäftsadresse 67, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, in Luxemburg, am 20. Februar 2006.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den

unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditge-

sellschaft auf Aktien, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I. - Name, Sitz, Dauer, Zweck

Art. 1. Name
Hiermit wird von den Zeichnern und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form einer «société en

commandite par actions» unter dem Namen OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A. (nachstehend die
«Gesellschaft») gegründet.

Art. 2. Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb dieses Verwaltungsbe-

zirks kann der Sitz der Gesellschaft kraft eines Geschäftsführerbeschlusses verlegt werden. Filialen, Tochtergesellschaf-

48313

ten oder andere Niederlassungen können mit Kraft eines Geschäftsführerbeschlusses entweder im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland eingerichtet werden.

Kommt die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse, die die

üblichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz bzw. die Kommunikation zwischen diesem Gesellschaftssitz
und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, eingetreten sind oder einzutreten drohen, so kann der Sitz vorüber-
gehend ins Ausland verlegt werden, bis die betreffenden außergewöhnlichen Ereignisse vollumfänglich überwunden sind;
eine solche provisorische Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet solcher
zeitlich befristeten Maßnahmen eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. 

Art. 3. Dauer
Die Gesellschaft wird für unbefristete Zeit gegründet.

Art. 4. Zweck
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung in jedweder Art an luxemburgischen und ausländischen

Unternehmen sowie in jeder weiteren Form der Investition, einschließlich des käuflichen Erwerbs, der Zeichnung oder
in anderer Weise und der Übertragung entsprechender Beteiligungen mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig sowie
der Verwaltung, Stimmbeteiligung an und Leitung von Beteiligungen.

Der Gesellschaftszweck umfasst ferner die Abgabe von Bürgschaften, Gewährung von Darlehen sowie jede andere

Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist oder die der gleichen
Unternehmensgruppe angehören wie die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann jeder wirtschaftlichen, industriellen oder finanziellen Beschäftigung nachgehen, die sie für die

Erreichung ihres Zwecks für nützlich hält.

Art. 5. Haftung der Aktionäre
Die Geschäftsführerin haftet gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten, die mit dem Vermögen der Gesellschaft

nicht bestritten werden können. Die anderen Aktionäre (der Klarheit halber: unter Ausschluss der Geschäftsführerin)
haben als Stammaktionäre davon Abstand zu nehmen, die Gesellschaft in einer Form oder Funktion, die über ihre Rechte
als Aktionäre- wie sie beispielsweise anlässlich von Hauptversammlungen wahrgenommen werden können - hinausgeht,
zu vertreten, und haften lediglich im Umfang ihrer Einlagen in die Gesellschaft.

Art. 6. Grundkapital
6.1. Gezeichnetes Kapital
Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), durch

vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich zusammensetzt aus vierundzwanzigtausendachthundert (24.800)
Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (die
«Stammaktien der Klasse A»). Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktio-
näre, die über Aktien mehrerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anders lautender Gesetze oder in diesen Artikeln
enthaltener Bestimmungen nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte je nach Klassenzugehörig-
keit unterschiedlich wahrzunehmen.

6.2. Stammaktien der Klasse A
(a) Sämtliche Stammaktien der Klasse A sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse A nehmen an-

teilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttungen
teil, die auf die Stammaktien der Klasse A auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich oder
anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse A können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zustimmung
einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass die Anzahl
ausgegebener Stammaktien der Klasse A entsprechend zu reduzieren ist.

(b) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse A berechtigt ihre Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter den

Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.

6.3. Einziehung; Austauschbarkeit
(a) Einziehbare Aktien. Bei den Stammaktien handelt es sich um einziehbare Aktien im Sinne der jeweils geltenden

Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften. Einziehbare Aktien haben
die gleichen Dividenden und Stimmrechte wie ggf. auch nicht einziehbare Stammaktien. Gezeichnete und vollständig ein-
gezahlte einziehbare Aktien können auf Wunsch der Gesellschaft anteilig - d.h. auf Basis der von dem jeweiligen Aktionär
gehaltenen einziehbaren Aktien jeder Anteilsklasse, eingezogen werden (i) unter Beachtung der jeweils geltenden Be-
stimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und (ii) nach Maßgabe eines
ggf. zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrags. Die Einzie-
hung der einziehbaren Aktien kann nur unter Verwendung von Mitteln erfolgen, die gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes
vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften zur Ausschüttung zur Verfügung stehen (ausschüttungsfähige Mittel ein-
schließlich der außerordentlichen Rücklagen, die mit Hilfe der von der Gesellschaft als Agio vereinnahmten Erlöse ein-
gerichtet wurden) oder aus einer neuen, mit dem Ziel einer entsprechenden Einziehung vorgenommenen Emission
gewonnen wurden. Eingezogene Aktien bieten weder Stimm- noch Dividendenrechte und berechtigen nicht zu Liquida-
tionserlösen. Sie können auf Wunsch der Geschäftsführerin mit der Zustimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abge-
haltenen Hauptversammlung gekündigt werden.

(b) Besondere Rücklagen. Ein Betrag in Höhe des Nennwerts bzw. falls dieser nicht ermittelt werden kann, der bilan-

zierte Stückwert sämtlicher eingelöster Aktien ist in Rücklagen zu hinterlegen, die lediglich im Falle einer Kapitalherab-
setzung des gezeichneten Aktienkapitals an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf; ansonsten sind diese Rücklagen
ausschließlich zur Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Wege der Umwandlung der Rücklagen einzusetzen.

(c) Rücknahmepreis. Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen (i) in diesen Artikeln oder (ii) im Rahmen einer

schriftlichen Vereinbarung, wie unter Umständen zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären abge-

48314

schossen wird, ist der Rücknahmepreis der einziehbaren Aktien seitens der Geschäftsführerin oder einer von dieser
ernannten Person zu bestimmten und von den Inhabern einer Mehrheit ausstehender Stammaktien anlässlich einer im
Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Aktionärsversammlung zu genehmigen. Abgesehen von Arglist, grober Fahrlässig-
keit oder offensichtlichem Irrtum ist jede seitens der Geschäftsführerin vorgenommene Berechnung des Rücknahme-
preises, die von einer Mehrheit der Aktionäre der Gesellschaft genehmigt wurde, für die Gesellschaft sowie ihre
gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Aktionäre endgültig und verbindlich.

(d) Rücknahmeverfahren. Vorbehaltlich anders lautender schriftlicher Vereinbarungen, wie sie zwischen der Gesell-

schaft und den betreffenden Aktionären mindestens 20 Tage vor dem Einzugstermin getroffen werden können, ist jeder
eingetragene Inhaber der einzuziehenden Stammaktien unter seiner im Aktionärsverzeichnis der Gesellschaft zuletzt
vermerkten Anschrift per Einschreiben (oder auf Verlangen der Geschäftsführerin unter Verwendung eines angesehe-
nen internationalen Übernacht-Kuriers) schriftlich unter Angabe von Einzugstermin und -preis, der Verfahren, die beim
Einzug der Stammaktien an die Gesellschaft zu Einzugszwecken Anwendung finden, des voraussichtlichen Termins der
Beschlussfassung der Hauptversammlung zum Thema des Einzugs von Stammaktien sowie der Bewertung des Rücknah-
mepreises gemäß Artikel 6.3(a) und 6.3(c) davon in Kenntnis zu setzen, wie viele Aktien auf diese Weise eingezogen
werden. Jeder Inhaber einzuziehender Stammaktien hat dabei die jeweiligen Aktienscheine abzuliefern, wie sie ggf. in
Bezug auf entsprechende Stammaktien der Gesellschaft ausgestellt wurden. Der Einzugspreis solcher Stammaktien ist
an die Person zahlbar, deren Name im Aktionärsverzeichnis als Inhaber der Stammaktien geführt ist, unter Verwendung
des seitens des betreffenden Aktionärs vor dem Einzugstermin gegenüber der Gesellschaft bezeichneten Kontos.

(e) Austauschbarkeit. Die Stammaktien der Klasse A können nicht in Aktien anderer Anteilsklasse umgewandet wer-

den.

6.4. Ausschüttungen an Aktionäre
Kommt die Aktionärsversammlung der Gesellschaft und/oder die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass an die Ak-

tionäre eine Ausschüttung zu erfolgen hat (mittels Abschlagsdividende, Einzug oder anderweitig), so haben die Aktionäre
nach Maßgabe der von der Aktionärsversammlung und/oder der Geschäftsführerin beschlossenen Konditionen und vor-
behaltlich anwendbaren Rechts Anspruch auf Ausschüttungen unter Verwendung der rechtmäßig zu diesem Zweck zur
Verfügung stehenden Mittel, anteilig unter den Aktionären auf der Grundlage der Anzahl von Stammaktien der Klasse
A im Besitz eines jeden Aktionärs.

6.5. Liquidationsansprüche
Im Falle einer Liquidation werden die verbleibenden Vermögenswerte der Gesellschaft nach Zahlung sämtlicher

Schulden und Verbindlichkeiten unter den Aktionären in der unter Artikel 6.4 oben beschriebenen Weise aufgeteilt.
Weder eine Fusion oder ein Zusammenschluss der Gesellschaft zu oder mit (einem) weiteren Unternehmen, noch eine
Fusion oder ein Zusammenschluss dritter Unternehmen zu oder mit der Gesellschaft, noch die Veräußerung, Abtretung,
Vermietung oder der Tausch (gegen Barmittel, Wertpapiere oder andere Werte) eines beliebigen Teils des Gesell-
schaftsvermögens gilt als eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 6.5, es sei denn, Fusionen, Zusammenschlüsse, Ver-
äußerungen, Abtretungen, Miet- oder Tauschgeschäfte dieser Art stehen im Zusammenhang mit oder beinhalten ein
Vorhaben zur Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft.

6.6. Genehmigtes Kapital
Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmigtes Kapital, das auf eine Milliarde Euro

(1.000.000.000,-) festgelegt ist und sich zusammensetzt aus achthundert Millionen (800.000.000,-) Stammaktien der Klas-
se A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Anteil. Über einen Zeitraum von
fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärsversammlung zur Schaffung des
genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», ist die
Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wirkung zu erhöhen, dass die Gesell-
schaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss. Neue Anteile dieser Art können
nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Geschäftsbedingungen gezeichnet und
ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und Zahlung neuer zu zeichnender bzw.
auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der neuen zu zeichnenden bzw. auszu-
gebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen sind, und zur Feststellung, in wel-
chem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form annehmbar ist, festzulegen sind.
Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin bei der teil- oder vollumfängli-
chen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Aktionären vorbehaltene Vorzugs-
zeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner berechtigt, die Verantwortung zur
Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen Teil der auf die beschriebene
Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte Direktoren oder Vorstände
der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Geschäftsführerinnen in der vor-
geschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende Artikel entsprechend zu ak-
tualisieren.

6.7. Änderung des gezeichneten und des genehmigten Kapitals
Das gezeichnete und das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann aufgrund einer Entscheidung der Hauptversamm-

lung mit derselben Mehrheit, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrages erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt
werden.

Art. 7. Aktien, Aktionärsverzeichnis und Aktienübertragung
7.1. Aktionärsverzeichnis
Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien. Am Sitz ist ein Aktionärsverzeichnis zu führen, das von jedem

Aktionär eingesehen werden kann. Das Verzeichnis enthält die exakte Bezeichnung jedes Aktionärs sowie Angaben zur
Anzahl seiner Aktien, den darauf geleisteten Zahlungen und der Übertragung von Aktien einschließlich des Zeitpunkts.

48315

Die Aktionäre haben die Gesellschaft per Einschreiben von ihren Anschriften und etwaigen Adressänderungen in Kennt-
nis zu setzen. Die Gesellschaft ist dabei berechtigt, sich auf die zuletzt gemeldete Anschrift zu verlassen. Abschriften
dieser Angaben werden auf Wunsch eines Aktionärs in beglaubigter Form ausgestellt und von der Geschäftsführerin
unterzeichnet.

7.2. Aktienbesitz
Der Besitz eingetragener Aktien ergibt sich aus den Aufzeichnungen im Aktionärsverzeichnis. Die Gesellschaft er-

kennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Befinden sich eine oder mehrere Aktien im Besitz mehrerer Inhaber oder
steht der Aktienbesitz in Streit, so haben alle Anspruchssteller einen einzigen Vertreter zu bestimmen, der die betref-
fende(n) Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft vertritt. Wird die Ernennung eines solchen Vertreters versäumt, so wer-
den sämtliche mit den betreffenden Aktien verbundenen Rechte so lange ausgesetzt, bis ein Vertreter berufen ist.
Ausgesetzte Ausschüttungen auf die betreffenden Aktien werden dann umgehend an diesen Vertreter zur Auszahlung
gebracht.

7.3. Aktienübertragung
(a) Abtretungserklärung. Die Übertragung von Aktien erfolgt auf dem Wege einer Abtretungserklärung, die im Ak-

tionärsverzeichnis einzutragen und seitens des Abtretenden und des Abtretungsempfängers bzw. ihrer Vertreter zu da-
tieren und zu unterzeichnen ist. Eine Übertragung von Aktien kann auch im Einklang mit den Regeln zur Übertragung
von Ansprüchen gemäß Artikel 1690 des Luxemburger Civil Code stattfinden. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt,
Übertragungen anzunehmen und in das Aktionärsverzeichnis einzutragen, auf die in Korrespondenzen oder anderen das
Einverständnis zwischen dem Abtretenden und dem Abtretungsempfänger nachweisenden Unterlagen Bezug genommen
wird. 

(b) Abtretungsbeschränkungen. Vor Ablauf des zehnten Jahrestages des Ausgabetermins bzw. vor Ablauf kürzerer

Fristen nach anwendbarem Recht können die Sedoncary Investors die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile vor-
behaltlich anders lautender Bestimmungen dieses Artikels 7.3 ohne das vorherige schriftliche Einverständnis der Ge-
schäftsführerin nicht wirksam übertragen.

(c) Zulässige Abtretungen. Secondary Investors dürfen sämtliche im Besitz solcher (natürlicher) Personen befindli-

chen Wertpapiere auf ihren Ehepartner oder Nachkommen (einschließlich Adoptivkinder) sowie auf beliebige, aus-
schließlich zugunsten solcher Personen bzw. ihrer Ehepartner und/oder Nachkommen (jeweils ein «zulässiger
Abtretungsempfänger») eingerichtete Treuhandvermögen übertragen, sofern dem keine Rechtsnachfolge oder Vertei-
lungsregeln oder weitere anwendbaren Gesetze entgegenstehen (eine «zulässige Abtretung»).

(d) Drag-Along Sale
(i) Verfahren. Im Falle einer angedachten Übertragung seitens der Primary Investors der Gesellschaft an einen Dritt-

käufer sind die Primary Investors bzw. die Geschäftsführerin berechtigt, vor - aber in Bezug auf - eine entsprechende
Übertragung diese als einen «Drag-Along Sale» zu betrachten, woraufhin sämtliche Secondary Investors im zumutbaren
Umfang alle in Verbindung mit einem solchen Drag-Along Sale gemäß diesem Artikel 7.3(d) vorgebrachten Wünsche der
Primary Investors bzw. der Geschäftsführerin nach Kräften zu erfüllen haben. Im Falle eines Drag-Along Sale kann die
Geschäftsführerin jeden beliebigen Secondary Investor zwingen, sich an diesem auf anteiliger Basis (wie sie auf der
Grundlage der Besitzverhältnisse zum Zeitpunkt der Umwandlung - «as converted basis» - zu ermitteln ist) zu beteiligen.
Die Geschäftsführerin hat den betreffenden Secondary Investors von einem Drag-Along Sale unter hinreichend detail-
lierter Angabe der vorgesehenen Anteilsklasse und Anzahl (bzw. des Prozentsatzes) der Stammaktien sowie des vorge-
sehenen Preises, weiterer anvisierter Bedingungen und Konditionen des vorgesehenen Drag-Along Sale und ggf. der
Identität des vorgesehenen Käufers schriftlich Mitteilung zu machen (die «Ankündigung des Drag-Along Sale»); dem
Drag-Along Sale unterliegen dabei Stammaktien, CPECs and PECs, die sich im Besitz der Secondary Investors befinden
(die «Wertpapiere des Drag-Along Sale»).

(ii) Zusammenarbeit. Im Hinblick auf einen Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor alle notwendigen oder rat-

samen Transaktionen vorzunehmen, wie sie seitens der Geschäftsführerin unter Berücksichtigung von Geschäfts-, Steu-
er- und Marktfähigkeitsgesichtspunkten festgelegt werden. Ferner verpflichtet sich jeder Secondary Investor, einen
entsprechenden Drag-Along Sale so rasch wie möglich abzuwickeln und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass alle seitens
der Geschäftsführerin bzw. der Primary Investors in Verbindung mit einem Drag-Along Sale nachvollziehbar angeforder-
ten und notwendigen Unterlagen, Urkunden, Vereinbarungen oder Verpflichtungen (auch unter Berücksichtigung der
Ankündigung des Drag-Along Sale) überbracht, unterzeichnet bzw. eingegangen werden. Die Secondary Investors erklä-
ren bereits hiermit ihr Einverständnis mit beliebigen, seitens der Gesellschaft und der Geschäftsführerin unternomme-
nen Schritten, wie sie nach Einschätzung der Geschäftsführerin zur Erledigung rechtlicher Formalitäten in Verbindung
mit der Übertragung der dem Drag-Along Sale zugrunde liegenden Wertpapiere notwendig oder ratsam sein mögen.
Zudem haben die Secondary Investors (i) einen (abhängig von den Gesamterlösen) entsprechenden Teil (pro rata) des
zumutbaren, seitens der Primary Investors im Zusammenhang mit dem betreffenden Drag-Along Sale entstandenen an-
gemessenen Aufwands zu entrichten und (ii) sich jeweils anteilig (auf der Basis des invertierten Betrags, wie er allen Be-
teiligten im Falle einer vollumfänglichen Liquidation der Gesellschaft zustünde) an etwaigen, in der Ankündigung des
Drag-Along Sale konkretisierten Entschädigungen oder Verpflichtungen zu beteiligen.

(iii) Gegenleistung. Im Falle eines Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor von seinen Wertpapieren all diejeni-

gen zu übertragen, die in der Ankündigung des Drag-Along Sale aufgeführt sind. Form und Umfang der Gegenleistung
für Wertpapiere, wie sie im Rahmen eines Drag-Along Sale übertragen werden, ist, wie in der Ankündigung des Drag-
Along Sale ausgewiesen, für alle Wertpapiere der gleichen Art oder Anteilsklasse identisch.

(e) Abtretung. Für Zwecke dieser Artikel bezeichnet 'Übertragung» oder «Abtretung» eine freiwillige oder unfreiwil-

lige (auch gesetzlich erzwungene) Transaktion, die zu einer Übertragung des Eigentums - «nue propriété», «usufruit» -
bzw. der Rechte an den von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien (einschließlich von Stimm- und Dividendenrechten)
auf eine beliebige Person mit Ausnahme der Gesellschaft - z.B. eines Aktionärs der Gesellschaft - auf beliebigem Wege

48316

(einschließlich von Schenkungen, teilumfänglichen Übertragungen von Vermögenswerten («apports partiels d’actifs»),
Fusionen, Splits («scissions»), Veräußerungen, Abtretungen, Verpfändungen oder anderen Formen der Übertragung, Ab-
tretung oder Verfügung von bzw. über Eigentums- oder Nießbrauchsrechten an den Aktien sowie jeder beliebigen Kom-
bination entsprechender Methoden der Besitzübertragung führt. Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien.

(f) Diesen Artikeln zuwiderhandelnde Abtretungen. Übertragungen von Wertpapieren (einschließlich möglicher

Übertragungsversuche), die den Bestimmungen dieser Artikel zuwiderhandeln, sind nichtig und wirkungslos und sind sei-
tens der Gesellschaft weder anzuerkennen noch in den Büchern der Gesellschaft zu dokumentieren. Ebenso wenig wird
ein angeblicher Abtretungsempfänger unter diesen Umständen als Inhaber der betreffenden Wertpapiere anerkannt.

Kapitel III. - Geschäftsführung

Art. 8. Geschäftsführerin
Die Gesellschaft wird von OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., einer gemäß dem Recht des Großherzog-

tums Luxemburg gegründeten «société anonyme» als ausschließliche Geschäftsführerin (associé commandité) und Ma-
nager der Gesellschaft (nachstehend als «Geschäftsführerin» bezeichnet) verwaltet. Die anderen Aktionäre sind an der
Geschäftsführung der Gesellschaft weder beteiligt, noch können sie in diese eingreifen. Im Falle der rechtlichen Ge-
schäftsunfähigkeit oder Liquidation der Gesellschaft bzw. bei einer anderweitigen ständigen Beeinträchtigung der Ge-
schäftsführung durch die Geschäftsführerin ist diese nicht umgehend aufzulösen und zu liquidieren. Dies setzt allerdings
voraus, dass der Aufsichtsrat gemäß Artikel 11 dieses Vertrages einen Verwalter bestellt (bei dem es sich nicht um einen
Aktionär handeln muss), der sich bis zur Abhaltung einer Hauptversammlung, die er innerhalb von 15 Tagen nach seiner
Bestellung anzuberaumen hat, dringenden Verwaltungsaufgaben widmet. Anlässlich der Versammlung können die Aktio-
näre unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrhei-
ten einen Nachfolger berufen. Kommt eine solche Berufung nicht zustande, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert.

Art. 9. Vollmachten der Geschäftsführerin
9.1. Allgemeine Vollmachten
Die Geschäftsführerin verfügt zur Wahrnehmung ihrer administrativen Aufgaben im Sinne des Gesellschaftszwecks

über weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt, die eine Einschränkung nur insofern erfah-
ren, als sie nach anwendbarem Recht und diesen Artikeln der Hauptversammlung bzw. dem Aufsichtsrat vorbehalten
sind.

9.2. Durchsetzung von Rechten
Die Geschäftsführerin hat auf der Grundlage ihres besten Wissens und Gewissens den Interessen der Gesellschaft

und ihrer Aktionäre zu dienen und nach Kräften sämtlichen Rechten zur Durchsetzung zu verhelfen, die der Gesellschaft
im Rahmen von Gesellschaftsverträgen von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie gemäß Wertpa-
pierinhaber- oder weiteren Verträgen zugestanden wurden, die zwischen der Gesellschaft und beliebiger ihrer Anteils-
eigner von Zeit zu Zeit abgeschlossen werden können.

9.3. Entlassung der Geschäftsführerin durch Stammaktionäre 
Falls die Geschäftsführerin gemäß der nachvollziehbaren Einschätzung der Stammaktionäre die Erfüllung ihrer Pflich-

ten gegenüber der Gesellschaft und den Aktionären im Sinne von Artikel 9.2 vernachlässigt, sind die Aktionäre aufgrund
einer im Rahmen einer ordnungsgemäß anberaumten Aktionärsversammlung und unter Einhaltung des Gebots der
Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden -
Abstimmung berechtigt, die Bestellung der Geschäftsführerin zu ersetzen, deren Bestellung ebenfalls einer unter Einhal-
tung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenomme-
nen - bejahenden- Abstimmung bedarf. Der Geschäftsführerin ist die Beteiligung an einer Abstimmung zur Frage der
Widerrufung ihrer Bestellung als Geschäftsführerin der Gesellschaft nicht gestattet.

Art. 10. Dritte
Die Gesellschaft ist wirksam gegenüber Dritten durch die Unterschrift der Geschäftsführerin bzw. die Unterschriften

weiterer Personen gebunden, deren Vollmacht diesen von der Geschäftsführerin nach eigenem Ermessen übertragen
wurde.

Kapitel IV. - Aufsicht

Art. 11. Aufsichtsrat
11.1. Mitglieder des Aufsichtsrates
Das Geschäft der Gesellschaft und ihre finanzielle Lage - insbesondere im Hinblick auf ihre Bücher und Konten - un-

terliegen der Aufsicht eines mindestens aus drei (3) Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrates («Conseil de Surveillance»
- der «Aufsichtsrat»). Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen Aktionäre der Gesellschaft sein. Zur Ausübung seiner
Aufsichtsfunktion verfügt dieses Gremium über die Vollmacht eines Prüfungsbeauftragten der Geschäftsführung gemäß
Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung. Der Auf-
sichtsrat kann von der Geschäftsführerin zu beliebigen Fragen konsultiert werden und ist zur Genehmigung von Maß-
nahmen der Geschäftsführerin berechtigt, die nach anwendbarem Recht oder diesen Artikeln die Befugnisse der
Geschäftsführerin unter Umständen überschreiten. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind von der jährlichen Hauptver-
sammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von jeweils einem (1) Jahr zu bestellen und bleiben bis zur Wahl ihrer Nach-
folger im Amt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können wiedergewählt werden, aber auch jederzeit ohne Angabe von
Gründen kraft eines Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre abgewählt werden. Der Aufsichtsrat kann eines
seiner Mitglieder zum Sprecher wählen.

11.2. Versammlungen des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat wird von seinem Sprecher bzw. von der Geschäftsführerin einberufen und tritt auch auf Wunsch

eines seiner Mitglieder zusammen.

11.3. Mitteilungen

48317

Von Versammlungen des Aufsichtsrates ist sämtlichen Mitgliedern mindestens drei (3) Tage vor dem für die Ver-

sammlung anberaumten Termin schriftlich Mitteilung zu machen. In dringenden Fällen ist diese Frist nicht verbindlich -
allerdings ist in entsprechenden Einladungen die Dringlichkeit detailliert zu erläutern. Mitteilungen erfolgen unter Anga-
be des Versammlungsorts und der Tagesordnung. Auf die Mitteilungsfrist kann schriftlich, per Telegramm, Telex, Fax
oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden verzichtet werden. Zu diesem Zweck genügt auch eine
Abschrift. Im Falle von Versammlungen, deren Zeitpunkt und Ort von dem Aufsichtsrat bereits in einem Terminkalender
eingetragen wurden, bedarf es keiner gesonderten Mitteilung.

11.4. Vorsitzender
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates sitzt allen Versammlungen des Rates vor und ist im Falle seiner Abwesenheit

durch ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrates zu ersetzen, das mit der Mehrheit der vertretenen Stimmen zum
vorübergehenden Vorsitzenden bestellt wird. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder kann schriftlich, per Telegramm,
Telex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck genügt auch eine
Abschrift. Dabei ist es zulässig, dass ein Mitglied mehrere seiner Kollegen vertritt.

11.5. Beschlüsse
Der Aufsichtsrat ist zu wirksamen Beschlüssen nur dann fähig, wenn zumindest eine einfache Mehrheit seiner Mitglie-

der anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse bedürfen zu ihrer Fassung einer Mehrheit der anwesenden oder vertrete-
nen Stimmen.

11.6. Protokolle
Beschlüsse des Aufsichtsrates sind in Versammlungsprotokollen festzuhalten und (i) von dem Vorsitzenden oder (ii)

von drei Direktoren zu unterzeichen. Abschriften der Auszüge solcher Protokolle, wie sie etwa anlässlich von Gerichts-
verfahren sowie bei anderen Anlässen vorzulegen sind, sind von dem Vorsitzenden der Versammlung oder von drei
beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

11.7. Schriftlich gefasste Beschlüsse - Konferenzgespräch
Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Aufsichtsrates unterzeichnet wurden, stehen auf dem

Wege der Abstimmung anlässlich von Aufsichtsratsversammlungen gefassten Beschlüssen gleich. Dabei sind schriftlich
gefasste Beschlüsse von allen Mitgliedern schriftlich durch ihre Unterschrift zu bestätigen. Zu diesem Zweck genügt auch
eine Abschrift. Alle Unterlagen bilden gemeinsam die Urkunde, die als Nachweis der jeweiligen Beschlussfassung dient.
Jedem Mitglied des Aufsichtrates steht es frei, an Versammlungen des Gremiums über eine Konferenzschaltung oder
weitere, im Großherzogtum von Luxemburg initiierte Kommunikationsmethoden teilzunehmen, die allen Versamm-
lungsteilnehmern erlaubt, einander zu hören. Eine derartige Teilnahme an einer Versammlung steht einer persönlichen
Teilnahme in keiner Hinsicht nach.

11.8. Haftung
Keines der Mitglieder des Aufsichtsrates übernimmt mit seinem Aufsichtsratsmandat eine wie auch immer geartete

Haftung in Bezug auf die von den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Namen der Gesellschaft regelmäßig eingegangenen
Verpflichtungen. Bei ihnen handelt es sich lediglich um Bevollmächtigte, die ausschließlich für die Erfüllung ihres Mandats
eine Verantwortung tragen.

11.9. Freistellung
(a) Freistellung. Die Gesellschaft stellt alle Mitglieder des Aufsichtsrates sowie deren Rechtsnachfolger, Testaments-

vollstrecker und Nachlassverwalter im gesetzlich zulässigen Umfang von allen Ausgaben frei, die diesen nachvollziehbar
im Rahmen von Klagen oder Verfahren entstehen, denen sie infolge ihres Aufsichtsratsmandats bei der Gesellschaft als
Partei ausgesetzt sind und von denen sie nicht freigestellt werden müssen. Dies gilt nicht in Bezug auf Klagen oder Ver-
fahren, im Rahmen derer sie letztendlich der Fahrlässigkeit oder des schwerwiegenden Fehlverhaltens als schuldig er-
achtet werden; im Falle eines Vergleichs wird eine Freistellung nur in Verbindung mit den durch den Vergleich
abgegoltenen Handlungen gewährt, für die nach Einschätzung der Rechtsvertreter der Gesellschaft seitens der freizu-
stellenden Person keine Pflichtverletzung vorliegt. Der vorstehende Freistellungsanspruch schließt andere Rechte, auf
die diese Personen ggf. Anspruch haben, nicht aus.

(b) Ausgaben. Die Gesellschaft kommt für sämtliche Ausgaben, die einer im Rahmen dieser Artikel freizustellenden

Person entstehen, vor endgültiger Entscheidung auf. Dies setzt allerdings voraus, dass der Gesellschaft eine schriftliche
und rechtlich verbindliche Verpflichtungserklärung der betreffenden Person zugeht, in der sich diese im Falle der ab-
schließenden Feststellung, dass sie über keinen Freistellungsanspruch verfügt, zur Einziehung des vollständigen Betrags
bereit erklärt. Die Beendigung von Klagen und Verfahren über Urteile, Verfügungen, Vergleiche, Verurteilungen oder
Schuldgeständnisse oder vergleichbare Abschlüsse bergen an sich keinen Hinweis darauf, dass die freizustellende Person
die an ihren im Rahmen dieses Vertrags bestehenden Freistellungsanspruch geknüpften Verhaltensvorgaben nicht erfüllt
hat. Nach Erhalt einer Mitteilung einer freizustellenden Person, in der diese unter Erfüllung zumutbarer Vorgaben der
Gesellschaft deren Freistellungsverpflichtung nachweist, ist die Gesellschaft umgehend zu einer Barzahlung an die betref-
fende Person in Höhe des vollen Freistellungsbetrags verpflichtet.

11.10. Konflikte
Sollte die Geschäftsführerin bzw. einer oder mehrere ihrer Direktoren oder Vorstände an einem weiteren Unter-

nehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt sein oder einem solchen als
Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehören, so nehmen die betreffenden Verträge oder Geschäftsbeziehungen
daran keinen Schaden. Ebenso bleibt es keinem Direktor oder Vorstand der Geschäftsführerin, der an einem weiteren
Unternehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt ist oder einem solchen
als Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehört, verwehrt, aufgrund seines Verhältnisses zu dem betreffenden Unter-
nehmen an der Besprechung oder Abstimmung zu Angelegenheiten teilzunehmen, die entsprechende Verträge oder
Geschäftsbeziehungen berühren.

48318

Kapitel V. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 12. Aktionärsversammlungen
(a) Vollmachten. Die Hauptversammlung der Aktionäre vertritt sämtliche Aktionäre der Gesellschaft und verfügt zur

Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Vorgängen betreffend den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft über
weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt. Diese ist lediglich dadurch eingeschränkt, dass
Beschlüsse zu ihrer wirksamen Fassung vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in diesen Artikeln der Zustim-
mung der Geschäftsführerin bedürfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft tritt immer dann zusam-
men, wenn die Geschäftsführerin oder der Aufsichtsrat eine Versammlung anberaumt. 

(b) Ort, Zeit. Die in jährlichen Abständen stattfindende Hauptversammlung wird in Luxemburg am Sitz der Gesell-

schaft bzw. an einem weiteren, in der Einladung genannten Ort in Luxemburg jeweils am 4. April abgehalten. Handelt es
sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag in Luxemburg, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf
folgenden Geschäftstag in Luxemburg statt. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre werden an den Orten und zu
den Zeitpunkten abgehalten, wie sie in den jeweiligen Einladungen angegeben sind. Die Hauptversammlungen der Ak-
tionäre werden in Form einer Einladung anberaumt, aus der die Tagesordnung hervorgeht und die von der Geschäfts-
führerin mindestens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär der Gesellschaft unter der im
Aktionärsverzeichnis angegebenen Anschrift verschickt wird. 

(c) Abstimmung. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder kann schriftlich, per

Telegramm, Telex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck ge-
nügt auch eine Abschrift. Die Versammlungen der Aktionäre unterliegen vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen
dieses Vertrags den gesetzlichen Bestimmungen zu Beschlussfähigkeit und erforderlichen Mehrheiten. Alle weiteren Be-
dingungen, die seitens der Aktionäre im Sinne ihrer Teilnahme an Aktionärsversammlungen zu erfüllen sind, bestimmt
die Geschäftsführerin. Falls alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Tagesordnung der Ver-
sammlung in Kenntnis gesetzt worden zu sein, so kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Bilanz

Art. 13. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 14. Rücklagen
Von dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen

zuzuführen. Diese Zuweisungspflicht entfällt, sobald die gesetzlichen Rücklagen zehn Prozent (10%) des gezeichneten
Aktienkapitals erreicht haben. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat auf Empfehlung der Geschäftsführerin zu be-
stimmen, wie über den verbleibenden Teil des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist, Vorbehaltlich der einschlägigen
gesetzlichen Bedingungen können Abschlagsdividenden ausgeschüttet werden.

Kapitel VII. - Liquidation, Änderung der Art

Art. 15. Änderung
Diese Artikel können vorbehaltlich der Zustimmung der Geschäftsführerin von einer Mehrheit von zwei Dritteln der

Stimmen der Gesellschaftsaktionäre anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre, bei dem wenigstens fünfzig Pro-
zent (50%) des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist, abgeändert werden. In dem Fall, dass die vorstehende
Voraussetzung der Beschlussfähigkeit nicht erfüllt ist, bedarf es zur Abänderung dieser Artikel vorbehaltlich der Zustim-
mung der Geschäftsführerin anlässlich einer zweiten Hauptversammlung der Aktionäre ebenfalls einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen der Gesellschaftsaktionäre; diese zweite Hauptversammlung unterliegt allerdings hinsichtlich
ihrer Beschlussfähigkeit keiner Voraussetzung mehr.

Art. 16. Auflösung
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren Liquidatoren (natürliche oder juristi-

sche Personen) durchgeführt. Liquidatoren werden von der Hauptversammlung bestellt, die auch die Auflösung be-
schloss und darüber hinaus den Umfang der Vollmachten und die Entschädigung der Liquidatoren festlegt.

Kapitel VIII. - Abschliessende Verfügungen

Art. 17. Verschiedenes
Im Hinblick auf alle nicht im Rahmen dieser Artikel geregelten Angelegenheiten haben sich die Vertragsparteien an

dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung zu orien-
tieren.

Art. 18. Definitionen
Für Zwecke dieser Artikel:
bezeichnen «Verbundene Unternehmen» sämtliche Personen, die von einer weiteren Person direkt oder indirekt

beherrscht werden, diese selbst beherrschen oder mit dieser oder anderen Personen, die an jenen mit über fünfzig Pro-
zent (50%) wirtschaftlich beteiligt sind oder ihrerseits eine Beteiligung jener Personen in eben diesem Umfang aufweisen,
gemeinsam von einer dritten Person beherrscht werden;

bezeichnen «Artikel» die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft, wie er von Zeit zu Zeit abgeän-

dert werden mag;

beschreibt «As-Converted Basis» im Hinblick auf die ausstehenden Wertpapiere der Gesellschaft das Szenario, dass

alle in Stammaktien umwandelbare bzw. als solche ausüb- oder umtauschbare Wertpapiere im Einklang mit den Bedin-
gungen dieser umgewandelt, ausgeübt oder umgetauscht werden (d.h. die Anzahl der ausstehenden Stammaktien zuzüg-

48319

lich der zusätzlichen Anzahl von Stammaktien, die unter der Voraussetzung einer entsprechenden Verwertung
ausstehen würden.);

haben «Stammaktien der Klasse A» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung;
hat «Gesellschaft» die in Artikel 1 dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Beherrschung» im Hinblick auf eine Person die Fähigkeit zur Verwaltung oder Kontrolle dieser Person

oder zur Bestellung ihrer Verwaltungsgremien bzw. einer Mehrheit der Mitglieder solcher Gremien im Falle einer ge-
meinschaftlichen Entscheidung auf der Grundlage des Besitzes stimmberechtigter Wertpapiere, der Vertragsgewalt oder
anderweitig (in dieser Hinsicht gilt eine Kommanditgesellschaft als von ihrem Geschäftsführer beherrscht);

bezeichnen «CPECs» CPECs der Serie 1, wie sie von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können,

sowie ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft
ebenfalls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können;

hat «Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung;
hat «Ankündigung des Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung;
haben «Drag-Along Securities» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung;
hat «Geschäftsführerin» die in Artikel 8 dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Gruppe» die Gesellschaft sowie deren Tochtergesellschaften, bei denen es sich jeweils um Gruppenun-

ternehmen handelt;

hat «Ausgabe» die in Artikel 6.13 dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Verwaltete juristische Person» eine juristische Person, die von der Geschäftsführerin, der Gesellschaft

oder einer ihrer Tochtergesellschaften beherrscht oder aber verwaltet oder betrieben wird oder der die Geschäftsfüh-
rerin, die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften als Partner oder Aktionär angehört;

bezeichnen «Stammaktien» von der Gesellschaft ausgegebene Stammaktien der Klasse A;
bezeichnen «PECs» PECs der Serie 1, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können, sowie

ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft eben-
falls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können;

hat «Zulässige Abtretung» die in Artikel 7.3(c) dargelegte Bedeutung;
hat «Zulässiger Abtretungsempfänger» die in Artikel 7.3(c) dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Person» ein Individuum, eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, einen Verband, eine Aktien-

gesellschaft, einen Trust, ein Gemeinschaftsunternehmen, eine nicht eingetragene Organisation oder eine Regierungs-
stelle (-amt, -ministerium, usw.);

bezeichnen «Primary Investors» OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC oder ein mit dieser Gesellschaft verbun-

denes Unternehmen, das als Stammaktionär bzw. Anteilseigner an der Gesellschaft oder der Geschäftsführerin beteiligt
ist;

bezeichnen «Secondary Investors» alle Inhaber von Stammaktien oder anderen Anteilen an der Gesellschaft mit

Ausnahme der Primary Investors;

bezeichnen «Wertpapiere» alle ordnungsgemäß genehmigten Wertpapiere der Gesellschaft, so z.B. der PECs und

CPECs;

bezeichnen «CPECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen umtauschbaren Vorzugsaktien der Serie

1;

bezeichnen «PECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen Vorzugsaktien der Serie 1;
bezeichnet «Tochtergesellschaft» im Hinblick auf eine Person alle weiteren Personen, deren Stimmrechte oder wei-

teren stimmberechtigten Anteile-auch im Sinne der Bestellung von Direktoren, Geschäftsführern oder Treuhände - jene
bzw. eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften in beliebiger Konstellation (ungeachtet des Eintritts möglicher Aus-
nahmefälle) zum Zeitpunkt des Besitzes oder der Beherrschung direkt oder indirekt mehrheitlich besitzen oder beherr-
schen. Für Zwecke dieses Vertrags gelten Personen als Mehrheitsaktionäre von, GmbHs, Personengesellschaften,
Verbänden oder weiterer gewerblich tätiger Organisationen, wenn die betreffenden Personen solche, GmbHs, Perso-
nengesellschaften, Verbände oder weiteren gewerblich tätigen Organisationen beherrschen oder deren Gewinne bzw.
Verluste überwiegend absorbieren;

hat «Aufsichtsrat» die in Artikel 11.1 dargelegte Bedeutung;
haben 'Übertragung» und «übertragen» [bzw. «Abtretung» und «abtreten»] die in Artikel 7.3(e) dargelegte

Bedeutung.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember 2006.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner habe die auszugebenen Aktien wie folgt gezeichnet:
1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, vorgenannt,
hat achtzehntausendzweihundertzweiundfünzig Euro und fünfzig Cent (EUR 18.252,50) eingezahlt und vierzehntau-

sendsechshundertzwei (14.602) Aktien gezeichnet;

2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, vorgennant,
hat dreihundertsiebenundvierzig Euro und fünfzig Cent (EUR 347,50) eingezahlt und zweihundertachtundsiebzig (278)

Aktien gezeichnet;

48320

3) OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND, LP, vorgennant,
hat zwölftausenddreihundertachtundneunzig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 12.398,75) eingezahlt und neuntau-

sendneunhundertneunzehn (9.919) Aktien gezeichnet;

4) OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., vorgenannt,
hat ein Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1.25) eingezahlt und eine (1) Aktie gezeichnet;
Insgesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingezahlt für vierundzwanzigtausendachthundert (24.800)

Aktien.

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr viertausend (4.000,-) Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
2. OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A. wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt mit sofortiger Wirkung.
3 Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
- ERNST &amp; YOUNG S.A., mit Geschäftsadresse in 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
- COMPAGNIE DE REVISIONS S.A., mit Geschäftsadresse in 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Luxembourg;
- ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., mit Geschäftsadresse in 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg.

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
5. Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten für das

Rechnungsjahr 2006 entscheidet oder vorzeitig zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Bevollmächtigten der

vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher
Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
maßgebend. 

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit

Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 45, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022756/230/1004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

IVEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 111.894. 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IVEFI S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxem-

bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée par acte notarié en date du 2 novembre 2005, non encore publié (ci-après
la «Société»). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 9 novembre 2005, non
encore publié.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Carole Closener, juriste, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Anthony Braesch, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Emma Garnica, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée a pour

Luxembourg, le 7 mars 2006.

A. Schwachtgen.

48321

<i>Ordre du jour:

1) Division des 1.000 (mille) actions existantes de EUR 1.000,- (mille euros) chacune en 500.000 (cinq cent mille)

actions de EUR 2,- (deux euros) chacune.

2) Décision que les actions sont et resteront nominatives.
3) Modification de l’article 5 des statuts de la Société.
4) Acceptation de la démission des administrateurs et décharge.
5) Nomination subséquente des nouveaux administrateurs.
6) Décision que les obligations à émettre le cas échéant seront et resteront nominatives.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les ac-
tionnaires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de diviser les 1.000 (mille) actions existantes d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille

euros) chacune en 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder à l’échange des titres.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide que les actions de la Société sont émises uniquement sous forme nominative et ne pour-

ront être converties en actions au porteur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa et le troisième alinéa de l’article 5 des statuts de la Société

qui auront désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par cinq cent mille (500.000) actions d’une

valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend note des démissions de Messieurs Tanguy de Pompignan, Bernard Lescalmel et Anthony Braesch

de leurs postes d’administrateurs. Décharge leur sera donné lors de la prochaine assemblée générale amenée à se pro-
noncer sur l’approbation des comptes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs: 
- M. Régis Meister, né à Bettendorf (France), le 3 janvier 1961, ayant son adresse professionnelle à L-2420 Luxem-

bourg, 11, avenue Emile Reuter.

- M. Yves Cacclin, né à Villerupt (France), le 17 septembre 1969, ayant son adresse professionnelle à L-2420 Luxem-

bourg, 11, avenue Emile Reuter.

- M. Juan-Pablo Coma, né à Madrid (Espagne), le 18 août 1965, ayant son adresse professionnelle à E-28020 Madrid,

Torre Picasso Plaza de Pablo Ruiz Picasso 1.

Les nouveaux administrateurs termineront les mandats accordés à leurs prédécesseurs échéant lors de l’Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que les obligations à émettre le cas échéant seront et resteront nominatives et décide d’insérer

un article 5bis dans les statuts de la Société qui aura la teneur suivante: «Les obligations qui seront émises le cas échéant
seront et resteront nominatives.».

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de EUR 1.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

48322

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and five, on the twenty-third of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of IVEFI S.A., having its registered office in L-1855 Lux-

embourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incorporated pursuant to a notarial deed of November 2, 2005, not yet published
(hereinafter referred to as the «Company»). The articles of incorporation have been amended by a deed of the under-
signed notary of the 9th of November 2005, not yet published.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mrs Carole Closener, juriste, with professional address in Luxembourg,

in the chair, who appointed as secretary Mr Anthony Braesch; employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Emma Garnica, employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Splitting of the 1,000 (one thousand) existing shares of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each into 500,000 (five

hundred thousand) shares of EUR 2.- (two Euro) each.

2) Decision that the shares are and shall remain in registered form.
3) Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company. 
4) Resignation of the directors of the Company and discharge.
5) Appointment of new directors.
6) Decision that the bonds that might be issued will be and shall remain in registered form.
II. That the shareholders present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy of the represented
shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The proxy of the represented shareholder, initialed ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed to

the present deed.

That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

III. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to split the 1,000 (one thousand) existing shares with a par value of EUR 1,000.- (one

thousand Euro) each into 500,000 (five hundred thousand) shares with a par value of EUR 2.- (two Euro) each.

All powers are conferred to the Board of Directors to proceed to the exchange of the share certificates.

<i>Second resolution

The general meeting resolved that the shares are issued in registered form only and may not be converted into bearer

shares.

<i>Third resolution

The general meeting resolved to amend the first paragraph and the third of article 5 of the Company’s articles of

incorporation which shall now read as follows:

«The subscribed share capital shall be one million Euro (EUR 1,000,000.-) divided into five hundred thousand

(500,000) shares of two Euro (EUR 2.-) each.

The shares are and will remain in registered form.»

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to accept the resignation of Messrs Tanguy de Pompignan, Bernard Lescalmel and Anthony

Braesch. Discharge will be granted at the next general meeting approving the annual accounts.

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to appoint new directors:
- Mr Régis Meister, born in Bettendorf (France), on January 3, 1961, with professional address in L-2420 Luxembourg,

11, avenue Emile Reuter.

- Mr Yves Cacclin, born in Villerupt (France), on September 17, 1969, with professional address in L-2420 Luxem-

bourg, 11, avenue Emile Reuter.

- Mr Juan-Pablo Coma, born in Madrid (Spain), on August 18, 1965, with professional address in E-28020 Madrid,

Torre Picasso Plaza de Pablo Ruiz Picasso 1.

The mandates of the directors thus appointed will end at the annual general meeting of the shareholders to be held

in the year 2011.

<i>Sixth resolution

The meetings resolve that the bonds that might be issued will be and shall remain in registered form and resolve to

create a new article 5bis in the articles of incorporation of the Company with the following content: «The bonds that
might be issued will be and shall remain in registered form.». 

48323

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at EUR 1,000.-.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; upon request of the appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said persons signed together with the notary the present deed.

Signé: C. Closener, A. Braesch, E. Garnica, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 décembre 2005, vol. 434, fol. 24. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Résolutions prises par le Conseil d’Administration de la Société le 22 novembre 2005

Le Conseil d’Administration de la Société a décidé de voter par voie de résolutions circulaires sur l’ordre du jour

suivant:

1. Location d’un bureau;
2. Transfert du siège social;
3. Recrutement d’un employé à temps partiel;
4. Divers.
Les administrateurs prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Souhaitant développer l’activité de la Société, le Conseil d’Administration décide de signer aujourd’hui un contrat de

prestation de services avec la société ATEAC LUXEMBOURG concernant la location d’un bureau meublé situé au 46A,
avenue John F. Kennedy à L-1855 Luxembourg. Le bureau sera mis à la disposition de la Société à partir du 1

er

 décembre

2005 moyennant un loyer mensuel de 1.500 EUR HT.

<i>Seconde résolution

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la Société du 85-91, route

de Thionville, L-1011 Luxembourg au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

Le Conseil d’Administration décide qu’il est dans l’intérêt de la Société de recruter - à temps partiel - un agent qui

sera en charge de réaliser les travaux comptables, administratifs et le secrétariat juridique de la Société. Dans cette op-
tique, le Conseil d’Administration décide de contacter plusieurs agences d’intérim locales afin de lancer le processus de
recrutement.

Luxembourg, le 22 novembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01193. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014504/242/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

IVEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 111.894. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014505/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

STAND’INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.650. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01218, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022361/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

Mersch, le 16 décembre 2005.

H. Hellinckx.

<i>Le Conseil d’Administration
A. Braesch / T. De Pompignan / B. Lescalmel

Mersch, le 7 février 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Signature.

48324

ARCADIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 114.561. 

L’an deux mille six, le deux mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARCADIE S.A., avec siège

social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, en cours d’immatriculation auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg section B, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 février
2006, acte non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pim Neirynck, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Modification de l’article 4 de statuts de ARCADIE S.A. comme suit:
«La société a pour objet l’acquisition, la vente, la promotion, la gestion et/ou la location de biens immobiliers sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant par tout moyen, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, et notamment par voie d’émissions d’obligations ou
de tout autre instrument qui pourront également être convertibles et/ou subordonnés.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ainsi

que financières, notamment par l’octroi de tout prêt ou garantie, se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou susceptible d’en faciliter la réalisation». 

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article quatre des statuts de

la société qui aura désormais teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la promotion, la gestion et/ou la location de biens immobiliers

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant par tout moyen, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, et notamment par voie d’émissions d’obligations ou
de tout autre instrument qui pourront également être convertibles et/ou subordonnés.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ainsi

que financières, notamment par l’octroi de tout prêt ou garantie, se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou susceptible d’en faciliter la réalisation». 

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: S. Mathot, S. Hennericy, P. Neirynck, P. Bettingen.

48325

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022478/202/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

ARCADIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 114.561. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022480/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

EUROENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 69.326. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05769, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022378/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.092. 

<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 6 février 2006

Suite aux cessions des parts sociales de la société WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l. suivantes:
- 17.514 parts sociales de FACTORY HOLDING COMPANY 25, S.L. à Juan Antonio Perez Ramirez, dont:
2.919 de la catégorie A,
2.919 de la catégorie B,
2.919 de la catégorie C,
2.919 de la catégorie D,
2.919 de la catégorie E,
2.919 de la catégorie F;
- 2.922 parts sociales de Javier Perez Dolset à Juan Antonio Perez Ramirez, dont:
487 de la catégorie A,
487 de la catégorie B,
487 de la catégorie C,
487 de la catégorie D,
487 de la catégorie E,
487 de la catégorie F;
- 2.922 parts sociales de Ignacio Perez Dolset à Juan Antonio Perez Ramirez, dont:
487 de la catégorie A,
487 de la catégorie B,
487 de la catégorie C,
487 de la catégorie D,
487 de la catégorie E,
487 de la catégorie F;
datées du 6 février 2006 dûment autorisées et signifiées, les parts sociales sont désormais détenues comme suit:
- APAX SERVICES I, S.à r.l.:
120.253 parts sociales de catégorie A,
120.253 parts sociales de catégorie B,
120.253 parts sociales de catégorie C,
120.253 parts sociales de catégorie D,
120.253 parts sociales de catégorie E,
120.253 parts sociales de catégorie F;

Senningerberg, le 7 mars 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 7 mars 2006.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

48326

- SONSIN HOLDING B.V.:
3.501 parts sociales de catégorie A,
3.501 parts sociales de catégorie B,
3.501 parts sociales de catégorie C,
3.501 parts sociales de catégorie D,
3.501 parts sociales de catégorie E,
3.501 parts sociales de catégorie F;
- FACTORY HOLDING COMPANY 25, S.L.:
428 parts sociales de catégorie A,
428 parts sociales de catégorie B,
428 parts sociales de catégorie C,
428 parts sociales de catégorie D,
428 parts sociales de catégorie E,
428 parts sociales de catégorie F;
- DOBLE A PROMOCIONES S.A.:
508 parts sociales de catégorie A,
508 parts sociales de catégorie B,
508 parts sociales de catégorie C,
508 parts sociales de catégorie D,
508 parts sociales de catégorie E,
508 parts sociales de catégorie F;
- ESTUDIO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS ONLINE S.L.:
67 parts sociales de catégorie A,
67 parts sociales de catégorie B,
67 parts sociales de catégorie C,
67 parts sociales de catégorie D,
67 parts sociales de catégorie E,
67 parts sociales de catégorie F;
- UN MAR DE RAZONES, S.L.:
22 parts sociales de catégorie A,
22 parts sociales de catégorie B,
22 parts sociales de catégorie C,
22 parts sociales de catégorie D,
22 parts sociales de catégorie E,
22 parts sociales de catégorie F;
- COMUNICACION TERCER MILENIO S.L.:
22 parts sociales de catégorie A,
22 parts sociales de catégorie B,
22 parts sociales de catégorie C,
22 parts sociales de catégorie D,
22 parts sociales de catégorie E,
22 parts sociales de catégorie F;
- NET GENERATION S.A.:
491 parts sociales de catégorie A,
491 parts sociales de catégorie B,
491 parts sociales de catégorie C,
491 parts sociales de catégorie D,
491 parts sociales de catégorie E,
491 parts sociales de catégorie F;
- HADIBU S.L.:
170 parts sociales de catégorie A,
170 parts sociales de catégorie B,
170 parts sociales de catégorie C,
170 parts sociales de catégorie D,
170 parts sociales de catégorie E,
170 parts sociales de catégorie F;
- TELVENT FACTORY HOLDING AG:
3.577 parts sociales de catégorie A,
3.577 parts sociales de catégorie B,
3.577 parts sociales de catégorie C,
3.577 parts sociales de catégorie D,
3.577 parts sociales de catégorie E,
3.577 parts sociales de catégorie F;

48327

- GRUPO SCHOLTZ S.A.:
6.240 parts sociales de catégorie A,
6.240 parts sociales de catégorie B,
6.240 parts sociales de catégorie C,
6.240 parts sociales de catégorie D,
6.240 parts sociales de catégorie E,
6.240 parts sociales de catégorie F;
- B y B PRODUCCIONES S.A.:
339 parts sociales de catégorie A,
339 parts sociales de catégorie B,
339 parts sociales de catégorie C,
339 parts sociales de catégorie D,
339 parts sociales de catégorie E,
339 parts sociales de catégorie F;
- REVERTER 17, S.L.:
88 parts sociales de catégorie A,
88 parts sociales de catégorie B,
88 parts sociales de catégorie C,
88 parts sociales de catégorie D,
88 parts sociales de catégorie E,
88 parts sociales de catégorie F;
- INOVA CAPITAL, S.C.R., S.A.:
60.617 parts sociales de catégorie A,
60.617 parts sociales de catégorie B,
60.617 parts sociales de catégorie C,
60.617 parts sociales de catégorie D,
60.617 parts sociales de catégorie E,
60.617 parts sociales de catégorie F;
- Juan Antonio Perez Ramirez:
43.503 parts sociales de catégorie A,
43.503 parts sociales de catégorie B,
43.503 parts sociales de catégorie C,
43.503 parts sociales de catégorie D,
43.503 parts sociales de catégorie E,
43.503 parts sociales de catégorie F;
- Maria Jesus Dolset Romero:
4.424 parts sociales de catégorie A,
4.424 parts sociales de catégorie B,
4.424 parts sociales de catégorie C,
4.424 parts sociales de catégorie D,
4.424 parts sociales de catégorie E,
4.424 parts sociales de catégorie F;
- Javier Perez Dolset:
47.926 parts sociales de catégorie A,
47.926 parts sociales de catégorie B,
47.926 parts sociales de catégorie C,
47.926 parts sociales de catégorie D,
47.926 parts sociales de catégorie E,
47.926 parts sociales de catégorie F;
- Ignacio Perez Dolset:
47.926 parts sociales de catégorie A,
47.926 parts sociales de catégorie B,
47.926 parts sociales de catégorie C,
47.926 parts sociales de catégorie D,
47.926 parts sociales de catégorie E,
47.926 parts sociales de catégorie F;
- Belén Cano Bulnes:
39 parts sociales de catégorie A,
39 parts sociales de catégorie B,
39 parts sociales de catégorie C,
39 parts sociales de catégorie D,
39 parts sociales de catégorie E,
39 parts sociales de catégorie F;

48328

- Luis Ignacio Torres Prada:
29 parts sociales de catégorie A,
29 parts sociales de catégorie B,
29 parts sociales de catégorie C,
29 parts sociales de catégorie D,
29 parts sociales de catégorie E,
29 parts sociales de catégorie F;
- Candido Velazquez Gaztelu Ruiz:
288 parts sociales de catégorie A,
288 parts sociales de catégorie B,
288 parts sociales de catégorie C,
288 parts sociales de catégorie D,
288 parts sociales de catégorie E,
288 parts sociales de catégorie F;
- Ladislao De Arriba Azcona:
70 parts sociales de catégorie A,
70 parts sociales de catégorie B,
70 parts sociales de catégorie C,
70 parts sociales de catégorie D,
70 parts sociales de catégorie E,
70 parts sociales de catégorie F;
- José Antonio De Francisco:
61 parts sociales de catégorie A,
61 parts sociales de catégorie B,
61 parts sociales de catégorie C,
61 parts sociales de catégorie D,
61 parts sociales de catégorie E,
61 parts sociales de catégorie F;
- PROYECTOS FINANCIEROS PALLISER S.L.:
2.404 parts sociales de catégorie A,
2.404 parts sociales de catégorie B,
2.404 parts sociales de catégorie C,
2.404 parts sociales de catégorie D,
2.404 parts sociales de catégorie E,
2.404 parts sociales de catégorie F;
- IF 4 S.A.:
131 parts sociales de catégorie A,
131 parts sociales de catégorie B,
131 parts sociales de catégorie C,
131 parts sociales de catégorie D,
131 parts sociales de catégorie E,
131 parts sociales de catégorie F;
- AXEL GROUP S.L.:
120 parts sociales de catégorie A,
120 parts sociales de catégorie B,
120 parts sociales de catégorie C,
120 parts sociales de catégorie D,
120 parts sociales de catégorie E,
120 parts sociales de catégorie F;
- Carlos Martinez De Campos Carulla:
72 parts sociales de catégorie A,
72 parts sociales de catégorie B,
72 parts sociales de catégorie C,
72 parts sociales de catégorie D,
72 parts sociales de catégorie E,
72 parts sociales de catégorie F;
- Ole Bo Axel Bredberg:
8 parts sociales de catégorie A,
8 parts sociales de catégorie B,
8 parts sociales de catégorie C,
8 parts sociales de catégorie D,
8 parts sociales de catégorie E,
8 parts sociales de catégorie F;
- Joaquin Rudy Fermin Tamames Meyer:
8 parts sociales de catégorie A,
8 parts sociales de catégorie B,

48329

8 parts sociales de catégorie C,
8 parts sociales de catégorie D,
8 parts sociales de catégorie E,
8 parts sociales de catégorie F;
- Eva Maria Campos Santamaria:
2 parts sociales de catégorie A,
2 parts sociales de catégorie B,
2 parts sociales de catégorie C,
2 parts sociales de catégorie D,
2 parts sociales de catégorie E,
2 parts sociales de catégorie F;
- Enrique Raimundo Grasset Gimenez-Arnau:
2 parts sociales de catégorie A,
2 parts sociales de catégorie B,
2 parts sociales de catégorie C,
2 parts sociales de catégorie D,
2 parts sociales de catégorie E,
2 parts sociales de catégorie F.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00005. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022080/029/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

EXTENSITY, Société à responsabilité limitée,

(anc. TriCage INTERMEDIATE HOLDCO).

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 113.859. 

In the year two thousand and six, on the eighth day of February.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

InTriCage HOLDCO, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, having its regis-
tered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in San

Francisco on February 1st, 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of TriCage INTERMEDIATE HOLDCO (hereinafter the «Company»), a so-

ciété à responsabilité limitée having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, incorporated pur-
suant to a deed of the undersigned notary dated October 28, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to change, with immediate effect, the name of the Company into EXTENSITY.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, article 4 of the articles of incorporation of the Company is amended and

now reads as follows:

Art. 4. «The Company will assume the name of EXTENSITY».

<i>Third resolution

The sole partner decides to appoint the following person as manager of the Company with immediate effect and for

an unlimited period:

- Mr Ken Walters, Business Executives, born on June 2, 1953 in Ohio, United States of America, with professional

address at Infor World Headquarters, 1000 Windward Concourse Parkway, Suite 100, Alpharetta, GA 30005.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

<i>Pour WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / S. Hansen

48330

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille six, le huit février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

InTriCage HOLDCO, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, dont l’enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours,
ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à San Francisco, en date du 1

er

 février 2006.

La procuration, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’associée unique de TriCage INTERMEDIATE HOLDCO (ci-après la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, dont l’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours,
constituée selon un acte notarié par-devant le notaire soussigné, en date du 28 octobre 2005, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.

Laquelle partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer, avec effet immédiat, la dénomination de la Société, laquelle sera désormais EX-

TENSITY.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l’article 4 des statuts de la Société est modifié et est désormais rédigé

comme suit:

Art. 4. «La Société prend la dénomination de EXTENSITY.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de nommer la personne suivante en qualité de gérant de la Société, avec effet immédiat et

pour une durée indéterminée:

- Monsieur Ken Walters, Business Executives, né le 2 juin 1953 à Ohio, Etats-Unis d’Amérique, ayant comme adresse

professionnelle Infor World Headquarters, 1000 Windward Concourse Parkway, Suite 100, Alpharetta, GA 30005.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 2006, vol. 901, fol. 39, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022486/239/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

EXTENSITY, Société à responsabilité limitée,

(anc. TriCage INTERMEDIATE HOLDCO).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 113.859. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022489/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

SOCIETE D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET ECOLOGIQUE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.259. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01430, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022591//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Belvaux, le 6 mars 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 6 mars 2006.

J.-J. Wagner.

WILSON ASSOCIATES
Signature 

48331

J &amp; L MONTANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3231 Bettembourg, 54, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 114.628. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jorge Manuel Da Silva Matias, employé privé, né à Chennevières (France), le 17 avril 1972 (No. Matricule

19720417254), demeurant à L-3231 Bettembourg, 54, route d’Esch;

2.- Monsieur Vitor Manuel Da Silva Matias, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 1976 (No. Matricule

19760515259), demeurant à L-3231 Bettembourg, 54, route d’Esch;

3.- Madame Lucinda Silva Acurcio, propriétaire, née à Figueira da Foz (Portugal), le 29 septembre 1953 (No. Matricule

19530929321), épouse de Monsieur Manuel Figueiredo Matias, demeurant ensemble à L-3231 Bettembourg, 54, route
d’Esch.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de J &amp; L MONTANA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, avec petite res-

tauration, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le
développement. 

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

- Monsieur Jorge Manuel Da Silva Matias, prédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40 parts

- Monsieur Vitor Manuel Da Silva Matias, prédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40 parts

- Madame Lucinda Silva Acurcio, épouse de Monsieur Manuel Figueiredo Matias, prédit  . . . . . . . . . . . . . 

45 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts

48332

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille euros (1.000,- EUR).

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-3231 Bettembourg, 54, route d’Esch;
- Est nommé gérant technique:
Monsieur Jorge Manuel Da Silva Matias, prédit.
- Gérante administrative sera Mme Lucinda Silva Acurcio, préqualifiée.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constitutants sur la né-

cessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire, lequel certifie l’état civil des parties d’après
des extraits du registre de l’état civil, respectivement cartes d’identité.

Signé: J.M. Da Silva Matias, V.M. Da Silva Matias, L. Silva Acurcio, Ch. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2006, vol. 901, fol. 58, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(022564/209/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

ATC STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Jean Bertholet.

H. R. Luxemburg B 114.635. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, am sechszehnten Februar.
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitze zu Bad-Mondorf.

Sind erschienen:

- FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l. mit Sitz in L-1233 Luxemburg, rue Bertholet, 13, hier vertreten durch

Herrn Alex Benoy, Geschäftsführer, wohnhaft in L-1233 Luxemburg rue Bertholet, 13, dieser

hier vertreten durch Frau Nathalie Carbotti-Prieur, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-1233 Luxemburg, 13, rue Jean

Bertholet, aufgrund einer Vollmacht vom 15. Februar 2006, welche nach ne varietur Zeichnung der Komparenten und
des instrumentierenden Notars gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

- ATC AUDIT TAX CONSULT AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit Sitz in D-60528 Frankfurt-am-Main,

eingetragen beim Handelsregister des dortigen Amtsgerichts unter der Nummer HRB 58445,

hier vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Felix Gross, dienstansässig in D-66763 Dillingen, Münchener Strasse,1,
aufgrund einer Vollmacht des Notars Jürgen Philippi,aus Dillingen/Saar vom 16. Februar 2006 wovon eine Kopie

gegenwärtiger Urkunde nach ne varietur Zeichnung der Komparenten und des instrumentiereden Notar beigebogen
bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet ATC STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT, GmbH.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind die: für Buchprüfungsgesellschaften und Steuerberatungsgesellschaften ge-

setzlich und berufsrechtlich zulässigen Tätigkeiten, insbesonders die Beratung und Vertretung in steuerlichen Angele-
genheiten nach Massgabe der bestehenden Vorschriften, sowie die Erstellung von steuerlichen Gutachten, insbesonders
Erstellung von Bilanzen, Prüfungsberichten, Steuerklärungen, Buchhaltungen und damit zusammenhängenden Aufgaben
sowie die Beratung und Wahrung fremder Interessen in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Gesellschaft kann
desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobiliarer Natur tätigen,
die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des
Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (15.000,-) und ist in hundert (100) Anteile von je

einhundertfünfzig Euro (150,-) eingeteilt.

Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Bettembourg, le 6 mars 2006.

Ch. Doerner.

48333

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter, sowie von Todes wegen an Nichtge-

sellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten oder die Nachkommen, bedarf der Genehmigung von Gesell-
schaftern, welche die drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen müssen. Die Übertragung ist der Gesellschaft und
Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zuge-
stellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden ist. Im Todesfall falls die Zustimmung nicht erteilt
wird, können die Anteile von den übrigen Gesellschaftern, von akzeptierten Dritten oder von der Gesellschaft selbst,
gemäss Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erworben werden. Der Preis errechnet sich auf Grund
des Durchschnitts der Bilanzen der letzten drei Jahre oder in Ermangelung von drei Geschäftsjahren, auf Grund zweier
beziehungsweise einer Bilanz. Wenn keine Gewinnzuteilung erfolgte oder wenn die Parteien sich nicht einigen können,
wird der Preis von den Gerichten festgesetzt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und

Befugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden
können, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der

Gesellschaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der
Gesellschaft anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen
werden wie sich aus der letzten Bilanz ergeben.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden

Jahres. Ausnahmsweise beginnt das jetzige Jahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft

aufgestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird
wie folgt zugewiesen:

- fünf (5%) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10%) vom

Hundert des Kapitals darstellt,

- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 11. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 12. Im Falle einer Einpersonengesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der

Generalversammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen

Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der
diesbezüglichen Abänderungsgesetze.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den

Parteien auf siebenhundertfünfzig Euro (750,-) abgeschätzt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt: 

Alle Anteile wurden vollständig und in Bar eingezahlt, so daß der Betrag von fünfzehntausend (15.000,-) Euro der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies vom instrumentiereden Notar festgestellt wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Generalversammlung

Sodann fassen die alleinigen Gesellschafter welche sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen-

finden, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf zwei.
2) Werden zu Geschäftsführern ernannt: Herr Alex Benoy, vorbenannt, geboren zu Luxemburg, am 29. Mai 1954.
Herr Bernard Ferring, Dipl-Ökonom, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, geboren am 6. September 1960 in Lebach

/Saar, wohnhaft in D-66822 Lebach, Römerstrasse, 54.

3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers bis zu

einem Betrag von 5.000,- Euro und darüber hinaus durch die gemeinsame Unterschrift beider Geschäftsführer.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1233 Luxemburg, rue Jean Bertholet, 13.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes. 

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., vorbezeichnet zwanzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

ATC AUDIT TAX CONSULT AG, vorbezeichnet achtzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

48334

Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: N. Carbotti, F. Gross, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 23 février 2006, vol. 470, fol. 5, case 6. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022574/218/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

LE RAMONEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3616 Kayl, 36, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 114.632. 

STATUTS

L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- Monsieur Vitor Manuel Neto Andrade, ramoneur, né à Vendas Novas (Portugal), le 15 juillet 1955, demeurant à

L-3616 Kayl, 36, rue du Commerce.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare

constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite, et dont elle a arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LE RAMONEUR,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Kayl.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de ramonage et de nettoyage de cheminées.
D’une façon générale, elle pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique Vitor Neto Andrade, préqualifié, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Art. 6. Les parts sont insaisissables.
En cas de pluralité d’associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou des

associés représentant l’intégralité des parts sociales. En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-
mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés réunis

en assemblée générale, qui fixe(nt) la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions

de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu
au siège social.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,

proportionnellement au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu’elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 11. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-

nime des associés survivants. Toutefois, le consentement du ou des associés survivants n’est pas requis lorsque les parts
sociales sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d’agrément, il est procédé comme prévu à l’article 6.

Mondorf-les-Bains, le 8 mars 2006.

R. Arrensdorff.

48335

Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année au 31 décembre, il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et

passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du

capital social,

- le solde restant est à la libre disposition des associés. 
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts
dont ils sont propriétaires.

Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 950,- EUR.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse du siège social est fixée à L-3616 Kayl, 36, rue du Commerce.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Vitor Neto Andrade, prénommé.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: V.M. Neto Andrade, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, vol. 27CS, fol. 63, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(022570/241/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

ONIRIA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 97.381. 

L’an deux mille six, le dix février.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ONIRIA PARTICIPATIONS

S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 205, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B 97.381,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 octobre 2003,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 62 du 16 janvier 2004, 

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven agissant en remplacement

de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 459 du 30 avril 2004.

L’assemblée est ouverte à 14.20 heures sous la présidence de Monsieur Thierry Schiel, producteur et réalisateur,

demeurant à L-8327 Olm, 22, rue de l’indépendance,

qui désigne comme secrétaire, Madame Françoise Lhoas, comptable, demeurant professionnellement à B-6700 Arlon,

20A, rue des Violettes.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sophia Kolokouri, productrice, demeurant professionnellement

à L-1471 Luxembourg, 205, route d’Esch.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Hesperange, le 7 mars 2006.

M. Decker.

48336

<i>Ordre du jour unique:

Modification de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. Addition d’un nouvel alinéa 3. La société à également pour objet la production d’oeuvres audiovisuelles

ainsi que l’exploitation de tous droits issus de telles oeuvres.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent
acte.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons à la base des points figurant à l’ordre

du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide d’élargir l’objet social de la Société et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts en lui

ajoutant un nouvel alinéa 3 comme suit:

«Art. 4. (alinéa 3). La société à également pour objet la production d’oeuvres audiovisuelles ainsi que l’exploitation

de tous droits issus de telles oeuvres.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.50 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 860,- EUR.

Fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Th. Schiel, F. Lhoas, S. Kolokouri, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, vol. 27CS, fol. 65, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(022653/241/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

ONIRIA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 97.381. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 3 mars 2006.

(022654/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

Hesperange, le 3 mars 2006.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Coditel, S.à r.l.

Restaurant Brasserie Chez Tony, S.à r.l.

Eurobeton Holding S.A.

Crystal Car Properties, S.à r.l.

Geula Finance, S.à r.l.

Lauriane Investissements Internationaux Holding S.A.

Lauriane Investissements Internationaux Holding S.A.

Lauriane Investissements Internationaux Holding S.A.

Lauriane Investissements Internationaux Holding S.A.

LAF S.A.

OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A.

Ivefi S.A.

Ivefi S.A.

Stand’Inn S.A.

Arcadie S.A.

Arcadie S.A.

Euroengineering, S.à r.l.

Wisdom Entertainment, S.à r.l.

Extensity

Extensity

Société d’Assistance Technique et Ecologique

J&amp;L Montana, S.à r.l.

ATC Steuerberatungsgesellschaft, GmbH

Le Ramoneur, S.à r.l.

Oniria Participations S.A.

Oniria Participations S.A.