This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
4801
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 101
26 janvier 2004
S O M M A I R E
ABF Hyde Park Investments & Co SNC, Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4819
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4808
Hedwige Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
4826
Alison Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
4844
Hedwige Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
4826
Aliva, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4840
Heler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4841
Alma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4840
Honeycomb Technologies S.A., Luxembourg . . . .
4813
Almeezan Luxembourg, S.à r.l., Munsbach . . . . . . .
4814
Horse Development Holding S.A., Luxembourg. .
4834
Amadeus Beteiligung A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4829
Horse Development Holding S.A., Luxembourg. .
4834
Asterlux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4822
Horse Development Holding S.A., Luxembourg. .
4834
B.P.H. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4839
Hysope Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
4841
Becrolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4802
Imedia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4841
Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4844
Immoline International S.A., Luxembourg . . . . . .
4832
Bress S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4826
Interlux Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
4823
C.L.P.K. Aircraft Funding, S.à r.l., Luxembourg . . .
4839
Interlux Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
4823
Capital Developments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
4842
Interlux Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
4823
Chemical Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4839
International Racing Betting System Development
Climmolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4836
(I.R.B.S.D.) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4831
Commerce du Carrelage, S.à r.l., Dippach . . . . . . .
4833
International Racing Betting System Development
Corbigny Investissement S.A., Luxembourg . . . . . .
4818
(I.R.B.S.D.) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4831
Corellia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4825
International Racing Betting System Development
Corellia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4837
(I.R.B.S.D.) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4831
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A., Lu-
International Racing Betting System Development
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4843
(I.R.B.S.D.) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4831
DDM Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4838
Interstel, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
4836
Ecotrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4828
J.F.B. Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . .
4836
EL 2 S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4829
Jones Lang LaSalle Group Finance Luxembourg,
Elna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4840
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4832
Euromutuel Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4841
Kone Luxembourg, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . .
4835
Fiduciaire Vincent La Mendola, S.à r.l., Luxem-
L.P.C. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4830
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4842
Labris Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
4803
Figinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4828
Lanco, SCP, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4842
Fitinfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4844
LB1 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4824
Flanders International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
4844
LB1 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4824
Fumseck Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
4829
León Participaciones Argentinas S.A., Luxem-
Fumseck Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
4829
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4830
Galerie Commerciale de Kirchberg S.A., Luxem-
Levana Informatique S.A., Luxembourg . . . . . . . .
4824
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4843
Levana Informatique S.A., Luxembourg . . . . . . . .
4824
Geromlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4835
Linston Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
4838
Gost S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4843
Loffice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4837
GTL S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4824
Lux-Bowling, GmbH, Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4832
HCEPP II Luxembourg Finance II, S.à r.l., Luxem-
Lux-Tri Services, S.à r.l., Schifflange. . . . . . . . . . . .
4832
4802
SOCIETE INTERCONTINENTALE DE NEGOCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.957.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 15 décembre 2003i>
<i> Résolutioni>
Le conseil décide à l’unanimité de changer le siège de la société pour le transférer de son adresse actuelle, 11, avenue
Emile Reuter, L-2420 Luxembourg à sa nouvelle adresse au 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
La prochaine Assemblée des Actionnaires procédera à la ratification de la présente nomination.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01177. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D.Hartmann.
(001986.3/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
BECROLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.584.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 janvier 2004.
(001681.3/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Magasin et Entreprise Poullig, S.à r.l., Niederkorn
4835
Realstar Healthcare, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
4838
Mediateam S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . .
4836
Regisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4841
Medpart Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
4836
Representation Public CY S.A., Luxembourg . . . .
4825
Medpart, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4839
Representation Public CY S.A., Luxembourg . . . .
4825
Medparticip, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4837
River Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
4838
Mercan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4833
Rosch Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4837
Natalia Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4826
RZ Architecture Int, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
4843
Natalia Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4827
Sabarel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4834
Natalia Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4827
Saint Eugène S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4828
Navale Baltique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4823
Side Group S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4833
Navale Baltique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4823
Side International S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . .
4830
New Rubeccan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
4842
Side International S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . .
4830
On Air Productions, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . .
4833
Sigval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4834
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4845
Sigval Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4844
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4846
Sipcam Financial Service S.A., Luxembourg . . . . .
4835
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4846
Société Intercontinentale de Négoce S.A., Lu-
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4846
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4802
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4846
Sofires S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4845
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4847
Sogeho International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
4840
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4847
Texeurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4838
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4847
Thobe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4845
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4847
Trenubel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4845
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4847
Union International Consulting, S.à r.l., Mersch . .
4845
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4848
Vega Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
4840
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4848
Venezia Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
4845
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4848
Vita Promotion S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . .
4835
Overlease Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
4848
Volteria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4828
Penny International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
4827
Volteria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4828
Penny International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
4827
W. BNK A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4825
Polifontaine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4833
W. BNK A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4825
Realstar Healthcare Financial, S.à r.l., Luxem-
Wilson Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4839
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4837
SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE S.A., Société Anonyme
T. Fleming / L. Hansen
<i>Deux Administrateursi>
<i>Pour la société
i>J. Seckler
4803
LABRIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 97.852.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- LANNAGE S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
(R.C. Luxembourg, section B numéro 63.130),
ici représentée par:
Madame Simone Wallers, employée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 décembre 2003.
2.- VALON S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
(R.C. Luxembourg, section B numéro 63.130),
ici représentée par:
Madame Catherine Day-Royemans, employée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les personnes comparantes et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles personnes comparantes, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant, d’arrêter
ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LABRIS HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par la
création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en numéraire.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration.
4804
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme
d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l’année suivante.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d’août à dix heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 mars 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
1. LANNAGE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. VALON S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
4805
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C. Luxem-
bourg B 63.130.
b) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C. Luxem-
bourg B 63.143.
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C. Luxem-
bourg B 86.086.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.
Luxembourg B 63.115.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2009.
5. Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Suit la traduction anglaise de ce qui précède:
In the year two thousand three, on the fifteenth of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- LANNAGE S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B number 63.130);
here represented by:
Mrs Simone Wallers, employee, residing in Luxembourg
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 12, 2003.
2. VALON S.A, a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Lux-
embourg (R.C. Luxembourg, section B number 63.143);
here represented by:
Mrs Catherine Day-Royemans, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 12, 2003.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, acting in their prenamed capacities, have requested the undersigned notary, to draw up the
following Articles of Incorporation of a «société anonyme», which the prenamed parties intend to organize among them-
selves.
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of LABRIS HOLDING S.A.
The registered office is established in Luxembourg-City.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
4806
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
direct and substantial interest.
The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-
complishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding Companies and by article 209 of the amended companies act.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into three hundred and
ten (310) shares of a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
The corporate share capital may be increased from its present amount up to five hundred thousand euros (EUR
500,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.
The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and
conditions of subscription and payment of the additional shares.
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any
denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-
moved at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the
meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-
tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or fac-simile.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the
delegate of the board.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on first day of April and shall end on thirty-first day of March of
the next year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-
cated in the convening notices on third Wednesday of August at 10.00 a.m..
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
4807
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding Compa-
nies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional Dispositionsi>
1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31st March 2005.
2) The first annual general meeting shall be held in 2005.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR
31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of Costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about two thousand euros.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C. Lux-
embourg B 63.130.
b) VALON S.A., société anonyme, having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C. Lux-
embourg B 63.143.
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C. Lux-
embourg B 86.086.
3) Has been appointed auditor:
- AUDIT TRUST S.A., société anonyme, having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.
Luxembourg B 63.115.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2009.
5) The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office in Luxembourg, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Signé: S. Wallers, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2003, vol. 881, fol. 65, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001828.3/239/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
1. LANNAGE S.A., previously named, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. VALON S.A., previously named, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Belvaux, le 29 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
4808
ABF HYDE PARK INVESTMENTS & CO SNC, Société en nom collectif.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 96.924.
—
In the year two thousand and three, on the tenth day of December.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of
Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the partners of the partnership ABF HYDE PARK INVESTMENTS &
Co SNC, Offene Handelsgesellschaft (Société en nom collectif), having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69A,
boulevard de la Pétrusse, incorporated by a deed received by the undersigned notary, on November 11, 2003, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1298 on December 5, 2003 («the Partnership»).
The extraordinary general meeting was opened at 10.15 a.m. by Mr Claude Erpelding, private employee, residing pro-
fessionally in Luxembourg acting as chairman and appointing Mrs Agnès Gauthier-Ribler, private employee, residing pro-
fessionally in Luxembourg, as secretary of the meeting.
The meeting appointed as scrutineer Maître Michel Bulach, lawyer, residing professionally in Luxembourg
These three individuals constituted the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the partners or by the proxy holders representing the partners, and by the members of the board and
the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the
present deed, with the registration authorities.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the partners representing the full amount of the partnership capital of fourteen
thousand Pounds Sterling (GBP 14,000,-) were present or validly represented at the meeting. The meeting could thus
validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening no-
tice.
II. The agenda of the meeting was the following:
1) increase of the partnership capital of the Partnership from its present amount of GBP 14,000.- represented by 140
partnership units with a par value of GBP 100.- each, to the amount of GBP 15,373,000.- represented by 153,730 part-
nership units, with a par value of GBP 100.- each.
2) issue of 153,590 new partnership units with a par value of GBP 100.- each, having the same rights and obligations
as the existing corporate units, together with an aggregate share premium amounting to GBP 138,231,000.-.
3) subscription and payment of 123,544 corporate units of the Partnership, together with the share premium of GBP
111,189,600.-, by ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. by contribution of all its assets and liabilities.
4) subscription and payment of 30,046 corporate units of the Partnership, together with the share premium of GBP
27,041,400.-, by ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. by contribution of all its assets and liabilities.
5) reduction of the partnership capital of the Partnership by GBP 14,000.-, to bring it from its new amount of GBP
15,373,000.-, represented by 153,730 partnership units with a par value of GBP 100.- each, to GBP 15,359,000.-, repre-
sented by 153,590 partnership units with a par value of GBP 100.- each, by cancellation of 140 partnership units with a
par value of GBP 100.- each.
6) cancellation of the 140 partnership units of the Partnership to be held by the Partnership pursuant to the contri-
bution by ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. and ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. of all their re-
spective assets and liabilities to the Partnership.
7) amendment of the Articles of Association of the Partnership further to the above resolutions.
8) increase of the number of managers of the Partnership from two to six.
9) appointment as additional managers of the Partnership for a mandate which shall terminate at the annual general
meeting relating to the accounts as at 14th September 2004 of:
- Mr Christopher Harris, English Solicitor, born on 3 August 1953 in Preston, Lancashire (Great Britain), residing at
Oak Walk, St. Peter, Jersey JE3 7EF (Great Britain),
- Mr Harry Taylor, Retired Banker, born on 18 February 1927 in Guisborough, North Yorkshire (Great Britain), re-
siding at Woodcote, Rue de l’Epinel, Forest, Guernsey GY8 0HJ (Great Britain),
- Mr John Boothman, Retired Banker, born on 8 April 1952 in Denmark Hill, London (Great Britain), residing at
Brooklands Le Mont Sorsoleil, St Lawrence JE3 1GD (Great Britain),
- Mr Peter Russell, Accountant, born on 12 September 1957 in Edgware, Middlesex (Great Britain), residing at 27
Valley Road, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 4DT (Great Britain).
10) Miscellaneous.
The meeting having approved the statements of the chairman and considering itself as duly constituted and convened,
deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners’ meeting resolved to increase the partnership capital of the Partnership so as to bring it from its present
amount of fourteen thousand Pounds Sterling (GBP 14,000.-) represented by one hundred and forty (140) partnership
units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, to the amount of fifteen million three hundred
seventy-three thousand Pounds Sterling (GBP 15,373,000.-) represented by one hundred fifty-three thousand seven
hundred thirty (153,730) partnership units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.
4809
<i>Second resolutioni>
The partners’ meeting resolved to issue one hundred fifty-three thousand five hundred ninety (153,590) partnership
units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, having the same rights and obligations as the
existing partnership units, together with an aggregate share premium amounting of one hundred thirty-eight million two
hundred thirty-one thousand Pounds Sterling (GBP 138,231,000.-).
<i>Subscriptions and Paymentsi>
1. There now appeared M
e
Michel Bulach, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney of the
company ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lux-
embourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on December 8, 2003, which power of attorney, after
having been signed ne varietur by the proxy holder, by the members of the board and by the notary, will remain attached
to the present deed, and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.
The prenamed company ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., represented as hereabove stated, being under-
stood that the proxy holder may not be considered as founder, declared to subscribe for one hundred twenty-three
thousand five hundred forty-four (123,544) additional partnership units, with a par value of one hundred Pounds Sterling
(GBP 100.-) each, together with an aggregate share premium amounting of one hundred eleven million one hundred
eighty-nine thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 111,189,600.-), and to make payment in full for such new part-
nership units together with the share premium by a contribution in kind, consisting in all the assets and liabilities of the
company ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l.
A valuation report was drawn-up by Mr Peter Russell, Director of ABF INVESTMENTS PLC, on December 5, 2003,
wherein all the assets and liabilities contributed have been described and valued.
The proxy holder produced that report, the conclusion of which is as follows:
«Based on the verification procedures applied as described above:
- the value of the contribution is at least equal to the number and value of the 123,544 partnership units with a par
value of GBP 100.- each, together with the aggregate share premium amounting to GBP 111,189,600.-;
- we have no further comment to make on the value of the contribution.».
A copy of the report, after having been signed ne varietur by the board of the meeting and by the notary, will remain
attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
It results from a contribution agreement duly signed on December 8, 2003 between ABF HYDE PARK INVEST-
MENTS, S.à r.l., ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC and the Partnership that all the assets and liabilities of the com-
pany ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. are transferred to the Partnership.
A copy of the contribution agreement, after having been signed ne varietur by the board of the meeting and by the
notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Thereupon, the partners’ meeting unanimously resolved to accept the said subscription and payment and to issue and
allot one hundred twenty-three thousand five hundred forty-four (123,544) fully paid-up additional partnership units
with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, together with an aggregate share premium amounting
to one hundred eleven million one hundred eighty-nine thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 111,189,600.-) to
the company ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l.
2. There now appeared M
e
Michel Bulach, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney of the
company ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on December 8, 2003, which power of attorney,
after having been signed ne varietur by the proxy holder, by the members of the board and by the notary, will remain
attached to the present deed, and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.
The prenamed company ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., represented as hereabove stated, being un-
derstood that the proxy holder may not be considered as founder, declared to subscribe for thirty thousand forty-six
(30,046) additional partnership units, with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, together with
an aggregate share premium amounting of twenty-seven million forty-one thousand four hundred Pounds Sterling (GBP
27,041,400.-), and to make payment in full for such new partnership units together with the share premium by a con-
tribution in kind, consisting in all the assets and liabilities of the company ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l.
A valuation report was drawn-up by Mr Peter Russell of ABF INVESTMENTS PLC, on December 5, 2003, wherein
all the assets and liabilities contributed have been described and valued.
The proxy holder produced that report, the conclusion of which is as follows:
«Based on the verification procedures applied as described above:
- the value of the contribution is at least equal to the number and value of the 30,046 partnership units with a par
value of GBP 100.- each, together with the aggregate share premium amounting to GBP 27,041,400.-;
- we have no further comment to make on the value of the contribution.».
A copy of the report, after having been signed ne varietur by the board of the meeting and by the notary, will remain
attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
It results from a contribution agreement duly signed on December 8, 2003 between ABF REGENTS PARK INVEST-
MENTS, S.à r.l., ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC, ABF INVESTMENTS PLC and the Partnership that all the assets
and liabilities of the company ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. are transferred to the Partnership.
A copy of the contribution agreement, after having been signed ne varietur by the board of the meeting and by the
notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Thereupon, the general meeting resolved to accept the said subscription and payment and to issue and allot thirty
thousand forty-six (30,046) fully paid-up additional partnership units with a par value of one hundred Pounds Sterling
(GBP 100.-) each, together with an aggregate share premium amounting of twenty-seven million forty-one thousand four
hundred Pounds Sterling (GBP 27,041,400.-) to the company ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l.
4810
<i>Third resolutioni>
The partners’ meeting resolved to reduce the partnership capital of the Partnership by fourteen thousand Pounds
Sterling (GBP 14,000.-) to bring it from its new amount of fifteen million three hundred seventy-three thousand Pounds
Sterling (GBP 15,373,000.-), represented by one hundred fifty-three thousand seven hundred thirty (153,730) partner-
ship units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, to fifteen million three hundred fifty-nine
thousand Pounds Sterling (GBP 15,359,000.-), represented by one hundred fifty-three thousand five hundred ninety
(153,590) partnership units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each, by cancellation of one
hundred forty (140) partnership units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.
<i>Fourth resolutioni>
The partners’ meeting resolved to cancel the one hundred forty (140) partnership units of the Partnership held by
the Partnership pursuant to the contribution by the company ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. and the company
ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. of all their assets and liabilities to the Partnership.
<i>Fifth resolutioni>
The partners’ meeting resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Part-
nership so as to reflect the said increase and decrease of the partnership capital of the Partnership, as follows:
«The Partnership’s capital is set at fifteen million three hundred fifty-nine thousand Pounds Sterling (GBP 15,359,000),
represented by one hundred fifty-three thousand five hundred ninety (153,590) partnership units with a par value of one
hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.».
<i>Sixth resolutioni>
The partners’ meeting resolved to increase the number of manager of the Partnership from two to six.
<i>Seventh resolutioni>
The partners’ meeting resolved to appoint as additional managers of the Partnership for a mandate which shall ter-
minate at the annual general meeting relating to the accounts as at September 14, 2004:
- Mr Christopher Harris, English Solicitor, born on August 3, 1953 in Preston, Lancashire (Great Britain), residing at
Oak Walk, St. Peter, Jersey JE3 7EF (Great Britain),
- Mr Harry Taylor, Retired Banker, born on February 18, 1927 in Guisborough, North Yorkshire (Great Britain), re-
siding at Woodcote, Rue de l’Epinel, Forest, Guernsey GY8 0HJ (Great Britain),
- Mr John Boothman, Retired Banker, born on April 8, 1952 in Denmark Hill, London (Great Britain), residing at
Brooklands, Le Mont Sorsoleil, St Lawrence JE3 1GD (Great Britain),
- Mr Peter Russell, Accountant, born on September 12, 1957 in Edgware, Middlesex (Great Britain), residing at 27
Valley Road, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 4DT (Great Britain).
<i>Expensesi>
Insofar as the contributions in kind results in the company ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. and the company
ABF HYDE REGENTS INVESTMENTS, S.à r.l., both companies incorporated in the European Union (Grand Duchy of
Luxembourg), contributing all their assets and liabilities to a partnership incorporated in the European Union (Grand
Duchy of Luxembourg), the Partnership refers to Articles 4-1 of the law dated December 29, 1971, which provides for
capital contribution exemption.
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Partnership, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 7,000.- (seven thousand Euros).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman
brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together
with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendunddrei, am zehnten Tag des Monats Dezember.
Vor Uns Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Großherzogtum
Luxemburg.
Versammelte sich eine ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft ABF HYDE PARK
INVESTMENTS & Co SNC, Offene Handelsgesellschaft (Société en nom collectif), mit eingetragenem Sitz in L-2320 Lu-
xemburg, 69A, boulevard de la Pétrusse, gegründet infolge einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten No-
tar am 11. November 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 1298 vom 5.
Dezember 2003, («die Gesellschaft»).
Die außerordentliche Hauptversammlung wurde um 10.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Claude Erpelding, Pri-
vatangestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmte sodann zum Sekretär Frau Agnès Gauthier-Ribler, Privatangestellte, beruflich wohnhaft
in Luxemburg.
4811
Zum Skrutator wurde durch die Versammlung Herr Rechtsanwalt Michel Bulach, beruflich wohnhaft in Luxemburg,
bestimmt.
Diese drei Personen bildeten das Büro der Versammlung.
Das wie hiervor aufgeführt zusammengesetzte Büro stellte die Anwesenheitsliste auf, welche von den Gesellschaf-
tern, oder von einem jeden Bevollmächtigten eines Gesellschafters, von den Büromitgliedern und dem Notar ne varietur
unterzeichnet wurde und dieser Urkunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Vorsitzende erklärte und bat den Notar, nachfolgendes zu beurkunden:
I. Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor, dass sämtliche Gesellschafter der Gesellschaft, welche zusammen das
gesamte Gesellschaftskapital in Höhe von vierzehntausend Pfund Sterling (GBP 14.000,-) darstellen, bei der Hauptver-
sammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten waren. Die Hauptversammlung konnte daher rechtsgültig ohne voran-
gehende Einberufungskundgabe über sämtliche Verhandlungspunkte der Tagesordnung beraten und entscheiden.
II. Die Hauptversammlung hatte folgende Tagesordnung:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem augenblicklichen Betrag von GBP 14.000,- eingeteilt in 140 Gesell-
schaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils GBP 100,- auf einen Betrag von GBP 15.373.000,- eingeteilt in 153.730
Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert zu jeweils GBP 100,-.
2. Ausgabe von 153.590 neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von GBP 100,- mit den gleichen Rechten
und Verpflichtungen wie die bestehenden Gesellschaftsanteile, mit einem gesamten Anteilsaufschlag in Höhe von GBP
138.231.000,-.
3. Zeichnung und Zahlung von 123.544 Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft mit einem gesamten Anteilsaufschlag in
Höhe von GBP 111.189.600,- durch ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. durch Einlage ihrer sämtlicher Aktiva und
Passiva.
4. Zeichnung und Zahlung von 30.046 Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft mit einem gesamten Anteilsaufschlag in
Höhe von GBP 27.041.400,- durch ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. durch Einlage ihrer sämtlicher Aktiva
und Passiva.
5. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um GBP 14.000,- um es von seinem neuen Betrag in Höhe
von GBP 15.373.000,- eingeteilt in 153.730 Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils GBP 100,- auf GBP
15.359.000,- eingeteilt in 153.590 Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils GBP 100,- durch Annullierung
von 140 Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft mit einem Nennwert zu jeweils GBP 100,- herauszusetzen.
6. Annullierung von 140 Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft, die von der Gesellschaft gehalten werden aufgrund
der Einlage ihrer respektiven sämtlichen Aktiva und Passiva durch die ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. und die
ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. zugunsten der Gesellschaft.
7. Abänderung der Satzung, um den obigen Beschlüssen Rechnung zu tragen.
8. Erhöhung der Anzahl der Geschäftsführer der Gesellschaft von zwei auf sechs.
9. Ernennung als zusätzliche Geschäftsführer der Gesellschaft für eine Dauer, die am Tag der Jahreshauptversamm-
lung, welche über den Jahresabschluss auf den 4. September 2004 beschliesst enden wird:
- Mr Christopher Harris, englischer Rechtsanwalt, geboren am 3. August 1953 in Preston, Lancashire (Großbritanni-
en), wohnhaft in Oak Walk, St. Peter, Jersey JE3 7EF (Großbritannien),
- Mr Harry Taylor, Bänker im Ruhestand, geboren am 18. Februar 1927 in Guisborough, North Yorkshire (Großbri-
tannien), wohnhaft in Woodcote, Rue de l’Epinel, Forest, Guernsey GY8 0HJ (Großbritannien),
- Mr John Boothman, Bänker im Ruhestand, geboren am 8. April 1952 in Denmark Hill, London (Großbritannien),
wohnhaft in Brooklands Le Mont Sorsoleil, St Lawrence JE3 1GD (Großbritannien),
- Mr Peter Russell, Buchhalter, geboren am 12. September 1957 in Edgware, Middlesex (Großbritannien), wohnhaft
in 27 Valley Road, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 4DT (Großbritannien).
10. Sonstiges
Die Hauptversammlung, nachdem sie den Aussagen des Vorsitzenden zugestimmt hat und sich für als ordnungsgemäß
zusammengesetzt und einberufen erachtet hat, hat nach Beratung folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschloss, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft vom aktuellen Betrag von vier-
zehntausend Pfund Sterling (GBP 14.000,-) eingeteilt in einhundertundvierzig (140) Gesellschaftsanteile mit einem Nenn-
wert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-), auf den Betrag von fünfzehn Millionen
dreihundertdreiundsiebzigtausend Pfund Sterling (GBP 15.373.000,-) eingeteilt in einhundertdreiundfünfzigtausendsie-
benhundertdreißig (153.730) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100)
zu erhöhen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschloss, einhundertdreiundfünfzigtausendfünfhundertneunzig (153.590) Gesell-
schaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-) welche die gleichen Rechte und
Verpflichtungen wie die bestehenden Gesellschaftsanteile haben, zusammen mit einem gesamten Anteilsaufschlag in
Höhe von einhundertachtunddreißig Millionen zweihunderteinunddreißigtausend Pfund Sterling (GBP 138.231.000,-)
auszugeben.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
1. Daraufhin erschien Herr Rechtsanwalt Michel Bulach vorgenannt in seiner Eigenschaft als rechtsgültig eingesetzter
Bevollmächtigter der Gesellschaft ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. mit eingetragenem Sitz in 69A, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 8. Dezember 2003. Die Voll-
macht wurde von den Büromitgliedern und dem Notar ne varietur unterzeichnet und wurde dieser Urkunde als Anlage
beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
4812
Die vorgenannte ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., wie vorerwähnt vertreten, vorausgesetzt dass der Be-
vollmächtigte nicht als Gesellschaftsgründer zu erachten ist, erklärt einhundertdreiundzwanzigtausendfünfhundertvie-
rundvierzig (123.544) zusätzliche Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP
100,-) zusammen mit einem gesamten Anteilsaufschlag in Höhe von elf Millionen einhundertneunundachtzigtausend-
sechshundert Pfund Sterling (GBP 111.189.600,-) zu zeichnen und diese neuen Gesellschaftsanteile und den gesamten
Anteilsaufschlag vollständig durch Sacheinlage, bestehend aus sämtlichen Aktiva und Passiva der ABF HYDE PARK IN-
VESTMENTS, S.à r.l. einzuzahlen.
Ein Wertbericht wurde durch Herrn Peter Russell Direktor von ABF INVESTMENTS PLC am 5. Dezember 2003
erstellt, worin sämtliche eingebrachten Aktiva und Passiva bezeichnet und bewertet werden.
Der Bevollmächtigte hat diesen Bericht vorgelegt, welcher folgende Schlussfolgerungen enthielt:
«Based on the verification procedures applied as described above:
- the value of the contribution is at least equal to the number and value of the 123,544 partnership units with a par
value of GBP 100.- each, together with the aggregate share premium amounting to GBP 111,189,600.-;
- we have no further comment to make on the value of the contribution.»
Eine Kopie des Berichtes wurde von den Büromitgliedern und dem Notar ne varietur unterzeichnet und wurde dieser
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Es geht aus einer Einlagevereinbarung vom 8. Dezember 2003 zwischen ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l.,
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC und der Gesellschaft hervor, dass der Gesellschaft sämtliche Aktiva und Passiva
von ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. übertragen werden.
Eine Kopie der Einlagevereinbarung wurde von den Büromitgliedern und dem Notar ne varietur unterzeichnet und
wurde dieser Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Daraufhin beschloss die Gesellschafterversammlung einstimmig, die vorerwähnte Zeichnung und Einzahlung anzuneh-
men und einhundertdreiundzwanzigtausendfünfhundertvierundvierzig (123.544) vollständig eingezahlte zusätzliche Ge-
sellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-) mit einem gesamten
Anteilsaufschlag in Höhe von einhundertelf Millionen einhundertneunundachtzigtausendsechshundert Pfund Sterling
(GBP 111.189.600,-) auszugeben und ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. zuzuteilen.
2. Darauf erschien Herr Rechtsanwalt Michel Bulach vorgenannt in seiner Eigenschaft als rechtsgültig eingesetzter Be-
vollmächtigter der Gesellschaft ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. mit eingetragenem Sitz in 69A, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 8. Dezember 2003. Die Voll-
macht wurde von den Büromitgliedern und dem Notar ne varietur unterzeichnet und wurde dieser Urkunde als Anlage
beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die vorgenannte ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., wie vorerwähnt vertreten, vorausgesetzt dass der
Bevollmächtigte nicht als Gesellschaftsgründer zu erachten ist, erklärt dreißigtausend sechsundvierzig (30.046) zusätzli-
che Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-) zusammen mit einem
gesamten Anteilsaufschlag in Höhe von siebenundzwanzig Millionen einundvierzigtausendvierhundert Pfund Sterling
(GBP 27.041.400,-) zu zeichnen und diese neuen Gesellschaftsanteile und den gesamten Anteilsaufschlag vollständig
durch Sacheinlage, bestehend aus sämtlichen Aktiva und Passiva der ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. ein-
zuzahlen.
Ein Wertbericht wurde durch Herrn Peter Russell von ABF INVESTMENTS PLC am 5. Dezember 2003 erstellt, wor-
in sämtliche eingebrachten Aktiva und Passiva bezeichnet und bewertet sind.
Der Bevollmächtigte hat diesen Bericht vorgelegt, welcher folgende Schlussfolgerung enthielt:
«Based on the verification procedures applied as described above:
- the value of the contribution is at least equal to the number and value of the 30,046 partnership units with a par
value of GBP 100.- each, together with the aggregate share premium amounting to GBP 27,041,400.-;
- we have no further comment to make on the value of the contribution.».
Eine Kopie des Berichtes wurde von den Büromitgliedern und dem Notar ne varietur unterzeichnet und wurde dieser
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Es geht aus einer Einlageversammlung vom 8. Dezember 2003 zwischen ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.àr.l.,
ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., ASSOCIATED BRITISH FOOD PLC, ABF INVESTMENTS PLC und der Ge-
sellschaft hervor, dass der Gesellschaft sämtliche Aktiva und Passiva von ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l.
übertragen werden.
Eine Kopie der Einlagevereinbarung wurde von den Büromitgliedern und dem Notar ne varietur unterzeichnet wurde
und dieser Urkunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben einregistriert zu werden.
Daraufhin beschloss die Gesellschafterversammlung einstimmig, die vorerwähnte Zeichnung und Zahlung anzuneh-
men und dreißigtausendsechsundvierzig (30.046) vollständig eingezahlte zusätzliche Gesellschaftsanteile mit einem
Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100.-) zusammen mit einem gesamten Anteilsaufschlag in Höhe
von siebenundzwanzig Millionen einundvierzigtausendvierhundert Pfund Sterling (GBP 27.041.400,-) auszugeben und
ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. zuzuteilen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschloss, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um vierzehntausend Pfund Ster-
ling (GBP 14.000,-) von seinem neuen Betrag in Höhe von fünfzehn Millionen dreihundertdreiundsiebzigtausend Pfund
Sterling (GBP 15.373.000,-) eingeteilt in einhundertdreiundfünfzigtausendsiebenhundertdreißig (153.730) Gesellschafts-
anteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-), auf fünfzehn Millionen dreihundertneun-
undfünfzigtausend Pfund Sterling (GBP 15.359.000,-) eingeteilt in einhundertdreiundfünfzigtausendfünfhundertneunzig
(153.590) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-) durch Annullie-
4813
rung von einhundertundvierzig (140) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling
(GBP 100,-) herabzusetzen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschloss, einhundertundvierzig (140) von der Gesellschaft gehaltene Gesellschafts-
anteile der Gesellschaft aufgrund der Einlagen von ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. und ABF HYDE PARK IN-
VESTMENTS, S.à r.l. ihrer respektiven sämtlichen Aktiva und Passiva zugunsten der Gesellschaft, zu annullieren.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den ersten Absatz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft folgender-
maßen abzuändern, um die vorerwähnte Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftsvermögens anzuzeigen:
«Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehn Millionen dreihundertneunundfünfzigtausend Pfund Sterling (GBP
15.359.000,-) eingeteilt in einhundertdreiundfünfzigtausendfünfhundertneunzig (153.590) Gesellschaftsanteile mit einem
Nennwert von jeweils einhundert Pfund Sterling (GBP 100.-).».
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschloss, die Anzahl der Geschäftsführer der Gesellschaft von zwei auf vier zu er-
höhen.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschloss, als zusätzliche Geschäftsführer der Gesellschaft für eine Dauer welche am
Tag der Jahreshauptversammlung, welche über den Jahresabschluss auf den 14. September 2004 bestimmt, zu ernennen:
- Herrn Christopher Harris, englischer Rechtsanwalt, geboren am 3. August 1953 in Preston, Lancashire (Grossbri-
tannien), wohnhaft in Oak Walk, St. Peter, Jersey JE3 7EF (Grossbritannien),
- Herrn Harry Taylor, Bankier im Ruhestand, geboren am 18. Februar 1927 in Guisborough, North Yorkshire
(Grossbritannien), wohnhaft in Woodcote, Rue de l’Epinel, Forest, Guernsey GY8 0HJ (Grossbritannien),
- Herrn John Boothman, Bankier im Ruhestand, geboren am 8. April 1952 in Denmark Hill, London (Grossbritannien),
wohnhaft in Brooklands, Le Mont Sorsoleil, St Lawrence JE3 1GD (Grossbritanien),
- Herrn Peter Russell, Buchhalter, geboren am 12. September 1957 in Edgware, Middlesex (Grossbritannien), wohn-
haft in 27 Valley Road, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 4DT (Grossbritannien).
<i>Kosteni>
Insoweit als die Sacheinlagen der ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l. und ABF HYDE PARK INVESTMENTS,
S.à r.l., beides in der Europäischen Union (Großherzogtum Luxemburg) eingetragene Gesellschaften, Einlagen ihrer
sämtlichen Aktiva und Passiva zugunsten einer in der Europäischen Union eingetragenen Gesellschaft (Großherzogtum
Luxemburg) ergibt, bezieht sich die Gesellschaft auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, das eine Kapi-
taleinlagebefreiung vorsieht.
Die von der Gesellschaft getragenen Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen aller Art, die durch
diese Handlungen anfallen, werden auf ungefähr EUR 7.000,- (siebentausend Euro) geschätzt.
Ohne weitere offene Tagesordnungspunkte und ohne weitere Bitten um Diskussion beendete der Vorsitzende die
Versammlung.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ver-
langen der obigen erschienenen Personen auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Verlangen
derselben erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung
ist die englische Fassung maßgeblich.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung haben die Mitglieder des Büros gemeinsam mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. Erpelding, A. Gauthier-Ribler, M. Bulach, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(001764.3/222/370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HONEYCOMB TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.453.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06550, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
(001862.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxemburg-Bonneweg, den 6. Januar 2004.
T. Metzler.
4814
ALMEEZAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 97.638.
—
STATUTES
In the year two thousand three, on the ninth of December.
Before Us, Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
QATAR ISLAMIC BANK, a shareholding company incorporated under the laws of Qatar, duly registered with the
Register of Companies of Qatar under the number 8338, having its registered office at P.O. Box 559, Doha, Qatar,
here represented by Mr Fatah Boudjelida, consultant, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach,
by virtue of a proxy given in Doha on December 2003.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The purposes for which the company is established is to acquire certain real estate property in Turkey, which
acquisition shall be financed by equity and the issuance of convertible bonds to the shareholder(s).
Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name ALMEEZAN LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach (Municipality of Schüttrange).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by two hundred
fifty-six (256) Class «A» shares and two hundred forty-four (244) Class «B» shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each,
fully paid up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the shareholder(s) to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in
direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of Category A manager(s) and of Category B manager(s).
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
4815
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its
single manager.
In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signatures
of all the Category A managers and one Category B manager.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case
the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the unanimous consent
of (i) all Category A managers present or represented, and (ii) the unanimous consent of at least one Category B Man-
ager with at least the presence or the representation of all Category A Managers and at least one Category B Manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the
basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by the unanimous consent of 100% of the share-
holders of each class of shares.
Decisions in connection with the operation, maintenance, development and/or disposition of any of the assets of the
company require the unanimous consent of 100% of the shareholders of each class of shares.
Furthermore, resolutions to alter or amend the Articles may only be adopted by unanimous consent of 100% of the
shareholders of each class of shares.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of
plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-
first of December 2004.
<i>Subscription - Paymenti>
The two hundred fifty-six (256) Class «A» shares and two hundred forty-four (244) Class «B» shares of twenty-five
Euros (EUR 25.-) each have been subscribed by QATAR ISLAMIC BANK, prenamed and have been fully paid in cash, so
that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
4816
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
Category A Managers:
- Mr Ahmed Elsayad, General Manager, with professional address at P.O. Box 559, Doha, Qatar;
- Mr Hassan Al Ammari, General Manager, CEO, residing at Dallah Tower - Palestine Street, P.O. Box 6854 Jeddah
21452, Kingdom of Saudi Arabia.
Category B Manager:
- Mr Marcel Stephany, expert comptable et fiscal, residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.
2) The address of the corporation is fixed at L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
3) The company will be validly committed towards third parties by the joint signatures of all the Category A managers
and one Category B manager.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le neuf décembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
QATAR ISLAMIC BANK, une société par action de droit qatari, enregistrée auprès du registre des sociétés de Qatar
sous le numéro 8338, avec siège social à P.O. Box 559, Doha, Qatar,
ici représenté par M. Fatah Boudjelida, consultant, avec adresse professionnelle à 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach,
en vertu d’une procuration donnée en décembre 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition de certains actifs immobiliers localisés en Turquie, dont l’acquisition sera
financée par des fonds propres et par l’émission d’obligations convertibles au profit de (s) l’associé (s).
La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être
convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination ALMEEZAN LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schüttrange).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
4817
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par deux cent cinquante
six (256) parts sociales de classe «A» et deux cent quarante-quatre (244) parts sociales de classe «B» d’une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à l’associé(s) à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en propor-
tion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est
admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique, en cas de pluralité de
gérants, la société sera valablement engagée par la signature conjointe de tous le gérants de catégorie A et la signature
d’un gérant de catégorie B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à l’approbation unanime (i) de
tous les gérants de catégorie A présents ou représentés, et (ii) le vote favorable d’au moins un gérant de catégorie B,
avec au mois la présence ou la représentation de tous les gérants de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises qu’avec l’accord unanime de 100% des associés de chaque classe
de parts sociales.
Les décisions relatives au fonctionnement, détention, développement et/ou vente, cession de l’un des actifs de la So-
ciété ne sont valablement prises qu’avec l’accord unanime de 100% des associés de chaque classe de parts sociales.
De plus, les résolutions modifiant ou amendant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés qu’avec l’accord
unanime de 100% des associés de chaque classe de parts sociales.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
4818
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
<i>Souscription - Libérationi>
Les deux cent cinquante-six (256) parts sociales de classe «A» et les deux cent quarante-quatre (244) parts sociales
de classe «B» d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune ont été souscrites par la QATAR ISLAMIC
BANK, préqualifiée, et ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le
reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
Gérants de Catégorie A:
- M. Ahmed Elsayad, General Manager, avec adresse professionnelle à P.O. Box 559, Doha, Qatar;
- M. Hassan Al Ammari, General Manager - CEO, demeurant à Dallah Tower - Palestine Street, P.O Box 6854 Jeddah
21452, Royaume d’Arabie Saoudite.
Gérant de Catégorie B:
- M. Marcel Stephany, expert comptable et fiscal, demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
3) La Société sera valablement engagée par la signature conjointe de tous le gérants de catégorie A et la signature
d’un gérant de catégorie B.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: F. Boudjelida.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, vol. 141S, fol. 69, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086317.3/211/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
CORBIGNY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.866.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2003i>
Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu’Administrateur.
Décharge lui est accordée jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05132. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001419.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
J. Elvinger.
<i>Pour la société
CORBIGNY INVESTISSEMENT S.A.
i>Signature
4819
HCEPP II LUXEMBOURG FINANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 97.608.
—
STATUTES
In the year two thousand three, on the twelfth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
HCEPP II LUXEMBOURG MASTER II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Mr Kim Kirsch, lawyer, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 11, 2003.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the
«Law»), as well as by the present articles of incorporation (the «Articles»), which specify in articles 7, 10, 11 and 14 the
exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The object of the Company is:
a. to borrow and/or lend moneys, act as surety or guarantor in any other manner, and bind itself jointly and severally
or otherwise in addition to or on behalf of others;
b. to incorporate, participate in, conduct the management of and take any other financial interest in other companies
and enterprises;
c. to render administrative, technical, financial, economic or managerial services to other companies, persons or en-
terprises;
d. to acquire, dispose of, manage and exploit real and personal property, including patents, marks, licenses, permits
and other industrial property rights,
the foregoing whether or not in collaboration with third parties and inclusive of the performance and promotion of
all activities which directly and indirectly relate to those objects, all this in the broadest sense of the terms.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name HCEPP II LUXEMBOURG FINANCE II, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) represented by five
thousand (5,000) shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the general
meeting of its shareholders, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law only.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders, in case of plurality of shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of any one manager.
4820
The manager, or in case of plurality of, managers, the board of managers may sub-delegate his/their powers for spe-
cific tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only valid taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of
plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-
first of December 2003.
<i>Subscription - Paymenti>
The five thousand (5,000) shares have been entirely subscribed by HCEPP II LUXEMBOURG MASTER II, S.à r.l., pre-
named.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of one hundred twenty-five thousand euro (EUR
125,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknow-
ledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand eight hundred euro.
<i>Resolutions of the shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Gordon Black, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL LLC, born in, Royal Oak, Michigan, U.S.A.,
on April 23, 1965, residing professionally at Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR, United Kingdom;
- Mr Christopher Nelson Merrill, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL LLC, born in Okinawa, Japan,
on May 28, 1971, residing professionally at 191 N. Wacker Drive, Suite 2500, Chicago, IL 60606, U.S.A.;
The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the sole signature of any one manager.
2) The address of the Company is fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
HCEPP LUXEMBOURG MASTER II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit du Grand-
Duché de Luxembourg,
4821
ici représenté par Monsieur Kim Kirsch, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 11 décembre 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d’une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société (les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société a pour objet:
a. d’emprunter et/ou de prêter des sommes d’argent, d’agir en tant que garant en toute autre occasion, et de s’enga-
ger conjointement et solidairement, ou autrement en supplément à ou pour le compte de tiers;
b. de créer, de participer à, de gérer et de prendre des intérêts financiers dans d’autres sociétés ou entreprises;
c. de rendre des services administratifs, techniques, financiers, économiques ou de gestion à d’autres sociétés, per-
sonnes ou entreprises;
d. d’acquérir, de céder, de gérer et d’exploiter des biens personnels et immobiliers, y compris des brevets, des mar-
ques, des licences, des permis et tout autre droit de propriété industrielle;
ce qui précède peut être effectué en collaboration ou non avec des tiers, et comprend l’exécution et la promotion
de toutes les activités directement ou indirectement y relatives, le étant compris dans le sens le plus large.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination HCEPP II LUXEMBOURG FINANCE II, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euro (EUR 125.000,-) représenté par cinq mille (5.000) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par décision de l’assemblée
générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre de parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application des dispositions de l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés en cas de pluralité des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société est engagée par la signature individuelle de l’un quelconque de ses gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
4822
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoires i>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2003.
<i>Souscription - Libérationi>
L’ensemble des cinq mille (5.000) parts sociales a été souscrit par HCEPP Il LUXEMBOURG MASTER II, S.à r.l., pré-
désignée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de cent
vingt-cinq mille euro (EUR 125.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille huit cents euro.
<i>Décision de l’associéi>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Gordon Black, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL, LLC, né à Royal Oak, Michigan,
U.S.A., le 23 avril 1965, demeurant professionnellement à Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR Royau-
me Uni;
- Monsieur Christopher Nelson Merrill, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL, LLC, né à Okinawa,
Japon, le 28 mai 1971, demeurant professionnellement à 191 N. Wacker Drive, Suite 2500, Chicago, IL 60606, U.S.A.
La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la signature individuelle de l’un quelcon-
que de ses gérants.
2) L’adresse de siège social est fixée à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont requis de documen-
ter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: K. Kirsch, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 décembre 2003, vol. 426, fol. 19, case 4. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086137.3/242/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
ASTERLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 59, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 73.418.
—
Les comptes de clôture au 30 novembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00326, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002120.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Mersch, le 19 décembre 2003.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
4823
NAVALE BALTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.124.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00176, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
(001893.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
NAVALE BALTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.124.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00156, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
(001897.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERLUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.065.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05961, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(001912.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERLUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.065.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05963, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(001914.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERLUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.065.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05966, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(001910.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
4824
LEVANA INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.777.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03790, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(001877.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LEVANA INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.777.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03789, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(001876.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LB1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.607.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04644, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2003.
(001880.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LB1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.607.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05945, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(001879.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
GTL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 74.143.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
décembre 2003, réf. LSO-AL00134, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002013.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signatures.
4825
REPRESENTATION PUBLIC CY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.221.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04653, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2003.
(001885.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
REPRESENTATION PUBLIC CY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.221.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04652, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2003.
(001883.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
W. BNK A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.460.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04631, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2003.
(001886.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
W. BNK A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.460.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05958, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(001882.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CORELLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.811.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06578, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
(001852.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
4826
HEDWIGE FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.761.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01250, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001990.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HEDWIGE FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.761.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 novembre 2003i>
<i>Quatrième résolution.i>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-
trange et lui donne pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.
L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comp-
table, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra
en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01252. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001993.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
NATALIA FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.509.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06573, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
(001847.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
BRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.718.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 27 mai 2003 à 10.00 heuresi>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Dhondt de son poste d’administrateur avec effet au 20 août
2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.
L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Michel Di Benedetto au poste d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06598. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001923.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HEDWIGE FINANCES S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
HEDWIGE FINANCES S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Deux Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour copie conforme
Signatures
4827
NATALIA FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.509.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 25 juin 2002 à 10.00 heuresi>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Luc Leroi de son poste d’administrateur avec effet le 31 janvier 2002
et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.
L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur François Derême au poste d’administrateur.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-
ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de un an.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06586. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001919.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
NATALIA FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.509.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 24 juin 2003 à 10.00 heuresi>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec effet le 20 dé-
cembre 2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.
L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Philippe de Castellane au poste d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06601. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001920.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PENNY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.535.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06536, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
(001856.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PENNY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.535.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 27 août 2002 à 10.00 heuresi>
L’assemblée accepte les démissions de Messieurs Luc Leroi et Patrick Dhondt de leur poste d’administrateur, respec-
tivement avec effet au 31 janvier 2002 et au 20 août 2002 et leur donne quitus pour leur gestion durant l’exercice des
mandats. L’assemblée ratifie les nominations de Messieurs François Dereme et Michel Di Benedetto aux postes d’admi-
nistrateurs.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-
ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de un an.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06590. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001917.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour copie conforme
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour copie conforme
Signatures
4828
VOLTERIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01260, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001996.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
VOLTERIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01258, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001995.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
SAINT EUGENE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.409.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00158, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
(001860.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ECOTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.186.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02690, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2003.
(001865.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FIGINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02685, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2003.
(001873.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
VOLTERIA HOLDING S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
VOLTERIA HOLDING S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
4829
FUMSECK PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.952.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01256, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001997.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FUMSECK PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.952.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 novembre 2003i>
<i>Quatrième résolution.i>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-
trange et lui donne pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.
L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comp-
table, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra
en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01254. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(001991.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
EL 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 79.600.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05953, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(001874.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
AMADEUS BETEILIGUNG A.G., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 79.153.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 28 février 2003 à 10.00 heuresi>
En conformité avec l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide
de continuer l’activité de la société malgré sa perte cumulée supérieure à son capital social.
L’assemblée accepte les démissions de Messieurs Patrick Dhondt et François Dereme aux postes d’administrateur,
respectivement avec effet au 20 août 2002 et au 20 décembre 2002 et donne quitus pour leur gestion durant l’exercice
de leur mandat. L’assemblée ratifie les nominations de Messieurs Michel Di Benedetto et Philippe de Castellane aux pos-
tes d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06580. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001925.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FUMSECK PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
FUMSECK PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Deux Administrateursi>
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour copie conforme
Signatures
4830
SIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 75.294.
Société constituée le 29 mars 2000 par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 octobre 2003i>
Tous les actionnaires sont présents.
<i>Démission - Nominationi>
DEXIA BANQUE BELGIQUE S.A., représentée par Didier Léon, remet sa démission comme administrateur.
Claude Jacqmin est nommé administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06918. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002023.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
SIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 75.294.
Société constituée le 29 mars 2000 par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 novembre 2003i>
Tous les actionnaires sont présents.
<i>Démission - Nominationi>
André Verguyse, remet sa démission comme administrateur.
Didier Léon est nommé administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06914. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002020.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LEÓN PARTICIPACIONES ARGENTINAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.192.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05970, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(001875.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
L.P.C. S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.250.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 28 mai 2002 à 9.00 heuresi>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Luc Leroi de son poste d’administrateur avec effet au 31 janvier 2002
et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.
L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur François Dereme au poste d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06585. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001922.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
L. Delbrassinne / C. Jacqmin
<i>Administrateur délégué / Administrateuri>
L. Delbrassinne / D. Léon
<i>Administrateur délégué / Administrateuri>
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Copie conforme
Signatures
4831
INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM DEVELOPMENT (I.R.B.S.D.) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.037.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, tel que arrêté par le Conseil d’Administration mais non approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire faute d’actionnaire présent ou représenté, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf.
LSO-AM00458, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002106.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM DEVELOPMENT (I.R.B.S.D.) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.037.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, tel que arrêté par le Conseil d’Administration mais non approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire faute d’actionnaire présent ou représenté, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf.
LSO-AM00454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002108.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM DEVELOPMENT (I.R.B.S.D.) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.037.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, tel que arrêté par le Conseil d’Administration mais non approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire faute d’actionnaire présent ou représenté, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf.
LSO-AM00451, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002110.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM DEVELOPMENT (I.R.B.S.D.) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.037.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, tel que arrêté par le Conseil d’Administration mais non approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire faute d’actionnaire présent ou représenté, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf.
LSO-AM00449, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002112.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
<i>Pour INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM DEVELOPMENT (I.R.B.S.D.) S.A.
i>SGG S.A.
I. Schul / J.-P. Reiland
<i>Pour INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM DEVELOPMENT (I.R.B.S.D.) S.A.
i>SGG S.A.
I. Schul / J.-P. Reiland
<i>Pour INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM DEVELOPMENT (I.R.B.S.D.) S.A.
i>SGG S.A.
I. Schul / J.-P. Reiland
<i>Pour INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM DEVELOPMENT (I.R.B.S.D.) S.A.
i>SGG S.A.
I. Schul / J.-P. Reiland
4832
LUX-TRI SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.
R. C. Luxembourg B 86.316.
—
Les comptes annuels au 30 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07259, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001284.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
JONES LANG LaSalle GROUP FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.061.
—
Il résulte des résolutions prises en date du 10 octobre 2003 que JONES LANG LaSalle GROUP FINANCE LUXEM-
BOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 35, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Frédéric Charpentier de Changry et Jacqueline Madeleine Dasoul ont été nommés comme gérants en rem-
placement de Keith Burman avec effet au 7 octobre 2003. Décharge a été accordée à Keith Burman pour l’exercice de
son mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001381.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
LUX-BOWLING, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 48.227.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04654, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001691.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
IMMOLINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 63.094.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2003 de la sociétéi>
Tous les actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:
L’assemblée décide de remplacer le mandat de commissaire aux comptes de Madame Lauer Andrée par la société
CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l. (R.C. B 50.577) avec siège social à L-4751 Pétange, 165A route
de Longwy et ce à dater du 10 septembre 2003. Son mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en l’an 2009.
La résolution a été prise à l’unanimité des voix.
Après cela l’assemblée extraordinaire est déclarée comme terminée.
Luxembourg, le 10 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06901. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002016.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
<i>Pour LUX-TRI SERVICES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour JONES LANG LaSalle GROUP FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
HLB FISOGEST S.A.
Signature
<i>Pour IMMOLINE INTERNATIONAL
i>Signatures
<i>Administrateursi>
4833
COMMERCE DU CARRELAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4974 Dippach, 1A, rue Centrale.
R. C. Luxembourg B 40.899.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04652, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001692.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ON AIR PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300D, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 43.545.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04651, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001693.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MERCAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.853.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05191, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001703.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.974.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05193, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001704.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
SIDE GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 96.369.
Société constituée le 14 octobre 2003 par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 20 novembre 2003i>
Tous les actionnaires sont présents.
<i>Nominationi>
Didier Léon est nommé administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06916. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002021.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HLB FISOGEST S.A.
Signature
HLB FISOGEST S.A.
Signature
Signature.
Signature.
L. Delbrassine / D. Léon
<i>Administrateur / Administrateuri>
4834
SABAREL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.408.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05194, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001706.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
SIGVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.010.
—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05195, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001709.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HORSE DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, tel que arrêté par le Conseil d’Administration mais non approuvé par l’Assemblée
Générale Statutaire faute d’actionnaire présent ou représenté, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-
AM00473, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002094.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HORSE DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, tel que arrêté par le Conseil d’Administration mais non approuvé par l’Assemblée
Générale Statutaire faute d’actionnaire présent ou représenté, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-
AM00469, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002095.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HORSE DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, tel que arrêté par le Conseil d’Administration mais non approuvé par l’Assemblée
Générale Statutaire faute d’actionnaire présent ou représenté, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-
AM00467, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002097.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
Signature.
<i>Pour HORSE DEVELOPMENT HOLDING S.A.
i>SGG S.A.
Signatures
<i>Pour HORSE DEVELOPMENT HOLDING S.A.
i>SGG S.A.
Signatures
<i>Pour HORSE DEVELOPMENT HOLDING S.A.
i>SGG S.A.
Signatures
4835
VITA PROMOTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8085 Bertrange, 46, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 62.930.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00494, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(001857.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
GEROMLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00498, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001859.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
KONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Z.I. route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 28.496.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00503, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2003.
(001861.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
SIPCAM FINANCIAL SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 90.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00294, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001894.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MAGASIN ET ENTREPRISE POULLIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4602 Niederkorn, 219, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 59.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00508, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001867.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
Luxembourg, le 25 décembre 2003.
Signatures.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
4836
INTERSTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 1, rue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 81.048.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00512, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2004.
(001863.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MEDIATEAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 40.571.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00506, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
(001866.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
J.F.B. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.019.
—
Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04656, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2003.
(001878.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MEDPART FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 150.000,- EUR.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 85.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00295, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001896.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CLIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04645, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2003.
(001881.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
4837
REALSTAR HEALTHCARE FINANCIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 80.000,- GBP.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.261.
—
Le bilan au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00289, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001884.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LOFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.229.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00290, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001887.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ROSCH BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.369.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03791, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(001888.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MEDPARTICIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 150.000,- EUR.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 85.018.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00297, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001899.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CORELLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.811.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 7 mai 2003 à 16.30 heuresi>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Dhondt de son poste d’administrateur avec effet au 20 août
2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat. L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur
Michel Di Benedetto au poste d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06602. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001928.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Signature.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature.
Pour copie conforme
Signatures
4838
REALSTAR HEALTHCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 2.000.000,- GBP.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.260.
—
Le bilan au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00291, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001889.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
TEXEUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.453.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04660, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2003.
(001890.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
DDM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.612.
—
Le bilan au 30 avril 2003, enregistré le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00292, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001891.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LINSTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.773.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00181, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
(001892.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
RIVER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 97.587.
—
Suite à la cession de parts intervenue en date du 25 novembre 2003 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOL-
DINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l. et CERBERUS PARTNERS L.P., les 130 parts sociales de la société sont entièrement
détenues par CERBERUS PARTNERS L.P.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00944. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001949.3/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Signature.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Signature.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
RIVER INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) SA
<i>Gérant
i>Signatures
4839
WILSON FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.380.
—
Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00150, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
(001895.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
B.P.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.675.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05942, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(001898.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
C.L.P.K. AIRCRAFT FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04593, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2003.
(001900.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MEDPART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 150.000,- EUR.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 85.085.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00299, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001901.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CHEMICAL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.610.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02696, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2003.
(001902.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
4840
SOGEHO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 69.904.
—
Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2002 et le rapport du réviseur d’entreprises y relatif, enregistrés à
Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00304, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001903.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ELNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00170, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
(001904.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ALMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02693, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2003.
(001908.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
VEGA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 95.340.
—
Suite à la cession de parts intervenue en date du 22 octobre 2003 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS
(LUXEMBOURG), S.à r.l. et CERBERUS INTERNATIONAL LTD, les 125 parts sociales de la Société sont entièrement
détenues par CERBERUS INTERNATIONAL LTD.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00946. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001952.3/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ALIVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 65.455.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00307, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002090.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Signatures.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>VEGA INVESTMENTS, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) SA
<i>Gérant
i>Signatures
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
4841
EUROMUTUEL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 34.148.
—
Le rapport annuel au 30 septembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-
bourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM0617, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001982.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HYSOPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 64.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01181, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001988.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HELER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 58.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01262, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001994.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
REGISA, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 83.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00776, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002005.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
IMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 26, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 13.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05239, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2003.
(002037.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 29 décembre 2004.
Signature.
HYSOPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
HELER S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
Signature
<i>Mandatairei>
4842
NEW RUBECCAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 85.557.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 9 décembre 2003, que:
- Le siège social de la société a été transféré de L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl à L-1840 Luxembourg, 39,
boulevard Joseph II, avec effet immédiat;
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07244. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002051.3/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 85.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07077, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2003.
(002061.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CAPITAL DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.725.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07073, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002063.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LANCO, Société Civile Particulière.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
—
a) En date du 17 novembre 2003, les associés ont décidé:
1) d’agréer la cession par Monsieur Colin Holland d’une part de la Société à Mademoiselle Véronique Lange;
2) de constater la conversion du capital au 1
er
janvier 2002 en
€ 2.478,9352;
3) d’augmenter le capital converti à concurrence de
€ 21,0648 pour le porter de € 2.478,9352 à € 2.500,- par prélè-
vement de
€ 21,0648 sur les comptes courants des associés et sans émission de parts nouvelles;
4) de modifier le 1
er
alinéa de l’article 6 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à
€ 2.500,- (deux mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent) parts sociales sans dé-
signation de valeur nominale entièrement libérées en espèces et attribuées comme suit:»
b) En date du 18 novembre 2003 et à la suite de la cession d’une part de la Société, dûment acceptée par la Société
conformément à l’article 1690 du code civil, les associés ont décidé de modifier comme suit l’article 6 des statuts:
«Le capital social est fixé à
€ 2.500,- (deux mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent) parts sociales sans dé-
signation de valeur nominale entièrement libérées en espèces et attribuées comme suit:
Pour la société
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour la société
Signature
Pour la société
Signature
1. Monsieur Guy F. Lange, conseiller fiscal, né le 12 août 1941 à Ixelles, Belgique, demeurant
à L-1420 Luxembourg,158,avenue Gaston Diderich, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales. . . . . .
99 parts sociales
2. Mademoiselle Véronique Lange, employée privée, née le 29 janvier 1969 à Uccle, Belgique,
demeurant à L-1420 Luxembourg, 158, avenue Gaston Diderich, une part sociale. . . . . . . . . . .
1 part sociale
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts sociales
4843
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05664. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001342.3/528/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
RZ ARCHITECTURE INT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.185.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07071, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002067.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.345.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04636, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2003.
(002074.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
GOST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.589.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00465, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002100.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 50.172.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00463, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002103.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LANCO, Société civile particulière
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
CLMS (LUXEMBOURG) SA
Signature
GOST S.A.
P. Dermitzel / O. Starvaggi
<i>Administrateur / Administrateuri>
GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
4844
ALISON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.756.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00460, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002104.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FLANDERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.684.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00444, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002114.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 13.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00442, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002116.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
SIGVAL VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 73.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05196, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001713.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FITINFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 80.273.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07102, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001643.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ALISON INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
FLANDERS INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
BERYTE HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
4845
SOFIRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.290.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05197, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001715.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
THOBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.878.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05194, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001719.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
TRENUBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05200, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001722.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
VENEZIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.290.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05201, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001724.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
UNION INTERNATIONAL CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7515 Mersch, 5, rue Comte d’Autel.
R. C. Luxembourg B 38.231.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07125, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001648.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1989 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06660, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
4846
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001488.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1990 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06658, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001490.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1991 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06656, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001494.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1992 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06652, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001497.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06645, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001499.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
4847
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06642, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001502.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06638, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001505.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06635, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001506.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06633, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001507.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06632, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
4848
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001510.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06628, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001511.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06626, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001512.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06623, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001515.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OVERLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 32.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06620, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001516.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Société Intercontinentale de Négoce S.A.
Becrolux S.A.
Labris Holding S.A.
ABF Hyde Park Investments & Co SNC
Honeycomb Technologies S.A.
Almeezan Luxembourg, S.à r.l.
Corbigny Investissement S.A.
HCEPP II Luxembourg Finance II, S.à r.l.
Asterlux Holding S.A.
Navale Baltique S.A.
Navale Baltique S.A.
Interlux Holding S.A.H.
Interlux Holding S.A.H.
Interlux Holding S.A.H.
Levana Informatique S.A.
Levana Informatique S.A.
LB1 S.A.
LB1 S.A.
GTL S.A.
Representation Public CY S.A.
Representation Public CY S.A.
W. BNK A.G.
W. BNK A.G.
Corellia S.A.
Hedwige Finances S.A.
Hedwige Finances S.A.
Natalia Fin S.A.
Bress S.A.
Natalia Fin S.A.
Natalia Fin S.A.
Penny International S.A.
Penny International S.A.
Volteria Holding S.A.
Volteria Holding S.A.
Saint Eugène S.A.
Ecotrade S.A.
Figinvest S.A.
Fumseck Participations S.A.
Fumseck Participations S.A.
EL 2 S.A.
Amadeus Beteiligung A.G.
Side International S.A.
Side International S.A.
León Participaciones Argentinas S.A.
L.P.C. S.A.
International Racing Betting System Development (I.R.B.S.D.) S.A.
International Racing Betting System Development (I.R.B.S.D.) S.A.
International Racing Betting System Development (I.R.B.S.D.) S.A.
International Racing Betting System Development (I.R.B.S.D.) S.A.
Lux Tri-Services, S.à r.l.
Jones Lang LaSalle Group Finance Luxembourg, S.à r.l.
Lux-Bowling, GmbH
Immoline International S.A.
Commerce du Carrelage, S.à r.l.
On Air Productions, S.à r.l.
Mercan Holding S.A.
Polifontaine S.A.
Side Group S.A.
Sabarel Holding S.A.
Sigval Holding S.A.
Horse Development Holding S.A.
Horse Development Holding S.A.
Horse Development Holding S.A.
Vita Promotion S.A.
Geromlux, S.à r.l.
Kone Luxembourg, S.à r.l.
Sipcam Financial Service S.A.
Magasin et Entreprise Poullig, S.à r.l.
Interstel, S.à r.l.
Mediateam S.A.
J.F.B. Investissements S.A.
Medpart Finance, S.à r.l.
Climmolux S.A.
Realstar Healthcare Financial, S.à r.l.
Loffice, S.à r.l.
Rosch Beteiligung S.A.
Medparticip, S.à r.l.
Corellia S.A.
Realstar Healthcare, S.à r.l.
Texeurope S.A.
DDM Luxembourg S.A.
Linston Holding S.A.
River Investments, S.à r.l.
Wilson Finance S.A.
B.P.H. Finance S.A.
C.L.P.K. Aircraft Funding, S.à r.l.
Medpart, S.à r.l.
Chemical Overseas S.A.
Sogeho International S.A.
Elna S.A.
Alma S.A.
Vega Investments, S.à r.l.
Aliva, S.à r.l.
Euromutuel Sicav
Hysope Investment S.A.
Heler S.A.
Regisa
Imedia, S.à r.l.
New Rubeccan S.A.
Fiduciaire Vincent La Mendola, S.à r.l.
Capital Developments S.A.
Lanco
RZ Architecture Int, S.à r.l.
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A.
Gost S.A.
Galerie Commerciale de Kirchberg S.A.
Alison Investments S.A.
Flanders International S.A.
Beryte Holding S.A.
Sigval Venture S.A.
Fitinfinance S.A.
Sofires S.A.
Thobe S.A.
Trenubel S.A.
Venezia Finance S.A.
Union International Consulting, S.à r.l.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.
Overlease Luxembourg S.A.