logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

6769

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 142

23 février 2001

S O M M A I R E

A.R.S. Groupe S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6812

Laser2000 S.A., Useldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6808

AF International S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . .

6810

Linisi, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . . . . . . . . . 

6810

Akhesa S.A., Kautenbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6812

Louvre-Bau, S.à r.l., Bad-Mondorf. . . . . . . . . . . . . . 

6778

Amguil S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6808

Loyola Financière S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . 

6770

APSI, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6808

Luxpo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6770

Arbo Property Services S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . .

6811

Luxpo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6771

Aton Holding S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6811

M.H.D. Group S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6814

Auberge Campagnarde, S.à r.l., Winseler . . . . . . . .

6816

M.H.D. Group S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6814

Auval - Lux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6808

M.H.D. Group S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6815

Bauma - Lux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6808

Menuiserie  Bodson,  S.à r.l.,  Schlindermander- 

Bonacci S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6780

scheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6814

Bonte, S.à r.l., Nocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6811

Mondo Luxembourg S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . 

6771

Consultive Co S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6813

Motorhomes Center, S.à r.l., Saeul  . . . . . . . . . . . . 

6816

D.W.L. Exploitation S.A., Esch-sur-Sûre . . . . . . . . .

6813

Multihold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6772

D.W.L. Holding S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6813

New Lecta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6773

D.W.L. Immobilière S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .

6813

New Lecta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6773

Dieschbourg et Fils, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . .

6809

New Lecta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6774

Dinva, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6812

Nina, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6782

Dutch Catering, S.à r.l., Vianden  . . . . . . . . . . . . . . .

6811

Omni Technology, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . 

6773

E-Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6813

Pantalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6775

Electricité Fautsch, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . .

6812

Papier ’97 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6776

Encolux, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6816

Perot  Systems  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Ets. Kaiser, S.à r.l., Pratz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6816

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6774

Euroestate AG, Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . .

6815

Proxima Capital Investment S.A.H., Luxembourg

6776

Euroestate AG, Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . .

6815

Reidener Spennchen S.A., Redange-sur-Attert . . . 

6814

Euroestate AG, Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . .

6815

Reisdorff Invest S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . 

6809

Euroestate AG, Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . .

6815

Ronor S.A., Nothum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6807

European Consultancy Services Industries, S.à r.l., 

S.C.I. Mon Rêve, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

6772

Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6814

SEIF,  Société  Européenne  d’Investissement  Fi- 

European Energy Development S.A., Wiltz  . . . . . .

6810

nancier S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6778

Ewerhardt Spedition, G.m.b.H., Echternach . . . . . .

6809

Société Financière UCB S.A., Luxembourg. . . . . . 

6778

Garage Besenius, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . .

6811

Société Financière UCB S.A., Luxembourg. . . . . . 

6780

Hydro 50 Management, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . .

6812

Techno Project, G.m.b.H., Luxemburg  . . . . . . . . . 

6775

I.V.B., S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6816

USR International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

6781

I.W.O. Holding S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . .

6783

V.L.G. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

6781

Immobilière Spielmann + Van Dyck,  S.à r.l., Ettel- 

V.L.G. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

6781

bruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6810

Wanmaiden S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

6782

LaSalle European Property Securities, Sicav, Lu- 

Weroco, S.à r.l., Steinheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6809

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6786

6770

LOYOLA FINANCIERE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 août 2000,

enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, volume 6CS, folio 37, case 5, que la société LOYOLA FINANCIERE S.A.
HOLDING a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la so-
ciété prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant
achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50513/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

LUXPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 58.573. 

L’an deux mille, le premier septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXPO S.A., ayant son siège

social à L-7433 Grevenknapp, Maison 18, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B
sous le numéro 58.573, constituée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date
du 11 mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 347 du 3 juillet 1997, et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 6 septembre 1999, publié au Mémorial C, numéro
907 du 30 novembre 1999, avec un capital social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), divisé
en cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Chantal Weber, secrétaire, demeurant à Ettelbruck.
Madame la présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-7433 Grevenknapp, Maison 18, à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse. 
2.- Modification afférente de l’article premier des statuts. 
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-7433 Grevenknapp, Maison 18, à L-2320

Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article deux (2) des
statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée délègue à Madame Ana-Cristina Da Cunha Mendes, gérante de la succursale au Portugal, le pouvoir d’en-

gager la société par sa seule signature pour l’achat d’un fond de commerce, avec ou sans immeuble, dans le secteur de
l’hôtellerie au Portugal. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg, le 12 septembre 2000.

6771

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Weber, C. Dostert, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2000, vol. 511, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50517/231/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

LUXPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 58.573. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50518/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

MONDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3985 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 16.619. 

L’an deux mille, le huit septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

A comparu:

Monsieur Paul Donven, directeur administratif, demeurant à Wahl,
agissant pour compte de la société anonyme MONDO LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-3985 Foetz, rue de

l’industrie.

Le comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations:
Que la société anonyme MONDO LUXEMBOURG S.A. a été constituée originairement sous le dénomination de

WORLD RUBBER S.A. suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 20
mars 1979, publié au Mémorial C, numéro 151 du 6 juillet 1979, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises
et dernièrement suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 octobre 1998, publié au Mémorial C, nu-
méro 910 du 16 décembre 1998.

Le capital social souscrit de ladite société a été fixé à trois cents millions de francs luxembourgeois (LUF

300.000.000,-), représenté par trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune.

- Lors d’une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MONDO LUXEMBOURG, prédésignée, do-

cumentée par acte de Maître Aloyse Biel, notaire, alors de résidence à Differdange, en date du 19 décembre 1994, publié
au Mémorial C, numéro 178 du 19 avril 1995, le capital social de la société a été augmenté d’un montant de soixante-
quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 75.000.000,-) par la création et l’émission de soixante-quinze mille
(75.000) actions entièrement souscrites mais seulement libérées à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent).

En date du 7 septembre 2000, ces mêmes actions ont été libérées en numéraire par l’actionnaire, à concurrence de

soixante-quinze pour cent (75%), soit d’un montant de cinquante-six millions deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 56.250.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par des pièces justificatives de libéra-
tion.

Le comparant déclare en outre, que suite à cette libération supplémentaire, les soixante-quinze mille (75.000) actions

d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune et représentant l’intégralité de la prédite
augmentation de capital du 19 décembre 1994, sont dorénavant entièrement libérées et peuvent être converties le cas
échéant en actions au porteur. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Foetz, rue de l’industrie, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: P. Donven, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 2000, vol. 862, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(50543/272/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Junglinster, le 18 septembre 2000.

J. Seckler.

Junglinster, le 18 septembre 2000.

J. Seckler.

Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2000.

B. Moutrier.

6772

S.C.I. MON RÊVE, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

Répartition des parts sociales de la S.C.I. MON RÊVE, dont l’acte constitutif a été fait le 13 juillet 1998, après cession

de part sociale.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50544/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

MULTIHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 30.801. 

L’an deux mille, le vingt-quatre août. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULTIHOLD S.A., avec siège social à

L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 31 mai 1989,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 302 du 23 octobre 1989 et inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 30.801.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui dési-

gne comme secrétaire, Maître Marc Bodelet, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation
2) Nomination d’un liquidateur de la société 
3) Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’Assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Seconde résolution

Est nommée liquidateur, la société anonyme INFIGEST S.A., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg,

21-25, allée Scheffer. 

<i>Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-

ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous

ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Goebel, M. Bodelet, P. Morales, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 125S, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50545/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Monique Weis, 11, place St. Pierre et Paul, L-2334 Luxembourg (nommée gérante), quatre-vingt-quinze parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Josy Schmitz, 11, place St. Pierre et Paul, L-2334 Luxembourg, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 19 septembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 12 septembre 2000.

J. Elvinger.

6773

NEW LECTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.198. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 8, case 9, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(50555/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

NEW LECTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.198. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 8, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(50556/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

OMNI TECHNOLOGY, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 54.273. 

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend, den ersten September. 
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster. 

Sind erschienen:

1.- Herr Dariusz Sanojca, Geschäftsmann, wohnhaft in PL-58377 Dobromierz (Polen); 
2.- Herr Pawel Suchonski, Geschäftsmann, wohnhaft in PL-53407 Wroczaw (Polen); 
beide hier vertreten durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BUREAU EUROPEEN DE COMPTABILITE ET

DE FISCALITE, S.à r.l., in Abkürzung BECOFIS, S.à r.l., mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, 

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Edgar Bisenius, Finanzberater, wohnhaft in L-1330 Luxemburg, 4A,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg, am 11. Mai 2000. 
Welche Vollmacht, von dem Bevollmächtigtem und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden. 

Welche Komparenten, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden: 
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung OMNI TECHNOLOGY, G.m.b.H., mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 45, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, R. C. Luxemburg B Nummer 54.273, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenom-
men durch den in Niederanven residierenden Notar Paul Bettingen, am 15. März 1996; veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 285 vom 11. Juni 1996, mit einem Gesellschaftskapital von fünfundzwanzigtausend Deutsche Mark (25.000,-
DEM), aufgeteilt in hundert (100) Anteile von jeweils zweihundertfünfzig Deutsche Mark (250,- DEM). 

Die Komparenten sub 1.- und 2.- sind alleinige Eigentümer aller Anteile vorgenannter Gesellschaft OMNI TECHNO-

LOGY, G.m.b.H. und beschliessen im gemeinsamen Einverständnis diese Gesellschaft mit sofortiger Wirkung den Rech-
ten der Parteien entsprechend aufzulösen; ein jeder übernimmt die Aktiva und Passiva der Gesellschaft im Verhältnis zu
der Zahl seiner Anteile an der aufgelösten Gesellschaft. 

Daraus ergibt sich dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung OMNI TECHNOLOGY, G.m.b.H., mit Wirkung

vom heutigen Tage an, definitiv aufgelöst ist und dass die Liquidation abgeschlossen ist. 

Luxembourg, le 19 septembre 2000.

<i>Pour NEW LECTA S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire 
Signatures

Luxembourg, le 19 septembre 2000.

<i>Pour NEW LECTA S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire 
Signatures

6774

Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft mit beschränkter Haftung OMNI TECHNOLOGY, G.m.b.H., wer-

den während mindestens fünf Jahren in L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aufbewahrt. 

Dem Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.
Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft. 
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. Bisenius, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2000, vol. 511, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50559/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

NEW LECTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.198. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 12 juillet 2000

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:

<i>Conseil d’administration

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG S.A. 13, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1353 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50557/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 69.893. 

Il résulte de la décision du gérant de la société PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., du 21 août 2000, la

résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50568/683/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Junglinster, den 18. September 2000.

J. Seckler.

MM. Bruce Hardy McLain, demeurant à Londres (Grande-Bretagne), président;

Andrea Minguzzi, demeurant à Bruxelles (Belgique), administrateur;
Ronald Leonard Singer, demeurant à Paris (France), administrateur.

<i>Pour NEW LECTA S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i> Pour PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

6775

PANTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.225. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 septembre 2000

Il résulte du conseil d’administration du 13 septembre 2000 que:
La démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet

au 1

er

 octobre 2000.

Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus a été nommé administrateur de

la société, et ceci avec effet au 1

er

 octobre 2000.

La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant

pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée générale des Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50562/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

TECHNO PROJECT, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1628 Luxemburg, 40, rue des Glacis.

H. R. Luxemburg B 68.215. 

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend, den ersten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Sind erschienen:

1.- Herr Dariusz Sanojca, Geschäftsmann, wohnhaft in PL-58377 Dobromierz (Polen);
2.- Herr Pawel Suchonski, Geschäftsmann, wohnhaft in PL-53407 Wroclaw (Polen);
Beide hier vertreten durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BUREAU EUROPEEN DE COMPTABILITE ET

DE FISCALITE, S.à r.l., in Abkürzung BECOFIS, S.à r.l., mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Edgar Bisenius, Finanzberater, wohnhaft in L-1330 Luxemburg, 4A,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegegeben in Luxemburg, am 11. Mai 2000.
Welche Vollmacht, von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung TECHNO PROJECT, G.m.b.H., mit Sitz in L-1628 Luxemburg, 40, rue des

Glacis, H. R. Luxemburg B Nummer 68.215, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Niederanven
residierenden Notar Paul Bettingen, am 22. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 262 vom 15. April
1999, mit einem Gesellschaftskapital von fünfundzwanzigtausend Deutsche Mark (25.000,- DEM), aufgeteilt in hundert
(100) Anteile von jeweils zweihundertfünfzig Deutsche Mark (250,- DEM).

Die Komparenten sub 1.- und 2.- sind alleinige Eigentümer aller Anteile vorgenannter Gesellschaft TECHNO PRO-

JECT, G.m.b.H., und beschliessen im gemeinsamen Einverständnis diese Gesellschaft mit sofortiger Wirkung den Rech-
ten der Parteien entsprechend aufzulösen; ein jeder übernimmt die Aktiva und Passiva der Gesellschaft im Verhältnis zu
der Zahl seiner Anteile an der aufgelösten Gesellschaft.

Daraus ergibt sich, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung TECHNO PROJECT, G.m.b.H., mit Wirkung vom

heutigen Tage an definitiv aufgelöst ist und dass die Liquidation abgeschlossen ist.

Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft mit beschränkter Haftung TECHNO PROJECT, G.m.b.H., werden

während mindestens fünf Jahren in L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aufbewahrt.

Dem Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.
Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnwort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. Bisenius, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2000, vol. 511, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50610/231/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

Pour extrait conforme
Signature

Junglinster, den 18. September 2000.

J. Seckler.

6776

PAPIER ’97 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.592. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 8, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(50563/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

PROXIMA CAPITAL INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.214. 

L’an deux mille, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PROXIMA CAPITAL

INVESTMENT, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B
numéro 77.214, constituée suivant acte reçu le 7 août 2000, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Cardi, juriste, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant à B-Messancy.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 3.100 (trois mille cent) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 5.102.830,- (cinq millions cent deux mille huit

cent trente Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 5.133.830,-
(cinq millions cent trente-trois mille huit cent trente Euros) par l’émission de 510.283 (cinq cent dix mille deux cent
quatre-vingt-trois) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, ayant les mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

2.- Souscription des 510.283 (cinq cent dix mille deux cent quatre-vingt-trois) nouvelles actions par Grzegorz Piotr

Dzik, par apport de 384.699 (trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de MULTINET
S.A., une société anonyme de droit polonais, ayant son siège social à Wroclaw.

3.- Modification afférente de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise

«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 5,133,830.- (five million one hundred and thirty-three thou-

sand eight hundred and thirty euros) divided into 513,383 (five hundred and thirteen thousand three hundred and eighty-
three) shares with a par Value of EUR 10.- (ten euros) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at EUR 15,000,000.- (fifteen million euros) to be

divided into 1,500,000 (one million five hundred thousand) shares with a par value of EUR 10.- (ten euros) each.».

Version française

«Le capital souscrit est fixé à EUR 5.133.830,- (cinq millions cent trente-trois mille huit cent trente Euros), représenté

par 513.383 (cinq cent treize mille trois cent quatre-vingt-trois) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, dans les limites tracées par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé, pendant la durée telle que prévue ci-après, à EUR 15.000.000,- (quinze millions d’Euros),

représenté par 1.500.000 (un million cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 19 septembre 2000.

<i>Pour PAPIER ’97 S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire 
Signatures

6777

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 5.102.830,- (cinq millions cent deux mille huit

cent trente Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 5.133.830,-
(cinq millions cent trente-trois mille huit cent trente Euros), par l’émission de 510.283 (cinq cent dix mille deux cent
quatre-vingt-trois) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, bénéficiant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 510.283 (cinq cent dix mille deux cent quatre-vingt-trois) actions

nouvelles, l’actionnaire majoritaire:

Monsieur Grzegorz Piotr Dzik, ingénieur, demeurant à Wroclaw, Pologne.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ici intervient Monsieur Grzegorz Piotr Dzik, prénommé, ici représenté par Monsieur Guy Hornick, prénommé;
en vertu d’une des procurations, dont question ci-avant;
lequel déclare et reconnaît que chacune des actions souscrites a été intégralement libérée comme suit:
par un apport en nature d’actions, comme suit:
384.699 (trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la société anonyme de droit

polonais MULTINET S.A., ayant son siège social à Wroclaw (Pologne).

<i>Rapport du réviseur

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait

l’objet d’un rapport en date du 25 août 2000 établi par le Réviseur d’Entreprises indépendant MONTBRUN REVISION,
S.à r.l., représentée par Monsieur Marc Lamesch, qui conclut comme suit:

Conclusion:
«On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of Valuation adopted

by the Board of Directors of PROXIMA CAPITAL INVESTMENT S.A. in relation to the contribution in kind results in
a value which corresponds at least in number and par value to the 510,283 shares of par value EUR 10.- each to be
issued, totalizing EUR 5,102,830. -.

Luxembourg, 25th August 2000.
MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
Un gérant
Signé: Marc Lamesch
Réviseur d’Entreprises.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de la société de EUR 310.000,- (trois cent dix mille Euros) à EUR

15.000.000,- (quinze millions d’Euros), représenté par 1.500.000 (un million cinq cent mille) actions d’une valeur nomi-
nale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les pre-

mier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Version anglaise

«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 5,133,830.- (five million one hundred and thirty-three thou-

sand eight hundred and thirty euros) divided into 513,383 (five hundred and thirteen thousand three hundred and eighty-
three) shares with a par value of EUR 10.- (ten euros) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at EUR 15,000,000.- (fifteen million euros) to be

divided into 1,500,000 (one million five hundred thousand) shares with a par value of EUR 10.- (ten euros) each.».

Version française

«Le capital souscrit est fixé à EUR 5.133.830,- (cinq millions cent trente-trois mille huit cent trente Euros), représenté

par 513.383 (cinq cent treize mille trois cent quatre-vingt-trois) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, dans les limites tracées par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé, pendant la durée telle que prévue ci-après, à EUR 15.000.000,- (quinze millions d’Euros),

représenté par 1.500.000 (un million cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ deux millions deux cent vingt-
deux mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

6778

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Hornick, J. Cardi, P. Ponsard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2000, vol. 125S, fol. 66, case 11. – Reçu 2.058.477 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50576/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

SEIF, SOCIETE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 45.000. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 2 mars 2000 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du franc luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 1999.

Le capital social a également été augmenté à concurrence de EUR 631,95, pour le porter à EUR 75.000,00 par incor-

poration des résultats reportés, sans émission d’actions nouvelles, et est à présent représenté par 3.000 actions d’une
valeur nominale de EUR 25,00 chacune.

- L’article 5, alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50587/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

SOCIETE FINANCIERE UCB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.500. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 94, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2000. 

(50599/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

LOUVRE-BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den elften September.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1.- Herr Michele Gilberto Orciari, Ingenieur, wohnhaft in L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains;
2.- Herr Raymund Lukas, Maurermeister, wohnhaft in D-66706 Perl/Hellendorf, Efter Strasse 20.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Statuten einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung LOUVRE-BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bad-Mondorf.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Luxembourg, le 12 septembre 2000.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 18 septembre 2000.

Pour extrait conforme
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

6779

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu

kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-

kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Bauunternehmens.
Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammen-

hang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (LUF 5.000,-).

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet von: 

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger Fran-

ken (LUF 500.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember des Jahres 2000.

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.

Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse, die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden Ge-

setze vom 10. August 1915 und 18. September 1933.

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-

sen, werden auf ungefähr zweiunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 32.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodarin vereinigten sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Zum technischen und administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt, Herr

Raymund Lukas, vorgenannt.

2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des Geschäftsführers und des

zweiten Gesellschafters.

3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Orciari, R. Lukas, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 125S, fol. 71, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

(50646/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

1.- Herrn Michele Gilberto Orciari, Ingenieur, wohnhaft in L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains, fünfzig An-

teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Herrn Raymund Lukas, Maurermeister, wohnhaft in D-66706 Perl/Hellendorf, Efter Strasse 20, fünfzig Anteile

50

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxemburg-Bonneweg, den 19. September 2000.

T. Metzler.

6780

SOCIETE FINANCIERE UCB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.500. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 juin 2000

Le mandat de Commissaire de MAZARS &amp; GUERARD venant à échéance à l’issue de l’Assemblée, l’Assemblée décide

de ne pas renouveler leur mandat. L’Assemblée décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire la société ABAX,
S.à r.l. pour un terme de trois ans.

Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50600/550/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

BONACCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck II.

L’an deux mille, le cinq septembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BONACCI S.A. avec siège

social à L-3378 Livange, Zone Commerciale, route de Bettembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 15 avril 1994, publié au Mémorial C, numéro 335 du 13 septembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 janvier 1998, publié au Mémorial C, numéro 304 du 4 mai 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Bonacci, délégué commercial, demeurant à F-

57100 Thionville-Garche, 7, rue Meilbourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Natale Bonacci, carreleur, demeurant à F-57310 Bertrange, 12 rue

St Nicolas.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-3378 Livange, Zone Commerciale, route de Bettembourg à L-3225 Bettembourg, Zone

Industrielle Scheleck II, et modification subséquente du premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-3378 Livange, Zone Commerciale, route de Bettembourg à

L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck Il.

Suite à cette résolution, le premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Bettembourg.». 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: D. Bonacci, D. Braune, N. Bonacci, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 6 septembre 2000, vol. 419, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50691/236/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

Luxembourg, le 12 septembre 2000.

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Bascharage, le 15 septembre 2000.

A. Weber.

6781

USR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.933. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société USR INTERNATIONAL S.A., du 25 août 2000, que

les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société: 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg.
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50619/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

V.L.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.974. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50627/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

V.L.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.974. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 20 juillet 2000

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:

<i>Composition du conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50628/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

<i>Pour USR INTERNATIONAL S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signature

Luxembourg, le 19 septembre 2000.

<i>Pour V.L.G. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

MM. Ottorino La Rocca, entrepreneur, demeurant à Paglieta, président;

Guiseppe Natale, entrepreneur, demeurant à Atessa, administrateur;
Leonardo Valenti, conseil fiscal, demeurant à Silvi Marina, administrateur.

Pour extrait conforme
<i>Pour V.L.G. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

6782

WANMAIDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 23.789. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de WANMAIDEN S.A., («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50630/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.

NINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

L’an deux mille, le onze septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société de droit des Iles Vierges Britanniques, dénommée EXPANSION PROJECT LTD, avec siège social à Tortola
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tortola, n° 371815
ici représentée par Monsieur Jean Reicherts, employé privé, demeurant à Luxembourg, 2A, place de Paris;
agissant en qualité de «Directors» de la prédite société et déclarant sous son unique responsabilité pouvoir engager

la prédite société, sous sa seule signature.

Laquelle comparante déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxem-

bourgeois, à ces fins, arrête le projet des statuts suivants:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de NINA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une sandwicherie avec débit de boissons non alccolisées et l’achat et

la vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’ex-
tension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs représenté par cinq cents parts sociales (500), de

mille francs (1.000,-), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

L’associée reconnaît que le capital de cinq cent mille (500.000,-) francs a été intégralement libéré par un versement

en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers sont subordonnées à l’agrément des associés représentant

au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre

pour déterminer la valeur des parts.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

la prédite société dénommée EXPANSION PROJECT LTD, cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

6783

Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de

décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-

texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légale régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement l’associée de la société à responsabilité limitée NINA, S.à r.l. ci-constituée, et représentant l’intégralité

du capital social, réunie en assemblée générale, a pris les décisions suivantes:

Est nommée gérante technique et administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Fatima Gouzoul, commerçante, demeurant à L-1221 Luxembourg, 135, rue de Beggen.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
L’adresse du siège social de la société est établie à L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Reicherts, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2000, vol. 862, fol. 57, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(50647/224/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

I.W.O. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9065 Ettelbruck, 27, rue Abbé Henri Müller.

STATUTS

L’an deux mille, le onze août 2000.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

 - Monsieur Anton Giesers, employé privé, époux de Madame Christel Theisen, demeurant à L-9065 Ettelbruck, 27,

rue Abbé Henri Müller,

- Madame Christel Theisen, ingénieur-diplômé, prénommée,
ici représentée par son époux Anton Giesers, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé en date de ce

jour, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui;

- Monsieur Osman Elibol, commerçant, demeurant à TR-16070 Çekirge/Bursa (TR), Selvili Cad. Bintas Evleri A Blok

no 45/,

- Monsieur Ismail Gürdere, commerçant, demeurant à TR-34850 Bahçesehir, Istanbul (TR), Akasya DI-7, no 14;
Monsieur Osman Elibol et Monsieur Ismail Gürdere, prénommés, sont ici représentés par Monsieur Vincent Isitmez,

Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Madame Christel Theisen, prénommée est ici représentée par Monsieur Anton Giesers, pénommé, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

Les trois procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et les comparants resteront annexées aux

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’ils suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituter entre eux.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de I.W.O. HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à L-9065 Ettelbrück, 27, rue Abbé Henri Müller.

Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2000.

N. Muller.

6784

II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’ad-

ministration.

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet: 
- la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces. 

- l’acquisition et la mise en valeur de biens, la gestion immobilière et mobilière.
Elle peut également faire toutes opérations qui se rapportent à son objet social et qui en facilitent la réalisation.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro.
II est divisé en mille actions d’une valeur nominale de trente et un (31) Euro chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.

Modifications du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-

pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales. 

Conseil d’administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive. 

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée-gé-

nérale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre prochain.

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de novembre à 17.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux
mille et un.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

6785

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante 

Les actions ont été libérées entièrement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un

mille (31.000,-) Euro se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.

Pour les besoins du fisc, le capital social de trente et un mille (31.000,-) Euro correspond à un million deux cent cin-

quante mille cinq cent trente-sept (1.250.537,-) francs.

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille
(50.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
Monsieur Anton Giesers, prénommé;
- Monsieur Osman Elibol, prénommé; 
- Monsieur Ismail Gürdere, prénommé.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Cornelio Memola, comptable, demeurant à L-9134 Schieren, 3, rue des Vergers.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2005.

5) Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Osman Elibol, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: A. Giesers, Isitmez, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 16 août 2000, vol. 603, fol. 78, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(92431/234/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

- Monsieur Anton Giesers, prénommé, deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

- Madame Christel Theisen, prénommée, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

- Monsieur Osman Elibol, prénommé, trois cent soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375

- Monsieur Ismail Gürdere, prénommé, trois cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  375
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Diekirch, le 19 septembre 2000.

F. Unsen.

6786

LaSALLE EUROPEAN PROPERTY SECURITIES, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

STATUTES

In the year two thousand one, on the eighteenth of January. 
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) LaSALLE INVESTMENT MANAGEMENT SECURITIES B.V., with its registered office at Herengracht 471, NL-1017

BS Amsterdam, represented by Me Rudi Dickhoff, avocat residing in L-8010 Strassen, by virtue of a proxy given in Am-
sterdam on 15 December 2000; and

2) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, with its registered office at 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg, represented by Mr Francis Guillaume, conseiller de banque, residing in B-6730 Tintigny, by virtue of a proxy given
in Luxembourg on 9 January 2001.

The above-named proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to notarise as a deed these Arti-

cles of Incorporation of a «société d’investissement à capital variable» which they declare to be incorporated between
themselves:

1. Denomination, Duration, Corporate object, Registered office

Art. 1. Denomination. 
There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation in

the form of a «société d’investissement à capital variable» under the name of LaSALLE EUROPEAN PROPERTY SECU-
RITIES, SICAV (hereinafter referred to as the «Company»). 

Art. 2. Duration. 
The Company is established for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. 

Art. 3. Corporate object. 
The sole object of the Company is the collective investment of its assets in transferable securities or other assets,

with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its port-
folio.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and de-

velopment of its object in the broadest sense in the frame of the Luxembourg law of 19 July 1991 concerning undertak-
ings for collective investment («UCIs») the securities of which are not intended to be placed with the public and the
Luxembourg Law dated 30 March 1988 (as amended from time to time) on UCIs. 

Art. 4. Registered office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established

either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military devel-

opments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg corporation.

2. Share capital, Variations of the share capital, Characteristics of the shares

Art. 5. Share capital.
The share capital of the company shall be at any time equal to the total net assets of the various sub-funds of the

Company, as defined in Article 12 hereof. The capital of the Company must reach 50 million Luxembourg Francs within
the first six months following its incorporation, and thereafter may not be less than this amount.

The initial share capital of the Company is set at EUR 50,000.- fully paid-up and represented by 2 Class A shares in

the LaSALLE EUROPEAN PROPERTY SECURITIES, SICAV Euro Property Securities Sub-Fund with no par value, as de-
fined in Article 8 hereof.

For consolidation purposes, the base currency of the Company is euro («EUR»).

Art. 6. Variations in share capital. 
The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the Company of new fully paid-up shares

or the repurchase by the Company of existing shares from its shareholders. 

Art. 7. Sub-funds. 
The board of directors of the Company may, at any time, establish several pools of assets, each constituting a sub-

fund, a «compartiment» within the meaning of Article 11 of the Luxembourg law dated 30 March 1988 (as amended
from time to time) on undertakings for collective investment.

The board of directors shall attribute specific investment objectives and policies and a denomination to each sub-fund. 

6787

Art. 8. Classes of shares. 
The board of directors of the Company may, at any time, issue other classes of shares within one or more sub-funds.

These other classes of shares may differ in, inter alia, their charging structure, dividend policy or type of target investors.

Initially, one class of shares, Class A shares of the LASALLE EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV Euro Prop-

erty Securities Sub-Fund, shall be issued. Other classes of shares, once created, shall differ in their characteristics as
more fully described in the current version of the prospectus of the Company from time to time.

Art. 9. Form of the shares. 
The company shall issue shares of each sub-fund and each class of shares in registered form.
Shares are issued in uncertificated form with a confirmation statement, unless a share certificate is specifically re-

quested at the time of subscription, and in such case, the subscriber will bear the risk and any additional expense arising
from the issue of such certificate. Holders of certificated shares must return their share certificates, duly renounced, to
the Company before conversion or redemption instructions may be effected.

A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such share register shall set forth

the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the class of each
such share, the amounts paid for each such share, the transfer of shares and the dates of such transfers. The share reg-
ister is conclusive evidence of ownership. The Company treats the registered owner of a share as the absolute and ben-
eficial owner thereof.

The transfer of a registered share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of

shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other in-
struments of transfer satisfactory to the Company.

Any owner of registered shares has to indicate to the Company an address to be maintained in the share register.

All notices and announcements of the Company given to owners of registered shares shall be validly made at such ad-
dress. Any shareholder may, at any moment, request in writing amendments to his address as maintained in the share
register. In case no address has been indicated by a owner of registered shares, the Company is entitled to deem that
the necessary address of the shareholder is at the registered office of the Company.

The shares are issued, and share certificates, if requested, are delivered only upon the acceptance of the subscription

and the receipt of the subscription price under the conditions as set out in the current prospectus. 

The Company will recognise only one holder in respect of each share in the Company. In the event of joint ownership,

the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company. 

Art. 10. Loss or destruction of share certificates. 
If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid or de-

stroyed, then at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the
Company may determine, including an indemnity or other verification of title or claim to title countersigned by’ a bank,
stockbroker or other party acceptable to the Company. Upon the issue of the new share certificate, on which it shall
be recorded that it is a duplicate, the original share certificate shall become null and void.

Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated or

defaced certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately. The Company, at its discretion,
may charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate, as well as all costs and reasonable
expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the
annulment of the old share certificate. 

Art. 11. Limitation to the ownership of shares.
Shares of the Company may only be owned by and are freely transferable between institutional investors in accord-

ance with the Luxembourg Law of 19 July 1991 concerning UCIs the securities of which are not intended to be placed
with the public.

The Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any person, firm,

partnership or corporate body, if in the sole opinion of the Company such holding may be detrimental to the interests
of the existing shareholders or of the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxem-
bourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages, fines or penalties
that it would not have otherwise incurred (such firms, partnerships or corporate bodies to be determined by the board
of directors).

For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears that such registration

or transfer would or may eventually result in the beneficial ownership of said share by a person who is precluded from
holding shares in the Company;

b) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, either

alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such
shareholder all shares held by such shareholder; or

c) where it appears to the Company that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the

Company which would render the Company subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg,
compulsorily repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders.

In such cases enumerated at (a) to (c) (inclusive) hereabove, the following proceedings shall be applicable:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the «redemption notice») upon the holders of shares

subject to compulsory repurchase; the redemption notice shall specify the shares to be repurchased as aforesaid, the

6788

redemption price (as defined herebelow) to be paid for such shares and the place at which this price is payable. Any
such notice may be served upon such shareholder by registered mail, addressed to such shareholder at his address as
indicated in the share register. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company
the share certificate, if issued, representing shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of
business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares
specified in the redemption notice and the share certificate, if issued, representing such shares shall be cancelled in the
books of the Company.

2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be purchased (hereinafter referred to as the

«redemption price») shall be an amount equal to the net asset value per share of the class and the Sub-Fund to which
the shares belong, determined in accordance with Article 12 hereof, as at the date of the redemption notice plus any
contingent deferred sales charge, if applicable.

3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the redemption price will be made to the owner of such

shares in the currency in which the shares are denominated, and will be deposited by the Company with a bank in Lux-
embourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon surrender of the share
certificate, if issued, representing the shares specified in such redemption notice. Upon deposit of such redemption price
as aforesaid, no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in
such shares or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder ap-
pearing as the owner thereof to receive the redemption price so deposited (without interest) from such bank upon
effective surrender of the share certificate, if issued, as aforesaid.

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article 11 shall not be questioned or invalidated in

any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person at the date of any
redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is pre-

cluded from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.

Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any

«US person», meaning a citizen or resident of the United States of America or of any of its territories or possessions
or areas subject to its jurisdiction.

3. Net asset value, Issue and repurchase of shares, Suspension of the calculation of the net asset value

Art. 12. Net asset value. 
The net asset value per share of each class of shares in each Sub-Fund of the Company shall be determined periodi-

cally by the Company, but in any case not less than once per month, as the board of directors may determine (every
such day for determination of the net asset value being referred to herein as the «valuation day») on the basis of the
last available closing prices. If such day falls on a (legal or bank) holiday in Luxembourg, then the valuation day shall be
the first succeeding full business day in Luxembourg. 

The net asset value per share is expressed in the reference currency of each Sub-Fund and, for each class of shares

for all Sub-Funds, is determined by dividing the value of the total assets of each Sub-Fund properly allocable to such class
of shares less value of the total liabilities of such Sub-Fund properly allocable to such class of shares, by the total number
of shares of such class outstanding on any valuation day.

If since the close of business, there has been a material change in the quotations on the markets on which a substantial

portion of the investments attributable to a particular Sub-Fund are dealt or quoted, the Company may, in order to
safeguard the interests of shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
All requests for subscription or redemption received to be executed on the first valuation will be executed on the sec-
ond valuation.

Upon the creation of a new Sub-Fund, the total net assets allocated to each class of shares of such Sub-Fund shall be

determined by multiplying the number of shares of a class issued in the Sub-Fund by the applicable purchase price per
share. The amount of such total net assets shall be subsequently adjusted when shares of such class are issued or re-
purchased according to the amount received or paid, as the case may be.

The valuation of the net asset value per share of the different classes of shares shall be made in the following manner: 
a) The assets of the Company shall be deemed to include: 
i) the value of any cash on hand or on deposit;
ii) bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends, interest declared or accrued

and not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to
be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered
appropriate in such case to reflect the true value thereof;

iii) securities listed on a recognised stock exchange or dealt on any other regulated market (hereinafter referred to

as a «regulated market») that operates regularly, is recognised and is open to the public, will be valued at their last avail-
able closing prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their last available closing
prices on the main market for the relevant security;

iv) in the event that the last available closing price does not, in the opinion of the directors, truly reflect the fair market

value of the relevant securities, the value of such securities will be defined by the directors based on the reasonably
foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith;

v) securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another regulated market will be valued on the

basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the directors; and

vi) the liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other regulated mar-

kets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the directors, on a basis
consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts

6789

traded on exchanges or on other regulated markets shall be based upon the last available settlement prices of these
contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded
by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect
to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such
value as the directors may deem fair and reasonable.

Any assets held in a particular Sub-Fund not expressed in the reference currency of such Sub-Fund will be translated

into such reference currency at the rate of exchange prevailing in a regulated market at 3.00 p.m. on the relevant Val-
uation Day.

b) The liabilities of the Company shall be deemed to include: 
i) all loans, bills and accounts payable;
ii) all accrued or payable administrative expenses (including portfolio management fees, distribution fees, custodian,

administrator, registrar and transfer agent fees); 

iii) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or

property:

iv) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the dealing day preceding the valuation

day, as determined from time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the di-
rectors, in particular those that have been set aside for a possible depreciation of the investments of the Company; and

v) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares of the

Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and
all costs incurred by the Company, which shall comprise the fees payable to the custodian, the administrator, the reg-
istrar and transfer agent, investment advisors (if any), portfolio managers, taxes, expenses for legal and auditing services,
cost of any proposed listings, maintaining such listings, printing Share Certificates, shareholders’ reports, prospectuses,
reasonable marketing and advertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all rea-
sonable out-of-pocket expenses of the Directors, registration fees and other expenses payable to supervisory authori-
ties in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and the costs of publication of the Net Asset
Value per Share for each Sub-Fund. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or re-
curring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal propor-
tions over any such period. 

As between the shareholders, each Sub-Fund shall be treated as a separate legal entity.
Vis-à-vis third parties, the Company shall constitute one single legal entity, and any commitment shall commit the

Company as a whole, whatever may be the Sub-Fund to which the commitments are attributed, unless otherwise agreed
with a counterparty. The assets, commitments, charges and expenses which cannot be allocated to one specific Sub-
Fund will be charged to the different Sub-Funds proportionally to their respective net assets, or pro rata to their re-
spective net assets, if appropriate due to the amounts considered.

All shares in the process of being redeemed by the Company shall be deemed to be issued until the close of business

on the valuation day applicable to the redemption. The redemption price is a liability of the Company from the close of
business on this date until paid.

All shares issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be deemed issued from

the close of business on the valuation day applicable to the subscription. The subscription price is an amount owed to
the Company from the close of business on such day until paid. 

As far as possible, all investments and divestments chosen and in relation to which action is taken by the Company

up to the valuation day shall be taken into consideration in the valuation. 

Art. 13. Issue, redemption and conversion of shares.
The board of directors is authorised to issue further fully paid-up shares of each class and of each Sub-Fund at any

time at a price based on the net asset value per share for each class of shares and for each Sub-Fund determined in
accordance with Article 12 hereof, as of such valuation date as is determined in accordance with such policy as the board
of directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and ex-
penses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales charges, as ap-
proved from time to time by the board of directors.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new shares.

All new share subscriptions shall, under pain of nullity, be entirely liberated, and the shares issued carry the same

rights as those shares in existence on the date of the issuance.

If the directors determine that it would be detrimental to the existing shareholders of the Company to accept a sub-

scription for shares of any Sub-Fund that represents more than 10% of the net assets of such Sub-Fund, then they may
postpone the acceptance of such subscription and, in consultation with the incoming shareholder, may require him to
stagger his proposed subscription over an agreed period of time.

The Company may reject any subscription in whole or in part, and the directors may, at any time and from time to

time and in their absolute discretion without liability and without notice, to discontinue the issue and sale of shares of
any class in any one or more Sub-Funds.

Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company under the terms and con-

ditions set forth by the board of directors in the prospectus and within the limits as provided in this Article 13. The
redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not exceed
ten business days from the relevant valuation date, as it is determined in accordance with such policy as the board of
directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have
been received by the Company. The redemption price shall be equal to the net asset value per share relative to the class

6790

and to the Sub-Fund to which it belongs, determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof, decreased
by charges and commissions at the rate provided in the prospectus. Any such request for redemption must be filed by
such shareholder in written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other legal entity
appointed by the Company for the redemption of shares. The request shall be accompanied by the certificate(s) for such
shares, if issued. The relevant redemption price may be rounded up or down to a maximum of three decimal places of
the reference currency as the board of directors shall determine.

The Company shall ensure that at all times each Sub-Fund has enough liquidity to enable satisfaction of any requests

for redemption of shares.

If as a result of any request for redemption, the aggregate net asset value per share of the shares held by a shareholder

in any class of shares would fall below such value as determined by the board of directors, then the Company may decide
that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder’s holding of shares in
such class.

Further if at any given date redemption request pursuant to this Article 13 and conversion requests exceed a certain

level to be determined by the board of directors in relation to the number of shares in issue in a class, the board of
directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and
in a manner the board of directors considers to be in the best interests of the Company. On the next valuation date
following that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company will have the right, if the board of directors so determines and with the consent of the shareholder

concerned, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder in specie by allocating to such shareholder
investments from the pool of assets set up in connection with such classes of shares equal in value (calculated in a man-
ner as described in Article 12 hereof) as of the valuation date on which the redemption price is calculated to the value
of shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair
and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the relevant class of shares, and
the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor. The cost of such transfer shall be borne by the
transferee.

Shares redeemed by the Company shall be cancelled in the books of the Company.
Any shareholder is entitled within a given class to request the conversion of whole or part of his shares, provided

that the board of directors may:

a) set terms and conditions as to the right for and frequency of conversion 
of shares between Sub-Funds; and
b) subject conversions to the payment of such charges and commissions as it shall determine.
If as a result of any request for conversion, the aggregate net asset value per share of the shares held by a shareholder

in any class of shares would fall below such value as determined by the board of directors, then the Company may decide
that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder’s holding of shares in
such class.

Such a conversion shall be effected on the basis of the net asset value of the relevant shares of the different Sub-

Funds, determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof. The relevant number of shares may be round-
ed up or down to a maximum of three decimal places as the board of directors shall determine.

The shares which have been converted into another Sub-Fund will be cancelled.
The requests for subscription, redemption and conversion shall be received at the location designated to and for this

effect by the board of directors. 

Art. 14. Suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, the redemption and the

conversion of shares. 

The Company may suspend the calculation of the net asset value of one or more Sub-Funds and the issue, redemption

and conversion of any classes of shares in the following circumstances:

a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of

the investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed other-
wise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such re-
striction or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund quoted
thereon;

b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the directors as a

result of which disposal or valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be imprac-
ticable;

c) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price

or value of any of the investments of such Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or other market
in respect of the assets attributable to such Sub-Fund;

d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition
of investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the directors, be effected at normal
rates of exchange;

e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to such Sub-Fund

cannot promptly or accurately be ascertained;

f) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding up the

Company.

The suspension of a Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the net asset value per share, the issue, re-

demption and conversion of shares of any other Sub-Fund which is not suspended.

6791

Under exceptional circumstances, which may adversely affect the rights of shareholders, the board of directors re-

serves the right to conduct the necessary sales of transferable securities before setting the share price at which share-
holders can apply to have their shares redeemed or converted. In this case, subscriptions, redemptions and conversion
applications in process shall be dealt with on the basis of the net asset value thus calculated after the necessary sales.

Subscribers and shareholders tendering shares for redemption and conversion shall be advised of the suspension of

the calculation of the net asset value. 

The suspension of the calculation of the net asset value may be published by adequate means if the duration of the

suspension is to exceed a certain period.

Suspended subscription, redemption and conversion applications may be withdrawn by written notice provided that

the Company receives such notice before the suspension ends.

Suspended subscriptions, redemptions and conversions shall be executed on the first valuation day following the re-

sumption of net asset value calculation by the Company.

4. General shareholders’ meeting

Art. 15. General provisions. 
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of
the Company.

Art. 16. Annual general shareholders’ meeting. 
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting,
on the second Tuesday in May at 12:00 am, and for the first time in 2002. If such day is a bank holiday, then the annual
general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad
if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting. 

Art. 17. General meetings of shareholders of classes of shares. 
The shareholders of the class of shares issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to

decide on any matters which relate exclusively to such class of shares in such Sub-Fund. In addition, the shareholders
of any class of shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such
class of shares. The general provisions set out in these Articles of Incorporation, as well as in the Luxembourg law dated
10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies, shall apply to such meetings.

 Art. 18. Functioning of shareholders’ meetings.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share, regardless of the class and of the Sub-Fund to which it belongs, is entitled to one vote, subject to the

limitations imposed by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. Fractions of shares are not entitled to
a vote.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Further, the shareholders of each class and of each Sub-Fund separately will deliberate and vote (subject to the con-

ditions of quorum and majority voting as provided by law) on the following items:

1. affectation of the net profits of their Sub-Fund and class; and 
2. resolutions affecting the rights of the shareholders of one class or of one Sub-Fund vis-à-vis of the other classes

and/or Sub-Funds. 

Art. 19. Notice to the general shareholders’ meetings. 
Shareholders shall meet upon call by the board of directors. To the extent required by law, the notice shall be pub-

lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such
other newspapers as the board of directors may decide. 

5. Management of the Company

Art. 20. Management.
The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members who need not be

shareholders of the Company. 

Art. 21. Duration of the functions of the directors, renewal of the board of directors. 
The directors shall be elected by the general shareholders’ meeting for a period not exceeding six years and until

their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/
or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. 

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general
meeting of shareholders. 

6792

Art. 22. Committee of the board of directors. 
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may chose from among its members

one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

Art. 23. Meetings and deliberations of the board of directors. 
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another director by a majority vote to preside at such meetings. For
general meetings of shareholders and in the case no director is present, any other person may be appointed as chairman.

The board of directors from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, any

assistant managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of
the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be di-
rectors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the pow-
ers and duties given to them by’ the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least three days in advance

of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram.
telex or facsimile transmission of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meetings of the board of directors by appointing, in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile transmission, another director as his proxy. One director may replace several other directors.

Any director who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the board

of directors by conference call or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the
meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.

Directors may not bind the Company by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of

the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least fifty per cent of the directors are present or rep-

resented at a meeting of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or rep-
resented at such meeting. The chairman shall have the casting vote.

Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmission and similar means. The date of such a res-
olution shall be the date of the last signature.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its

powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to natural persons or corporate entities
which need not be members of the board. 

Art. 24. Minutes.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman, or in his absence, by the chair-

man pro tempore who presides at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

such chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 25. Engagement of the Company vis-à-vis third persons. 
The Company shall be engaged by the signature of two members of the board of directors or by the individual sig-

nature of any duly authorised director or officer of the Company or by the individual signature of any other person to
whom authority has been delegated by the board of directors. 

Art. 26. Powers of the board of directors. 
The board of directors determines the general orientation of the management and of the investment policy, as well

as the guidelines to be followed in the management of the Company, always in application of the principle of risk diver-
sification. 

Art. 27. Interest.
No contract or other transaction which the Company and any other corporation or firm might enter into shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the company are interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Company who serves as a director, officer of employee of any corporation or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

In the event that any director or officer of the company may have any personal interest in any transaction of the

Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the next
succeeding meeting of shareholders.

6793

The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any position, relationship with or

interest in any matter, position or transaction involving LaSALLE GROUP, its subsidiaries and associated companies or
such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion. 

Art. 28. Indemnification of the directors. 
The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 29. Allowances to the board of directors. 
The general meeting of shareholders may allow the members of the board of directors, as remuneration for services

rendered, a fixed annual sum, as directors’ remuneration, such amount being carried as general expenses of the Com-
pany and which shall be divided at the discretion of the board of directors among themselves.

Furthermore, the members of the board of directors may be reimbursed for any expenses engaged in on behalf of

the Company insofar as they are reasonable. 

The remuneration of the chairman or the secretary of the board of directors as well as those of the general manag-

er(s) and officers shall be fixed by the board.

Art. 30. Advisor, fund managers, Custodian and other contractual parties.
The Company may enter into an investment advisory agreement in order to be advised and assisted while managing

its portfolio, as well as enter into investment management agreements with one or more fund managers.

In addition, the Company shall enter into service agreements with other contractual parties, for example an admin-

istrative, corporate and domiciliary agent to fulfil the role of «administration centrale» as defined in the «Institut
Monétaire Luxembourgeois» Circular 91/75 of 21 January 1991.

The Company shall enter into a custody agreement with a bank (hereinafter referred to as the «Custodian») which

shall satisfy the requirements of the Luxembourg law dated 30 March 1988 as amended from time to time on undertak-
ings for collective investment. All transferable securities and cash of the Company are to be held by or to the order of
the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by law. 

In the event of the Custodian desiring to retire the board of directors shall use their best endeavours to find another

bank to be Custodian in place of the retiring Custodian and the board of directors shall appoint such bank as Custodian.
The board of directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and
until a successor Custodian shall have been appointed in accordance with these provisions to act in the place thereof.

6. Auditor

Art. 31. Auditor.
The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised by an

auditor who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to respectability and professional experience and who
shall perform the duties foreseen by the Luxembourg law dated 30 March 1988 as amended from time to time on un-
dertakings for collective investment. The auditors shall be elected by the general meeting of shareholders.

7. Annual accounts

Art. 32. Accounting year.
The accounting year of the Company shall begin on 1st January in each year and shall terminate on 31 December of

the same year, excepted the first accounting year which shall begin on the date of incorporation and shall terminate on
31 December 2001. 

Art. 33. Profit balance.
At the annual general meeting of shareholders, the shareholders of each class of each sub-fund shall determine, at the

proposal of the board of directors, whether, and if so the amount thereof, dividends are to be distributed to the share-
holders of, within the limits prescribed by the Luxembourg law dated 30 March 1988 on collective investment under-
takings.

In each sub-fund, interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law and subject to the de-

cision of the board of directors, be paid out on shares.

Dividends which are not claimed within a period of five years starting from their payment date will become statute-

barred for their beneficiaries and will revert to the relevant sub-fund.

8. Dissolution and Liquidation

Art. 34. Dissolution of the Company.
The Company may at any time be dissolved by a resolution taken by the general meeting of shareholders subject to

the quorum and majority requirements as defined in Article 18 hereof.

Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the Luxembourg law dated 30

March 1988 as amended from time to time on undertakings for collective investment, the board of directors has to
submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders. The general meeting for
which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the shares presented at the meeting. 

6794

The question of the dissolution of the Company shall also be referred to the general meeting of shareholders when-

ever the capital falls below one quarter of the minimum capital as provided by the Luxembourg law dated 30 March
1988 as amended from time to time on undertakings for collective investment. In such event the general meeting shall
be held without quorum requirements and the dissolution may be decided by the shareholders holding one quarter of
the votes present or represented at that meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets

of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum as the case may be.

The issue of new shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the general share-

holders’ meeting, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.

One or more liquidators shall be appointed by the general meeting of shareholders to realise the assets of the Com-

pany, subject to the supervision of the relevant supervisory authority in the best interests of the shareholders.

The proceeds of the liquidation of each Sub-Fund, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators

among the holders of shares in each class in accordance with their respective rights. The amounts not claimed by share-
holders at the end of the liquidation process shall be deposited, in accordance with Luxembourg law, with the Caisse
des Consignations in Luxembourg until the statutory limitation period has lapsed.

 Art. 35. Termination, division and amalgamation of Sub-Funds.
The directors may decide at any moment the termination, division and/or amalgamation of any Sub-Fund. In the case

of termination of a Sub-Fund, the directors may offer to the shareholders of such Sub-Fund the conversion of their class
of shares into classes of shares of another Sub-Fund, under terms fixed by the directors.

In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund or of any class of shares within a Sub-

Fund has decreased to an amount determined by the directors from time to time to be the minimum level for such Sub-
Fund or such class of shares to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or po-
litical situation relating to the Sub-Fund concerned would have material adverse consequences on the investments of
that Sub-Fund, the directors may decide to compulsorily redeem all the shares of the relevant classes issued in such Sub-
Fund at the net asset value per share, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expens-
es and calculated on the valuation day at which such decision shall take effect.

The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant class of shares prior to the effective date of

the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations. Reg-
istered shareholders will be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to maintain equal
treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund concerned may continue to request redemp-
tion or conversion of their shares free of charge, taking into account actual realisation prices of investments and reali-
sation expenses and prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred on the board of directors by the preceding paragraph hereof, the general

meeting of shareholders of any one or all classes of shares issued in any Sub-Fund may, upon proposal of the board of
directors, redeem all the shares of the relevant classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares,
taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and calculated on the valuation day
at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of sharehold-
ers that shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented.

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited

with the Custodian of the Company for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited
with the Caisse des Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares will be cancelled in the books of the Company. Under the same circumstances as provided in

the second paragraph of this Article 35. the board of directors may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to
those of another existing Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment organised
under the provisions of Part I of the Luxembourg law dated 30 March 1988 as amended from time to time on under-
takings for collective investment or to another Sub-Fund within such undertakings for collective investment (hereinafter
referred to as the «new Sub-Fund») and to redesignate the classes of shares concerned as shares of another class (fol-
lowing a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement
to shareholders). Such decision will be published in the same manner as described hereabove (and, in addition, the pub-
lication will contain information in relation to the new Sub-Fund), one month before the date on which the amalgamation
becomes effective in order to enable shareholders to request redemption or conversion of their shares free of charge
during such period.

Under the same circumstances provided for under this Article 35 the board of directors may decide to reorganise a

Sub-Fund or class by means of a division into two or more Sub-Funds or classes. Such decision will be published in the
same manner as described hereabove (and, in addition, the publication will contain information about the two or more
new Sub-Funds) one month before the date on which the division becomes effective in order to enable the shareholders
to request redemption of their shares free of charge during such period.

Notwithstanding the powers conferred on the board of directors by the preceding paragraph, an amalgamation or

division of Sub-Funds within the Company may be decided upon by a general meeting of shareholders of the classes of
shares in the Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide, upon such
amalgamation or division, by resolution taken by simple majority of those present or represented.

A contribution of the assets and of the liabilities distributable of any Sub-Fund to another undertaking for collective

investment referred to hereinbefore or to another Sub-Fund within such undertaking for collective investment shall re-
quire a resolution of the shareholders of the classes of shares issued in the Sub-Fund concerned taken with 50 % quorum
requirement of the shares in issue and adopted at two-thirds majority of the shares present or represented at such
meeting, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collective invest-

6795

ment of the contractual type («fonds commun de placement») or a foreign-based undertaking for collective undertak-
ings, in which case resolutions shall be binding only on such shareholders who have voted in favour of such
amalgamation.

Art. 36. Liquidation.
In case of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be natural persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

The net product of the liquidation of each Sub-Fund shall be distributed by the liquidators to the shareholders of each

Sub-Fund in proportion to the number of shares which they hold in that Sub-Fund. The amounts not claimed by the
shareholders at the end of the liquidation shall be deposited with the Caisse des Consignations in Luxembourg. If these
amounts were not claimed before the end of a period of five years, the amounts shall become statute-barred and cannot
be claimed anymore.

Art. 37. Expenses borne by the Company.
Each of the Portfolio Manager, the Custodian, the Administrator, the Registrar and Transfer Agent are entitled to

receive fees out of the net assets of the Company. pursuant to the relevant agreements between each of them and the
Company and in accordance with usual market practice. Such fees are calculated on the basis of the average monthly
net assets of each Sub-Fund and are payable monthly in arrears. In addition, reasonable disbursements and out-of-pocket
expenses incurred by such parties are charged to the Company as appropriate.

The Sub-Funds will also bear all other expenses incurred in the operation of the Company which include, without

limitation, taxes, expenses for legal and auditing services, cost of any proposed listings, maintaining such listings, printing
Share Certificates, shareholders’ reports prospectuses, reasonable marketing and advertising expenses, costs of prepar-
ing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses of the Directors, registration
fees and other expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, bro-
kerage costs and the costs of publication of the Net Asset Value per Share for each Sub-Fund.

The allocation of costs and expenses to be borne by the Company will be made pro rata to the net assets of each

Sub-fund in accordance with the articles of incorporation of the Company.

The formation expenses of the Company and each of the Sub-funds will be borne by the Company and will be written

off during the first 5 years upon incorporation.

The Company bears all its running costs as foreseen in Article 12 hereof. 

Art. 38. Amendment of the Articles of Incorporation.
These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quo-

rum and majority voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Any amendment of the terms and conditions of the Company which has as an effect a decrease of the rights or guar-

antees of the shareholders or which imposes on them additional costs, shall only come into force after a period of three
months starting at the date of the approbation of the amendment by the general shareholders’ meeting. During these
three months, the shareholders may continue to request the redemption of their shares under the conditions in force
before the relevant amendment. 

Art. 39. General provisions.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies and the Luxembourg law of 19 July
1991 concerning UCIs the securities of which are not intended to be placed with the public and the Luxembourg Law
dated 30 March 1988 (as amended from time to time) on UCIs.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given as specifically stated to the undersigned notary.

<i>Expenses

The parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by

the Company as a result of its formation at approximately 300,000.- LUF. 

<i>Statement

The undersigned notary hereby states that the conditions provided for in article 26 of the Luxembourg law dated 10

August 1915 as amended from time to time on commercial companies have been observed. 

<i>General Meeting of Shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors of the Company is set at four and the number of auditors to one.

<i>Name of shareholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<i>Subscribed capital

<i>Paid-in capital

<i>Number of 

<i>shares

LaSALLE INVESTMENT MANAGEMENT SECURITIES B.V.   

25,000.- EUR

25,000.- EUR

1

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG . . . . . . . . 

25,000.- EUR

 25,000.- EUR

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50,000.- EUR

50,000.- EUR

2

6796

2) The following persons are appointed directors of the Company for a period ending on the date of the annual gen-

eral meeting of shareholders to be held in Luxembourg in 2002 and until their successors are elected and qualified:

- Mr Robert LaFors, LaSALLE INVESTMENT MANAGEMENT SECURITIES B.V., 
residing in Dorpstraat 202A, 3481 ER Harmelen, The Netherlands; 
- Mr Michiel Dubois, LaSalle Investment Management Securities BV, residing in Amstelveenseweg 651, 1081 JD Am-

sterdam, The Netherlands;

- Mr Peter Manley, LaSalle Investment Management, residing in ., Preston Park, Faversham, Kent, ME13 8 LH, England. 
- Mr Gilles Reiter, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., residing in 27, rue des Prés, L-8265 Mam-

er.

3) KPMG Audit, 31 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, is appointed auditor of the Company for a period ending on

the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2002 and until his successor is elected and qualified.

4) The registered office of the Company is set at 69, route d’Esch, L2953 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
5) The board of directors is hereby authorised, according to Article 23 hereof, to delegate its powers to conduct the

daily management of the Company to natural persons and corporate entities.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

persons, the present notarial deed appears in English followed by a German translation; on request of the same above
appearing persons and in case of any inconsistencies between the English and the German text, the English version shall
prevail.

Thereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this notarial

deed.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the German translation of the foregoing text:

Im Jahre zweitausendundeins, den achtzehnten Januar. 
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) LaSALLE INVESTMENT MANAGEMENT SECURITIES B.V., mit eingetragenem Sitz in Herengracht 471, NL-1017

BS Amsterdam, Niederlande, vertreten durch Herrn Rudi Dickhoff avocat, wohnhaft in L-8010 Strassen, aufgrund einer
Vollmacht, die ihm am 15. Dezember 2000 in Amsterdam erteilt wurde; und

2) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, mit eingetragenem Sitz in 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg,

vertreten durch Herrn Francis Guillaume, conseiller de banque, wohnhaft in 13-6730 Tintigny, aufgrund einer Vollmacht,
ausgestellt in Luxemburg, am 9. Januar 2001.

Die oben angegebenen Vollmachturkunden, welche ne varietur durch alle erscheinenden Personen und dem unter-

zeichneten Notar unterschrieben wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr den Forma-
litäten der Einregistrierung unterworfen zu werden.

Welche erscheinenden Personen, im Namen wie sie handelten, den unterzeichnenden Notar ersuchten, die Satzung

einer zwischen ihnen zu gründenden «société d’investissement à capital variable» wie folgt zu dokumentieren:

1. Name, Dauer, Gegenstand, Eingetragener Sitz 

Art. 1. Name.
Zwischen den Vertragsparteien und allen, welche Eigentümer von später ausgegebenen Aktien werden, besteht eine

Gesellschaft in der Form einer «Société dInvestissement à Capital Variable» mit der Bezeichnung LaSALLE EUROPEAN
PROPERTY SECURITIES SICAV (nachfolgend die «Gesellschaft»). 

Art. 2. Dauer. 
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Zeit gebildet. Sie kann durch Beschluss der Aktionäre, welcher in den für

Satzungsänderungen vorgeschriebenen Formen gefasst wird, aufgelöst werden. 

Art. 3. Gesellschaftszweck. 
Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage ihres Vermögens in Wertpapieren

und anderen Vermögenswerten mit dem Zweck, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse der
Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck im weitesten Sin-

ne dienen oder nützlich sind, im Rahmen des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinsame Anlagen,
deren Anteile nicht zum öffentlichen Vertrieb bestimmt sind, in Verbindung mit den Vorschriften des Gesetzes vom 30.
März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen, so wie es abgeändert worden ist und werden wird.

Art. 4. Gesellschaftssitz.
Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Durch Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen

und Repräsentanzen im Grossherzogtum oder im Ausland gegründet werden.

In Falle, wo der Verwaltungsrat feststellt, dass ausserordentliche politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche oder mi-

litärische Entwicklungen stattgefunden haben oder bevorstehen, welche die normale Geschäftsabwicklung der Gesell-
schaft am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland
beeinträchtigen, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum Ende dieser ausserordentlichen Gegebenheiten ins
Ausland verlegt werden; eine solche vorübergehende Massnahme wird keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesell-
schaft haben, welche unbeschadet einer solchen vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgi-
sche Gesellschaft bleiben wird.

6797

2. Gesellschaftskapital, Veränderungen des Gesellschaftskapitals, Charakteristika der Aktien

Art. 5. Aktienkapital.
Das Aktienkapital der Gesellschaft ist zu jedem Zeitpunkt gleich dem (gemäss dem nachfolgenden Artikel 12 berech-

neten) Nettovermögenswert der verschiedenen Subfonds der Gesellschaft. Das Aktienkapital der Gesellschaft muss 50
Millionen Luxemburger Franken innerhalb der ersten sechs Monate nach der Gründung der Gesellschaft erreichen und
darf nach sechs Monaten diesen Betrag nicht unterschreiten.

Das Anfangskapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,-, voll eingezahlt und eingeteilt in 2 Aktien ohne Nennwert

der Klasse A des LaSALLE EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV Euro Property Securities Subfonds, wie in Ar-
tikel 8 der vorliegenden Statuten beschrieben.

Für Konsolidierungszwecke ist die Basiswährung der Gesellschaft der Euro («EUR»).

Art. 6. Schwankungen des Gesellschaftskapitals.
Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von neuen voll eingezahlten Aktien durch die Gesellschaft oder

des Rückkaufs durch die Gesellschaft von bestehenden Aktien ihrer Aktionäre erhöhen oder vermindern. 

Art. 7. Subfonds. 
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit verschiedene Pools von Aktiven gründen, welche die sogenann-

ten «Subfonds» darstellen, ein «compartiment» im Sinne des Artikels 11 des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März
1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen, so wie es abgeändert worden ist und in Zukunft abgeändert werden
wird.

Der Verwaltungsrat wird jeder Subfonds eine spezifische Anlagepolitik sowie eine Bezeichnung zuteilen. 

Art. 8. Aktienklassen. 
Der Verwaltungsrat kann jederzeit neue Aktienklassen in einem oder mehreren Subfonds ausgeben. Diese neue Ak-

tienklassen können, inter alia, in der Belastungsstruktur, der Dividendenpolitik, und den Zielinvestoren abweichen. 

Am Anfang wird eine Klasse Aktien, Aktienklasse A des LaSALLE EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV Euro

Property Securities Subfonds, ausgegeben. Andere Aktienklassen, wenn einmal geschaffen, werden in ihren Charakteri-
stiken abweichen, entsprechend der genaueren Beschreibung in der jeweils aktuellen Ausgabe des Prospektes der Ge-
sellschaft. 

Art. 9. Form der Aktien. 
Die Gesellschaft wird Aktien jedes Subfonds und jeder Aktienklasse als Namensaktien ausgeben.
Die Aktien werden als Namensaktien mit einer Bestätigungsschrift ausgegeben, ausser wenn ein Aktienzertifikat bei

der Zeichnung ausdrücklich angefragt wird und in diesem Fall trägt der Zeichner das Risiko und etwaige daraus entste-
hende zusätzliche Kosten. Inhaber solcher Aktienzertifikate müssen diese zurückbringen und ordnungsgemäss aufgeben,
ehe Umtauschoder Rückzahlungsanweisungen ausgeführt werden können.

Ein Aktienregister wird am Gesellschaftssitz gehalten. In diesem Register ist der Name, Wohnort, oder gewähltes

Domizil von jedem Aktieninhaber, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Klasse von jeder Aktie, der für jede
Aktie bezahlte Betrag, der Transfer der Aktien und die Daten von solchen Transfers, eingetragen.

Dieses Register ist für das Besitzverhältnis der Aktien beweiskräftig. Die Gesellschaft behandelt den eingetragenen

Aktieninhaber als den absoluten Besitzer und den wirtschaftlichen Berechtigten.

Die Übertragung einer Namensaktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche in das Aktienregister

eingetragen wird und welche datiert und durch den Käufer und den Veräusserer oder durch Personen, welche vertre-
tungsberechtigt sind, unterschrieben wird, durchgeführt. Die Gesellschaft kann auch andere, für sie zulässige Beweise
einer Aktienübertragung annehmen.

Jeder Aktionär von Namensaktien muss der Gesellschaft eine Adresse zwecks Eintragung im Aktienregister mitteilen.

Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Gesellschaft zugunsten von Aktionär von Namensaktien können rechtsver-
bindlich an diese Adresse gesandt werden. Ein Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderung sei-
ner Adresse im Register beantragen.

Falls ein Inhaber von Namensaktien der Gesellschaft keine Adresse mitgeteilt hat, ist die Gesellschaft berechtigt, an-

zunehmen, dass die erforderliche Adresse des Aktionärs sich am Sitz der Gesellschaft befindet.

Aktien und Aktienzertifikate, insofern sie beantragt sind, werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenom-

men und der Preis unter den Bedingungen des aktuellen Prospektes eingegangen ist.

Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes kann

die Gesellschaft die Ausübung der aus der oder den Aktien hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt,
an dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 10. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. 
Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugender Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat einer ihm

gehörenden Aktie abhanden gekommen ist oder zerstört wurde, kann auf seinen Antrag die Gesellschaft ein Ersatzzer-
tifikat ausgeben unter den Bedingungen und Garantien, welche die Gesellschaft festlegen kann, mit einbegriffen eine Ge-
bühr oder eine Urkundenüberprüfung oder Urkundenforderung, welche durch eine Bank, einen Börsenmakler, oder
einer andere Partei, zur Zufriedenheit der Gesellschaft, unterschrieben ist. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifi-
kates, auf welchem vermerkt wird, dass es sich um ein Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

Verstümmelte oder beschädigte Aktienzertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Aktienzertifikate ausge-

tauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und
werden von derselben umgehend für ungültig erklärt. Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Ak-
tionär Ersatz in angemessener Höhe für die Kosten zu verlangen, welche ihr durch die Ausgabe und Eintragung eines
neuen Aktienzertifikates oder durch die Annullierung und Zerstörung des Originalzertifikates entstanden sind. 

6798

Art. 11. Einschränkungen der Eigentumsrechte auf Aktien. 
Aktien der Gesellschaft dürfen nur besitzt werden von und sind frei übertragbar zwischen institutionellen Investoren

im Sinne des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht zum öffentlichen
Vertrieb bestimmt sind.

Die Gesellschaft kann den direkten oder indirekten Besitz von Aktien der Gesellschaft durch bestimmte natürliche

oder juristische Personen einschränken oder verbieten, wenn die Gesellschaft nach eigenem Ermessen der Ansicht ist,
dass ein solcher Besitz zu Lasten der Interessen der bestehenden Aktionäre oder der Gesellschaft geht, oder wenn ein
solcher Besitz eine Verletzung einer gesetzlichen Bestimmung des Grossherzogtums Luxemburg oder eines anderen
Landes mit sich zieht oder bewirken kann, oder wenn durch einen solchen Besitz die Gesellschaft mit steuerlichen Nach-
teilen, Geld- oder anderen Strafen, zu rechnen hat, denen sie andernfalls nicht ausgesetzt worden wäre (solche juristi-
sche Personen sind durch den Verwaltungsrat festzustellen).

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen und ohne Haftung:
a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktienregister verweigern, wenn es offenkundig ist, dass

diese Ausgabe oder Umschreibung zur Folge haben kann oder wird, dass der Aktienbesitz an eine Person übergeht, die
nicht dazu berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen.

b) den Zwangsrückkauf von allen Aktien, welche von einem Aktionär gehalten werden, tätigen, wenn der Gesellschaft

offenkundig wird, dass eine Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, entweder allein oder
aber zusammen mit anderen Personen wirtschaftlicher Berechtigter dieser Aktien ist, oder,

c) wenn der Gesellschaft offenkundig wird, dass eine oder mehrere Personen einen solchen Anteil der Aktien der

Gesellschaft halten, dass die Steuergesetze oder andere Gesetze von anderen Ländern als jene von Luxemburg auf die
Gesellschaft anwendbar werden könnten, den Zwangsrückkauf von allen oder einem Teil der von solchen Aktionären
gehaltenen Aktien tätigen.

In diesen in (a) bis (c) (einbegriffen) aufgezählten Fällen wird folgendes Verfahren angewandt:
1) Die Gesellschaft sendet dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (nachstehend Rückkaufsbe-

nachrichtigung genannt) zu; die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden
Rückkaufspreis und den Ort, wo dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Rückkaufsbenachrichtigung kann dem Aktionär
durch Einschreibebrief an seine im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden. Der betroffene Aktionär ist
verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufsbenachrichtigung
aufgeführten Aktien darstellen, zurückzugeben. Sofort nach Büroschluss am Tag, der in der Rückkaufsbenachrichtigung
angegeben ist, hört der Aktionär auf, Besitzer derjenigen Aktien zu sein, die in der Rückkaufsbenachrichtigung erwähnt
sind, und die Aktienzertifikate (falls ausgegeben), welche die entsprechenden Aktien darstellen, werden in den Büchern
der Gesellschaft annulliert.

2) Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden («der Rück-

kaufspreis»), ist gleich dem Nettovermögenswert der Aktien der Klasse(n) und Subfonds, zu der die Aktien jeweils ge-
hören, so wie dieser am Tag der Rückkaufsbenachrichtigung gemäss Artikel 12 der vorliegenden Statuten festgestellt
wird, zuzüglich einer Rückkaufgebühr, falls anwendbar.

3) Vorbehaltlich aller anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen wird der Rückkaufspreis dem Besitzer jener Aktien

in der Währung der betreffenden Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo ansässigen Bank,
welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Preis dem betroffenen Ak-
tionär gegen Rückgabe des oder der Zertifikate, die die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien darstel-
len, auszahlen. Sobald der Preis gemäss diesen Bedingungen hinterlegt wurde, kann keine Person, die an den in der
Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert ist, Anspruch auf diese Aktien geltend machen; ausserdem
kann keine Person rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft oder ihre Guthaben unternehmen, ausser das Recht des
Aktionärs, welcher sich als rechtmässiger Besitzer der Aktien ausweist, den hinterlegten Preis ohne Zinsen bei der Bank
gegen Rückgabe des oder der Zertifikate ausgezahlt zu bekommen, wie vorgehend erläutert.

4) Die Ausübung durch die Gesellschaft der ihr durch diesen Artikel 11 zugestandenen Befugnisse kann in keinem Fall

mit der Begründung, dass es keinen ausreichenden Nachweis des Besitzes der Aktien durch eine Person gab, in Frage
gestellt oder ungültig erklärt werden, unter der einzigen Bedingung, dass die Gesellschaft ihre Befugnisse in gutem Glau-
ben ausführte. Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen und ohne Haftung bei Aktionärsversammlungen denjenigen
Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

Insbesondere kann die Gesellschaft den Besitz von Aktien der Gesellschaft durch jede «US Person» einschränken

oder verbieten. Der Ausdruck «US Person», so wie dieser Ausdruck in der vorliegenden Satzung gebraucht wird, be-
deutet jeder Staatsangehörige, Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten oder eines ihrer Territorien oder Be-
sitztümer oder Gegenden unter ihrer Gerichtsbarkeit.

3. Nettovermögenswert, Ausgabe und Rückkauf von Aktien, Aussetzung der Berechnung des 

Nettovermögenswertes

Art. 12. Nettovermögenswert. 
Der Nettovermögenswert per Aktie jeder Aktienklasse in jedem Subfonds der Gesellschaft wird periodisch durch

die Gesellschaft berechnet, wie der Verwaltungsrat es bestimmen wird, aber in keinem Falle weniger als einmal im Mo-
nat. Der Tag, an dem der Nettovermögenswert der Aktien berechnet wird, wird in der vorliegenden Satzung als «Be-
wertungstag» bezeichnet, auf der Basis des letzt verfügbaren Verkaufskurses. Wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen
Feiertag oder einen Bankfeiertag in Luxemburg fällt, ist der Bewertungstag der darauffolgende volle Arbeitstag in Lu-
xemburg.

Der Nettovermögenswert pro Aktie wird an jedem Bewertungstag in der jeweiligen Referenzwährung des Subfonds

ausgedrückt und wird für jede Aktienklasse eines jeden Subfonds dadurch bestimmt, dass das der betreffenden Aktien-

6799

klasse zugewiesene Vermögen minus die der betreffenden Aktienklasse zugewiesene Passiva durch die Zahl der an einem
Bewertungstag im Umlauf befindlichen ausgegebenen Aktien derselben Aktienklasse geteilt wird. 

Falls eine materielle Änderung der Kurse in den Märkten seit Handelsschluss stattgefunden hat, in denen ein wesent-

licher Teil der Investitionen, die einem jeweiligen Subfonds zugewiesen sind, notiert werden, kann die Gesellschaft, im
Interesse der Aktionäre die erste Wertbestimmung annullieren und eine zweite Wertberechnung durchführen. Jeder
eingegangene Antrag auf Zeichnung oder Rückkauf um an der ersten Wertbestimmung getätigt zu werden, werden an
der zweiten Wertbestimmung getätigt. 

Im Falle der Schaffung einer neuen Subfonds, werden die gesamten Vermögenswerte, welche jeder Aktienklasse in

diesem Subfonds zugeteilt werden, durch die Multiplikation der Anzahl der Aktien einer Klasse welche in diesem Sub-
fonds ausgegeben wurden, welche ausgegeben wurden, mit den anwendbaren Erstausgabepreis, berechnet, und werden
nachher infolge von Aktienausgaben und -rückkaufen angepasst, gemäss dem erhaltenen oder bezahlten Betrag.

Die Bewertung des Nettovermögenswertes pro Aktie der verschiedenen Aktienklassen wird wie folgt ausgeführt: 
a) Als Vermögenswerte der Gesellschaft gelten:
I) alles Bargeld, welches sich in der Kasse oder auf einem Bankkonto befindet;
II) Rechnungen, Zahlungsaufforderungen, welche auf Sicht zahlbar sind oder fällige Abrechnungen darstellen, im vor-

aus bezahlte Kosten, Dividenden, angefallene und noch nicht aufgelaufene Zinsen; als Wert wird der ganze Nennwert
angenommen, ausser wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass dieser Wert voll bezahlt werden wird oder eingenom-
men werden kann, wobei in diesem Falle der Wert nach Abzug eines Betrages, der als angemessen angesehen wird, be-
stimmt wird;

 III) Wertpapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der/die regelmässig

operiert, vom Publikum anerkannt und dem Publikum zugänglich ist («anerkannter Markt»), werden zum letzten verfüg-
baren Verkaufskurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen notiert, ist der letzte verfügbare Verkaufskurs
an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für jenes Wertpapier ist;

 IV) falls der letzte verfügbare Verkaufskurs in der Auffassung des Verwaltungsrates nicht marktgerecht sind, werden

diese Wertpapiere zum wahrscheinlichen Verkehrswert bewertet, wie ihn der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben
festlegt;

V) Wertpapiere, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anerkannten geregelten und dem Publikum

zugänglichen Markt gehandelt werden, werden auf des Basis des wahrscheinlichen Verkaufserlöses bewertet, wie ihn
der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt;

VI) Der Liquidationswert für Terminware, Terminabschlüsse oder Optionsscheinen welche nicht an einer Börse oder

an einem anerkannten geregelten Markt notiert werden, entspricht ihren Nettoliquidationswert, so wie er bestimmt
wird anhand der vom Verwaltungsrat festgelegten Politik, welche systematisch angewandt wird für jede Vertragskate-
gorie. Der Liquidationswert für Terminware, Terminabschlüsse oder Optionsscheinen welche an einer Börse oder an
einem anerkannten geregelten Markt notiert werden entspricht dem zuletzt verfügbaren bezahlten Kurs für diese Ver-
träge auf denjenigen Märkten, wo jeweils die Terminware, Terminabschlüsse oder Optionsscheinen gehandelt werden;
falls eine Terminware, ein Terminabschluss oder ein Optionsvertrag an dem Tage, der als Bewertungstag zwecks der
Berechnung des Vermögenswertes gilt, nicht liquidiert werden kann, wird der Liquidationswert eines solchen Vertrages
vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festgelegt.

Vermögenswerte, welche auf eine andere Devise als die Referenzwährung in der die Aktien des betreffenden Sub-

fonds lauten, werden nach dem um 15.00 Uhr Luxemburger Zeit des entsprechenden Bewertungstages an einem aner-
kannten Markt geltenden Wechselkurs umgerechnet.

b) Als Verpflichtungen der Gesellschaft werden betrachtet:
I) alle Anleihen, angefallene Wechsel und fällige zu bezahlende Abrechnungen;
II) sämtliche fällige und zahlbare Verwaltungskosten (darin einschliesslich Kosten für das Portfoliomanagement, Ver-

treibungskosten, Kosten für die Depotbank, den administrativen Agenten und den Registrier- und Transferagenten);

III) alle bekannten, fälligen oder noch nicht fälligen Verbindlichkeiten, darin einbegriffen sämtliche fälligen vertraglichen

Verpflichtungen, welche eine Zahlung in bar oder in Naturalien vorsehen

IV) angemessene von Verwaltungsrat bestimmte Rückstellungen für zukünftig fällige Steuern, die auf das Vermögen

und Einkommen bis zum Handelstag der dem Bewertungstag vorausgeht, basieren, und andere durch den Verwaltungs-
rat genehmigte oder gebilligte Reserven, falls vorhanden, insbesondere diejenigen für die mögliche Entwertung der An-
lagen der Gesellschaft;

V) alle anderen Verpflichtungen der Gesellschaft, welcher Natur und Art sie auch seien, abgesehen von solchen die

durch die Aktien der Gesellschaft dargestellt werden. Um den Betrag dieser anderen Verpflichtungen zu bestimmen be-
rücksichtigt die Gesellschaft alle von ihr zu tragenden und erwachsenen Ausgaben und, darin einbegriffen, die Vergütun-
gen und Kosten für die Depotbank, den administrativen Agenten und den Registrier- und Transferagenten, den/die
Anlageberater (falls vorhanden), Portfoliomanagern; die Steuern und Kosten für Rechtsberatung und Prüfung der Jah-
resberichte, die Kosten der Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, die Druckkosten der Aktienzertifikate,
der Aktionärsberichte, der Prospekte, angemessene Vertriebs- und Werbekosten, die Kosten für das Vorbereiten, das
Übersetzen und das Drucken in verschiedenen Sprachen, alle angemessenen Out-of-Pocket Kosten der Direktoren, Re-
gistrierungsgebühren und andere den Überwachungsbehörden in den betreffenden Gerichtsbarkeiten zu zahlenden Ko-
sten, Versicherungskosten, Zinsen, Brokergebühren und die Kosten zur Veröffentlichung des Nettovermögenswertes
der Aktien jedes Subfonds. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und sonstige Kosten regelmässiger oder wiederkehren-
der Art auf der Grundlage geschätzter Zahlen für jährliche oder andere Perioden im voraus ansetzen und kann diese in
gleichen Raten über einen solchen periodischen Zeitraum zusammenfassen.

In den Beziehungen zwischen den Aktionären wird jeder Subfonds als eine einzelne juristische Einheit behandelt.

6800

Drittpersonen gegenüber stellt die Gesellschaft eine einzige juristische Einheit dar und jede Verpflichtung bindet die

ganze Gesellschaft. welchem Subfonds die Verpflichtungen auch zugeschrieben werden können, ausser wenn anders mit
einer Gegenpartei vereinbart wurde. Die Vermögenswerte, Verpflichtungen, Kosten und Ausgaben, welche keinem spe-
zifischen Subfonds zugerechnet werden können, werden den verschiedenen Subfonds pro rata ihres jeweiligen Netto-
vermögens zugerechnet, falls die betreffenden Beträge dies als angemessen erscheinen lassen.

Aktien, die im Begriff sind, von der Gesellschaft zurückgekauft zu werden, gelten als ausgegeben bis zum Geschäfts-

schluss des jeweiligen Bewertungstages, welcher auf den Rückkauf anwendbar ist. Der Preis der Aktien, die zurückge-
kauft worden sind, gilt als Verbindlichkeit der Gesellschaft ab dem Geschäftsschluss des besagten Tages bis zur Zahlung:
Im Zusammenhang mit eingegangenen Kaufaufträgen ausgegebene Aktien gelten ab Geschäftsschluss am jeweilig für die
Zeichnung anwendbaren Bewertungstag als ausgegebene Aktien. Der Ausgabepreis gilt als Forderung der Gesellschaft
an den Zeichner ab dem Geschäftsschluss des besagten Tages und so lange, bis dieser Preis bezahlt ist.

Soweit als möglich gehen alle Anlagen und Verkäufe, welche durch die Gesellschaft bis zu einem Bewertungstag be-

schlossen und vollzogen werden in die Bewertung ein.

Art. 13. Ausgabe, Rückkauf und Umtausch von Aktien.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, zu jeder Zeit weitere voll eingezahlte Aktien jeder Aktienklasse und von jedem

Subfonds auszugeben, und zwar zu einem Preis, der auf dem gemäss Artikel 12 dieser Satzung berechneten Nettover-
mögenswert pro Aktie des betreffenden Subfonds und Aktienklasse, und zu einem Bewertungsdatum, das entsprechend
der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit bestimmten Politik festgelegt wird. Dieser Preis ist zuzüglich eventuell anfal-
lender Rückkaufgebühren und einer prozentualen Provision für bei der Investition des Ertrages anfallende Kosten, wie
von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat festgelegt. 

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Angestellten der Gesellschaft oder andere Per-

sonen ermächtigen, Zeichnungen anzunehmen und den Preis für die neuen Aktien entgegenzunehmen.

Um gültig zu sein muss jede neue Zeichnung von Aktien voll eingezahlt sein; die ausgegebenen Aktien haben dieselben

Rechte wie diejenigen Aktien, welche am Tage der Aktienausgabe in Umlauf waren.

Falls der Verwaltungsrat bestimmt, dass die Annahme einer Zeichnung von Aktien eines Subfonds, deren Wert mehr

als 10% der Nettovermögens dieses Subfonds darstellt, die bestehenden Aktionären dieses Subfonds schaden kann, kann
er die Annahme der Zeichnung aufschieben, und in Absprache mit dem neuen Aktionär, ihn dazu auffordern, die Zeich-
nung über einen bestimmten Zeitraum zu staffeln.

Die Gesellschaft kann eine Zeichnung teilweise oder ganz zurückweisen, und der Verwaltungsrat kann, nach eigenem

Ermessen, und ohne Haftung und ohne vorherige Ankündigung, die Ausgabe und den Verkauf von Aktien jeder Aktien-
klasse und jedes Subfonds abbrechen.

Jeder Aktionär hat das Recht, den Rückkauf von allen oder einem Teil seiner Aktien durch die Gesellschaft, zu den

vom Verwaltungsrat festgelegten und im Prospekt veröffentlichen Bedingungen, und mit den Einschränkungen dieses Ar-
tikels 13. Der Rückkaufspreis wird binnen einer vom Verwaltungsrat bestimmten Frist, die zehn Arbeitstage vom be-
treffenden Bewertungsdatum an dem der anwendbare Nettowert der Aktien bestimmt wurde, nicht überschreiten darf,
ausbezahlt, falls die Aktienzertifikate der Gesellschaft übergeben worden sind. Der Rückkaufspreis ist gleich dem Net-
towert der Aktien der betreffenden Aktienklasse und Subfonds zu dem die Aktien gehören, so wie dieser gemäss den
Bestimmungen des Artikels 12 bestimmt wird, gegebenenfalls abzüglich einer Provision und Kosten, wie sie im Prospekt
beschrieben sind. Jeder Rückkaufsantrag muss durch den Aktionär schriftlich am Firmensitz der Gesellschaft in Luxem-
burg oder bei anderen natürlichen oder juristischen Personen, die von der Gesellschaft als bevollmächtigt für den Rück-
kauf der Aktien bestimmt wurden, eingereicht werden. Die Aktienzertifikate, falls solche ausgegeben wurden, müssen
dem Antrag beigefügt sein. Der entsprechende Rückkaufpreis kann nach Ermessen des Verwaltungsrates bis zu maximal
drei Dezimalstellen auf- oder abgerundet werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit dafür sorgen, dass jeder Subfonds über genügende Liquiditäten verfügt, um die Aus-

führung der Rückkaufanträge zu ermöglichen.

Sollte, als Konsequenz eines Rückkaufsantrages der Gesamtnettovermögenswert pro Aktie der Aktien einer be-

stimmten Aktienklasse die ein Aktionär besitzt, unter einem gewissen vom Verwaltungsrat festgelegten Betrag fallen,
kann die Gesellschaft den Antrag als einen Rückkaufantrag aller Aktien dieser Klasse, die jener Aktionär besitzt, ansehen.

Falls ausserdem an einem bestimmten Datum die Anzahl der Rückkaufanträge gemäss diesem Artikel 13 und der Um-

tauschanträge einen gewissen Grenzwert, der durch den Verwaltungsrat, im Verhältnis zu den ausgegebenen Aktien ei-
ner Aktienklasse, festgelegt wird, überschreitet, kann der Verwaltungsrat die Hinausschiebung oder der Umtausch eines
Teils oder aller derartigen Anträge beschliessen, und zwar für einen Zeitabschnitt und in einer Art und Weise die der
Verwaltungsrat als die besten für die Interessen der Gesellschaft ansieht. Am ersten Bewertungsdatum, der diesem Zeit-
abschnitt folgt, werden die betroffenen Rückkauf- und Umtauschanträge mit Vorrang behandelt.

Die Gesellschaft hat das Recht, falls der Verwaltungsrat es so bestimmt, und mit dem Einverständnis des betroffenen

Aktionärs, der Zahlung des Rückkaufes Genüge zu tun, indem sie den betreffenden Aktionär mit Papieren aus dem In-
vestmentpool der betreffenden Aktienklasse bezahlt, im Wert der zurückgekauften Aktien, (so wie er anhand des Arti-
kels 12 festgelegt wird ist), und zwar am Bewertungstdatum an dem der Rückkaufpreis berechnet wird. Die
Charakteristika und der Typ der Papiere die auf dieser Weise übergeben werden, werden auf einer fairen und vernünf-
tigen Art bestimmt, die die Interessen der anderen Aktionäre des betreffenden Subfonds nicht schaden darf, ferner muss
die angewandte Bewertung von einem externen Auditor bestätigt werden. Etwaige anfallende Kosten des Transfers ge-
hen zu Lasten des Erwerbers.

Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert.
Jeder Aktionär kann innerhalb einer Aktienklasse den Umtausch aller oder eines Teiles seiner Aktien eines bestimm-

ten Subfonds in Aktien eines anderen Subfonds verlangen, wobei der Verwaltungsrat die Bedingungen festlegen kann.
Der Verwaltungsrat kann:

6801

a) die Termine und Bedingungen was das Recht zum Umtausch sowie die Häufigkeit eines Umtauschs zwischen Sub-

fonds angeht; 

b) die Zahlung von Kosten und Kommissionen festlegen und zur Bedingung für einen Umtausch machen.
Sollte, als Konsequenz des Umtauschantrages der Gesamtnettovermögenswert pro Aktie der Aktien einer bestimm-

ten Aktienklasse die ein Aktionär besitzt, unter einem gewissen vom Verwaltungsrat festgelegten Betrag fallen, kann die
Gesellschaft den Antrag als einen Umtauschantrag aller Aktien dieser Klasse, die jener Aktionär besitzt, ansehen.

Der Umtausch wird zu einem Preis, der auf dem Nettowert pro Aktie des betreffenden Subfonds, gemäss Artikel 12

dieser Satzung berechnet wird, durchgeführt. Die anwendbare Anzahl von Aktien wird gegebenenfalls ab- oder aufge-
rundet, bis zu einem Maximum von drei dezimalen Stellen so wie der Verwaltungsrat es bestimmt.

Die umgetauschten Aktien werden in dem alten Subfonds annulliert. Die Anträge auf Zeichnung, Rückkauf, und Um-

tausch von Aktien werden an den vom Verwaltungsrat festgelegten Stellen angenommen. 

Art. 14. Einstellung der Berechnung des Nettovermögenswertes sowie der Ausgabe, des Rückkaufs

und des Umtauschs von Aktien.

Die Gesellschaft ist dazu befugt, zeitweilig die Berechnung des Nettovermögenswertes eines oder mehrere Subfonds,

die Ausgabe, den Umtausch sowie den Rückkauf von Aktien eines oder mehreren Subfonds der Gesellschaft in den fol-
genden Fällen einzustellen

a) während jedem Zeitraum., in welchem eine Börse oder ein Hauptmarkt, an dem/der ein wesentlicher Teil der An-

lagen der Gesellschaft notiert wird, geschlossen ist, oder der Handel ausgesetzt oder eingeschränkt ist, ausser wegen
gewöhnlichen Wochenenden und Feiertagen, vorausgesetzt solche Einschränkungen beeinflussen die Bewertung der In-
vestitionen des betreffenden Subfonds der Gesellschaft;

b) falls ein Zustand besteht der in der Meinung der Direktoren als ein Notfall einzustufen ist, in der Hinsicht wo die

Veräusserung oder die Bewertung der Aktiva des betreffenden Subfonds undurchführbar ist; 

c) falls die Kommunikationsmittel und Datenverarbeitungssysteme, die normalerweise zur Bestimmung des Wertes

der Anlagen der Gesellschaft oder der aktuellen Preise auf den Märkten oder Börsen zu gebraucht werden, ausser Be-
trieb sind;

d) falls die Gesellschaft die Übertragung von Erträgen, zum Zwecke der Zahlung von Rückkäufen des jeweiligen Sub-

fonds nicht durchführen kann, oder wenn ein Geldtransfer zum Zwecke der Verwirklichung oder des Erwerbes von
Investitionen oder wegen Rückkäufen in der Meinung des Verwaltungsrates nicht zu normalen Wechselkursen durch-
geführt werden kann;

e) wenn aus irgendeinem anderen Grund der Wert einer dem betreffenden Subfonds zuzuweisenden Investition nicht

rasch und genau festgelegt werden kann; oder

f) ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Einberufung zu einer Generalversammlung, in der über die Auflösung

der Gesellschaft Beschluss gefasst werden soll.

Die Aufhebung eines Subfonds hat keinen Einfluss auf die Berechnung des Nettovermögenswertes pro Aktie oder die

Ausgabe, den Rückkauf oder den Umtausch von Aktien anderer Subfonds, die nicht aufgehoben worden sind. 

Unter aussergewöhnlichen Bedingungen. welche die Rechte der Aktionäre nachteilig beeinflussen können, behält sich

der Verwaltungsrat das Recht vor, erst die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren durchzuführen, bevor der Preis,
zu dem die Aktionäre einen Rückkauf oder den Umtausch ihrer Aktien verlangen können, bestimmt wird. In einem sol-
chen Fall werden schwebende Anträge zur Zeichnung, Rückkauf und Umtausch auf der Basis des derart nach den not-
wendigen Verkäufen berechneten Nettovermögenswertes.

Zeichner und Aktionäre, die einen Rückkauf oder einen Umtausch beantragt haben, werden von der Einstellung der

Berechnung des Nettovermögenswertes pro Aktie benachrichtigt.

Die Einstellung der Berechnung des Nettovermögenswertes pro Aktie kann durch angemessene Mittel veröffentlicht

werden, falls ihre Dauer eine gewisse Zeitspanne überschreitet.

Schwebende Anträge auf eine Zeichnung, einen Rückkauf und einen Umtausch von Aktien können durch schriftliche

Benachrichtigung zurückgezogen werden, unter der Bedingung, dass die Gesellschaft die entsprechende Benachrichti-
gung vor dem Ende des Schwebezustandes erhält. 

Derart schwebende Anträge auf eine Zeichnung, einen Rückkauf und einen Umtausch von Aktien werden am ersten

Bewertungstag nach der Wiederaufnahme der Berechnung des Nettovermögenswertes pro Aktie durch die Gesellschaft
getätigt.

4. Generalversammlung

Art. 15. Allgemeine Bestimmungen. 
Die ordnungsgemäss gebildete Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Ge-

sellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu
bestätigen.

Art. 16. Jährliche Generalversammlung.
Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre wird gemäss der luxemburgischen Gesetzgebung in Luxemburg, am

Firmensitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der in der Einberufung festgelegt wird, am zwei-
ten Dienstag im Mai jeden Jahres um 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) abgehalten, und zum erstenmal im Jahre 2002. Falls
dieser Tag auf einen Bankfeiertag fällt, wird die jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden Bankarbeitstag
abgehalten. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach ei-
genem Ermessen feststellt, dass Umstände höherer Gewalt dies erfordern.

Andere Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in der Einberufung zur je-

weiligen Versammlung angegeben ist. 

6802

Art. 17. Generalversammlungen von Aktionären von Aktienklassen.
Die Aktionären der Aktienklasse in einem bestimmten Subfonds können zu jeder Zeit eine Generalversammlung ein-

berufen, um über Angelegenheiten, welche ausschliesslich jene Aktienklasse in jenem Subfonds betreffen, zu entschei-
den. Ausserdem können die Aktionäre einer Aktienklasse zu jeder Zeit eine Generalversammlung einberufen, um über
Angelegenheiten, welche ausschliesslich jene Aktienklasse betreffen, zu entscheiden. Es gelten die Regeln die in dieser
Satzung vorgesehen sind, sowie das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915, so wie es danach abgeändert worden
ist und werden wird.

Art. 18. Funktionsweise der Generalversammlungen. 
Die Einberufungen, sowie das Quorum und die Fristen, sowie der Ablauf der Versammlungen der Aktionäre müssen,

soweit die vorliegende Satzung nichts anderes bestimmt, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Jede Aktie gibt ungeachtet der Klasse und des Subfonds, denen sie angehört, das Recht auf eine Stimme unter Vor-

behalt der Einschränkungen, die durch die vorliegende Satzung verfügt werden. Jeder Aktionär kann an den Versamm-
lungen der Aktionäre teilnehmen, indem er schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax eine andere Person
als seinen Bevollmächtigten angibt. Teile einer einzelnen Aktie geben kein Anrecht auf eine Stimme.

Sofern das Gesetz oder die vorliegende Satzung nichts Gegenteiliges anordnen, werden die Entscheidungen der ord-

nungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und
mitbestimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um an den Generalver-

sammlungen teilnehmen zu können.

Ausserdem werden die Aktionäre jeder Klasse und jedes Subfonds getrennt beraten und unter den gesetzlich vorge-

sehenen Quorums- und Mehrheitsbedingungen über folgende Punkte abstimmen: 

1. Gewinnverwendung ihres Subfonds und ihrer Aktienklasse; und 
2. Entscheidungen, welche die Rechte der Aktionäre einer Aktienklasse oder eines Subfonds gegenüber anderen Ak-

tienklassen und/oder Subfonds betreffen.

Art. 19. Einberufungen zu den Generalversammlungen. 
Die Aktionäre werden durch den Verwaltungsrat einberufen. Soweit gesetzlich erforderlich, wird das Einberufungs-

schreiben im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations in Luxemburg sowie in einer luxemburgischen Zeitung
und in anderen, vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen veröffentlicht.

5. Verwaltung der Gesellschaft

Art. 20. Verwaltung. 
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, verwaltet ; die Ver-

waltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein.

Art. 21. Dauer des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder, Erneuerung des Verwaltungsrats.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Generalversammlung für einen Zeitraum, der sechs Jahre nicht

überschreiten kann, gewählt. Sie bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt wurden und im Amt stehen. Ein Verwal-
tungsratsmitglied kann mit oder ohne Begründung jederzeit durch eine Entscheidung der Generalversammlung abberu-
fen und ersetzt werden.

Im Falle einer Vakanz eines Verwaltungsratsmitgliedes aufgrund von Tod, Pension oder aus einem anderen Grund

können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung einberufen und durch eine mehrheitliche Abstimmung
ein Verwaltungsratsmitglied bestimmen um diese Vakanz auf einer provisorischen Basis bis zur nächsten Generalver-
sammlung zu füllen. 

Art. 22. Präsidium des Verwaltungsrats. 
Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden sowie einen oder mehrere stellvertretende

Vorsitzenden wählen. Ferner kann er einen Sekretär ernennen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und der
verantwortlich ist für die Redaktion der Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen
der Aktionäre. 

Art. 23. Versammlungen und Beratungen des Verwaltungsrats. 
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern an dem Ort, das in dem Ein-

berufungsschreiben angegeben ist, einberufen.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats steht jeder der Versammlungen des Verwaltungsrats und der Aktionäre vor,

in seiner Abwesenheit können jedoch die Aktionäre oder der Verwaltungsrat mit einfacher Mehrheit ein anderes Ver-
waltungsratsmitglied zum Vorsitzenden der Versammlung ernennen. Bei einer Generalversammlung an der kein Verwal-
tungsratsmitglied anwesend ist, kann jede andere Person ernannt werden, um den Vorsitz dieser Versammlung zu
übernehmen. Der Verwaltungsrat kann Direktoren der Gesellschaft ernennen, auch einen Generaldirektor, beigeord-
nete Direktoren, beigeordnete Sekretäre und andere Bevollmächtigte, die für die Angelegenheiten der Gesellschaft zu
führen als nötig empfunden werden. Solche Ernennungen können zu jedem Zeitpunkt durch den Verwaltungsrat zurück-
gezogen werden. Die Direktoren und Bevollmächtigten brauchen keine Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre der
Gesellschaft zu sein. Sofern die Satzung es nicht anderes vorsieht, haben die Direktoren und Bevollmächtigten diejenigen
Vollmachten und Pflichten, die ihnen vom Verwaltungsrat erteilt worden sind.

Eine schriftliche Einberufung zu jeder Versammlung des Verwaltungsrats wird an alle Verwaltungsratsmitglieder min-

destens drei Tage vor der Stunde, die für die Versammlung vorgesehen ist, ausgegeben, ausser im Falle einer Dringlich-
keit, wobei in diesem Fall die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden. Ein
Einberufungsschreiben ist nicht notwendig, falls jedes Verwaltungsratsmitglied dazu seine schriftliche Zustimmung, durch
Kabel, Telegramm, Telex, oder Telefax gegeben hat. Für eine Versammlung des Verwaltungsrats, die zu einer Stunde

6803

und an einem Ort abgehalten wird, welche in einer Entscheidung, die vorher durch den Verwaltungsrat angenommen
wurde, festgelegt worden sind, ist eine besondere Einberufung nicht notwendig.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Versammlung des Verwaltungsrats durch ein schriftlich, durch Kabel, Te-

legramm, Telex oder Telefax bevollmächtigtes anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Verwaltungsratsmit-
glied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied, das nicht physisch am Versammlungsort anwesend ist, kann an einer solchen Ver-

sammlung per Telefonkonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel, bei denen alle an der Versammlung teilnehmen-
den Personen sich gegenseitig hören können, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung durch solche Mittel ist
der persönlichen Anwesenheit an einer solchen Versammlung gleichgestellt.

Die Gesellschaft kann nicht durch die einzelne Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds verpflichtet werden, es

sei denn es besitzt eine ausdrückliche Vollmacht durch einen Beschluss des Verwaltungsrats.

Gültig verhandeln und handeln kann der Verwaltungsrat nur, wenn mindestens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglie-

der bei der Versammlung des Verwaltungsrates anwesend oder vertreten ist. Entscheidungen werden durch die einfache
Mehrheit der Stimmen der anwesenden beziehungsweise vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen. Der Vorsit-
zende des Verwaltungsrates hat die ausschlaggebende Stimme.

Von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterschriebene Entscheidungen sind ebenso gültig und durchführbar wie

jene, die während einer ordnungsgemäss einberufenen und durchgeführten Versammlung getroffen werden. Diese Un-
terschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehrere Kopien gemacht werden und können durch Brief,
Kabel, Telegramm, Telex, Telefax und ähnliche Mittel belegt werden. Als Datum eines solchen Beschlusses gilt das Da-
tum der letzten Unterschrift.

Was die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie Handlungen im Rahmen der Gesellschaftspolitik und des Gesell-

schaftszweckes angeht, kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse an juristische Personen oder an natürliche Personen,
die nicht Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen, delegieren. 

Art. 24 Versammlungsprotokolle.
Die Versammlungsprotokolle der Versammlungen des Verwaltungsrats werden durch den Vorsitzenden oder, in sei-

ner Abwesenheit, durch dasjenige Verwaltungsratsmitglied, das den Vorsitz übernommen hat, unterschrieben. 

Abschriften oder Auszüge von Protokollen, die vor Gericht oder anderswo vorgelegt werden sollen, werden durch

den Vorsitzenden, den Sekretär oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben. 

Art. 25. Vertretung der Gesellschaft gegenüber Drittpersonen. 
Rechtlich gebunden wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

oder durch die einzelne Unterschrift eines Direktors oder Bevollmächtigten der Gesellschaft, der die entsprechende
Vollmacht erhalten hat, oder durch die einzelne Unterschrift jeder anderen Person, der der Verwaltungsrat eine ent-
sprechende Vollmacht gegeben hat.

Art. 26. Befugnisse des Verwaltungsrats. 
Der Verwaltungsrat bestimmt, durch die Anwendung des Prinzips der Risikoverteilung, die generelle Linie der Ver-

mögensverwaltung und die Investitionspolitik ebenso wie die Richtlinien, die in der Verwaltung der Gesellschaft zu be-
folgen sind. 

Art. 27. Interessenkollisionen.
Kein Vertrag und kein Vergleich, den die Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder Firma schliesst, kann durch

die Tatsache, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren oder Bevollmächtigte der Gesellschaft ir-
gendwelche Interessen in jener anderen Gesellschaft oder Firma haben beeinträchtigt oder ungültig gemacht werden.

Ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, welcher lediglich Verwaltungsratsmit-

glied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter einer anderen Gesellschaft oder Firma ist, mit der die Gesellschaft
einen Vertrag schliesst oder in einer anderen Weise in geschäftliche Beziehungen tritt, verliert dadurch nicht das Recht,
zu beraten, abzustimmen und zu handeln, was die Angelegenheiten, die mit einem solchen Vertrag oder solchen Ge-
schäftssachen in Verbindung stehen, anbetrifft.

Falls ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter ein persönliches Interesse in irgendeiner Angele-

genheit der Gesellschaft hat, muss dieses Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Gesellschaft den
Verwaltungsrat von diesem persönlichen Interesse informieren, und wird weder mitberaten noch am Votum über diese
Angelegenheit teilnehmen. Ein Bericht über diese Angelegenheit und über das persönliche Interesse des Verwaltungs-
ratsmitglieds, Direktors oder Bevollmächtigten wird bei der nächsten Versammlung der Aktionäre erstattet.

Der im vorstehenden Absatz verwendete Begriff «persönliches Interesse» findet keine Anwendung auf Beziehungen

und Interessen, die LaSALLE Gesellschaftsgruppe, deren Tochtergesellschaften oder verbundene Gesellschaften oder
jeder anderen von dem Verwaltungsrat nach freiem Ermessen benannten Gesellschaft oder Firma betreffen. 

Art. 28 Entschädigung der Direktoren.
Die Gesellschaft kann jedem Direktor oder Bevollmächtigten, seinen Erben, Vollstrecker und Administratoren die

eingegangenen vernünftigen Ausgaben im Rahmen seiner Handlungen, die er in seiner Eigenschaft als Verwaltungsrats-
mitglied oder Bevollmächtigter der Gesellschaft durchgeführt hat oder, auf Bitte der Gesellschaft, falls jene ihn nicht ent-
schädigt, als Verwaltungsratsmitglied oder Bevollmächtigter einer anderen Gesellschaft in welcher die Gesellschaft
Aktionär ist, durchgeführt hat, vergüten. Dies beinhaltet nicht jene Handlungen für deren Fahrlässigkeit oder Misswirt-
schaft oder andere Pflichtverletzungen das Verwaltungsratsmitglied oder Bevollmächtigte haften muss aufgrund eines
gerichtlichen Beschlusses, oder eine solche Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft oder andere Pflichtverletzungen aner-
kannt worden ist. Im Falle einer Schlichtung betrifft die Vergütung lediglich jene Angelegenheiten, in denen die Gesell-

6804

schaft sich Rat geholt hat und feststellen kann, dass sie die Pflichtverletzungen nicht betreffen. Das Recht auf Vergütung
schliesst keine anderen Ansprüche seitens dieser Personen aus. 

Art. 29 Vergütungen des Verwaltungsrats. 
Die Generalversammlung kann den Verwaltungsratsmitgliedern, als Entgelt für die geleisteten Dienste, eine feste jähr-

liche Summe als Vergütungen zuteilen; solche Summen werden als allgemeine Ausgaben der Gesellschaft verbucht und
werden durch den Verwaltungsrat nach freiem Ermessen unter seinen Mitgliedern aufgeteilt.

Ausserdem können den Verwaltungsratsmitgliedern die von ihnen in Bezug auf die Gesellschaft getätigten Ausgaben

vergütet bekommen, sofern sie angemessen sind.

Die Vergütung des Vorsitzenden und des Sekretärs des Verwaltungsrats sowie diejenigen der Generaldirektoren und

Bevollmächtigte werden durch den Verwaltungsrat festgelegt.

Art. 30 Anlageberater, Anlageverwalter, Depotbank und andere Vertragsparteien.
Die Gesellschaft kann einen Anlageberatervertrag abschliessen, um bei der Verwaltung ihres Portfolios Beratung und

Beistand zu erhalten. Sie kann ebenfalls mit einem oder mehreren Anlageverwaltern Verwaltungsverträge abschliessen.

Ausserdem kann die Gesellschaft auf Serviceverträge mit andern Parteien eingehen. Dies beinhaltet unter anderem

den Einsatz eines Zentralverwalters für die Verwaltung und die Domizilierung der Gesellschaft, der die Rolle der «ad-
ministration centrale» im Sinne des Rundschreibens des «Institut Monétaire Luxembourgeois» n

°

 1991/75 vom 21. Ja-

nuar 1991 übernimmt.

Die Gesellschaft wird mit einer Bank (im folgenden «Depotbank»), die den Anforderungen des Gesetzes vom 30.

März 1988, so wie es abgeändert worden ist und werden wird, betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen,
gerecht wird einen Depotbankvertrag abschliessen. Alle übertragbaren Wertpapiere und das Bargeld der Gesellschaft
werden von der Depotbank oder für das Konto der Gesellschaft gehalten. Die Depotbank wird gegenüber der Gesell-
schaft und ihren Aktionären die gesetzlichen Verantwortungen tragen.

Falls die Depotbank den Vertrag kündigen möchte, tut der Verwaltungsrat sein Bestes, um eine andere Depotbank

zu ermitteln, welche an die Stelle der kündigenden Depotbank tritt; der Verwaltungsrat wird die betreffende Bank als
neue Depotbank ernennen. Der Verwaltungsrat ist dazu berechtigt, die Depotbank zu kündigen; eine Kündigung wird
jedoch erst wirksam, wenn eine neue Depotbank den vorgehenden Bestimmungen zufolge als Nachfolgerin ernannt
wurde.

6. Wirtschaftsprüfer

Art. 31. Wirtschaftsprüfer.
Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre Finanzlage, insbesondere ihre Buchführung werden durch einen oder meh-

rere unabhängige Wirtschaftsprüfer kontrolliert, welcher die Bedingungen erfüllt; die das Gesetz vom 30. März 1988,
so wie es abgeändert worden ist und werden wird, betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen, in Bezug auf
Seriosität und Berufserfahrung vorschreibt. Die Wirtschaftsprüfer werden von der Generalversammlung ernannt.

7. Jahresabschluss

Art. 32. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben

Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Gründungstag beginnt und am 31. Dezember 2001 endet.

Art. 33. Gewinnverwendung.
Die Aktionäre jeder Aktienklasse eines jeden Subfonds beschliessen auf der jährlichen Generalversammlung, auf Vor-

schlag des Verwaltungsrates hin, falls und wenn den Betrag der Ausschüttungen, innerhalb der Grenzen des Gesetzes
vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen, zugunsten der Aktionäre vorgenommen wer-
den.

In jedem Subfonds können, unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Beschluss des Verwaltungsrates, Zwischen-

dividenden auf Aktien ausgezahlt werden.

Ausschüttungen, die nicht innerhalb einer Frist von 5 Jahren beginnend am Datum ihrer Auszahlung gefordert wer-

den, werden ihren Nutzniessern aberkannt und dem entsprechendem Subfonds zugesprochen.

8. Auflösung und Liquidation

Art. 34 Auflösung der Gesellschaft.
Zu jeder Zeit kann die Generalversammlung durch einen mit dem Quorum, wie es im Artikel 18 festgelegt ist, ge-

stimmten Beschluss die Gesellschaft auflösen.

Sobald das Kapital der Gesellschaft unter den zwei Dritteln des Mindestkapitals, so wie es vom luxemburgischen Ge-

setz vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen vorgesehen wird, fällt, muss der Verwal-
tungsrat die Frage der etwaigen Auflösung den Aktionären in der Generalversammlung unterbreiten. Diese
Generalversammlung, für die kein Quorum nötig ist, wird mit einfacher Mehrheit der an der Versammlung anwesenden
oder vertretenen Aktien entscheiden.

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird auch an die Hauptversammlung von Aktionären weitergeleitet werden,

sobald das Kapital unter einem Viertel des Mindestkapitals fällt, wie durch das Gesetz vom 30. März 1988 betreffend die
Organismen für gemeinsame Anlagen vorgesehen.

In diesem Fall, wird die Hauptversammlung ohne Beschlussfähigkeitsauflagen abgehalten und die Auflösung kann von

den Aktionären die ein Viertel der anwesenden oder vertretenen Aktien halten, beschlossen werden.

Die Versammlung muss innerhalb einer Frist von vierzig Tagen vom Tag der Feststellung der Tatsache, dass die Net-

tovermögenswerte der Gesellschaft unter zwei Drittel oder einen Viertel des gesetzlichen Minimums gefallen sind, je
nachdem, einberufen werden.

6805

Die Ausgabe neuer Aktien durch die Gesellschaft wird am Tag der Veröffentlichung der Einberufung zur Versammlung

der allgemeinen Aktionäre, an der die Auflösung und die Liquidierung der Gesellschaft vorgeschlagen werden wird, ein-
gestellt.

In diesem Fall werden ein oder mehrere Liquidatoren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt, um unter

der Aufsicht der relevanten überwachenden Behörde die Vermögenswerte der Gesellschaft in den besten Interessen
der Aktionäre zu veräussern. 

Der Erlös der Liquidation jedes Subfonds wird von den Liquidatoren netto abzüglich aller Liquidationsausgaben, unter

den Inhabern von Aktien in jeder Klasse in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Rechten verteilt werden. Die Summen,
die am Ende des Liquidationsprozesses von Aktionären nicht gefordert werden, werden, in Übereinstimmung mit der
luxemburgischen Gesetzesgebung, in der Caisse des Consignations in Luxemburg deponiert. bis die gesetzliche Verjäh-
rung eingetreten ist.

Art. 35. Schluss, Teilung und Verschmelzung von einzelnen Subfonds.
Der Verwaltungsrat kann zu jedem Moment den Schluss, die Teilung und/oder die Verschmelzung irgendeines einzel-

nen Subfonds entscheiden. Im Fall vom Schluss eines einzelnen Subfonds kann der Verwaltungsrat den Aktionären sol-
cher einzelne Subfonds die Umwandlung ihrer Aktien in Aktien einer anderen Klasse eines anderen Subfonds
vorschlagen, und zwar unter den Bedingungen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden.

Falls aus irgendeinem Grund der Wert des Nettovermögens eines Subfonds oder irgendeiner Klasse von Aktien in-

nerhalb eines einzelnen Subfonds in einem Masse, das von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat bestimmt wird, abgenommen
hat, so dass eine wirtschaftlich effiziente Bedienung der Klasse dieses Subfonds von Aktien nicht mehr möglich ist, oder
wenn eine Änderung in der wirtschaftlichen oder politischen Situation in Beziehung mit einem Subfonds materiell un-
günstige Folgen auf die Anlagen dieses einzelnen Subfonds haben könnte, kann der Verwaltungsrat den zwangsweisen
Rückkauf sämtlicher Aktien der betreffenden Klassen entscheiden, und zwar zum Nettovermögenswert der Aktien, un-
ter Berücksichtigung der eigentlichen Verwirklichungspreise von Anlagen und Verwirklichungsausgaben und basierend
auf den Wertschätzungstag, an dem eine solche Entscheidung in Kraft tritt.

Vor dem Tag des Inkrafttretens des verbindlichen Rückkaufs benachrichtigt die Gesellschaft die betroffenen Aktionä-

re der relevanten Klassen von Aktien, und gibt in dieser Benachrichtigung die Gründe des verbindlichen Rückkaufs und
das Verfahren der Rückkaufsoperationen an. Im Register eingetragene Aktionäre werden per Schreiben benachrichtigt.
Ausser wenn es im Interesse der Aktionäre ist oder um eine gerechte Behandlung der Aktionären zu garantieren, anders
beschlossen wird, können Aktionäre der betroffenen Subfonds bis zum Datum, an dem der verbindliche Rückkauf wirk-
sam wird,  weiter Rückkauf-  oder Umtauschanträge kostenlos stellen, wobei die eigentlichen Veräusserungspreise und
- ausgaben der Aktien in Betracht gezogen werden. 

Ungeachtet der Vollmachten, die dem Verwaltungsrat im vorausgehenden Absatz verliehen werden, darf die Gene-

ralversammlung von Aktionären von irgendeiner oder allen Klassen von Aktien, von irgendeinem Subfonds, auf Vor-
schlag des Verwaltungsrates, alle Aktien der relevanten Klasse zurückkaufen und den Aktionären den
Nettovermögenswert pro Aktie ihrer Aktien zurückerstatten, wobei die eigentlichen Veräusserungspreise und Ausga-
ben der Anlagen berücksichtigt werden, und auf den Bewertungstag, an dem solche Entscheidung wirksam wird, berech-
net werden. Es werden keine Quora für solche Generalversammlungen von Aktionären angewandt; die Beschlüsse
werden mit der einfachen Mehrheit der an dieser Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre, angenommen.

Vermögenswerte, die nicht an ihre Besitzer nach der Durchführung des Rückkaufs ausgeschüttet werden können,

werden für sechs Monate bei der Depotbank deponiert; nach diesem Zeitraum werden die Vermögenswerte bei der
Caisse des Consignations im Namen der Besitzer deponiert.

Alle zurückgezahlten Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert.
Unter den gleichen Umständen wie im zweiten Absatz dieses Artikels 35 vorgesehen kann der Verwaltungsrat ent-

scheiden, dass die Vermögenswerte irgendeines Subfonds einem noch bestehenden Subfonds innerhalb der Gesellschaft,
oder innerhalb eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen, und nach den Bestimmungen von Teil 1 des luxem-
burgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen organisiert ist, oder einem
ihrem Subfonds (nachstehend «der neue Subfonds») zugeteilt werden, und jene Klassen von Aktien als Aktien einer an-
deren Klasse neu bezeichnen (nach einem Split oder einer Konsolidierung, falls notwendig, und der Auszahlung eines
Betrages, welcher dem Anspruch auf Bruchteile der Aktionäre entspricht). Einen Monat vor dem Datum an dem die
Verschmelzung wirksam wird, wird die Entscheidung in der gleichen Weise als vorher beschrieben veröffentlicht (und,
ausserdem wird die Veröffentlichung Informationen in Beziehung zum neuen Subfonds enthalten), um den Aktionären
zu ermöglichen, während diesem Monat den Rückkauf oder den Umtausch ihrer Aktien ohne Gebühr zu beantragen. 

Unter den gleichen Umständen dieses Artikels 35 kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass ein Subfonds oder eine

Aktienkategorie in zwei oder mehrere Subfonds oder Klassen aufgeteilt wird. Einen Monat vor dem Datum an dem die
Aufteilung wirksam wird, wird eine solche Entscheidung in der gleichen Weise als vorher beschrieben veröffentlicht
(und, ausserdem wird die Veröffentlichung Informationen in Beziehung zu den zwei oder mehreren neuen Subfonds ent-
halten), um den Aktionären zu ermöglichen, während diesem Monat den Rückkauf ihrer Aktien ohne Gebühr zu bean-
tragen.

Ungeachtet der Vollmacht, die dem Verwaltungsrat im vorausgehenden Absatz verliehen wird, kann eine Hauptver-

sammlung von Aktionären aller Aktienklassen eines bestimmten Subfonds eine Verschmelzung oder eine Teilung der
betreffenden Subfonds entscheiden; es gibt in diesem Fall kein Quorum, der Beschluss kann mit der einfachen Mehrheit
der anwesenden oder vertretenen Aktien genommen werden.

Eine Einlage der Vermögenswerte und der verteilbaren Verpflichtungen eines Subfonds in einen anderen Organismus

für gemeinsame Anlagen, wie in den vorausgehenden Absätzen beschrieben, oder in einen anderen Subfonds innerhalb
eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen kann nur unter der Bedingung eines Beschlusses der Aktionäre der
Aktien des betroffenen Subfonds, mit einem Quorum von 50 % der Aktien, die mit einer Zweidrittelmehrheit der an-

6806

wesenden oder vertretenen Aktien genommen wird, getroffen werden, es sei denn die Verschmelzung geschieht mit
einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen, auf vertraglicher Basis (fonds commun de placement),
oder einem im Ausland domizilierten Organismus für gemeinsame Anlagen, wobei in diesem Fall der Beschluss nur für
diejenigen Aktionäre bindend ist, die für eine solche Verschmelzung gewählt haben.

Art. 36. Liquidation.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche

oder juristische Personen sein können), die von der Generalversammlung der Aktionäre, welche die Auflösung be-
schliesst, ernannt werden, durchgeführt; die Generalversammlung der Aktionäre setzt ferner die Befugnisse der Liqui-
datoren und ihre Vergütungen fest.

Der Nettoerlös der Liquidation eines jeden Subfonds wird durch die Liquidatoren den Aktionären jedes Subfonds im

Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im betreffenden Subfonds gehaltenen Aktien verteilt. Die Beträge, die von den Ak-
tionären am Ende der Liquidation noch nicht angefordert wurden, werden bei der Caisse des Consignations in Luxem-
burg hinterlegt. Falls diese Beträge nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren noch nicht verlangt wurden, verjähren sie und
ein Anspruch darauf kann nicht mehr erhoben werden. 

Art. 37. Von der Gesellschaft getragene Ausgaben.
Der Portfoliomanager, die Depotbank, der administrative Agent und der Registrier- und Transferagent haben das

Recht Vergütungen aus dem Nettovermögenswert der Gesellschaft zu empfangen wie in den Verträgen zwischen ihnen
und der Gesellschaft festgelegt ist und in Übereinstimmung mit der geltenden Marktusanz. Diese Vergütungen werden
auf Basis der durchschnittlichen monatlichen Nettovermögenswerte jedes Subfonds berechnet und sind monatlich zahl-
bar. Ausserdem werden angemessene Auslagen und Out-of-Pocket Kosten dieser Dienstleister der Gesellschaft wie an-
gemessen belastet.

Die Subfonds werden ebenfalls alle anderen Kosten tragen die entstanden sind bei der Tätigung der Geschäfte der

Gesellschaft, inklusive, und zwar ohne Begrenzung, Steuern und Kosten für Rechtsberatung und Prüfung der Jahresbe-
richte, die Kosten der Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, die Druckkosten der Aktienzertifikate, der Ak-
tionärsberichte, der Prospekte, angemessene Vertriebs- und Werbekosten, die Kosten für das Vorbereiten, das
Übersetzen und das Drucken in verschiedenen Sprachen, alle angemessene Out-of-Pocket Kosten der Direktoren, Re-
gistrierungsgebühren und andere den Überwachungsbehörden in den betreffenden Gerichtsbarkeiten zu zahlenden Ko-
sten, Versicherungskosten, Zinsen, Brokergebühren und die Kosten zur Veröffentlichung des Nettovermögenswertes
der Aktien jedes Subfonds.

Die Gründungskosten der Gesellschaft und jedes Subfonds werden während der ersten fünf Jahre nach Gründung

abgeschrieben.

Die Gesellschaft trägt alle ihre laufenden Ausgaben, wie in Artikel 12 beschrieben.

Art. 38. Satzungsänderung.
Die vorliegende Satzung kann jederzeit geändert werden, und zwar durch Beschluss der Generalversammlung der

Aktionäre, die den Bedingungen betreffend das Quorum und die Mehrheit, wie es das Luxemburgische Gesetz vorsieht,
unterworfen ist.

Jede die Gesellschaft betreffende Änderung der allgemeinen Bedingungen, die eine Verminderung der Rechte oder

Garantien der Aktionäre als Folge hat oder die den Aktionären zusätzliche Kosten auferlegt, kann erst drei Monate nach
dem Datum der Zustimmung der Generalversammlung zur Satzungsänderung in Kraft treten. Während dieser drei Mo-
nate können die Aktionäre den Rückkauf ihrer Aktien zu den vor der betreffenden Änderung anwendbaren Bedingungen
verlangen. 

Art. 39. Allgemeine Bestimmungen.
Alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, werden von den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 (einschliesslich Änderungsgesetzen) über die Handelsgesellschaften sowie vom Gesetz vom 19. Juli 1991 über Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht zum öffentlichen Vertrieb bestimmt sind und vom Gesetz vom
30. März 1988 betreffend die Organismen flur gemeinsame Anlagen, so wie es abgeändert worden ist und werden wird,
geregelt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Zeichner haben die Aktien in bar wie folgt gezeichnet und eingezahlt:  

Dem unterzeichneten Notar wurde ausdrücklich nachgewiesen, dass solche Zahlungen eingegangen sind. 

<i>Kosten

Die Parteien schätzen die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die in irgendeiner Form der Gesellschaft zur

Last fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, auf 300.000,- LUF. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Name des Aktionärs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <i>Gezeichnetes Kapital   <i>Eingezahltes Kapital Anzahl der 

<i>Aktien

LaSALLE INVESTMENT MANAGMENT SECURITIES B.V.  . .

25.000,- EUR

25.000,- EUR

1

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  . . . . . . . .

25.000,- EUR

 25.000,- EUR

1

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,- EUR

50.000,- EUR

2

6807

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann treten die Erscheinenden, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstim-

mig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf vier und die der Wirtschaftsprüfer auf einen festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden bis zur jährlichen Generalversammlung, welche in Luxemburg in 2002

abgehalten wird und bis Nachfolger ernannt und genehmigt sind, ernannt:

- Herr Robert LaFors, LaSALLE INVESTMENT MANAGEMENT SECURITIES BV, wohnhaft in Dorpstraat 202 A,

3481 ER Harmelen, Niederlande;

- Herr Michiel Dubois, LaSALLE INVESTMENT MANAGEMENT SECURITIES BV, wohnhaft in Amstelveenseweg 651,

1081 JD Amsterdam, Niederlande;

- Herr Peter Manley, LaSALLE INVETMENT MANAGEMENT, wohnhaft in 3 Preston Park, Faversham, Kent, ME13

BLH, England. 

- Herr Gilles Reiter, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., wohnhaft in 27, rue des Prés, L-8265

Mamer.

3. KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, wird bis zur jährlichen Generalversammlung welche in 2002

abgehalten wird, und bis ein Nachfolger ernannt und genehmigt ist, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt.

4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 69, route d’Esch, L2953 Luxemburg.
5. Auf der Grundlage von Artikel 23 der Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt, seine Befugnisse im Rahmen

der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft an natürliche Personen und juristische Einheiten zu delegieren. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 

Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der Erschienenen,

die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag derselben Er-
scheinenden und im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der englische Text
ausschlaggebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichret: R. Dickhoff, F. Guillaume, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 18, case 8. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr, zwecks Veröffentlichung erteilt.

(06590/200/1444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

RONOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9678 Nothum, 29, rue Duerfstrooss.

R. C. Diekirch B 5.721. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Nothum en date du 18 septembre 2000

Sont présents à la réunion:
- Michel Theys, Administrateur
- Jean Weiss, Administrateur
Le Conseil d’Administration constate que la majorité des Administrateurs est présente, et que dès lors, l’ordre du

jour peut être valablement discuté.

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de INVESTISSEMENTS DIFFUSION S.A. comme Administrateur
2. Cooptation d’un nouvel Administrateur. 
3. Divers.
Après en avoir délibéré, les Administrateurs ont pris, chacune à la majorité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le Conseil d’Administration prend acte de la lettre de démission de INVESTISSEMENTS ET DIFFUSION S.A. et

accepte sa démission en tant qu’Administrateur.

2. Le Conseil d’Administration décide de coopter Monsieur Van Stappen Thierry, Administrateur, demeurant à

B-1495 Tilly, rue de Strichon, 76, en tant qu’Administrateur. La prochaine Assemblée des Actionnaires est invitée à pro-
céder à l’élection définitive de Monsieur Van Stappen.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. 

Enregistré à Wiltz, le 19 septembre 2000, vol. 171, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

(92405/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Luxemburg, den 19. Januar 2001.

F. Baden.

M. Theys / J. Weiss

6808

BAUMA - LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.

R. C. Diekirch B 4.963. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 60, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92390/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

AUVAL - LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.172. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 60, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92391/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

APSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.320. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 60, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92392/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

LASER2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.766. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 24 août 2000

Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires nomme:

Monsieur Philippe Bolle, ingénieur, résidant 21, rue de Berzée, Thy-le-Château (B),
comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle. 

Enregistré à Mersch, le 19 septembre 2000, vol. 126, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature

(92433/228/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

AMGUIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.310. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 60, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92393/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

<i>Pour la société
BAUMA - LUX S.A.

<i>Pour la société
AUVAL - LUX S.A.

<i>Pour la société
APSI, S.à r.l.

Signatures.

<i>Pour la société
AMGUIL S.A.

6809

WEROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6585 Steinheim, 8, route d’Echternach.

R. C. Diekirch B 4.551. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 13 septembre 2000, vol. 133, fol. 21, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92395/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

EWERHARDT SPEDITION, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 1, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 1.716. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 13 septembre 2000, vol. 133, fol. 21, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92396/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

REISDORFF INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.763. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2000

Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2000, enregistré le 1

er

 août 2000 à Clervaux,

volume 208, folio 71, case 4, il ressort ce qui suit:

L’assemblée générale décide à l’unanimité:
1. de transférer le siège social de la société de L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot à L-9991 Weiswampach,

144, route de Stavelot.

2. de supprimer la valeur nominale des actions.
3. de majorer le capital par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de 84.975,- LUF pour le porter à

10.084.975,- LUF, sans émission d’actions nouvelles. L’existence de ces bénéfices reportés se dégage du bilan arrêté au
31 décembre 1999 et du détail de l’affectation du résultat 1999, dont une copie restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

4. de convertir le capital social actuel de 10.084.975,- LUF en euros au cours de change d’un euro pour 40,3399 LUF

de façon à ce que le capital s’établisse à 250.000,- EUR, représenté par 100 actions de 2.500,- EUR chacune. Le nombre
total des actions reste donc inchangé après la conversion du capital social en euros.

5. de modifier, suite à ces résolutions, le paragraphe 1 de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante, les

autres données de l’article 3 restant inchangées.

Art. 3. Paragraphe 1

er

. Le capital social est fixé à 250.000,- EUR, représenté par 100 actions de 2.500,- EUR cha-

cune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 15 septembre 2000.

(92406/667/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

DIESCHBOURG ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 4, rue Maximilien.

R. C. Diekirch B 2.138. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 13 septembre 2000, vol. 133, fol. 21, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92397/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

Echternach, le 15 septembre 2000.

Signature.

Echternach, le 15 septembre 2000.

Signature.

<i>Pour REISDORFF INVEST S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Echternach, le 15 septembre 2000.

Signature.

6810

AF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.256. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 80, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92398/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

EUROPEAN ENERGY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.098. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par 

Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives

du capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.

Le Point à l’ordre du jour est le suivant:
Modification du Conseil d’Administration
Les décisions prises sont les suivantes:
1) L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur-délégué:
Eynar Fastings
Pour des raisons qui lui sont personnelles.
Décharge pleine et définitive lui est donnée pour son mandat.
2) L’Assemblée nomme au poste d’administrateur-délégué:
Monsieur Jean-Yves Greven, indépendant, résidant à B-4652 Xhendelesse, 79, rue du Bief.
3) DELMA &amp; CIE, S.à r.l. reste Administrateur de la société ainsi qu’est nommée SOLFICORP S.A. au poste d’Admi-

nistrateur.

Ces décisions sortent leurs effets à la date du 15 septembre 2000. 

Enregistré à Wiltz, le 15 septembre 2000, vol. 171, fol. 63, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92400/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

LINISI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 5, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 4.081. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 91, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92407/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

IMMOBILIERE SPIELMANN + VAN DYCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9016 Ettelbruck, 3, rue de l’Ecole Agricole.

R. C. Diekirch B 3.123. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Die-

kirch, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 13 septembre 2000.

(92401/663/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

Strassen, le 12 septembre 2000.

DELMA &amp; CIE, S.à r.l.
59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.248 actions au porteur
SOLFICORP S.A.
59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 actions au porteur

B. de Bien / DELMA &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Strassen, le 14 septembre 2000.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

6811

GARAGE BESENIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Diekirch B 4.216. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Die-

kirch, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 13 septembre 2000.

(92402/663/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

BONTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9674 Nocher, 20, Welscheidchen.

R. C. Diekirch B 3.292. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 61, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92408/772/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

ARBO PROPERTY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, Ilôt du Château .

R. C. Diekirch B 2.416. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 61, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92409/772/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

DUTCH CATERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9410 Vianden, 41, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 822. 

Le bilan au 23 avril 1998, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 61, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92389/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.

ATON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 35, Ilôt du Château .

R. C. Diekirch B 3.008. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 61, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92410/772/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

<i>Pour la société
DUTCH CATERING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

6812

HYDRO 50 MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 11, Bohey.

R. C. Diekirch B 2.481. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92411/772/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

AKHESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9663 Kautenbach, Maison 52C.

R. C. Diekirch B 3.009. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 62, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92412/772/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

A.R.S. GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Doncols, 7, Bohey.

R. C. Diekirch B 2.288. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 62, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92413/772/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

ELECTRICITE FAUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9536 Wiltz, 7A, avenue Nicolas Kreins.

R. C. Diekirch B 3.119. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92414/772/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

DINVA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 19.272. 

Société  à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence  à

Luxembourg, en date du 13 avril 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

°

 165

du 19 juillet 1982. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence
à Pétange, en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 148 du

16 février 2000.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(51109/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

DINVA, Société à responsabilité limitée
Signature

6813

CONSULTIVE CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.

R. C. Diekirch B 4.530. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 62, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92415/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

D.W.L. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.

R. C. Diekirch B 3.190. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92416/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

D.W.L. EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.

R. C. Diekirch B 3.174. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 62, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92417/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

D.W.L. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 35, Ilôt du Château.

R. C. Diekirch B 3.173. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 13 septembre 2000, vol. 171, fol. 62, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92418/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

E-TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 7 septembre 2000

Au Conseil d’Administration de E-TRADE S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51113/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

FIDUCIAIRE ARBO
Signature

Signature
<i>Agent Domiciliataire

6814

REIDENER SPENNCHEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 59, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.186. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 11 septembre 2000, vol. 266, fol. 47, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange, le 18 septembre 2000.

(92419/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

EUROPEAN CONSULTANCY SERVICES INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9906 Troisvierges.

R. C. Diekirch B 2.560. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 19 septembre 2000, vol. 266, fol. 51, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92424/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

MENUISERIE BODSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9183 Schlindermanderscheid, 5, rue de l’Ecole.

R. C. Diekirch B 4.345. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 6, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92427/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

M.H.D. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.144.

<i>Rapport du Conseil d’Administration relatif au bilan de l’exercice 1998

Les soldes des bilan et compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1998 ont une perte de 129 francs.
Le Conseil d’Administration acte que l’activité de la société en 1998 a été nulle vu l’état de santé déficient de son

administrateur-délégué, Monsieur Depireux.

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de reporter le résultat à nouveau et d’approuver le bilan

et le compte de profits et pertes qui vous ont été soumis. 

(92435/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

M.H.D. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.144.

<i>Résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 1999

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale des actionnaires, réunie le 30 mai 1999 au siège social de la société à Wiltz, après avoir cons-

taté que tous les actionnaires sont représentés et ayant pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration et
du Rapport du Commissaire aux Comptes, ainsi que du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre
1998 approuve les comptes et décide à l’unanimité de reporter le solde à nouveau.

<i>Pour la société
C. Kieffer-Gillen
<i>Administratrice-Déléguée

Diekirch, le 19 septembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2000.

<i>Pour le gérant
Signature

Wiltz, le 30 mai 1999.

M. Depireux / J.-L. Delvaux / G. Cherroucha

6815

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale des actionnaires donne décharge de leur gestion à la direction et aux administrateurs et elle

donne décharge au commissaire aux comptes.

Ces deux résolutions ont été prises à l’unanimité des voix. 

Enregistré à Wiltz, le 19 septembre 2000, vol. 171, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

(92436/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

EUROESTATE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 3.016. 

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 19 septembre 2000, vol. 266, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92420/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

EUROESTATE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 3.016. 

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 19 septembre 2000, vol. 266, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92421/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

EUROESTATE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 3.016. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 19 septembre 2000, vol. 266, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92422/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

EUROESTATE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 3.016. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 19 septembre 2000, vol. 266, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92423/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2000.

M.H.D. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.144. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 19 septembre 2000, vol. 171, fol. 64, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92437/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

Wiltz, le 30 mai 1999.

Signatures.

Diekirch, le 19 septembre 2000.

Signature.

Diekirch, le 19 septembre 2000.

Signature.

Diekirch, le 19 septembre 2000.

Signature.

Diekirch, le 19 septembre 2000.

Signature.

Diekirch, le 20 septembre 2000.

Signature.

6816

AUBERGE CAMPAGNARDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Winseler.

R. C. Diekirch B 5.126. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92438/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

I.V.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 75.509. 

Le siège social de la société I.V.B., S.à r.l. à L-6686 Mertert - 51, route de Wasserbillig, est dénoncé avec effet immé-

diat.

Mertert, le 31 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13289/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.

MOTORHOMES CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Saeul.

R. C. Diekirch B 1.849. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92439/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

ETS. KAISER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pratz.

R. C. Diekirch B 5.471. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2000, vol. 541, fol. 60, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92446/601/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2000.

ENCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 2.317. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92440/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.

<i>Pour AUBERGE CAMPAGNARDE, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour MOTORHOMES CENTER, S.à r.l.
J. Reuter

Pratz, le 21 septembre 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

<i>Pour ENCOLUX, S.à r.l.
J. Reuter

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


Document Outline

Sommaire

Loyola Financière S.A. Holding

Luxpo S.A.

Luxpo S.A.

Mondo Luxembourg S.A.

S.C.I. Mon Rêve

Multihold S.A.

New Lecta S.A.

New Lecta S.A.

Omni Technology, G.m.b.H.

New Lecta S.A.

Perot Systems Luxembourg, S.à r.l.

Pantalux S.A.

Techno Project, G.m.b.H.

Papier ’97 S.A.

Proxima Capital Investment

SEIF, Société Européenne d’Investissement Financier S.A.

Société Financière UCB S.A.

Louvre-Bau, S.à r.l.

Société Financière UCB S.A.

Bonacci S.A.

USR International S.A.

V.L.G. International S.A.

V.L.G. International S.A.

Wanmaiden S.A.

Nina, S.à r.l.

I.W.O. Holding S.A.

LaSalle European Property Securities, Sicav

Ronor S.A.

Bauma - Lux S.A.

Auval - Lux S.A.

APSI, S.à r.l.

Laser2000 S.A.

Amguil S.A.

Weroco, S.à r.l.

Ewerhardt Spedition, G.m.b.H.

Reisdorff Invest S.A.

Dieschbourg et Fils, S.à r.l.

AF International S.A.

European Energy Development S.A.

Linisi, S.à r.l.

Immobilière Spielmann + Van Dyck, S.à r.l.

Garage Besenius, S.à r.l.

Bonte, S.à r.l.

Arbo Property Services S.A.

Dutch Catering, S..à r.l.

Aton Holding S.A.

Hydro 50 Management, S.à r.l.

Akhesa S.A.

A.R.S. Groupe S.A.

Electricité Fautsch, S.à r.l.

Dinva

Consultive Co S.A.

D.W.L. Holding S.A.

D.W.L. Exploitation S.A.

D.W.L. Immobilière S.A.

E-Trade S.A.

Reidener Spennchen S.A.

European Consultancy Services Industries, S.à r.l.

Menuiserie Bodson, S.à r.l.

M.H.D. Group S.A.

M.H.D. Group S.A.

Euroestate AG

Euroestate AG

Euroestate AG

Euroestate AG

M.H.D. Group S.A.

Auberge Campagnarde, S.à r.l.

I.V.B., S.à r.l.

Motorhomes Center, S.à r.l.

Ets. Kaiser, S.à r.l.

Encolux, S.à r.l.