This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
12433
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 260
6 avril 2000
S O M M A I R E
Agero, Zivilgesellschaft, Roullingen ……………… page
12435
American Coffee Investment Holding S.A., Luxem-
bourg………………………………………………………………………
12445
,
12446
Anc. Ets Aloyse Heidesch, S.à r.l., Rambrouch ………
12434
Burelbach, S.à r.l., Mertzig ………………………………………………
12434
Goldrose S.A.H., Nothum…………………………………………………
12434
Guy Wecker - l’Art du Jardin S.A., Rambrouch ……
12434
(Pierre) Kremer et Cie, S.à r.l., Mersch ……………………
12448
Kutten Alain, S.à r.l., Bettembourg ……………
12446
,
12447
Megamed, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
12437
Mer Bleue Charter S.A., Luxembourg ………………………
12437
Metaleurop International S.A., Luxembourg …………
12439
M & F Promotions, S.à r.l., Bridel …………………………………
12439
Micosta, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
12439
Mondial Fruit Company S.A., Luxembourg ……………
12439
Mot de Brentul S.A., Luxembourg ………………………………
12439
Newark S.A., Luxembourg ………………………………………………
12439
New Generation, S.à r.l., Luxembourg ………………………
12440
New Life, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………
12440
Newplace S.A., Luxembourg …………………………………………
12440
Nilaco, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
12440
Nouvelle Restauration Steiler, S.à r.l., Luxem-
bourg………………………………………………………………………………………
12440
NULUX, Nukem Luxemburg GmbH, Luxbg
12437
,
12438
Nutrition Animale Luxembourg, S.à r.l., Remer-
schen ………………………………………………………………………
12440
,
12441
Oatfield S.A., Luxembourg ………………………………………………
12441
Opéra Immo S.A., Luxembourg ……………………………………
12441
Othee Holding S.A., Luxembourg ………………………………
12441
Outremont Invest S.A. Holding, Luxembourg ………
12442
Outsimer, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
12442
OVB Publishing GmbH, Luxembourg…………………………
12442
Oxon S.A., Luxembourg ……………………………………
12442
,
12444
Pack, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………
12444
Par-Itech S.A., Luxembourg ……………………………………………
12444
PC Finanz International S.A. Holding, Luxembg
12445
Peg Val de Hamm S.A., Luxembourg …………………………
12445
Peinture De Lorenzi Ed. et Fils, S.à r.l., Luxem-
bourg………………………………………………………………………………………
12446
Peinture Stoltz, S.à r.l., Schifflange………………………………
12448
Pela, S.à r.l., Frisange …………………………………………………………
12448
(Jos) Petry, S.à r.l., Remerschen ……………………………………
12448
Pictet Country Fund, Sicav, Luxembourg…………………
12447
Pictet Global Selection Fund, Fonds Commun de
Placement ……………………………………………………………………………
12459
Piet Van Luijk, S.à r.l., Consdorf ……………………………………
12435
Pinus Jardinage, S.à r.l., Bergem ……………………………………
12448
PI-W, S.à r.l., Luxembourg-Grund ………………………………
12449
PK Diffusion, S.à r.l., Leudelange …………………………………
12450
Plastobras Holding S.A., Hesperingen ………………………
12455
Platanus S.A., Luxembourg ……………………………
12450
,
12453
Polar Bek Construction Management S.A., Luxem-
bourg………………………………………………………………………………………
12448
Polarlux S.A., Luxembourg………………………………………………
12455
Pompei, S.à r.l., Dudelange………………………………………………
12456
Premafin International S.A., Luxembourg ………………
12456
Primet, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
12456
Promofin Outremer S.A.H., Luxembourg ………………
12456
Promotion-Invest S.A., Bridel…………………………………………
12457
Prorenta, Sicav, Luxembourg …………………………………………
12453
Ramalux S.A., Luxembourg ……………………………………………
12457
Ramirez-Data S.A., Luxembourg …………………………………
12456
Ramirez Electro S.A., Luxembourg ……………………………
12458
RCH, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………
12457
René Schiltz et Cie, Fonderie de Luxembourg,
S.e.c.s., Luxembourg………………………………………………………
12472
Repucom, S.à r.l., Fentange ……………………………………………
12458
Retrouvailles Prêt-à-Porter, S.à r.l., Remich……………
12458
R.M.C., Restaurant Maurizio Clausen, S.à r.l., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
12458
Romigold, S.à r.l., Strassen ………………………………………………
12457
Sabian Properties S.A., Luxembourg …………………………
12459
Sablière Hein, S.à r.l., Bech-Kleinmacher …………………
12459
Salon Le Passage, S.à r.l., Vianden ………………………………
12434
Saragy S.A., Luxembourg …………………………………………………
12476
Sastro S.A., Luxembourg …………………………………………………
12458
Scorpio S.A., Luxembourg ………………………………………………
12476
Sematic S.A., Luxembourg ………………………………………………
12480
Sidergie International Invest Holding S.A., Luxem-
bourg………………………………………………………………………………………
12475
Sidney Immobilière S.A., Luxembourg………………………
12480
Simisa International S.A., Luxembourg ……………………
12474
Tinfos Nizi S.A., Luxembourg ………………………
12477
,
12479
Translogistics, S.A., Weiswampach ……………
12436
,
12437
Xin-Xing, S.à r.l., Vianden…………………………………………………
12434
GOLDROSE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9678 Nothum, Maison 34.
R. C. Diekirch B 1.859.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 26 janvier 2000, vol. 265, fol. 8, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 janvier 2000.
Signature.
(90326/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2000.
GUY WECKER - L’ART DU JARDIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8805 Rambrouch, 32, rue Principale.
R. C. Diekirch B 4.751.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 26 janvier 2000, vol. 265, fol. 8, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 janvier 2000.
Signature.
(90327/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2000.
XIN-XING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9414 Vianden, 15, rue Victor Hugo.
R. C. Diekirch B 3.224.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré le 28 janvier 2000, vol. 265, fol. 9, case 8, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 janvier 2000.
Signature.
(90331/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
BURELBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9168 Mertzig, 25, rue Principale.
R. C. Diekirch B 2.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Mersch, le 28 janvier 2000, vol. 125, fol. 43, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
N. Burelbach
<i>Le géranti>
(90332/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
ANC ETS ALOYSE HEIDESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8805 Rambrouch, 7, rue de Roodt.
R. C. Diekirch B 3.181.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Mersch, le 25 janvier 2000, vol. 125, fol. 40, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Heidesch
<i>Le géranti>
(90333/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
SALON LE PASSAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9420 Vianden, 11, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 2.994.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Mersch, le 25 janvier 2000, vol. 125, fol. 40, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M. Beerthuizen
<i>La gérantei>
(90334/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
12434
PIET VAN LUIJK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6211 Consdorf, 1, rue de Mullerthaf.
R. C. Diekirch B 2.559.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Mersch, le 25 janvier 2000, vol. 125, fol. 40, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 janvier 2000.
P. Van Luijk
<i>Le géranti>
(90335/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2000.
AGERO, Zivilgesellschaft.
Gesellschaftssitz: Roullingen, 10, Am Duerf.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.
Sind erschienen:
1.- Herr Yves Klein, Landwirt, geboren zu Wiltz, am 11. Dezember 1971, wohnhaft zu Roullingen, 10, Am Duerf,
2.- Herr Antonius Johannes Maria, genannt Toni Bossers, Landwirt, geboren zu Wiltz, am 7. Oktober 1961, wohnhaft
zu Roullingen, 8A, Duerfstrooss,
3.- Herr Alphonse Malget, Landwirt, geboren zu Wiltz, am 15. April 1948, wohnhaft zu Roullingen, 15, Am Duerf.
Welche Komparenten, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzten:
Dass sie die alleinigen Anteilhaber und das gesamte Kapital vertreten der Zivilgesellschaft AGERO, mit Sitz in
Roullingen, 10, Am Duerf,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Roger Arrensdorff, mit dem damaligen Amtssitz zu Wiltz,
am 29. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 378 vom 7. August
1996.
Dass die Gesellschaft ein Kapital von 17.916.000,- LUF hat, eingeteilt in 17.916 Anteile zu je 1.000,- LUF, welche, wie
folgt verteilt sind:
- Herr Yves Klein, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………
5.972 Anteile
- Herr Toni Bossers, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………
5.972 Anteile
- Herr Alphonse Malget, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………
5.972 Anteile
Dass die Gesellschaft weder Immobilien noch Immobilienanteile besitzt.
<i>Anteilabtretung und Kapitalverminderungi>
Herr Alphonse Malget, vorgenannt, ist mit Wirkung zum 1. April 1999 aus der Gesellschaft ausgeschieden.
Zu vorgenanntem Datum, erklären die Gesellschafter, gemäss Artikel 5 der Statuten, das Gesellschaftskapital
einstimmig, zwecks Rückkauf der Anteile des scheidenden Gesellschafters Alphonse Malget durch die Zivilgesellschaft
AGERO, herabzusetzen auf 11.944.000,- LUF.
Vorstehender Rückkauf geschieht mit Wirkung zum vorgenannten 1. April 1999 sowie die Parteien dies in einer
Konvention unter Privatschrift datiert vom 23. November 1999 festgehalten haben.
Herr Alphonse Malget erklärt als scheidender Gesellschafter keine Ansprüche mehr betreffend der von ihm cedierten
Anteile gegenüber der Gesellschaft AGERO, sowie den verbleibenden Gesellschafter, zu haben.
STATUTENÄNDERUNG
Und sofort erklären die verbleibenden Gesellschafter, Herr Yves Klein und Toni Bossers, sich in einer ausserge-
wöhnlichen Generalversammlung zusammenzufinden, zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären, und haben
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst, infolge der hiervor getätigten Kapitalverminderung, Artikel 4 der Statuten abzuändern
wie folgt:
«Art. 4. Das Gesellschaftskapital beträgt elf Millionen neunhundertvierundvierzigtausend luxemburgische Franken
(11.944.000,- LUF), eingeteilt in elftausendneunhundertvierundvierzig (11.944) Anteile.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Artikel 5 der Statuten wird abgeändert wie folgt:
«Art. 5. Die Anteile sind wie folgt unter die Gesellschafter verteilt:
- Herr Yves Klein, vorgenannt, fünftausendneunhundertzweiundsiebzig Anteile …………………………………
5.972
- Herr Toni Bossers, vorgenannt, fünftausendneunhundertzweiundsiebzig Anteile ………………………………
5.972
Total: elftausendneunhundertvierundvierzig Anteile ……………………………………………………………………………………
11.944
Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden. »
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst Artikel 18 erster Absatz der Statuten infolge des Ausscheidens des Gesellschafters
Alphonse Malget wie folgt abzuändern:
12435
«Art. 18. Absatz 1. Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern. Zu Verwaltern der Gesellschaft sind die
Herren Yves Klein und Toni Bossers bestellt.»
<i>Vierter und letzter Beschlussi>
Dem scheidenden Verwalter Alphonse Malget wird andurch Demission mit Entlastung erteilt.
<i>Kosten und Honorarei>
Die Kosten, Gebühren und Honorare gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden
abgeschätzt auf 25.000,- LUF.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und
Wohnort bekannt, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Y. Klein, T. Bossers, A. Malget, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 29 décembre 1999, vol. 314, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Biver.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Wiltz, den 28. Januar 2000.
M. Decker.
(90336/241/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2000.
TRANSLOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRANSLOGISTICS S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 11 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 600 du 19 août
1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à
Messancy (B).
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Monique Klein-Glodt, employée privée, demeurant à Hautcharage.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
La Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par la Présidente, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de 16.000.000,- LUF par apport en espèces, pour le porter de son
montant actuel de 10.000.000,- LUF à 26.000.000,- LUF par l’émission de 160 actions nouvelles de 100.000,- LUF
chacune.
2.- Souscription et libération des actions ainsi créées.
3.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital ainsi inter-
venue.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de seize millions de francs luxembourgeois
(16.000.000,- LUF) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de dix millions de francs luxembour-
geois (10.000.000,- LUF) à vingt-six millions de francs luxembourgeois (26.000.000,- LUF) par l’émission de 160 actions
nouvelles de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les 100.000 actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la
somme de 16.000.000,- LUF se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été apportée au notaire instru-
mentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à cette augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1
er
) des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
12436
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à vingt-six millions de francs luxembourgeois (26.000.000,-
LUF), représenté par deux cent soixante (260) actions de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ deux cent vingt mille francs luxembourgeois (220.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Hennericy, M. Glodt, G. Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 20 décembre 1999, vol. 412, fol. 22, case 1. – Reçu 160.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 23 décembre 1999.
E. Schroeder.
(90337/228/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2000.
TRANSLOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 janvier 2000.
E. Schroeder.
(90338/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2000.
MEGAMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1134 Luxembourg, 43, rue Charles Arendt.
R. C. Luxembourg B 32.147.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 5, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06581/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
MER BLEUE CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 49.776.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 1999, acté sous le
n° 815/99 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06582/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
NULUX, NUKEM LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 12.118.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den dreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) NUKEM NUKLEAR, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in D-63754 Alzenau, Industriestrasse
13,
hier vertreten durch Herrn John Seil, licencié en sciences économiques, wohnhaft in Contern,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Alzenau, am 28. Dezember 1999.
2) DRESDNER BANK A.G., Aktiengesellschaft, mit Sitz in D-60301 Frankfurt/Main,
hier vertreten durch Herrn John Seil, vorgenannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Frankfurt/Main, am 27. Dezember 1999.
3) Herr André Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn John Seil, vorgenannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 27. Dezember 1999.
12437
Vorerwähnte Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Die hiervor bezeichneten Komparenten erklären, dass sie die alleinigen Anteilinhaber der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung NULUX, NUKEM LUXEMBURG, GmbH, mit Sitz in Luxemburg, sind.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde am 3. Mai 1974, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 148 vom 26. Juli 1974. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert
gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 26. Oktober 1990, welche im Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 136 vom 18. März 1991, veröffentlicht wurde.
Diese Erschienenen erklären zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, welche folgende Tagesordnung hat,
zusammenzutreten:
<i>Tagesordnung:i>
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von dreissigtausend Deutsche Mark (30.000,- DEM), eingeteilt in
zweihundert (200) Anteile zu je einhundertfünfzig Deutsche Mark (150,- DEM) in ein Kapital von fünfzehntausenddrei-
hundertachtunddreissig Euro sechsundsiebzig Cents (15.338,76 EUR).
2. Erhöhung des Kapitals von fünfzehntausenddreihundertachtunddreissig Euro sechsundsiebzig Cents (15.338,76
EUR) auf zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR), durch Eingliederung eines Betrages von viertausendsechshundert-
einundsechzig Euro vierundzwanzig Cents (4.661,24 EUR) der Rücklagen zum Kapital, ohne Ausgabe von neuen Anteilen.
3. Anpassung des 1. Absatzes von Artikel 3 der Satzungen wie folgt:
«Art. 3. Absatz 1. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR),
eingeteilt in zweihundert (200) Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR).»
Alsdann fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von dreissigtausend Deutsche Mark (30.000,- DEM),
eingeteilt in zweihundert (200) Anteile zu je einhundertfünfzig Deutsche Mark (150,- DEM) in fünfzehntausenddreihun-
dertachtunddreissig Euro sechsundsiebzig Cents (15.338,76 EUR) umzuwandeln und die Bezeichnung des Nennwertes
der Anteile abzuschaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Kapital um viertausendsechshunderteinundsechzig Euro vierundzwanzig
Cents (4.661,24 EUR) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von fünfzehntausend dreihundertachtunddreissig
Euro sechsundsiebzig Cents (15.338,76 EUR) auf zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR) zu erhöhen, ohne Ausgabe von
neuen Anteilen, durch Einbringung eines Betrages von viertausendsechshunderteinundsechzig Euro vierundzwanzig
Cents (4.661,24 EUR) aus den «Sonstigen Rücklagen» der Gesellschaft.
Der Nachweis solcher Rücklagen wurde dem Notar durch die Bilanz zum 31. Dezember 1998 erbracht, welche
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nennwert der Anteile auf einhundert Euro (100,- EUR) pro Anteil festzu-
setzen. Das Gesellschaftskapital ist somit in zweihundert (200) Anteile zu je einhundert Euro (100,- FUR) eingeteilt.
<i>Vierter Beschlussi>
Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 3, Absatz 1 wie folgt abgeändert:
«Art. 3. Absatz 1. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR),
eingeteilt in zweihundert (200) Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR).
<i>Abschätzung der Kosteni>
Der Betrag der Kosten, für die die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde auf zukommen hat, beläuft sich schät-
zungsweise auf vierzigtausend Luxemburger Franken (40.000,- LUF).
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Seil, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 122S, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. Januar 2000.
F. Baden.
(06596/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
NULUX, NUKEM LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.118.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
F. Baden.
(06597/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12438
METALEUROP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.854.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 532, fol. 98, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Pour la S.A. METALEUROP INTERNATIONAL.i>
(06583/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
M & F PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.
(06584/502/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
MICOSTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 66.033.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 13, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L. Petré.
(06585/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
MONDIAL FRUIT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 63.867.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 531, fol. 4, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
<i>MONDIAL FRUIT COMPANY S.A.i>
VIP COMPTA S.A.
Signature
(06588/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
MOT DE BRENTUL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 46.220.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 décembre 1999 actée sous le
n° 844/99 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06589/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
NEWARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.739.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 11, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
<i>Pour la S.A. NEWARKi>
Signature
(06590/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12439
NEW GENERATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 40.458.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 13, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
M. Rahmé.
(06591/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
NEW LIFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 13, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 17.790.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2000, vol. 315, fol. 43, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
Signature.
(06592/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
NEWPLACE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.685.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06593/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
NILACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 21, rue Raymond Poincaré.
R. C. Luxembourg B 42.635.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 13, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Probst-Nicoletti Mobley
(06594/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
NOUVELLE RESTAURATION STEILER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 2, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 56.717.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 85, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.
(06595/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5506 Remerschen, 16, rue de Reichlange.
R. C. Luxembourg B 4.205.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 85, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.
(06598/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12440
NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5506 Remerschen, 16, rue de Reichlange.
R. C. Luxembourg B 4.205.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 85, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.
(06599/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
OATFIELD S.A., Société Anonyme
(anc. LES COUTURIERS DE LA NATURE S.A.).
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 56.876.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 531, fol. 4, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Pour la société OATFIELD S.A.i>
VIP COMPTA S.A.
Signature
(06600/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
OATFIELD S.A., Société Anonyme
(anc. LES COUTURIERS DE LA NATURE S.A.).
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 56.876.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 531, fol. 4, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Pour la société OATFIELD S.A.i>
VIP COMPTA S.A.
Signature
(06601/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.926.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 532, fol. 100, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Pour la société OPERA IMMO S.A.i>
VIP COMPTA S.A.
Signature
(06602/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
OTHEE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.940.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2000, vol. 533, fol. 7, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2000 que FIDEI REVISION,
Société à responsabilité limitée, ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg a été élu commissaire aux
comptes de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(06603/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12441
OUTREMONT INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.082.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2000, vol. 532, fol. 98, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Pour OUTREMONT INVEST S.A. HOLDINGi>
Signature
(06604/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
OUTSIMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2327 Luxembourg, 32, route de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 57.205.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 84, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
VIP COMPTA S.A.
Signature
(06605/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
OVB PUBLISHING G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 13, rue Louvigny.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 90, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Pour la société OVB PUBLISHING G.m.b.H.i>
VIP COMPTA S.A.
Signature
(06606/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
OXON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.551.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société OXON S.A., une société anonyme,
avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, inscrite au R. C. de Luxembourg sous la section B numéro
64.551 constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 28 mai 1998,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 575 du 7 août 1998.
L’assemblée est présidée par M
e
Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire M
e
Marc Bodelet, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur M
e
Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
1. Qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.
2. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Que dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points de l’ordre du jour,
dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
3. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Emission de nouvelles actions et modification subséquente de la valeur nominale de chacune d’elle.
2. Augmentation du capital social de la société à concurrence d’un montant d’un milliard sept cent et un millions six
cent cinquante mille lires italiennes (1.701.650.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel de cent millions de lires
italiennes (100.000.000,- ITL) à un milliard huit cent et un millions six cent cinquante mille lires italiennes
(1.801.650.000,- ITL), souscrit et libéré par un apport en nature, par la création et l’émission de six cent quatre-vingt
mille six cent soixante (680.660) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux mille cinq cents lires italiennes
(2.500,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
12442
3. Renonciation par l’actionnaire minoritaire de son droit de souscription préférentiel et acceptation de la
souscription des nouvelles actions par Monsieur Conti Andrea Guido, demeurant à Vicenza, Corso A. Fogazzaro
153/155 (Italie).
Cette augmentation de capital portera, dès lors, sur l’émission de six cent quatre-vingt mille six cent soixante
(680.660) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux mille cinq cents lires italiennes (2.500,- ITL) chacune,
jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
Cette émission d’actions nouvelles sera entièrement souscrite par Monsieur Conti Andrea Guido, précité, et sera
libérée par voie d’apport en nature et répartie comme suit:
- d’une part, par la création de six cent quatorze mille sept cent vingt-cinq (614.725) actions nouvelles consistant dans
l’apport de 89,55% du capital social de la société GALTOM S.r.l. évalué à un montant d’un milliard cinq cent trente-six
millions huit cent et douze mille cinq cents lires italiennes (1.536.812.500,- ITL)
- et d’autre part, par la création de soixante-cinq mille neuf cent trente-cinq (65.935) actions nouvelles consistant dans
l’apport de 89,55% du capital social de la société QUID S.r.l. évalué à un montant de cent soixante-quatre millions huit
cent trente-sept mille cinq cents lires italiennes (164.837.500,- ITL)
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts de façon à refléter les résolutions prises.
<i>Délibérationi>
Après délibération, l’assemblée a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le nombre d’actions de mille (1.000) à quarante mille (40.000) et de
modifier, en conséquence, la valeur nominale de chacune des actions du capital de manière à établir la valeur d’une action
ancienne à quarante actions nouvelles. La nouvelle valeur nominale de chacune des actions est alors fixée à deux mille
cinq cents lires italiennes (2.500,- ITL).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le montant du capital souscrit de la société d’un montant d’un milliard sept
cent et un millions six cent cinquante mille lires italiennes (1.701.650.000,- ITL) afin qu’il soit porté de son montant actuel
de cent millions de lires italiennes (100.000.000,- ITL) à un milliard huit cent et un millions six cent cinquante mille lires
italiennes (1.801.650.000,- ITL), par la création et l’émission de six cent quatre-vingt mille six cent soixante (680.660)
actions nouvelles d’une valeur nominale de deux mille cinq cents lires italiennes (2.500,- ITL) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la souscription par Monsieur Conti Andrea Guido, précité, des six cent quatre-vingt mille six
cent soixante (680.660) nouvelles actions lesquelles sont souscrites et libérées comme suit:
- A hauteur d’un milliard cinq cent trente-six millions huit cent et douze mille cinq cent lires italiennes (1.536.812.500,- ITL)
par un apport en nature consistant dans l’apport de 89,55% du capital social de la société GALTOM S.r.l., société de
droit italien, avec siège à Treviso, Vicolo del Molinetto 1, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Treviso
sous le numéro 32.981 (Italie).
- A hauteur de cent soixante quatre millions huit cent trente-sept mille cinq cents lires italiennes (164.837.500,- ITL),
par un apport en nature consistant dans l’apport de 89,55% du capital social de la société QUID S.r.l., société de droit
italien, avec siège à TREVISO, Vicolo del Molinetto, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Treviso sous le
numéro 3006/1999 (Italie).
Par la voix de son mandataire, Monsieur Conti Andrea Guido déclare que l’apport en nature portant sur 89,55% du
capital social de la société GALTOM S.r.l. et sur 89,55% du capital social de la société QUID S.r.l. constitue un échange
de participation effectué conformément à la législation italienne et en particulier au «Decreto Legislativo» du 30
décembre 1992, n° 544. Toutes les conditions prévues à l’article 1
e
r, première «virgule» lettre e) et par l’article 2, virgule
5 dudit «Decreto Legislativo» sont respectées.
Conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,
cette valeur est établie par un rapport de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, daté
du 22 novembre 1999 dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport après avoir été signé «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire soussigné restera annexé au
présent acte.
En considération des souscriptions et des paiements ci-dessus par le souscripteur, les six cent quatre-vingt mille six
cent soixante (680.660) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux mille cinq cents lires italiennes (2.500,- ITL)
chacune, et entièrement libérées sont émises par la société et attribuées à Monsieur Conti Andrea Guido, précité.
<i>Déclarations pour l’enregistrementi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que le milliard sept cent et un millions six cent cinquante mille lires
italiennes (1.701.650.000,- ITL) représentant le capital augmenté, est évalué à trente cinq millions quatre cent cinquante
et un mille huit cent trente-six francs luxembourgeois (35.451.836,- LUF);
La société OXON S.A. détenant dès lors plus de 75% du capital émis de GALTOM S.r.l. et plus de 75% du capital émis
de QUID S.r.l., il est demandé pour ce qui concerne l’augmentation de capital par apport en nature à hauteur d’un
milliard sept cent et un millions six cent cinquante mille lires italiennes (1.701.650.000,- ITL), application des dispositions
de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 prévoyant l’exonération du droit d’apport.
12443
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des décisions prises par l’Assemblée générale sous les résolutions précédentes, l’assemblée décide
de modifier les alinéas 1
er
et 2 de l’article 3 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à un milliard huit cent et un millions six cent cinquante mille lires italiennes
(1.801.650.000,- ITL) représenté par sept cent vingt mille six cent soixante (720.660) actions d’une valeur nominale de
deux mille cinq cents lires italiennes (2.500,- ITL) chacune, entièrement libérées».
«Le capital autorisé est fixé à un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,- ITL), représenté par quatre cent mille
(400.000) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents lires italiennes (2.500,- ITL) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent est approximativement estimé à la somme de quatre-vingt mille francs
luxembourgeois (80.000,- LUF).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont présent procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous avec Nous, notaire, signé le présent acte.
Signé: C. Duro, M. Bodelet, P. Morales, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 novembre 1999, vol. 411, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 décembre 1999.
E. Schroeder.
(06607/228/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
OXON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.551.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 janvier 2000.
E. Schroeder.
(06608/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.446.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN
Signature
(06609/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PAR-ITECH, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 51.831.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 532, fol. 100, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 15 juin 1999i>
L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Pierre Letargez,
- Monsieur Yves Geltmeyer,
- Madame Pascale Paindavoine
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(06612/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12444
PC FINANZ INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.275.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 11, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
<i>Pour la PC FINANZ INTERNATIONAL S.A. HOLDINGi>
Signature
(06613/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PEG VAL DE HAMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 29.232.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 5, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06614/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. PANAFRICAN HANDICRAFTS S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 12.619.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PANAFRICAN
HANDICRAFTS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg
section B numéro 12.619, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 27 du 17 février 1975.
L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les 4.000 (quatre mille) actions, représentant l’intégralité du capital
social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination en AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A. et modification de
l’article 1
er
.
2.- Modification de la durée de la société qui sera illimitée et modification afférente de l’article 4.
3.- Modification de la dernière phrase de l’article 5 en lui donnant la teneur suivante.
«Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix des actionnaires.» et ajout de l’alinéa suivant: «La société
peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
4.- Modification de l’article 14 des statuts en lui donnant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination en AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A. et de
modifier l’article 1
er
en lui donnant la teneur suivante:
«La société a pour dénomination AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de la durée de la société qui sera illimitée et de modifier l’article 4 pour lui donner la teneur
suivante:
«La durée de la société est illimitée.».
12445
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dernière phrase de l’article 5 en lui donnant la teneur suivante.
«Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, au choix des actionnaires.» et ajout de l’alinéa suivant: «La
société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts en lui donnant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, C. Schmitz, M. Lamesch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 121S, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 1999.
J. Elvinger.
(06610/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. PANAFRICAN HANDICRAFTS S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 12.619.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Elvinger.
(06611/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PEINTURE DE LORENZI ED. ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 3, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 53.960.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2000, vol. 315, fol. 43, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
Signature.
(06615/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
KUTTEN ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. PEINTURES KUTTEN ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-3225 Bettembourg, rue Lachemer, Zone Industrielle Scheleck II.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Alain Kutten, maître-peintre, demeurant à L-3522 Dudelange, 22, rue Emile Mayrisch.
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société PEINTURES KUTTEN ALAIN, S.à r.l., avec siège social à
L-3570 Dudelange, 21, rue Victor Tesch, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 mars
1994 publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 246 du 22 juin 1994.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire , en date du 29 février 1996,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 273 du 5 juin 1996.
L’associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’associé décide de transférer le siège social de la société à L-3225 Bettembourg, rue Lachemer, Zone Industrielle
Scheleck II.
L’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le siège social est établi à Bettembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier la dénomination de la société de PEINTURES KUTTEN ALAIN, S.à r.l. en
KUTTEN ALAIN, S.à r.l.
12446
L’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société prend la dénomination de KUTTEN ALAIN, S.à r.l.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés à concurrence d’un
montant de sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (7.500.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel
de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) et
émission de sept mille cinq cents (7.500) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune.
L’existence de ces bénéfices reportés se dégage d’un bilan arrêté au 31 décembre 1998 dont une copie restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’article 6 (alinéa 1
er
) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à la somme de huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF),
représenté par huit mille (8.000) parts sociales, d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
entièrement libérées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Kutten, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 décembre 1999, vol. 412, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 décembre 1999.
E. Schroeder.
(06616/228/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
KUTTEN ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. PEINTURES KUTTEN ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-3225 Bettembourg, rue Lachemer, Zone Industrielle Scheleck II.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06617/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PICTET COUNTRY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.913.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 18 janvier 2000 et a adopté les résolutions
suivantes:
1. L’assemblée a approuvé les rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises.
2. L’assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 30 septembre 1999 tels que soumis par le conseil d’adminis-
tration.
3. L’assemblée a approuvé le report du bénéfice.
4. L’assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours
de l’exercice social se terminant le 30 septembre 1999.
5. L’assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Frédéric Fasel, Pierre-Alain Eggly, Yves Martignier, Jean Pilloud,
Patrick Schott et de Madame Ailbhe Jennings pour une période d’une année.
6. L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Jean Pilloud en remplacement de Monsieur Nicolas Pictet.
7. L’assemblée a reconduit le mandat du réviseur d’entreprise DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l’exercice
1999/2000.
<i>Pour PICTET COUNTRY FUNDi>
Signature Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06621/052/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12447
PEINTURE STOLTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3857 Schifflange, 24, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 23.721.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Mersch, le 26 janvier 2000, vol. 125, fol. 41, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmdange, le 28 janvier 2000.
FISEC, S.à r.l.
Signature
(06618/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 33, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 25.413.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Mersch, le 26 janvier 2000, vol. 125, fol. 41, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmdange, le 28 janvier 2000.
FISEC, S.à r.l.
Signature
(06619/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
JOS PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5506 Remerschen, 124, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 49.492.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 85, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN
Signature
(06620/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PIERRE KREMER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, Zone industrielle.
R. C. Luxembourg B 23.793.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 5, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06623/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PINUS JARDINAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3315 Bergem, 6, rue de Noetzange.
R. C. Luxembourg B 63.304.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 20 janvier 2000, vol. 132, fol. 78, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 28 janvier 2000.
Signature.
(06624/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
POLAR BEK CONSTRUCTION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 30.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 5, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06630/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12448
PI-W, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2651 Luxembourg-Grund, 20, route de Trèves.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Patrick Pawlenko, étudiant, demeurant à L-7447 Lintgen.
Lequel comparant déclare être, suite à des cessions de parts sous seing privé, le seul associé de la société à respon-
sabilité limitée PI-W, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg-Grund, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 10 octobre 1996 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 650 du 14
décembre 1996.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 février 1998,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 536 du 23 juillet 1998.
L’associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide la refonte des statuts comme suit:
«STATUTS
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 29 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 3. La société prend la dénomination de PI-W, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Grund.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par
cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Toutes ces parts sont détenues par Monsieur Patrick Pawlenko, étudiant, demeurant à L-7447 Lintgen.
Art. 7. Les cessions de parts à des non-associés doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après
qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elles dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code
civil.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le
cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont révocables ad nutum.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de son objet social.
Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou
établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. L’associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et
du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
12449
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
Approbation de la fusion par absorption de la Société et de SECURENTA, une société d’investissement à capital
variable ayant son siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, par CORDIUS LUXINVEST, une société d’investis-
sement à capital variable, ayant son siège social à Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri, et plus spécialement:
1) entendre le rapport du Conseil d’Administration expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations le 26 octobre 1999 et déposé auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg,
2) entendre le rapport spécial prescrit par l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
préparé par l’expert indépendant ERNST & YOUNG, Luxembourg et relatif à la méthode suivie pour la détermination
du rapport d’échange des actions de la Société contre des actions nouvelles de CORDIUS LUXINVEST (relevant du
compartiment CORDIUS LUXINVEST INTERNATIONAL BONDS),
3) approuver la fusion de la Société avec CORDIUS LUXINVEST par absorption de la société dans le compartiment
CORDIUS LUXINVEST INTERNATIONAL BONDS selon les termes du projet de fusion, comprenant (i) le transfert à
ce compartiment de l’ensemble du patrimoine, activement et passivement, de la Société, pour une valeur nette d’inven-
taire totale correspondant à celle des actions émises de la Société, (ii) l’attribution d’actions au porteur de capitalisation
et/ou de distribution de ce compartiment à émettre aux anciens actionnaires de la Société, et (iii) la constatation de la
dissolution sans liquidation de la Société et de l’annulation de ses actions,
4) donner quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat du 1
er
janvier 1999 à la date effective de
la fusion.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les vingt-sept mille cinq cent une (27.501) actions en circulation, deux
cent quarante-cinq (245) actions sont représentées à la présente Assemblée.
V.- Qu’une première Assemblée générale extrarordinaire a été convoquée pour le 26 novembre 1999 et que les
conditions de quorum pour voter les points à l’ordre du jour n’étaient pas remplies.
Que la présente Assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour.
VI.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées à savoir:
1) Publication du projet de fusion établi en la forme notariée par les Conseils d’Administration des sociétés qui
fusionnent le 26 octobre 1999 au Mémorial soit un mois au moins avant la réunion des Assemblées Générales des
sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2) Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-
quant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.
3) Etablissement d’un rapport par un expert indépendant en l’occurence ERNST & YOUNG autorisé suivant ordon-
nance du 26 octobre 1999 à établir un rapport conjoint pour les trois sociétés qui fusionnent. Ce rapport, établi en date
du 26 octobre 1999, constate entre autres que les méthodes retenues pour le rapport d’échange des actions sont
adéquates et qu’un second rapport sera établi dans lequel le réviseur se prononcera sur les rapports d’échange.
4) Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un
mois avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale en vue de leur inspection par les actionnaires.
Les rapports des conseils d’administration, le rapport de l’expert indépendant établi en date du 26 octobre 1999, une
copie de l’ordonnance susmentionnée ainsi qu’une attestation certifiant le dépôt des documents ci-dessus indiqués
pendant le délai légal au siège social de la société resteront annexés aux présentes.
Ces constatations ayant été faites, le Président informe l’Assemblée que pour des raisons techniques la valeur nette
d’inventaire des actions des sociétés participant à la fusion n’a pas encore pu être établie à ce jour et donc le rapport
d’échange n’a pas encore pu être déterminé par l’expert indépendant et le Président propose en conséquence à
l’assemblée de s’ajourner jusqu’à 17.00 heures de cet après midi afin de délibérer en connaissance de cause sur l’ordre
du jour.
Tous les actionnaires présents et représentés marquent leur accord avec cette proposition et dès lors l’Assemblée
est ajournée jusqu’à 17.00 heures de cet après-midi.
* * *
A 17.00 heures de ce jour s’est continuée l’Assemblée générale extraordinaires des actionnaires de la société
PRORENTA avec les mêmes membres du bureau et les mêmes actionnaires présents ou représentés.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré et discuté le projet de fusion, prend à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve la fusion entre la société PRORENTA, société absorbée (ci-après désignée «la Société») et la
société CORDIUS LUXINVEST, société absorbante, ayant son siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal
(COMPARTIMENT CORDIUS LUXINVEST INTERNATIONAL BONDS) conformément au projet de fusion reçu par
acte authentique en date du 18 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 797 du
26 octobre 1999.
Conformément à l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales le projet de fusion a fait l’objet d’un examen par
ERNST & YOUNG, réviseur d’entreprises, avec siège social à Luxembourg, autorisée à établir un rapport commun pour
12454
toutes les sociétés participant à la fusion. Un premier rapport, établi en date du 26 octobre 1999, a été complété par un
deuxième rapport établi en date de ce jour et qui établit le rapport d’échange. Ce deuxième rapport restera également
annexé aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
Après lecture du rapport des administrateurs sur le projet de fusion et des rapports de ERNST & YOUNG sur le
rapport d’échange des actions, l’Assemblée accepte l’émission d’actions, sans commission d’entrée, par CORDIUS
LUXINVEST («société absorbante»), dans le compartiment CORDIUS LUXINVEST INTERNATIONAL BONDS en
échange de l’apport de tous les actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante comme suit:
Des actions au porteur ou nominatives de capitalisation et/ou de distribution du COMPARTIMENT CORDIUS
LUXINVEST INTERNATIONAL BONDS sont attribuées aux actionnaires de PRORENTA, sans commission d’entrée,
sur base des actions détenues à ce jour et sur base du ratio d’échange qui a été déterminé par l’expert indépendant à la
date de ce jour, à savoir:
7,800289 actions de distribution CORDIUS LUXINVEST INTERNATIONAL BONDS pour chaque action de distri-
bution PRORENTA;
6,445577 actions de capitalisation CORDIUS LUXINVEST INTERNATIONAL BONDS pour chaque action de capita-
lisation PRORENTA.
Ensuite l’Assemblée constate que la fusion est réalisée sous la réserve que conformément à l’article 264 de la loi sur
les sociétés commerciales, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins cinq pour cent des
actions du capital souscrit de celle-ci ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de la présente Assemblée
la convocation d’une Assemblée Générale appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée constate que sous la condition énoncée ci-dessus, la Société est dissoute sans liquidation, tous les actifs
et passifs de la société absorbée étant transmis à titre universel à la société absorbante, et toutes les actions en circu-
lation de la société absorbée sont annulées.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée donne quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat du 1
er
janvier 1999 à ce jour.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste
par les présentes l’existence du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formelles imposés à la société en
relation avec la fusion projetée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Renaud, J.-C. Michels, C. Birnbaum, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2000.
F. Baden.
(06637/200/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PLASTOBRAS HOLDING S.A., Aktiengeselleschaft.
Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperingen.
H. R. Luxemburg B 48.847.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1998, eingetragen in Luxemburg, am 28. Januar 2000, Vol. 533, Fol. 13, Case
12, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 31. Januar 2000.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 31. Januar 2000.
PLASTOBRAS HOLDING S.A.
Unterschrift
(06629/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
POLARLUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 35.354.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 11, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06631/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12455
POMPEI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, 106, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.143.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Mersch, le 26 janvier 2000, vol. 125, fol. 41, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmdange, le 28 janvier 2000.
FISEC, S.à r.l.
Signature
(06632/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PREMAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.715.
—
Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 5 août 1999, actée sous le numéro
486/99 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06633/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PRIMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 120, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 26.034.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 76, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Pour la société PRIMET, S.à r.l.i>
VIP COMPTA S.A.
Signature
(06634/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PROMOFIN OUTREMER S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 33.254.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 11, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06635/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
RAMIREZ-DATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2423 Luxembourg, 27, rue du Pont-Rémy.
R. C. Luxembourg B 59.574.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administration:i>
M. Udo Schönwolf, administrateur de société, D-Rehlingen/Hemmersdorf, administrateur-délégué;
Mme Michèle Ramirez-Schmitz, administrateur de société, Luxembourg;
M. Francisco Ramirez, administrateur de société, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Mme Margot Bechet-Gras, employée privée, Luxembourg.
Luxembourg, le 13 octobre 1999.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RAMIREZ-DATA S.A.i>
KPMG Experts-Comptables
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembr 1999, vol. 530, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06639/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12456
PROMOTION-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8104 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 532, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN
Signature
(06636/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
RAMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 34.044.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 1999 que l’assemblée a pris, entre
autres, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Madame Vania Migliore-Baravini de sa fonction
d’administrateur et par de Monsieur Reno Tonelli de sa fonction d’administrateur de la société. Les lettres de démission
resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires concernant l’exécution de leur
mandat jusqu’à la date de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d’administrateurs de la société:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.G. de Cicignon, en remplacement de
Madame Vania Migliore-Baravini, démissionnaire;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, en remplacement de
Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire.
Les mandats ainsi conférés, à l’instar du mandat des autres administrateurs, expireront à l’assembée générale à tenir
en 2001.
Luxembourg, le 24 janvier 2000.
RAMALUX S.A.
S. Vandi
R. Szymanski
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06638/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
RCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.
R. C. Luxembourg B 60.338.
—
Suite au contrat de cession de parts sociales du 21 avril 1999, la gérance de la société RCH, S.à r.l., a été modifié
comme suit:
<i>Gérant unique:i>
Monsieur Christophe Santini, demeurant à Bettembourg, 123, rue Klensch.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06641/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
ROMIGOLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 136, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 44.419.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 5, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06646/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12457
REPUCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Fentange, 132, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 51.606.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 15, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.
Signature
(06642/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
RAMIREZ ELECTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2423 Luxembourg, 27, rue du Pont-Rémy.
R. C. Luxembourg B 43.508.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administration:i>
M. Francisco Ramirez, administrateur de société, Luxembourg, administrateur-délégué;
Mme Michèle Ramirez-Schmitz, administrateur de société, Luxembourg;
M. Udo Schönwolf, administrateur de société, D-Rehlingen/Hemmersdorf (en remplacement de M. Guy Charpantier).
<i>Commissaire aux comptes:i>
Mme Margot Bechet-Gras, employée privée, Luxembourg.
Luxembourg, le 13 octobre 1999.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RAMIREZ ELECTRO S.A.
i>KPMG Experts-Comptables
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembr 1999, vol. 530, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06640/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
R.M.C., RESTAURANT MAURIZIO CLAUSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1831 Luxembourg, 21, rue de la Tour Jacob.
R. C. Luxembourg B 57.271.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN
Signature
(06643/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
RETROUVAILLES PRET-A-PORTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5552 Remich, 40, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 65.543.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 90, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Pour la société RETROUVAILLES PRET-A-PORTER, S.à r.l.i>
VIP COMPTA S.A.
Signature
(06644/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SASTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 59.125.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06656/779/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12458
SABIAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 31.491.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 532, fol. 100, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 13 mai 1999i>
L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Stéphane Liegeois.
Et le mandat de commissaire aux comptes de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
P. Rochas
Signature
(06651/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SABLIERE HEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5404 Bech-Kleinmacher, 1, quai de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 19.166.
Constituée par-devant Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 1982, acte
publié au Mémorial C, numéro 114 du 1
er
juin 1982, modifiée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence
à Junglinster, en date du 15 octobre 1987, acte publié au Mémorial C, numéro 20 du 22 janvier 1988, modifiée par-
devant le même notaire en date du 6 janvier 1992, acte publié au Mémorial C, numéro 297 du 6 juillet 1992,
modifiée par-devant le même notaire en date du 13 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, numéro 35 du 19
janvier 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2000, vol. 532, fol. 93, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SABLIERE HEIN, S.à r.l.i>
KPMG Experts-Comptables
Signature
(06652/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
PICTET GLOBAL SELECTION FUND, Fonds Commun de Placement.
—
MANAGEMENT REGULATIONS
1) The Fund
PICTET GLOBAL SELECTION FUND (hereafter referred to as the «Trust»), organised under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund (fonds commun de placement), is an unincorporated coproprie-
torship of securities and other assets (hereinafter referred to as «securities»), managed in the interest of its co-owners
(hereafter referred to as the «shareholders») by PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEM-
BOURG) S.A. (hereafter referred to as the «Management Company»), a company incorporated under the laws of
Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. The assets of the Trust, which are held in custody by
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A. (hereafter referred to as the «Custodian») are segregated from those of the
Management Company and from those of any other funds managed by the Management Company. By the acquisition of
shares of the Trust, any shareholder fully accepts these management regulations which determine the contractual relati-
onship between the shareholders, the Management Company and the Custodian.
The Trust will be an umbrella fund consisting of different sub-funds (hereinafter referred to as «Fund» or the «Funds»)
(as defined hereafter) to be created pursuant to Article 4).
2) The management company
The Trust is managed on behalf of the shareholders by the Management Company which shall have its registered
office in Luxembourg.
The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Trust, subject to the
restrictions set forth in Article 6) hereafter, on behalf of the shareholders, including but not limited to, the purchase,
sale, subscription, exchange and of any securities and the exercise of all rights attached directly or indirectly to the assets
of the Trust.
The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of each Fund.
12459
The Board of Directors of the Management Company may appoint a general manager or managers and/or admini-
strative agents to implement the investment policy and administer and manage the assets of the Trust.
The Management Company may obtain investment information, advice and other services, remuneration for which
will be at the Trust’s or the Fund’s charge to the extent provided herein.
3) The custodian
The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian. BANQUE PICTET
(LUXEMBOURG) S.A. has been appointed Custodian.
The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon 90
days written notice delivered by the one to the other.
In the event of termination of the appointment of the Custodian, the Management Company will use its best endea-
vours to appoint within 2 months of such termination, a new custodian who will assume the responsibilities and
functions of the Custodian under these Management Regulations. Pending the appointment of a new Custodian, the
Custodian shall take all necessary steps to ensure good preservation of the interests of the shareholders. After termi-
nation as aforesaid, the appointment of the Custodian shall continue thereafter for such period as may be necessary for
the transfer of all assets of the Trust to the new Custodian. The Custodian shall assume its functions and responsibilities
in accordance with the law of March 30, 1988 on collective investment undertakings.
All cash and securities constituting the assets of the Trust shall be held by the Custodian on behalf of the shareholders
of the Trust. The Custodian may entrust banks and financial institutions with the custody of such securities. The
Custodian may hold securities in accounts with such clearing houses as the Custodian may determine. It will have the
normal duties of a bank with respect to the Trust’s deposits of cash and securities. The Custodian may only dispose of
the assets of the Trust and make payments to third parties on behalf of the Trust on receipt of instructions from the
Management Company or its appointed agents.
Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all
acts of disposal with respect to the assets of the Trust.
The Custodian is entitled to such fees as will be determined from time to time by agreement between the
Management Company and the Custodian. Such fee is based on the net assets of the Trust or the Funds.
4) The Sub-Funds
The Management Company may, from time to time, with the consent of the Custodian, create Funds (collectively
«Funds» and individually «Fund»), which have different investment policies. The shares issued by the Management
Company in relation to each Fund shall constitute shares of a class separate from the other share classes created in
relation to other Funds.
A separate portfolio of investments and assets will be maintained for each Fund. The different portfolios will be
separately invested in accordance with an investment policy fixed for each Fund.
Upon creation of a Fund, these Management Regulations shall be completed by an appendix containing the name and
investment policy of the Fund concerned as well as any other possible specificities of the Fund.
Any Fund may be dissolved upon decision of the Management Company with the consent of the Custodian as more
fully described in Article 20) hereafter.
5) Investment policy
The investment policy of each Fund will be set forth in an appendix, for each Fund, attached to these Management
Regulations.
6) Investment restrictions
1) The Management Company may not, on behalf of a Fund, invest in securities of any one issuer, if the value of the
holdings of a Fund in the securities of such issuer exceeds 10% of such Fund’s total net assets, except that such
restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the Organisation for Economic
Cooperation and Development («OECD») or their local authorities or public international bodies with European Union
(«EU»), regional or world-wide scope.
2) The Management Company may not invest, on behalf of any Fund, in securities of any single issuer if, as a result of
such investment, the Trust owns more than 10% of any class of securities issued by any single issuer. The Management
Company may not purchase securities of any company or other body if, upon such purchase, the Trust, together with
other investment funds which are managed by the Management Company, would own more than 15% of any class of the
securities of such company or body. This restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by member States
of the OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or worldwide scope. The
aforesaid limitations of 10% and 15%, to the extent that they refer to a specific kind of securities or a specific class of
securities, shall not prevent any Fund from subscribing to 100% of one issue of certificates of deposit or of commercial
paper of one specific issuer.
3) The Management Company may not make investments for the purpose of exercising control or management.
4) The Management Company may invest, up to 10% of the net assets of each Fund in shares or units of other
collective investment funds . The acquisition of shares or units in a collective investment fund managed by the same
Management Company or by any other company with which the Management Company is linked by common
management or control or by substantial direct or indirect holding shall be permitted only if the Management Company
and any investment managers/advisers appointed by it, do not charge any fee or cost on account of transactions in
connection with such shares or units.
12460
5) The Management Company may not purchase, on behalf of a Fund, real estate except that it may purchase and sell,
on behalf of the Fund, securities that are secured by real estate or interests therein or issued by companies which invest
in real estate or interests therein.
6) The Management Company may not, on behalf of a Fund, enter into transactions involving commodities,
commodity contracts or securities representing merchandise or rights to merchandise and for the purposes hereof
commodities includes precious metals, except that it may purchase and sell, on behalf of a Fund, securities that are
secured by commodities and securities of companies which invest or deal in commodities.
7) The Management Company may not, on behalf of a Fund, purchase any securities on margin, (except that it may
obtain such short-term credit as may be necessary for the clearance of purchases and sales of portfolio securities) or
make short sales of securities or maintain a short position, except that it may make initial and maintenance margin
deposits in respect of futures and forward contracts (and options thereon).
8) The Management Company may not, on behalf of a Fund, borrow other than borrowings which in the aggregate
do not exceed 10% of the total net assets of such Fund, which borrowings may, however, only be made on a temporary
basis.
9) The Management Company may not, on behalf of a Fund, invest more than 10% of the net assets of such Fund in
securities which are not traded on an official stock exchange or other regulated market, except that such restriction
shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the OECD or their local authorities or public
international bodies with EU, regional or world-wide scope; provided however that this restriction shall not apply to
money market instruments which are traded regularly.
10) The Management Company may not use the assets of a Fund to underwrite or subunderwrite any securities.
11) The Management Company may employ, on behalf of a Fund, techniques and instruments relating to transferable
securities under the conditions and within the limits laid down by law, regulation or administrative practice provided that
such techniques or instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. With respect to options:
a) the Management Company may not invest, on behalf of a Fund, in put or call options on securities unless:
i) such options are quoted on a stock exchange or dealt in on a regulated market; and
ii) the acquisition price of such options does not exceed, in terms of premiums, 15% of the total net assets of such
Fund;
b) the Management Company may not sell, on behalf of a Fund, call options on securities which it does not hold,
except that the Management Company may, on behalf of a Fund, sell uncovered call options, provided that the aggregate
of the exercise prices of such uncovered call options does not exceed 25% of the net assets of the relevant Fund and
the Management Company is at any time in a position to ensure the coverage of the position taken as a result of the sale
of such options;
c) the Management Company, on behalf of a Fund, may not write put options on securities unless such Fund holds
sufficient liquid assets to cover the aggregate of the exercise prices of such options written.
12) The Management Company shall not, on behalf of a Fund, acquire or deal in forward currency contracts except
that the Management Company may, for the purpose of hedging currency risks, enter into swap contracts and forward
currency contracts or write call options and purchase put options on currencies provided, however, that:
a) these transactions may only concern contracts which are traded on a regulated market operating regularly, being
recognised and open to the public except that the Management Company may, on behalf of a Fund, also enter into
forward sales of currencies or exchange currencies on the basis of private agreements with highly rated financial insti-
tutions specialised in these type of transactions;
b) the transactions made for a Fund in one currency may in principle not exceed the valuation of the aggregate assets
of such Fund denominated in that currency nor exceed the period during which such assets are held provided, however,
that this limitation shall not be applicable to hedging transactions intended to preserve the Yen value of shares, if such
hedging policy is provided for in the investment policy of the relevant Fund. The Management Company may, on behalf
of each Fund, purchase the currency concerned through a cross transaction (entered into through the same
counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the Fund concerned.
13) The Management Company shall not deal, on behalf of a Fund, in financial futures, except that:
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of the portfolio securities the Management
Company, on behalf of a Fund, may have outstanding commitments in respect of financial futures sales contracts not
exceeding the corresponding risk of fluctuation of the value of the corresponding portion of such Fund’s portfolio; and
b) for the purpose of efficient portfolio management the Management Company, on behalf of a Fund, may enter into
financial futures purchase contracts in order to facilitate changes in the allocation of such Fund’s assets between markets
or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided that sufficient cash, short dated debt securities
or instruments (other than the liquid assets referred to in 11c) above), or securities to be disposed of at a predeter-
mined value exist within such Fund to match the underlying exposure of any such futures positions.
14) The Management Company shall not deal, on behalf of a Fund, in index options except that:
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of a Fund’s portfolio securities, the Management Company,
on behalf of such Fund, may sell call options on stock indexes or acquire put options on stock indexes. In such event the
value of the underlying securities included in the relevant stock index option shall not exceed, together with outstanding
commitments in financial futures contracts sold for the same purpose, the aggregate value of the portion of the securities
portfolio to be hedged; and
b) for the purpose of the efficient management of a Fund’s portfolio securities, the Management Company, on behalf
of a Fund, may acquire call options on stock indexes mainly in order to facilitate changes in the allocation of such Fund’s
assets between markets or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided the value of the under-
12461
lying securities included in the relevant stock index options is covered by cash, short dated debt securities and instru-
ments (other than the liquid assets which may have to be held by a Fund concerned pursuant to restriction 11c) and 13b)
above) or securities to be disposed of at predetermined prices;
provided however that the aggregate acquisition cost (in terms of premiums paid) of options on securities and index
options purchased by the Management Company, on behalf of such Fund, shall not exceed 15% of the net assets of such
Fund.
15) The Management Company may, on behalf of a Fund, sell interest rate future contracts for the purpose of
achieving a global hedge against interest rate fluctuations. It may also for the same purpose write call options or purchase
put options on interest rates or enter into interest rate swaps by private agreement with highly rated financial institu-
tions specialised in this type of transactions. The aggregate of the commitments relating to future contracts, options and
swap transactions on interest rates may not exceed the aggregate estimated market value of the assets to be hedged and
held by a sub-fund in the currency corresponding to these contracts.
The Management Company need not comply with the investment limit percentages laid down above when exercising
subscription rights attached to securities which form part of the assets of a Fund.
If such percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the
exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transactions
for the Fund concerned the remedying of that situation, taking due account of the interests of the relevant Fund’s
shareholders.
The Management Company, acting on behalf of the Fund, shall not sell, purchase or loan securities except the shares
of the Funds, or receive loans, to or from (a) the Management Company (b) its affiliated companies (c) any director of
the Management Company or its affiliated companies or (d) any major shareholder thereof (meaning a shareholder who
holds, on his own account whether in his own or other name (as well as a nominee’s name), 10% or more of the total
issued outstanding shares of such a company) acting as principal or for their own account unless the transaction is made
within the restrictions set forth hereabove, and, either (i) at a price determined by current publicly available quotations,
or (ii) at competitive prices or interest rates prevailing from time to time, on internationally recognised securities
markets or internationally recognised money markets.
The Management Company, on behalf of a Fund, may not grant loans or act as guarantor in favour of third parties.
The Management Company may from time to time impose further investment restrictions as shall be compatible with
or in the interest of the shareholders, in order to comply with the laws and regulations of the countries where the
shares of the Funds are placed.
7) Issue of shares
Shares of a Fund shall be issued by the Management Company subject to payment therefor to the Custodian within
such period thereafter as the Management Company may from time to time determine.
All shares within each Fund have equal rights and privileges. Each share of each Fund is, upon issue, entitled to parti-
cipate equally with all other shares of such Fund in any distribution upon declaration of dividends in respect of such Fund
and upon liquidation of the Fund.
Certificates for shares or confirmations of shareholding shall be delivered by the Management Company provided that
payment therefor has been received by the Custodian.
The Management Company shall comply, with respect to the issuing of shares, with the laws and regulations of the
countries where these shares are offered. The Management Company may, at its discretion, discontinue temporarily,
cease definitely or limit the issue of shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain
countries or territories. The Management Company may prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring
shares, if such a measure is necessary for the protection of the shareholders as a whole and the Trust.
The Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for purchase of shares;
(b) repurchase at any time the shares held by shareholders who are excluded from purchasing or holding shares.
More specifically:
a) The Management Company will not promote the sale of the Trust’s shares to the public within the European Union
(«EU»), or any part of it,
b) None of the shares is registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the «1933 Act»).
Except as described below, none of the shares may be offered, sold, transferred or delivered, directly or indirectly, in
the United States of America or to any citizen or resident thereof («U.S. Person»).
For the purpose of restricting or preventing the beneficial ownership of Trust shares by any U.S. Person, as defined
above, except those U.S. Persons who purchase shares in a private placement, as provided above, the Management
Company or its agent may:
(a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in beneficial ownership of such shares by a U.S. Person; and
(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on, the Register of shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider
necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s shares rests in a
U.S. Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a U.S. Person; and
(c) where it appears to the Management Company that any U.S. person either alone or in conjunction with any other
person is a beneficial owner of shares, compulsorily repurchase or cause to be repurchased from any such shareholder
all shares held by such shareholder, in the following manner:
12462
(i) the Management Company or its agent shall serve a notice (the «purchase notice») upon the shareholder appearing
in the Register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser. Any such notice may
be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder
at his address appearing in the books of the Trust. The shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to
the Management Company or its agent the share certificate or certificates (if any are issued) representing the shares
specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such
shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed from the
registration of such shares in the Register of shareholders;
(ii) the price at which each such share is to be purchased (the «purchase price») shall be an amount equal to the per
share Net Asset Value of shares in the relevant Fund as at the applicable Dealing Day specified by the Management
Company or the Dealing Day following the surrender of the share certificate or certificates representing the shares
specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with these Management Regulations;
(iii) payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares in the reference
currency of the relevant Fund or, in the discretion of the Management Company, in any other freely convertible
currency at the rate of exchange for the reference currency of the relevant Fund on the date of payment and will be
deposited for payment to such owner with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice)
upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified in
such notice. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such
shares or any of them, nor any claim against the Trust or its assets nor against the Management Company, the Custodian
or any other person in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank
following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any funds receivable by a shareholder
under this paragraph, but not collected within a period of notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the
relevant Fund. The Management Company shall have power from time to time to take all steps necessary and to
authorise such action on behalf of the Trust to perfect such reversion;
(iv) the exercise by the Management Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or
invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that
the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Management Company at the date of any purchase
notice, provided in such case the said powers were exercised by the Management Company in good faith.
8) Issue price
The issue price per share of each Fund will be the net asset value per share of each sub-fund determined on the appli-
cable Dealing Day and calculated in accordance with Article 10) hereafter.
Shares of a Fund are issued by the Management Company on every day defined as a «Dealing Day» for such Fund in
its relevant Appendix hereto. Any application for purchase of shares received in respect of a specific Dealing Day must
be received by the Management Company prior to such time on such Dealing Day as the Management Company may
from time to time decide and any application received after the relevant time shall be deemed to have been received on
the next Dealing Day.
After the initial offering of shares of a Fund, the issue price per share of such Fund will be the net asset value per share
determined for such Fund on the Dealing Day on which the application for purchase of shares is received or deemed to
be received. There may be added to the applicable net asset value a sales charge of up to 3% of such net asset value. Such
sales charge shall be retained by the distributors acting in the placement of the shares.
Under certain circumstances, the Management Company has the Power to charge a «dilution levy» on the issue price
as described hereafter under the Article 14) «Dilution Levy». In any case, the effective dilution levy charged on any
Dealing Day shall be identical for all issues effected on such day.
Payment for shares must be made in the currency of the relevant Fund in the form of cash transfer to the order of
the Custodian within 4 Dealing Days following the Dealing Day on which the application for purchase of shares was dealt
unless otherwise specified in the relevant Fund’s Appendix.
9) Share certificates
Any person or corporate body shall be eligible to participate in a Fund by subscribing for one or several shares,
subject, however, to the provisions contained in Article 7) of these Management Regulations. The Management
Company shall issue shares in registered form only. Fractions of shares shall be issued up to five (5) decimal places.
Shares certificates shall carry the signatures of the Management Company and the Custodian, both of which may be in
facsimile. Certificates confirming ownership of fractional shares will not be issued. In the absence of a request for certi-
ficates, investors will be deemed to have requested that no certificate be issued in respect of their shares and a confir-
mation of shareholding will be delivered instead. Where share certificates are requested a standard charge per certi-
ficate will be levied by the Registrar and Transfer Agent to cover the expenses resulting from the issue and the mailing
of the certificate.
10) Determination of net asset value of shares
The Net Asset Value of Shares of each Fund in the Trust shall be expressed in its reference currency defined in its
Appendix as a per share figure.
The Net Asset Value of Shares of each Fund will be determined by the Management Company on each Dealing Day
by dividing the value of the assets of the relevant Fund less the liabilities attributable to it (including any provisions consi-
dered by the Management Company to be necessary or prudent) by the total number of Shares of the relevant Fund
12463
outstanding and by rounding the resulting amount to the nearest cent of the relevant reference currency. To the extent
possible, investment income, interest payable, fees and other liabilities (including management fees) will be accrued.
Unless otherwise provided in the Appendix of the concerned Fund, the assets of the Trust will be valued as follows:
(a) securities listed on a Stock Exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last available
price on such Exchange or market. If a security is listed on several Stock Exchanges or markets, the last available price
at the Stock Exchange or market which constitutes the main market for such securities, will be determining;
(b) securities not listed on any Stock Exchange or traded on any regulated market will be valued at their last available
transaction price;
(c) securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is not repre-
sentative of the fair market value, will be valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonable foreseeable
sales prices;
(d) short term liquid assets will be valued at their amortised cost;
(e) values expressed in a currency other than the currency of the Fund concerned shall be translated to that currency
at the applicable exchange rate.
Funds dealing in markets where the transaction costs are high may apply the cost of dealing to the calculation of the
net asset value. In order to maintain a single net asset value for subscriptions and redemptions the net movement of
shares for any Dealing Day will determine the method of calculation of the Net Asset Value. Where there are net
subscriptions the dealing costs will be added to the total net assets; in the case where there are net redemptions the
dealing costs will be deducted from the total net assets.
In the event that extraordinary circumstances render such a valuation impracticable or inadequate, the Management
Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets
of the Trust.
For the purpose of determining the assets and liabilities of each Fund there shall be established a pool (each a «pool»)
of assets for each Fund in the following manner:
(a) the proceeds from the issue of shares of each Fund shall be applied in the books of the Trust to the pool of assets
established for that Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied
to such pool subject to the provisions of this Article;
(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Trust to
the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in
value shall be applied to the relevant pool;
(c) where the Trust incurs a liability which relates to any asset of a particular pool, such liability shall be allocated to
the relevant pool;
(d) in the case where any asset or liability of the Trust cannot be considered as being attributable to a particular pool,
such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the total Net Asset Values of the relevant Funds;
provided that all liabilities, whatsoever pool they are attributable to, shall unless otherwise agreed upon the creditors,
be binding upon the Trust as a whole;
(e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any Fund, the Net
Asset Value of shares of such Fund shall be reduced by the amount of such dividends.
11) Suspension of determination of net asset value
The Management Company may temporarily suspend the determination of the net asset value of a Fund and in conse-
quence the issue, repurchase and conversion (if applicable) of shares of such Fund in any of the following events:
- when one or more Stock Exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the
assets of the Fund, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of the
assets of the Fund is denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are restricted
or suspended;
- when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility
and the control of the Management Company, disposal of the assets of the Fund is not reasonably or normally
practicable without being seriously detrimental to the interests of the shareholders;
- in the case of a breakdown in the normal means of communication or of the computers used for the valuation of
any investment of the Fund or if, for any reason, the value of any asset of the Fund may not be determined as rapidly and
accurately as required;
- if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of
the Fund are rendered impracticable or if purchases and sales of the Fund’s assets cannot be effected at normal rates of
exchange.
12) Repurchase
Unless otherwise provided in the Appendix relating to a Fund, shareholders may request the repurchase of their
shares on any day defined as a Dealing Day for the relevant Fund. Any application for repurchase of shares must indicate
the number of Shares to be repurchased and must be received by the Management Company prior to such time on the
applicable Dealing Day as the Management Company may from time to time decide and any application received after
such time shall be deemed to have been received on the next Dealing Day.
Repurchase will be made at such net asset value per share of the relevant Fund determined on the Dealing Day on
which the application for repurchase of shares is received or deemed to be received. Such repurchase request must be
accompanied by the relevant share certificates (if issued).
12464
No repurchase fee will be charged. However, under certain circumstances, the Management Company has the power
to charge a «dilution levy» on the redemption price as described hereafter under Article 14) «Dilution Levy». In any
case, the effective dilution levy charged on any Dealing Day shall be identical for all redemptions effected on such day.
Repurchase must be made in integral multiples of one share.
Payment of the repurchase price shall be made within 4 Dealing Days following the Dealing Day on which the appli-
cation was dealt with provided that the share certificates (if issued) are received by the Management Company.
The Management Company shall ensure that each Fund maintains an appropriate level of liquidity, so that under
normal circumstances repurchase of the shares of the Fund may be made promptly upon request by shareholders.
If total requests for repurchase on any Dealing Day (the «relevant Dealing Day») are received in respect of a number
of shares of any Fund which exceed 5% of the total number of shares of that Fund outstanding on such Dealing Day, the
Management Company may, at its discretion, defer all redemption requests pro-rata so that the 5% level is not
exceeded. Any repurchase requests in respect of the relevant Dealing Day so reduced will be effected in priority to
subsequent repurchase requests received on the Dealing Day, subject always to the 5% limit.
The Custodian must make payment only if no statutory provisions, such as exchange control regulations or other
circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the transfer of the payment of the repurchase price to the
country where reimbursement was applied for.
13) Conversions
If several Funds exist and if to the extent permitted and provided in an Appendix hereto relating to each Fund,
shareholders wishing to convert shares of one Fund to shares of other Funds and vice versa will be entitled to do so on
any Dealing Day of both relevant Funds, or on the next following common Dealing Day, by tendering the Share certifi-
cates (if issued) to the Management Company, accompanied with an irrevocable written conversion request.
Any conversion request should specify the number of shares to be converted, provided that the number of Shares to
be converted shall be more than the minimum number designated in the appendix of each sub-fund. The number of
Shares issued upon conversion will be based upon the respective Net Asset Value of the two Funds on the applicable
Dealing Day and shall be calculated as follows:
NAV2 x N2
N1 =
NAV1
N1: The number of shares to be issued upon conversion.
N2: The number of shares requested for conversion.
NAV1: Applicable Net Asset Value of shares to be issued upon conversion.
NAV2: Applicable Net Asset Value of Shares requested for conversion which is converted into the reference
currency of shares to be issued upon conversion at the applicable exchange rate on the applicable Dealing Day.
There will be no conversion charge. However, under certain circumstances, the Management Company has the
power to charge a «dilution levy» on the conversion amount as described hereafter under Article 14) «Dilution Levy».
In any case, the effective dilution levy charged on any Dealing Day shall be identical for all conversions effected on such
day.
14) Dilution levy
Under certain circumstances (for example, large volumes of deals) investment and/or disinvestment costs may have
an adverse effect on the shareholder’s interest in a Fund or Funds. In order to prevent this effect, called «dilution», the
Management Company has the power to charge a «dilution levy» on the issue, redemption and/or conversion of shares
of any Fund. If charged, the dilution levy will be paid into the relevant Fund and will become part of the relevant Fund.
The dilution levy for each Fund will be calculated by reference to the costs of dealing in the underlying investments of
that Fund, including any dealing spreads, commission and transfer taxes.
The need to charge a dilution levy will depend on the volume of issues, redemptions or conversions. The Management
Company may charge a discretionary dilution levy on the issues, redemptions and conversions of shares, if in its opinion,
the existing shareholders (for issues) or remaining shareholders (for redemptions) might otherwise be adversely
affected. In particular, the dilution levy may be charged in the following circumstances: (a) where a Fund is in continual
decline (for example, large volume of redemption requests); (b) on a Fund experiencing large levels of net issues relative
to its size; (c) on «large deals». For these purposes, a large deal is defined as 5% of the size of the Fund; (d) in any other
case where the Management Company is of the opinion that the interests of the shareholders require the imposition of
the dilution levy.
In any case, the dilution levy shall not exceed 2% of the net asset value per share.
15) Charges of the trust
The fees payable to the Management Company, any investment managers and/or investment advisers and the distri-
butors are fixed for each Fund in its relevant Appendix.
The Custodian shall be entitled to receive out of the moneys of each Fund a custodian fee in accordance with usual
practice in Luxembourg. Such fee is based on the total net assets of each Fund and is payable monthly. Any reasonable
disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses)
incurred by the Custodian, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of a
Fund is entrusted, shall be borne by such Fund.
12465
The Trust and the Funds, as appropriate, will bear the following charges:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Trust;
- the reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Custodian and any custody charges of banks and financial institutions to whom
custody of assets of the Funds is entrusted;
- usual banking fees due on transactions involving securities held in the portfolio of the Funds (such fees to be included
in the acquisition price and to be deducted from the selling price);
- the fees and expenses of the Custodian and other banks and financial institutions entrusted by the Custodian with
custody of assets of the Funds, and of the Registrar and Transfer Agent, Administrative Agent, Domiciliary Agent and
Paying Agent;
- legal expenses incurred by the Management Company or the Custodian while acting in the interests of the
shareholders;
- the cost of preparing and/or filing the Management Regulations and all other documents concerning the Trust,
including registration statements, prospectuses and explanatory memoranda with all authorities (including local
securities dealers associations) having jurisdiction over the Trust or the offering of shares of the Trust; the cost of
preparing, in such languages as are necessary for the benefit of the shareholders (including the beneficial holders of the
shares), and distributing annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be required under
the applicable laws or regulations of the above-cited authorities; the cost of accounting, bookkeeping and calculating the
daily net asset value; the cost of preparing and distributing public notices to the shareholders; lawyers’ and auditor’s fees;
the costs incurred with the admission and the maintenance of the shares on the stock exchanges on which they are listed
(if listed); and all similar administrative charges, including, unless otherwise decided by the Management Company, all
advertising expenses and other expenses directly incurred in offering or distributing the shares.
All organisational expenses may be amortised over a period not exceeding five years.
16) Accounting year, Audit
The accounts of the Trust and the Funds are closed each year on 31st December and for the first time on 31st
December, 1999.
The Management Company shall appoint an auditor who shall, with respect to the assets of the Trust, carry out the
duties prescribed by the law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings.
The Management Company or its appointed agent shall prepare audited annual accounts and unaudited semi-annual
accounts for the Trust. The reports shall contain individual financial informations on each Fund expressed in the
reference currency of such Fund and consolidated financial informations on the Trust, expressed in United states
Dollars.
17) Dividends
The distribution policy applicable to each Fund is described in its relevant Appendix.
No distribution may be made as a result of which the net assets of the Trust would become less than the minimum
of Luxembourg Francs 50,000,000.-as prescribed by Luxembourg law. Dividends not claimed within five years from their
due date will lapse and revert to the relevant Fund.
18) Amendment of the management regulations
The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or
in part at any time.
Amendments will become effective five days after their publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of Luxembourg.
19) Publications
The net asset value, the issue price and the repurchase price per share of each Fund will be available in Luxembourg
at the registered office of the Management Company and the Custodian.
The audited annual reports and the unaudited semi-annual reports of the Trust are made available to the shareholders
at the registered offices of the Management Company, the Custodian and any Paying Agent.
Any amendments to these Management Regulations, will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of Luxembourg.
The amendments and any notices to shareholders may also be published, as the Management Company may decide,
in newspapers of countries where the shares of the Trust are offered and sold.
20) Duration of the trust and the Sub-Funds, Liquidation
The Trust is established for an undetermined period. The Trust may be dissolved at any time by mutual agreement
between the Management Company and the Custodian. The Trust will further be dissolved in any cases required under
Luxembourg law. Any notice of dissolution will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of
Luxembourg and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a Luxembourg
newspaper.
Issuance, repurchase and conversion of shares will cease at the time of the decision or event leading to the dissolution
of the Trust.
The Management Company will realise the assets of the Trust in the best interests of the shareholders and, upon
instructions given by the Management Company, the Custodian will distribute the net proceeds of the liquidation, after
deducting all liquidation expenses, among the shareholders in proportion of the shares held.
Each Fund is established for a period specified in the appendix relating to such Fund.
12466
By agreement between the Management Company and the Custodian, (i) a Fund may be liquidated at any time and
shareholders of such Fund will be allocated the net sales proceeds of the assets of the Fund or (ii) a Fund may be liqui-
dated at any time and shares of another Fund may be allocated to the shareholders of the Fund to be liquidated against
contribution in kind of the assets of such Fund (to be valued by an auditor’s report) to the other Fund. A liquidation and
contribution as contemplated in (ii) can only be made if such liquidation is justified by the size of the liquidated Fund, by
a change of the economical or political situation affecting the Fund or is made for any other reason to assure the best
interest of the shareholders concerned.
In case of a liquidation as described in (i) above, the effective date of the liquidation will be notified to shareholders
by mail or by fax.
In case of liquidation and contribution of a Fund as described in (ii) above, all shareholders of the concerned Fund will
receive one month prior notice of such liquidation by mail.
If the net asets of a Fund fall below USD 3,000,000.- the Management Company will contemplate the dissolution of
such Fund.
Until the effective date of the liquidation of a Fund, shareholders may continue to repurchase or convert their shares
at the applicable net asset value reflecting provisions made to cover expenses resulting from the liquidation of the
relevant Fund.
The liquidation or the partition of the Trust and/or any Fund may not be requested by a shareholder, nor by his heirs
or beneficiaries.
21) Statute of limitation
The claims of the shareholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date
of the event which gave rise to such claims.
22) Applicable law, Jurisdiction and governing language
Disputes arising between the shareholders, the Management Company and the Custodian shall be settled according
to Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the
Management Company and the Custodian may subject themselves and the Trust to the jurisdiction of courts of the
countries, in which the shares of the Trust are offered and sold, with respect to claims by investors resident in such
countries and with respect to matters relating to subscriptions and repurchases by shareholders resident in such
countries, to the laws of such countries. English shall be the governing language for these Management Regulations.
These Management Regulations have been executed on 28th October, 1998 and become effective on 28th October,
1998.
These Management Regulations have been modified on 7 May, 1999 and become effective on 1 June 1999. They also
have been modified on 12 January, 2000 and become effective on 2 February 2000.
Luxembourg, 25 January, 2000
PICTET GLOBAL SELECTION FUND
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
a<i>s Custodiani>
<i>as Management Compi>any
APPENDIX 1
Relating to the Fund
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - GLOBAL EQUITY FUND
1. Name
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - GLOBAL EQUITY FUND (the «Fund»).
2. Objectives and Investment Policy
The objective of this Fund is to offer the opportunity to share in the growth of the world’s leading stock markets.
For this purpose, the Fund will mainly be invested in negotiable securities listed on world equity markets. This Fund
will be actively managed and the aim of the manager is to outperform the reference index by the allocation of the assets
among an adequate selection of equities.
The reference index for this Fund shall be the Morgan Stanley Capital International («MSCI») World Index (or any
other Index that shall be deemed an appropriate comparison for performance purposes by the Management Company).
The Fund may also hold, on an ancillary basis, cash and equivalent short-term money-market instruments which are
dealt in on a regular basis and which have a residual maturity not exceeding twelve months.
The Fund may, within the limits specified in the investment restrictions, use derivative instruments and products, and
deal in currency forward operations.
Use of the aforesaid techniques and instruments involves certain risks, for example the leveraging effect may have a
negative effect on the performance of the Fund, and there can be no assurance that the objective sought from the use
of such instruments will be achieved.
The reference currency of the Fund shall be the Euro.
3. Distribution policy
It is the present intention of the Management Company not to make any dividend distributions.
4. Dealing Day
A «Dealing Day» for the Fund shall mean each day which is a Bank Business day in Luxembourg.
12467
5. Management Company fee
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of
0.95% calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter.
6. Management and Investment Advice
The Management Company has appointed PICTET ASSET MANAGEMENT UK Ltd. («PAM») and PICTET
ADVISORY SERVICES (OVERSEAS) Ltd («PASO») as investment advisers (the «Investment Advisers») to advise on the
investments of the Fund. The Mnagagement Company has also delegated, under its overall supervision and control the
day-to-day management of the Fund to PAM.
PASO was formed in Nassau, Bahamas, in 1976 with a capital of CHF 150,000.-. Its main function is to gather all
worldwide information produced by Pictet’s financial analysts and to reformat the reports for Pictet’s offshore offices.
PAM is an affiliate of PICTET & CIE, Genève, a private Swiss bank, which was founded in 1805. PAM was established
in 1980 and manages institutional assets of the Pictet Group. It is regulated by the Investment Management Regulatory
Organisation (IMRO).
The fees of the Investment Advisers will be borne by the Management Company out of the fee which it receives from
the Fund as described under 5. above.
7. Distributors’ Fee
The Distributor outside Japan appointed by the Management Company in connection with the offer of the Fund
outside Japan is entitled to fees payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of 0.95% calculated on
the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter. If an Agent Securities
Company and Distributor(s) in Japan have been appointed by the Management Company in connection with the offer of
the Fund in Japan, they will receive the fees referred to in this paragraph, in respect of the assets of the Fund attributable
to the shares sold in Japan and, in respect of such shares, no such fee will be paid to the Distributor outside Japan.
8. Duration
The Fund has been established for an undetermined period.
APPENDIX 2
Relating to the Fund
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - EUROPEAN EQUITY FUND
1. Name
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - EUROPEAN EQUITY FUND (the «Fund»).
2. Objectives and Investment Policy
The objective of this Fund is to achieve long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of European
equities listed on European exchanges (including the United Kingdom). A strong emphasis is placed on fundamental,
analytically-based stock selection. The Fund may invest up to 10% of its net assets in warrants on European equities. The
Fund may also invest up to maximum of 10% of its net assets in European companies which are listed on foreign
exchanges.
This Fund will be managed by a specialist team and will be benchmarked against the MSCI Europe Index (or any other
index that shall be deemed an appropriate comparison for performance purposes by the Management Company).
The portfolio structure may vary from the benchmark, since sector allocation depends on Europe’s position within
the prevailing macro-economic cycle. The portfolio construction will reflect a preference for stocks offering strong
earnings and cashflow progression. Stock selection will, therefore, be based on an appreciation of individual company
fundamentals. The investment team will undertake extensive primary company analysis to complement the use of broker
research information.
This Fund may hold, on an ancillary basis, cash and equivalent short-term money market instruments which are dealt
in regularly and have a residual maturity not exceeding twelve months.
In addition, the Fund may use derivative instruments to enhance the performance of the portfolio or to hedge the
portfolio, if it is considered to be in the best interests of shareholders. Such instruments may include, within the limits
set forth in the investment restrictions, future contracts.
Use of the aforesaid techniques and instruments involves certain risks, for example the leveraging effect may have a
negative effect on the performance of the Fund, and there can be no assurance that the objective sought to be obtained
from the use of such instruments will be achieved.
The reference currency of the Fund shall be the Euro.
3. Distribution policy
It is the present intention of the Management Company not to make any dividend distributions.
4. Dealing Day
A «Dealing Day» for the Fund shall mean each day which is a Bank Business day in Luxembourg.
5. Management Company fee
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of
0.95% calculated on the basis of the total average net assets attributable to this Fund during the relevant quarter.
6. Management and Investment Advice
The Management Company has appointed PICTET ASSET MANAGEMENT UK LTD. («PAM») and PICTET
ADVISORY SERVICES (OVERSEAS) Ltd («PASO») as investment advisers (the «Investment Advisers») to advise on the
investments of the Fund. The Management Company has also delegated, under its overall supervision and control, the
day-to-day management of the Fund to PAM.
12468
PASO was formed in Nassau, Bahamas, in 1976 with a capital of CHF 150,000.-. Its main function is to gather all
worldwide information produced by Pictet’s financial analysts and to reformat the reports for Pictet’s offshore offices.
PAM is an affiliate of PICTET & CIE, Genève, a private Swiss bank, which was founded in 1805. PAM was established
in 1980 and manages institutional assets of the Pictet Group. It is regulated by the Investment Management Regulatory
Organisation (IMRO).
The fees of the Investment Advisers will be borne by the Management Company out of the fee which it receives from
the Fund as described under 5. above.
7. Distributors’ Fee
The Distributor outside Japan appointed by the Management Company in connection with the offer of the Fund
outside Japan is entitled to fees payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of 0.95% calculated on
the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter. If an Agent Securities
Company and Distributor(s) in Japan have been appointed by the Management Company in connection with the offer of
the Fund in Japan, they will receive the fees referred to in this paragraph, in respect of the assets of the Fund attributable
to the shares sold in Japan and, in respect of such shares, no such fee will be paid to the Distributor outside Japan.
8. Duration
The Fund has been established for an undetermined period.
APPENDIX 3
Relating to the Fund
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - EUROPEAN BOND FUND
1. Name
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - EUROPEAN BOND FUND (the «Fund»).
2. Objectives and Investment Policy
The objective of the Fund is to achieve long term gains through investment in fixed income and floating rate securities
denominated in the currencies of or issued by countries of the European Union and other European countries. The
Fund’s portfolio include debt securities issued by sovereign entities, supranational organisations, public corporations and
private sector companies. The Fund may also invest in asset-backed securities.
The management team will take a fundamental approach to security selection, including macro-economic analysis,
yield curve analysis and a degree of credit analysis. The Fund will be invested predominantly in investment grade
securities or the equivalent, as defined by major rating agencies.
The Fund may also hold cash and short term money market instruments within the restrictions set forth under
«Management Regulations and Investment Restrictions» above.
In addition, the Fund may use derivatives instruments to enhance the performance of the portfolio or to hedge the
portfolio, if it is considered to be in the interest of shareholders. Such instruments may include, within the limits set forth
in the investment restrictions, futures contracts, options, warrants and other derivative contracts.
The Fund may use derivative instruments from time to time to hedge or to gain currency exposure which may expose
the shareholder to fluctuations in rates of exchange against the reference currency of the Fund. This may have a negative
effect on the value of the Fund’s assets, irrespective of the behaviour of the underlying securities.
Use of the aforesaid techniques and instruments involves certain risks, for example the leveraging effect may have a
negative effect on the performance of the Fund, and there can be no assurance that the objective sought to be obtained
from the use of such instruments will be achieved.
The reference index for this Fund shall be the Salomon Smith Barney Government Bond Index (or any other index
that shall be deemed an appropriate comparison for performance purposes by the Management Company).
The reference currency of the Fund shall be the Euro.
3. Distribution policy
It is the present intention of the Management Company not to make any dividend distributions.
4. Dealing Day
A «Dealing Day» for the Fund shall mean each day which is a Bank Business day in Luxembourg.
5. Management Company fee
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of
0.50% calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter.
6. Management and Investment Advice
The Management Company has appointed PICTET & CIE, Genève and PICTET ADVISORY SERVICES (OVERSEAS)
Ltd («PASO») as investment advisers (the «Investment Advisers») to advise on the investments of the Fund. The
Management Company has also delegated, under its overall supervision and control, the day-to-day management of the
Fund to PICTET & CIE, Genève.
PASO was formed in Nassau, Bahamas, in 1976 with a capital of CHF 150,000.-. Its main function is to gather all
worldwide information produced by Pictet’s financial analysts and to reformat the reports for Pictet’s offshore offices.
PICTET & CIE, Genève, is a private Swiss bank, which was founded in 1805 and which specialises in asset management.
With funds under management of more than 140 billion Swiss francs, PICTET & CIE is one of the largest Swiss private
banks and one of the leading fund management institutions in Europe.
The fees of the Investment Advisers will be borne by the Management Company out of the fee which it receives from
the Fund as described under 5. above.
12469
7. Distributors’ Fee
The Distributor outside Japan appointed by the Management Company in connection with the offer of the Fund
outside Japan is entitled to fees payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of 0.50% calculated on
the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter. If an Agent Securities
Company and Distributor(s) in Japan have been appointed by the Management Company in connection with the offer of
the Fund in Japan, they will receive the fees referred to in this paragraph, in respect of the assets of the Fund attributable
to the shares sold in Japan and, in respect of such shares, no such fee will be paid to the Distributor outside Japan.
8. Duration
The Fund has been established for an undetermined period.
APPENDIX 4
Relating to the Fund
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - US BOND FUND
1. Name
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - US BOND FUND (the «Fund»).
2. Objectives and Investment Policy
The objective of the Fund is to achieve long term gains through investment in fixed income and floating rate securities
predominantly denominated in the US dollar. The Fund may also from time to time invest in securities denominated in
currencies other than the US dollar. The Fund’s portfolio may include debt securities issued by sovereign entities, supra-
national organisations, public corporations and private sector companies. The Fund may also invest in asset-backed
securities.
The management team will take a fundamental approach to security selection, including macro-economic analysis,
yield curve analysis and a degree of credit analysis. The Fund will be invested predominantly in investment grade
securities or the equivalent, as defined by major rating agencies.
The Fund may also hold cash and short term money market instruments within the restrictions set forth under
«Management Regulations and Investment Restrictions» above.
In addition, the Fund may use derivative instruments to enhance the performance of the portfolio or to hedge the
portfolio, if it is considered to be in the best interest of shareholders. Such instruments may include within the limits set
forth in the investment restrictions, futures contracts, options, warrants and other derivative contracts.
The Fund may use derivative instruments from time to time to hedge or to gain exposure which may expose the
shareholder to fluctuations in rates of exchange against the reference currency of the Fund. This may have a negative
effect on the value of the Fund’s assets, irrespective of the behaviour of the underlying securities.
Use of the aforesaid techniques and instruments involves certain risks, for example the leveraging effect may have a
negative effect on the performance of the Fund, and there can be no assurance that the objective sought to be obtained
from the use of such instruments will be achieved.
The reference index for this Fund shall be the Salomon Smith Barney US Dollar Bond Index expressed in USD (or any
other index that shall be deemed an appropriate comparison for performance purposes by the Management Company).
The reference currency of the Fund shall be the USD.
3. Distribution policy
It is the present intention of the Management Company not to make any dividend distributions.
4. Dealing Day
A «Dealing Day» for the Fund shall mean each day which is a Bank Business day in Luxembourg.
5. Management Company fee
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of
0.50% calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter.
6. Management and Investment Advice
The Management Company has appointed PICTET ET CIE, Genève and PICTET ADVISORY SERVICES (OVERSEAS)
Ltd («PASO») as investment advisers (the «Investment Advisers») to advise on the investments of the Fund. The
Management Company has also delegated under its overall supervision and control, the day-to-day management of the
Fund to PICTET ET CIE, Genève.
PASO was formed in Nassau, Bahamas, in 1976 with a capital of CHF 150,000.-. Its main function is to gather all
worldwide information produced by Pictet’s financial analysts and to reformat the reports for Pictet’s offshore offices.
PICTET & CIE, is a private Swiss bank, which was founded in 1805 and which specialises in asset management. With
funds under management of more than 140 billion Swiss francs, PICTET & CIE, Genève is one of the largest Swiss private
banks and one of the leading fund management institutions in Europe.
The fees of the Investment Advisers will be borne by the Management Company out of the fee which it receives from
the Fund as described under 5. above.
7. Distributors’ Fee
The Distributor outside Japan appointed by the Management Company in connection with the offer of the Fund
outside Japan is entitled to fees payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of 0.50% calculated on
the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter. If an Agent Securities
Company and Distributor(s) in Japan have been appointed by the Management Company in connection with the offer of
12470
the Fund in Japan, they will receive the fees referred to in this paragraph, in respect of the assets of the Fund attributable
to the shares sold in Japan and, in respect of such shares, no such fee will be paid to the Distributor outside Japan.
8. Duration
The Fund has been established for an undetermined period.
APPENDIX 5
Relating to the Fund
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - EURO CASH FUND
1. Name
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - EURO CASH FUND (the «Fund»). On 1st January 1999 the Fund has
changed its name from PICTET GLOBAL SELECTION FUND - ECU CASH FUND to the current name.
2. Objectives and Investment Policy
The aim of the Fund is to offer investors a high level of capital preservation and a steady income in Euro through
investment in a diversified portfolio of liquid, high quality, fixed and floating rate instruments. The portfolio may include
fixed income securities such as bonds and bills issued by sovereign or government guaranteed entities, corporations,
eurobonds and floating rate securities. The Fund may also invest in debt instruments such as certificates of deposit,
commercial paper and bankers’ acceptances as well as time deposits.
The Fund may also hold cash and short term money market instruments within the restrictions set forth under
«Management Regulations and Investment Restrictions» above, as well as ancillary liquid assets and money market
instruments with a residual maturity of less than twelve months issued by first-class financial institutions.
The reference index of the Fund shall be the Three Months EURO LIBID (London Interbank Bid Rate) (or any other
index that shall be deemed an appropriate comparison for performance purposes by the Management Company).
The reference currency of the Fund is the Euro.
3. Distribution policy
It is the present intention of the Management Company not to make any dividend distributions.
4. Dealing Day
A «Dealing Day» for the Fund shall mean each day which is a Bank Business day in Luxembourg.
5. Management Company fee
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of
0.20% calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter.
6. Management and Investment Advice
The Management Company has appointed PICTET ET CIE, Genève and PICTET ADVISORY SERVICES (OVERSEAS)
Ltd («PASO») as investment advisers (the «Investment Advisers») to advise on the investments of the Fund. The
Management Company has also delegated, under its overall supervision and control, the day-to-day management
activities of the Fund to PICTET ET CIE Genève.
PASO was formed in Nassau, Bahamas, in 1976 with a capital of CHF 150,000.-. Its main function is to gather all
worldwide information produced by Pictet’s financial analysts and to reformat the reports for Pictet’s offshore offices.
PICTET & CIE, Genève, is a private Swiss bank, which was founded in 1805 and which specialises in asset management.
With funds under management of more than 140 billion Swiss francs, PICTET & CIE, Genève is one of the largest Swiss
private banks and one of the leading fund management institutions in Europe.
The fees of the Investment Advisers will be borne by the Management Company out of the fee which it receives from
the Fund as described under 5. above.
7. Distributors’ Fee
The Distributor outside Japan appointed by the Management Company in connection with the offer of the Fund
outside Japan is entitled to fees payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of 0.20% calculated on
the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter. If an Agent Securities
Company and Distributor(s) in Japan have been appointed by the Management Company in connection with the offer of
the Fund in Japan, they will receive the fees referred to in this paragraph, in respect of the assets of the Fund attributable
to the shares sold in Japan and, in respect of such shares, no such fee will be paid to the Distributor outside Japan.
8. Duration
The Fund has been established for an undetermined period.
APPENDIX 6
Relating to the Fund
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY FUND
1. Name
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY FUND (the «Fund»).
2. Objectives and Investment Policy
The objective of this Fund is to achieve capital growth by investing in the shares of Japanese companies that, in the
opinion of the manager, are likely to provide positive rates of return over the long term.
The Fund may also hold, on an ancillary basis, cash and equivalent short-term money market instruments which are
dealt in on a regular basis and which have a residual maturity not exceeding twelve months.
12471
The Fund may, within the limits specified in the investment restrictions, use derivative instruments and products, and
deal in currency forward operations.
Use of the aforesaid techniques and instruments involves certain risks, for example the leveraging effect may have a
negative effect on the performance of the Fund, and there can be no assurance that the objective sought from the use
of such instruments will be achieved.
The reference currency of the Fund shall be the Yen.
3. Distribution policy
It is the present intention of the Management Company not to make any dividend distributions.
4. Dealing Day
A «Dealing Day» for the Fund shall mean each day which is a Bank Business day in Luxembourg.
5. Management Company fee
The Management Company is entitled to a fee payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of
0.75% calculated on the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter.
6. Management and Investment Advice
The Management Company has appointed PICTET ASSET MANAGEMENT UK Ltd. («PAM»), PICTET ADVISORY
SERVICES (OVERSEAS) Ltd («PASO») and PICTET ASSET MANAGEMENT JAPAN Ltd («PAM Japan») as investment
advisers (the «Investment Advisers») to advise on the investments of the Fund. The Management Company has also
delegated, under its overall supervision and control the day-to-day management of the Fund to PAM.
PASO was formed in Nassau, Bahamas, in 1976 with a capital of CHF 150,000.-. Its main function is to gather all
worldwide information produced by Pictet’s financial analysts and to reformat the reports for Pictet’s offshore offices.
PAM is an affiliate of PICTET & CIE, Genève, a private Swiss bank, which was founded in 1805. PAM was established
in 1980 and manages institutional assets of the Pictet Group. It is regulated by the Investment Management Regulatory
Organisation (IMRO).
PAM Japan is an affiliate of PICTET & CIE, Genève, a private Swiss bank, which was founded in 1805. PAM Japan was
established in 1986 and manages institutional assets of the Pictet Group. It is regulated by the Ministry of Japan.
The fees of the Investment Advisers will be borne by the Management Company out of the fee which it receives from
the Fund as described under 6. above.
7. Distributors’ Fee
The Distributor outside Japan appointed by the Management Company in connection with the offer of the Fund
outside Japan is entitled to fees payable quarterly, out of the assets of the Fund, at an annual rate of 0.75% calculated on
the basis of the total average net assets attributable to the Fund during the relevant quarter. If an Agent Securities
Company and a Distributor in Japan have been appointed by the Management Company in connection with the offer of
the Fund in Japan, they will be entitled to the same fees as referred to hereabove for the Distributor outside Japan. The
fees for the Distributors will be shared amongst them on the basis of the number of shares which have been sold by each
of them.
8. Duration
The Fund has been established for an undetermined period.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06622/052/847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
RENE SCHILTZ ET CIE, FONDERIE DE LUXEMBOURG,
Société en commandite simple.
Siège social: L-2173 Luxembourg, 5, rue München-Tesch.
R. C. Luxembourg B 5.637.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie:
l’assemblée générale extraordinaire de la société en commandite simple RENE SCHILTZ ET CIE, FONDERIE DE
LUXEMBOURG, avec siège social à L-2173 Luxembourg, 5, rue München-Tesch, constituée initialement sous forme
d’une société anonyme avec la dénomination FONDERIE D’EICH suivant acte reçu par Maître Paul Kuborn alors notaire
de résidence à Luxembourg en date du 24 décembre 1925, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 2 du 14 janvier
1926,
transformée en société en nom collectif sous la dénomination WIES FRÈRES, FONDERIE DE LUXEMBOURG en
vertu d’un acte reçu par Maître Roger Wurth alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 30 décembre 1948,
publié au Mémorial C numéro 15 du 9 mars 1949,
transformée en société en commandite simple sous le nom de PIERRE WIES, FONDERIE DE LUXEMBOURG suivant
acte reçu par Maître Tony Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 juillet 1956, publié au
Mémorial C numéro 58 du 24 août 1956,
12472
ayant adopté sa dénomination actuelle suite à un acte de cession de parts sociales documenté par Maître Roger
Wurth alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 23 octobre 1974, publié au Mémorial C, numéro 259 du 20
décembre 1974,
immatriculée au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 5.637.
La société a été mise en liquidation lors d’une assemblée générale extraordinaire documentée par acte du notaire
instrumentaire en date du 19 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 778 du 20 octobre 1999. L’assemblée se
compose de:
1) Madame Chantal Schiltz, employée d’Etat, épouse de Monsieur James Smith, demeurant à L-1467 Howald, 39, rue
Henri Entringer, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire spéciale de:
2) Monsieur James Smith, employé privé, demeurant à L-1467 Howald, 39, rue Henri Entringer,
3) Madame Laurence Philippine dite Laurence Steinborn, sans état particulier, veuve de Monsieur René Schiltz,
demeurant à L-2723 Howald, 16, rue Eugène Welter,
4) Madame Andrée Schiltz, secrétaire, veuve de Monsieur Ferdinand Trommer, demeurant à L-1139 Luxembourg,
21A, rue des Sept Arpents,
Mesdames Chantal Schiltz, Laurence Steinborn et Andrée Schiltz comparant en leur qualité d’héritières de l’associé
commandité Monsieur René Schiltz, décédé à Luxembourg en date du 28 août 1997;
Madame Andrée Schiltz comparant également en sa qualité de détentrice de la part ayant appartenu à l’associé
commanditaire Monsieur Ferdinand Trommer, décédé à Luxembourg en date du 17 décembre 1996.
5) Monsieur Pierre Henri Ernest Wies, kinésithérapeute, demeurant à L-5732 Schuttrange, 18, rue du Verger,
6) Madame Marie Paule Wies, sans état particulier, veuve de Monsieur Léo Boes, demeurant à B-8670 Koksijde, 23,
Orchideestraat 0501,
7) Madame Jacqueline Wies, sans état particulier, épouse de Monsieur Georges Oestreicher, demeurant à L-2511
Luxembourg, 48, boulevard Salentiny,
8) Monsieur Jean Wies, tourneur, et son épouse Madame Liliane Neser, sans état, demeurant ensemble à L-8390
Nospelt, 18, rue de Kehlen.
Les comparants sub 2) et 3) étant représentés par Madame Chantal Schiltz prénommée, en vertu de procurations
sous seing privé données à Howald, le 9 janvier 2000.
Mesdames Jacqueline Wies, Marie-Paule Wies, Liliane Neser, Messieurs Pierre Wies et Jean Wies comparant en leur
qualité d’héritiers l’associé commanditaire Monsieur Pierre Wies, décédé à Luxembourg, le 24 mars 1986.
Les comparants sub 5), 6) et 8) étant représentés par Madame Jacqueline Wies, prénommée, en vertu de procura-
tions sous seing privé données à Luxembourg en date des 23 décembre 1999, 10 janvier 2000 et 11 janvier 2000.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire,
resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.
Lesquelles comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1) Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes,
2) Approbation de la clôture,
3) Décharge au liquidateur,
4) Décision de la date de la répartition du produit de liquidation.
Que tous les associés étant présents ou dûment représentés, la présente assemblée est régulièrement constituée et
les comparants ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve le Bilan de clôture et le Compte de Pertes et Profits.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide la clôture de la liquidation de la société en commandite simple RENE SCHILTZ ET CIE,
FONDERIE DE LUXEMBOURG.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge de son mandat est accordée au liquidateur, Madame Chantal Schiltz, prénommée.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé d’un commun accord que la répartition du produit de liquidation s’opérera endéans les deux mois de la
signature des présentes.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à la charge de la société en liquidation, le liqui-
dateur s’obligeant expressément à leur acquittement.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire.
Les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: A. Schiltz, C. Schiltz, J. Wies, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2000, vol. 856, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2000.
B. Moutrier.
(06659/272/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12473
SIMISA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.064.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, soussigné.
S’est réunie:
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée SIMISA INTERNATIONAL
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 36.064.
Ladite société constituée par acte du notaire Marc Elter en date du 1
er
février 1991, publié au Mémorial C numéro
280 du 22 juillet 1991.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le
notaire soussigné en date du 10 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 208 du 3 avril 1998 page 9954.
Ladite société a un capital social actuel de trente et un millions six cent trente-neuf mille neuf cent soixante-dix
Dollars US (31.639.970,- USD), représenté par trois millions cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept
(3.163.997) actions d’une valeur nominale de dix Dollars (10,- USD), chacune entièrement libérée.
L’assemblée est présidée par Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les trois millions cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (3.163.997) actions représentatives
de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation
préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la clôture de l’exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du 30 juin de chaque année
et modification conséquente de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
2.- Modification du premier alinéa de l’article 13 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier lundi
du mois de mai (10.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.
3.- Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant débuté le premier juillet 1999, se terminera le 31 décembre
1999, et conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à
approuver les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999, se tiendra le premier lundi du mois de
mai 2000 à 10.00 heures.
4.- Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de changer la clôture de l’exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu
du 30 juin de chaque année, et modifie en conséquence l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 13 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier lundi
du mois de mai (10.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le premier juillet 1999, se
terminera le 31 décembre 1999, et conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts de la société, l’assemblée
12474
générale appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999, se tiendra le premier
lundi du mois de mai 2000 à 10.00 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
40.000,- LUF.
<i>Clôture de l’assembléei>
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: F. Franzina, M. Longoni, P. Mariotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2000.
J. Delvaux.
(06674/208/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SIDERGIE INTERNATIONAL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.457.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIDERGIE INTERNATIONAL INVEST
HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 60.457, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 août 1997, publié au
Mémorial, Recueil C, numéro 650 du 21 novembre 1997.
L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant
à Arlon, qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’ acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à l48bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
12475
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Grandjean, T. Dahm, N. Henoumont, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 122S, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.
F. Baden.
(06670/200/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SARAGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 49.794.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 532, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 15 juin 1999i>
L’assemblée a été informée du décès de Monsieur Léon Feffer, administrateur de la société et président du conseil.
L’assemblée nomme comme nouveau administrateur Monsieur David Feffer et renouvelle les mandats d’administra-
teurs de Monsieur Max Feffer et Monsieur German Vecino Sanchez.
Monsieur Max Feffer est élu président du conseil.
L’assemblée renouvelle le mandat de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), avec siège social à Luxem-
bourg, en tant que commissaire aux comptes.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(06654/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SARAGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 49.794.
—
Monsieur le préposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg est requis d’inscrire, suivant
l’assemblée générale annuelle du 15 juin 1999:
1. Le décès de Monsieur Léon Feffer, administrateur de la société et président du conseil.
2. La nomination de Monsieur David Feffer, industriel, demeurant à São Paulo (Brésil), comme nouveau adminis-
trateur.
3. L’élection de Monsieur Max Feffer comme président du conseil d’administration.
<i>Pour réquisitioni>
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 532, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06655/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SCORPIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 28.238.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 10, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Signature.
(06660/278/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12476
TINFOS NIZI S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 69.587.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.
Is held:
An Extraordinary General Meeting of the shareholders of TINFOS NIZI S.A., a société anonyme having its registered
office at Luxembourg, 1 rue Nicolas Welter, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under
number 69.587.
The meeting is opened at 3.15 p.m., Mr Gjermund Röynerstad, chairman of the board of directors, residing at Bridel,
being in the chair,
who appoints as secretary Mr Thierry Becker, avocat, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Pierre Lahr, member of the board of directors, residing at Mondorf-les-
Bains, all hereby present and accepting.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the undersigned notary
to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1.- To change the currency of the share capital of the Company from Luxembourg Francs into Euros and to cancel
the reference at the nominal value.
2.- To increase the share capital in order to put it at an amount of 750,000.- Euros by the issue of new shares, having
the same rights and obligations as the existing shares.
3.- To fix the nominal value of all shares at an amount of 25.- Euros
4.- To state the subscription and the paying-up of new shares.
5.- To modify the authorised share capital and to put it at an amount of 1,240,000.- Euros.
6.- To modify Article 5 of Articles of Incorporation.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau and the undersigned notary will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present minute.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Pursuant to the Law of 10 December 1998 relative to the conversion of Commercial companies share capital into
Euro, the meeting of the shareholders decides to change the currency of the share capital from Luxembourg Francs to
Euro.
The share capital is therefore fixed at thirty thousand nine hundred and eighty-six point sixty-nine (30,986.69) Euro.
Pursuant to the Law above mentioned, the meeting of the shareholders also decides to cancel the reference to the
nominal value of the one thousand two hundred and fifty (1,250) existing shares.
<i>Second resolutioni>
The meeting of the shareholders decides to increase the share capital by seven hundred nineteen thousand thirteen
point thirty-one (719,013.31) Euro by which action the share capital will increase from thirty thousand nine hundred
eighty-six point sixty-nine (30,986.69) Euro to seven hundred fifty thousand (750,000.-) Euro.
The share capital increase is made by the issue of twenty-eight thousand seven hundred fifty (28,750) new shares
without designation of par value.
The share capital is thus divided in thirty thousand (30,000) shares without designation of par value.
<i>Third resolutioni>
The meeting of the shareholders decides to fix a new nominal value for the thirty thousand (30,000) shares.
The shareholders decide to fix the new nominal value of each share at twenty- five (25.-) Euro and to exchange the
thirty thousand (30,000) shares against thirty thousand (30,000) new shares of twenty-five (25.-) Euro each.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting of the shareholders states that subject to the allotment letters of the current shareholders, TINFOS
JERNVERK A/S has renounced to its preferential allotment and that TINFOS LUXEMBOURG S.A. has declared to
subscribe all the 28,750 (twenty-eight thousand seven hundred fifty) new shares.
The share capital is thus divided as follows:
TINFOS LUXEMBOURG S.A., twenty-nine thousand nine hundred ninety-nine shares ……………………………………… 29,999
TINFOS JERNVERK A/S, one share…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: thirty thousand shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30,000
12477
The meeting of the shareholders also states that the subscribed shares have been fully paid up with payments in cash
made on a Company bank’s account by the shareholder subscriber.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting of shareholders decides to modify the authorised share capital and to put it at an amount of one million
two hundred forty thousand (1,240,000.-) Euro.
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the foregoing, the meeting of the shareholders decides to modify the first and the fourth
paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation, as follows:
«The subscribed capital is set at seven hundred fifty thousand (750,000.-) Euro, represented by thirty thousand
(30,000) shares with a par value of twenty-five (25.-) Euro each.»
and
«Authorized Capital:
The corporate capital may be increased from its present amount to one million two hundred forty thousand
(1,240,000.-) Euro by the creation and the issue of new shares with a par value of twenty-five (25.-) Euro, having the
same rights and advantages than the existing shares.»
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at three hundred seventy thousand (370,000.-) Luxembourg francs.
There being no further business, the meeting is terminated at 3.30 p.m.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,
by their surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original
deed, no other shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction francaise du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TINFOS NIZI S.A., avec siège social à
Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le
numéro 69.587.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Gjermund Röynerstad, président du conseil
d’administration, demeurant à Bridel,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Lahr, membre du conseil d’administration, demeurant à
Mondorf-les-Bains, tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Convertir la devise du capital social de la société en Euros et supprimer la référence à la valeur nominale.
2.- Augmenter le capital social pour le porter à la somme de 750.000,- Euros par l’émission de nouvelles actions ayant
les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
3.- Fixer la valeur nominale de l’ensemble des actions à la somme de 25,- Euros.
4.- Constater la souscription et la libération des nouvelles actions.
5.- Modifier le montant du capital social autorisé pour le porter à la somme de 1.240.000,- Euros.
6.- Modifier l’article 5 des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
En application de la Loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital social des sociétés commerciales,
l’assemblée des actionnaires décide de convertir la devise du capital social en Euros.
Le capital social est ainsi fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euros.
12478
Par application de la Loi sus-visée, l’assemblée des actionnaires décide également de supprimer la référence à la valeur
nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social de sept cent dix-neuf mille treize virgule trente et
un (719.013,31) Euro pour porter le capital social de la somme de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule
soixante-neuf (30.986,69) Euro à sept cent cinquante mille (750.000,-) Euros.
L’augmentation de capital est réalisée par l’émission de vingt-huit mille sept cent cinquante (28.750) actions sans désig-
nation de valeur nominale.
Le capital social est donc divisé en trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale aux trente mille (30.000) actions.
Les actionnaires décident de fixer la nouvelle valeur nominale de chaque action à vingt-cinq (25,-) Euros et d’échanger
les trente mille (30.000) actions contre trente mille (30.000) nouvelles actions de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires constate, eu égard aux bulletins de souscription des actionnaires actuels, que TINFOS
JERNVERK A/S, a renoncé à son droit préférentiel de souscription et que TINFOS LUXEMBOURG S.A. a déclaré
souscrire l’intégralité des 28.750 actions nouvelles.
Le capital social est alors réparti ainsi qu’il suit:
TINFOS LUXEMBOURG S.A., vingt-neuf mille neuf cent quatre vingt-dix-neuf actions ……………………………………… 29.999
TIINFOS JERNVERK A/S, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: trente mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30.000
L’assemblée des actionnaires constate également, au vu du certificat de blocage de la Banque, que les actions
souscrites sont entièrement libérées au moyen de versements en espèces sur un compte bancaire de la société par
l’actionnaire souscripteur.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier le montant du capital social autorisé pour le porter à la somme de
un million deux cent quarante mille (1.240.000,-) Euro.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée des actionnaires décide de modifier le premier et le deuxième alinéa
de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à sept cent cinquante mille (750.000,-) Euros, représenté par trente mille (30.000) actions
d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euro chacune.»
et
«Capital Autorisé:
Le capital autorisé pourra être porté à un million deux cent quarante mille (1.240.000,-) Euros par la création et
l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.»
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à trois cent soixante-dix mille (370.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue
anglaise, est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les
deux versions, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: G. Röynerstad, T. Becker, J-P. Lahr, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 121S, fol. 97, case 2. – Reçu 290.049 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 21 janvier 2000.
R. Neuman.
(06701/226/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
TINFOS NIZI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 69.587.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
(06702/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12479
SEMATIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.896.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,
enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 4, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
(06664/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SEMATIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.896.
—
L’assemblée prend acte que le mandat des administrateurs est venu à échéance à la date du 29 mars 1999 et qu’en
l’absence de renouvellement et/ou de nouvelle nomination, les administrateurs ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date
de ce jour.
L’assemblée décide de nommer pour un nouveau terme d’un an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Paolo Zappa, employé, demeurant à Ranica (Italie), président du conseil d’administration;
- Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), administrateur;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), administrateur.
Les mandats des administrateurs ainsi conférés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2000.
L’assemblée prend acte que le mandat du commissaire aux comptes est venu à échéance à la date du 29 mars 1999
et qu’en l’absence de renouvellement et/ou de nouvelle nomination, le commissaire aux comptes a poursuivi son mandat
jusqu’à la date de ce jour.
L’assemblée décide de nommer pour un nouveau terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET
CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de commissaire aux
comptes.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi conféré prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2000.
Luxembourg, le 24 janvier 2000.
<i>Le conseil d’administrationi>
p.p. P. Zappa
R. Tonelli
S. Vandi
<i>Présidenti>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 533, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06665/043/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
SIDNEY IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.551.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 19 janvier 2000 a pris acte de la démission du conseil d’admi-
nistration et a nommé en son remplacement trois nouveaux administrateurs: Mme Luisella Moreschi, demeurant à L-
Brouch-Mersch, 32, route d’Arlon, Mlle Angela Cinarelli, demeurant à Luxembourg, 28, rue Beethoven et Mlle
Frédérique Vigneron, demeurnat à Luxembourg, 9, rue de l’Egalité.
L’assemblée générale a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes et a nommé en son rempla-
cement Mme Catherine Calvi, demeurant à L-Bascharage, 8A, rue du Ruisseau.
Décharge spéciale a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et gestion
jusqu’à ce jour.
L’adresse du siège social a été transférée au 8, boulevard Royal à L-2499 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06671/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2000.
12480
S O M M A I R E
GOLDROSE S.A.H.
GUY WECKER - L’ART DU JARDIN S.A.
XIN-XING
BURELBACH
ANC ETS ALOYSE HEIDESCH
SALON LE PASSAGE
PIET VAN LUIJK
AGERO
TRANSLOGISTICS S.A.
TRANSLOGISTICS S.A.
MEGAMED
MER BLEUE CHARTER S.A.
NULUX
NULUX
METALEUROP INTERNATIONAL S.A.
M & F PROMOTIONS
MICOSTA
MONDIAL FRUIT COMPANY S.A.
MOT DE BRENTUL S.A.
NEWARK S.A.
NEW GENERATION
NEW LIFE
NEWPLACE S.A.
NILACO
NOUVELLE RESTAURATION STEILER
NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG
NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG
OATFIELD S.A.
OATFIELD S.A.
OPERA IMMO S.A.
OTHEE HOLDING S.A.
OUTREMONT INVEST S.A. HOLDING
OUTSIMER
OVB PUBLISHING G.m.b.H.
OXON S.A.
OXON S.A.
PACK
PAR-ITECH
PC FINANZ INTERNATIONAL S.A. HOLDING
PEG VAL DE HAMM S.A.
AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A.
AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A.
PEINTURE DE LORENZI ED. ET FILS
KUTTEN ALAIN
KUTTEN ALAIN
PICTET COUNTRY FUND
PEINTURE STOLTZ
PELA
JOS PETRY
PIERRE KREMER ET CIE
PINUS JARDINAGE
POLAR BEK CONSTRUCTION MANAGEMENT S.A.
PI-W
PK DIFFUSION
PLATANUS S.A.
PLATANUS S.A.
PRORENTA
PLASTOBRAS HOLDING S.A.
POLARLUX S.A.
POMPEI
PREMAFIN INTERNATIONAL S.A.
PRIMET
PROMOFIN OUTREMER S.A.H.
RAMIREZ-DATA S.A.
PROMOTION-INVEST S.A.
RAMALUX S.A.
RCH
ROMIGOLD
REPUCOM
RAMIREZ ELECTRO S.A.
R.M.C.
RETROUVAILLES PRET-A-PORTER
SASTRO S.A.
SABIAN PROPERTIES S.A.
SABLIERE HEIN
RENE SCHILTZ ET CIE
SIMISA INTERNATIONAL S.A.
SIDERGIE INTERNATIONAL INVEST HOLDING S.A.
SARAGY S.A.
SARAGY S.A.
SCORPIO S.A.
TINFOS NIZI S.A.
TINFOS NIZI S.A.
SEMATIC S.A.
SEMATIC S.A.
SIDNEY IMMOBILIERE S.A.