logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2201

23 juillet 2016

SOMMAIRE

AHead  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105617

Alpes S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105648

ATRC SC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105618

AviaRent Capital Management  . . . . . . . . . . . .

105616

Bati Expansion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105645

Bionext  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105647

BMVA S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105602

BOC Frankfurt GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

105603

Cavalia International Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

105602

C. Prestige Investissements S.A. . . . . . . . . . . . .

105602

EOS REAL ESTATE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105624

Europe Property Fund IV Feeder S.A. SICAV-

SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105635

EventClearing Service S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

105619

HACA Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105605

Haplus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105603

Harsco Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

105603

Healix Financial Corporation S.à r.l.  . . . . . . .

105604

Hellaby S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105605

Henderson Diversified Income (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105604

Holdicam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105606

Holdun S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105606

Hotel & Co II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105604

Hotel & Co I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105604

IK Investment Partners AIFM . . . . . . . . . . . . .

105605

Immo-Ardennes s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105605

Immobilière du 3 Joseph II . . . . . . . . . . . . . . . .

105606

Intermediate Finance Europe II SICAR  . . . . .

105606

Inteuro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105604

Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105602

JG, Jean GEORG S.à. r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

105603

Keytrade Bank Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

105606

L.C.L. S.A. - La Centrale Luxembourgeoise

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105627

Lux Ministore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105607

Malva S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105608

Minassara S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105628

NAEV Lime Street S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

105629

Redbrick Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

105630

Silva & Rolo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105609

Société Immobiliere Oestreicher  . . . . . . . . . . .

105632

TAXolution Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

105633

Thor 11 Puerta del Sol S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

105610

Thor 16 Fuencarral S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

105610

UK Strategic Alternative Income Fund SLP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105613

Universum F.O. Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

105634

Virelux Inspection Systems S.à r.l.  . . . . . . . . .

105612

Yacuba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105615

105601

L

U X E M B O U R G

Cavalia International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 184.660.

Les comptes annuels au 31 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2016112337/11.
(160086151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

C. Prestige Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 173.694.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016112328/9.
(160085421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

BMVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 170.448.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2016.

Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammedia (Algérie), adresse

professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Nor-
bert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.

<i>Pour la société
BMVA S.A.

Référence de publication: 2016112310/13.
(160085551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 271.163,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 171.882.

En date du 3 mai 2016, l'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de M. Louis Voizard en tant que

gérant Ivanhoé de la Société avec effet au 3 mai 2016 inclus.

L'associé unique a décidé de le remplacer par M. Sylvain Dubois, résidant professionnellement au 1001, rue du Square

Victoria, Montréal, Québec, H2Z 2B5, Canada, avec effet au 3 mai 2016 inclus et pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes depuis le 3 mai 2016:
(i) Jean-Philippe Gachet, en tant que gérant Ivanhoé;
(ii) Sylvain Dubois, en tant que gérant Ivanhoé;
(iii) William Jaewon Yoo, en tant que gérant BEI, et
(iv) Pamela Valasuo, en tant que gérant BEI
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016113651/21.
(160087268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

105602

L

U X E M B O U R G

BOC Frankfurt GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 112.643.

- Suivant les résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 10 mai 2016, il a été décidé de ne pas

renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

<i>Pour la société
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2016112314/16.
(160086415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

Haplus, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 153.417.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

C.W. Karsten
<i>Gérante

Référence de publication: 2016113608/12.
(160086686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Harsco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3593 Dudelange, 100, rue de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 132.255.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 31 mars 2016.

Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2016113609/13.
(160087478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

JG, Jean GEORG S.à. r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Docteur Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 123.510.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MS GESTION SA
<i>Bureau Comptable et Fiscal
14 avenue de la Gare
L-9233 DIEKIRCH

Référence de publication: 2016113688/13.
(160086545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

105603

L

U X E M B O U R G

Healix Financial Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 181.150.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2016.

Référence de publication: 2016113610/10.
(160086965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Henderson Diversified Income (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 133.443.

Les comptes annuels au 31 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2016113611/11.
(160087101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Hotel &amp; Co I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 96.675.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2015 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2016113613/11.
(160087355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Hotel &amp; Co II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 96.676.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2015 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'organe de Gestion

Référence de publication: 2016113614/11.
(160087354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Inteuro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 93.041.

L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2016.

Référence de publication: 2016113675/11.
(160087164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

105604

L

U X E M B O U R G

HACA Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-7240 Bereldange, 75, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 204.968.

EXTRAIT

Il résulte:
- d'une convention de cession de parts sous seing privé («Share Purchase Agreement») datée du 16 Mai 2016 entre la

société CCA Holding S.à r.l., ayant son siège social au 75 route de Luxembourg L-7240 Bereldange, représenté par Mon-
sieur Cyril Cayez, associé gérant unique né le 03/08/1976 à Amiens (France) et Monsieur Saïd HADJI, né le 03/08/1984
à Argenteuil (France), demeurant 75 route de Luxembourg L-7240 Bereldange,

que la société CCA Holding S.à r.l. cède 6.249 parts sociales de la société HACA Partners S.à r.l. à Monsieur Saïd

HADJI.

Depuis le 16 Mai 2016, les parts sociales des deux associés de la société HACA Partners S.à r.l. sont réparties comme

suit:

CCA Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.251 parts sociales
HADJI Saïd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.249 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 Mai 2016.

CCA Holding S.à r.l.
Cyril Cayez

Référence de publication: 2016113615/24.
(160087039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Hellaby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 65.990.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016113617/12.
(160086790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

IK Investment Partners AIFM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 195.447.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2924 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016113661/9.
(160087400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Immo-Ardennes s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9676 Noertrange, 17, Op der Hekt.

R.C.S. Luxembourg B 94.664.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016113666/9.
(160086703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

105605

L

U X E M B O U R G

Holdicam, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 158.133.

Les  comptes  annuels  consolidés  au  31  décembre  2015  ont  été  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016113618/10.
(160087281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Holdun S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 59, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 55.565.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Référence de publication: 2016113619/10.
(160087381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Immobilière du 3 Joseph II, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 64.565.

Avec effet au 18 avril 2016, le siège social du commissaire aux comptes AUDIEX S.A. a été transféré au 1, rue Jean

Piret, L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 mai 2016.

Référence de publication: 2016113624/10.
(160086577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Intermediate Finance Europe II SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Inves-

tissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 109.432.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2016.

<i>Pour: IFE II, INTERMEDIATE FINANCE EUROPE II SICAR
Société en commandite par actions
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2016113626/15.
(160086860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Keytrade Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 69.935.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016113692/9.
(160087242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

105606

L

U X E M B O U R G

Lux Ministore, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 17, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 18.787.

DISSOLUTION

L'an deux mille seize, le onze mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Armand SASSON, commerçant, né à Fés (Maroc), le 9 juin 1949, demeurant à L-1933 Luxembourg, 32,

rue Siggy vu Letzebuerg,

2.- Monsieur Maurice SASSON, commerçant, né à Fés (Maroc), le 11 octobre 1951, demeurant à L-1349 Luxembourg,

36, Rue Christophe Colomb,

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de
3.- Monsieur David MEDIONI, commerçant, né à Fés (Maroc), le 24 mars 1944, demeurant à L-1240 Luxembourg,

268, avenue Gaston Diderich et

4.- Monsieur Joël ZEKRI, commerçant, né à Fés (Maroc), le 6 juillet 1958, demeurant à Holon, 4 Kadmon, (Israël),
ici  représentés  en  vertu  de  deux  (2)  procurations  délivrées  aux  mandataires,  lesquelles  après  avoir  été  signées  «ne

varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
a.- Que la société à responsabilité limitée "Lux Ministore, S.à r.l.", avec siège social à L-1136 Luxembourg, 17, place

d’Armes., (R.C.S. Luxembourg section B numéro 18.787), été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Raymond
Steichen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 1981, publié au Mémorial C numéro 12 du 20
janvier 1982,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg:
- en date du 14 mai 1986, publié au Mémorial C numéro 235 du 18 août 1986,
- en date du 1 

er

 octobre 1986, publié au Mémorial C numéro 361 du 31 décembre 1986,

- en date du 28 septembre 1989, publié au Mémorial C numéro 77 du 13 mars 1990, que les statuts ont été modifiés

suivant acte reçu par:

- Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 18 novembre 1997, publié au Mémorial

C numéro 160 du 18 mars 1998, et

- Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 28 mai 2003,

publié au Mémorial C numéro 706 du 4 juillet 2006.

b.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.

c.- Que la société "Lux Ministore, S.à r.l." ne détient pas de bien immobilier.
d.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société.
e.- Que l’activité de la société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'associés uniques, siégeant en assemblée

générale extraordinaire modificative des statuts de la société, prononcent la dissolution anticipée de la prédite société, avec
effet immédiat, et sa mise en liquidation.

f.- Que les associés se désignent comme liquidateurs de la société, mission qu’ils acceptent.
g.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d’acter qu’ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société

dissoute, moyennant reprise par les associés de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au profit
des associés.

h.- Que les comparants sont investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

i.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
j.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leurs mandats.
k.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à L-1724 Luxembourg,

33, boulevard du Prince Henri.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de neuf cent vingt euros, sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants agissant comme ci-avant, tous connus du notaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte

105607

L

U X E M B O U R G

Signé: Armand SASSON, Maurice SASSON, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 mai 2016. Relation GAC/2016/3825. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016113760/61.
(160087745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Malva S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 175.524.

L’an deux mille seize, le douze mai.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de MALVA S.à r.l. (ci-dessous la «Société»), une société à responsabilité limitée,

constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.175.524,
constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 7 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations le 24 avril 2013, numéro 980, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est ouverte à sous la présidence de Flora Gibert, employée, résidant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Nora Esslingen, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Flora Gibert, prénommée.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
2. Modification de l'article 11 des statuts de la Société.
3. Divers.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 6 qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Parts Sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, elles ne sont transmissibles

qu'à MALVA MANAGEMENT SCsp.

En cas de transmission à MALVA MANAGEMENT SCsp, ces parts sociales deviennent alors incessibles pendant toute

la durée du contrat social de MALVA MANAGEMENT SCsp. Si celui-ci prenait fin, les parts sociales de MALVA S.àr.l.
lui reviendraient de plein droit au titre de la liquidation de MALVA MANAGEMENT SCsp.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

105608

L

U X E M B O U R G

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut racheter ses parts sociales pour leur valeur nominale dans le but de les apporter en nature à MALVA

MANAGEMENT SCsp.

6.6 Par référence à l'article 49-8 de la Loi, si les parts sociales rachetées sont comptabilisées à l'actif du bilan, une somme

équivalente à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable, doit être incorporée dans une réserve
non distribuable.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 11 qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts, les dispositions de la Loi et le pacte social de MALVA MANAGEMENT SCsp».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est

évalué à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. GIBERT, N. ESSLINGEN, et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 17 mai 2016. 1LAC/2016/15840. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Référence de publication: 2016113770/76.
(160086629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Silva &amp; Rolo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-5950 Itzig, 2, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 108.397.

DISSOLUTION

L'an deux mille seize,
le onze mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Madame Milène Margarida BELEM ROLO, employée privée, née à Coimbra (Portugal), le 13 août 1985, demeurant

au 4, route de Luxembourg, L-6195 Imbringen.

Laquelle comparante, ici personnellement présente, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

1. - Que elle, est la seule et unique associée (l'«Associé») de la société «SILVA &amp; ROLO S.à r.l. (la «Société»), une

société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 2, Rue de
Bonnevoie, L-5950 Itzig,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 108 397 et
constituée suivant acte notarié dressé en date du 02 juin 2005, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations (le «Mémorial»), le 18 octobre 2005, sous le numéro 1053 et page 50517;

2. - Que les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis sa création.
3. - Que le capital social de la Société s'élève actuellement à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12'400.-

EUR) et se trouve représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS
(124.- EUR) chacune, toutes intégralement libérées en numéraire;

105609

L

U X E M B O U R G

4. - Que l'Associé est le seul et unique propriétaire de toutes les cent (100) parts sociales de la Société, représentant

l'intégralité de son capital social;

5. - Que l'Associé, étant ainsi le seul et unique associé de ladite Société, a décidé de procéder à la dissolution immédiate

de ladite Société;

6. - Que le même Associé déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société telle

qu'indiquée dans la situation intermédiaire de la Société arrêtée au 30 avril 2016, par conséquent déclare approuver, sans
restriction ni réserve lesdits comptes;

7. - Que l'Associé, en sa qualité de détenteur unique des parts sociales de la Société déclare avoir reçu tous les actifs de

la Société et qu'il prendra personnellement en charge tout le passif de la Société qu'il soit occulte et inconnu à ce moment;

8. - Que partant la Société se trouve par le présent acte complètement liquidée à partir de ce jour;
9. - Que décharge pleine et entière est accordée à la gérante unique de la Société pour l'exercice dudit mandat jusqu'à

ce jour;

10. - Que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant le délai légal de cinq (5) ans à

l'adresse suivante: 4, route de Luxembourg, L-6195 Imbringen.

11.- Que l'Associé déclare prendre à sa charge tous les frais résultant du présent acte.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an

qu'en tête des présentes.

Et après lecture, l'Associé prénommé a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. BELEM ROLO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 mai 2016. Relation: EAC/2016/11268. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016113965/48.
(160087025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Thor 16 Fuencarral S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Thor 11 Puerta del Sol S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 203.412.

In the year two thousand and sixteen, on the ninth day of May,
before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Thor 11 Puerta del Sol S.à r.l., a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 203412 and having a share capital
of EUR 12.500 (the Company).

The Company was incorporated on 13 January 2016 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in

Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, acting as replacement of the undersigned notary, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1083 of 12 April 2016. The articles of association of the Company (the
Articles) have not been amended since then.

THERE APPEARED:

Thor 16 Fuencarral Investment LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o United

Corporate Services, Inc., 874 Walker Road, Suite C, in the City of Dover, County of Kent in the State of Delaware, 19904,
registered with the Registrar of the State of Delaware under file number 5839185 in its capacity as sole shareholder (the
Sole Shareholder),

represented by Peggy Simon, notary’s clerk, residing professionally in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said  power  of  attorney,  after  signature  ne  varietur  by  the  authorised  representative  of  the  appearing  party  and  the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in the capital of the Company;
II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Change of the name of the Company from “Thor 11 Puerta del Sol S.à r.l.” into “Thor 16 Fuencarral S.à r.l.”;
2. Amendment to article 1 of the articles of association of the Company to reflect the change of name; and

105610

L

U X E M B O U R G

3. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The  Sole  Shareholder  resolves  to  change  the  name  of  the  Company  from  “Thor  11  Puerta  del  Sol”  into  “Thor  16

Fuencarral S.à r.l.” with immediate effect.

<i>Second resolution

As a result of the above, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles, so that it shall henceforth read

as follows:

“ Art. 1. Name. The name of the company is “Thor 16 Fuencarral S.à r.l.” (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).”

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and
the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the latter signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille seize, le neuvième jour de mai,
par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Thor 11 Puerta del Sol S.à r.l., une société

à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe
au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203412 et disposant d’un capital social de EUR 12.500 (la Société).

La Société a été constituée le 13 janvier 2016 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,

Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1083 du 12 avril 2016. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis.

A COMPARU:

Thor 16 Fuencarral Investment LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) régie par le droit

du Delaware, dont le siège social se situe à c/o United Corporate Services, Inc., 874 Walker Road, Suite C, ville de Dover,
comté de Kent dans l'état du Delaware, 19904, immatriculée auprès du registre de l'état du Delaware (Registrar of the State
of Delaware) sous le numéro 5839185 en sa qualité d’associé unique (l’Associé Unique),

représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu

d’une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités d’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’Associé Unique détient la totalité des parts sociales du capital social de la Société;
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination de la Société de «Thor 11 Puerta del Sol S.à r.l.» en «Thor 16 Fuencarral S.à r.l.»;
2. Modification de l’article 1 des statuts de la Société afin d’y refléter le changement de dénomination; et
3. Divers.
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société de «Thor 11 Puerta del Sol S.à r.l.» en «Thor 16

Fuencarral S.à r.l.» avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 1 des Statuts, de sorte qu’il aura

désormais la teneur suivante:

105611

L

U X E M B O U R G

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est «Thor 16 Fuencarral S.à r.l.» (la Société). La Société est une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version
anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Echternach, à la date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent

acte original.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 20 mai 2016. Relation: GAC/2016/3670. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 mai 2016.

Référence de publication: 2016114009/103.
(160086955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Virelux Inspection Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-4531 Differdange, 126, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 157.209.

L'an deux mille seize, le douze mai.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Reichert Technology Partners S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social

au 126, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-4531 Differdange et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.267,

ici dûment représentée par son gérant unique Monsieur Tom Alain REICHERT, lui-même ici représenté par Madame

Carole CAHEN, avec adresse professionnelle au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, en vertu d'une procuration lui
délivrée à Differdange, Grand-Duché de Luxembourg le 29 avril 2016; et

2. Monsieur Gerard BASEOTTO, né le 24 novembre 1953 à Algrange (France) et demeurant au 4, hameaux de la grange,

F-57155 Marly,

ici représenté par Madame Carole CAHEN, prénommée, en vertu d'une procuration lui délivrée à Marly (France) le 29

avril 2016.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont prié le notaire d'acter ce qui suit:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société dénommée Virelux Inspection Systems S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 126, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-4531
Differdange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.209 et
constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en date du 24 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 99 du 18
janvier 2011.

Les statuts de ladite société n'ont pas encore été modifiés depuis.
II. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-sept mille cinq cents euros (27.500.- EUR) afin

de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) à quarante mille euros (40.000.- EUR)
par l'émission de deux cent soixante-quinze (275) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR)
chacune;

2. Souscription et libération de l'augmentation de capital sub. 1) par un apport en espèces par l'un des associés actuels

et renonciation à son droit de souscription par l'autre associé;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société; et

105612

L

U X E M B O U R G

4. Divers.
Ceci ayant été déclaré, les associés ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt-sept mille cinq cents euros

(27.500.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) à quarante mille
euros (40.000.- EUR) par l'émission de deux cent soixante-quinze (275) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de
cent euros (100.- EUR) chacune.

<i>Souscription et libération

Toutes les deux cent soixante-quinze (275) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR)

chacune à émettre, ont été intégralement souscrites par Reichert Technology Partners S.à r.l., prénommée.

Toutes les deux cent soixante-quinze (275) parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme

de de vingt-sept mille cinq cents euros (27.500.- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le deuxième associé Monsieur Gerard BASEOTTO, prénommé, renonce expressément à son droit de souscription.
Suite à cette augmentation, les parts sociales sont désormais réparties comme suit:

1) Reichert Technology Partners S.à r.l., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 parts sociales
2) Monsieur Gerard BASEOTTO, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts sociales

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 parts sociales

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions précédentes les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société de sorte qu'il aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000.- EUR), représenté par quatre cents (400) parts sociales

d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés

à environ mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est terminée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: C. Cahen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 13 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/10192. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 23 mai 2016.

Référence de publication: 2016114047/76.
(160086575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

UK Strategic Alternative Income Fund SLP, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 206.215.

<i>Excerpt of the limited partnership agreement (the “Partnership agreement”) of the partnership executed on 20 may 2016

1. Partners who are jointly and severally liable. UK SAIF GP S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with a share capital
of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register
(the “General Partner”).

2. Name, Partnership's purpose and registered office.
I. Name

105613

L

U X E M B O U R G

“UK Strategic Alternative Income Fund SLP”, a special limited partnership (société en commandite spéciale).
II. Purpose
The purpose of the Partnership is to identify, acquire, hold, manage and dispose of equity and debt related securities

across a wide number of asset classes, including long lease real estate equity, real estate debt, infrastructure equity, infra-
structure debt and other tactical opportunities in accordance with the terms of the Partnership Agreement, and to engage
in any other activities which may be directly or indirectly related or incidental to any of the foregoing. The Partnership
shall have all power and authority to enter into, make and perform all contracts and other undertakings and to engage in
all activities and transactions and take any and all actions necessary, appropriate, desirable, incidental or convenient to or
for the furtherance or accomplishment of the above purposes or of any other purpose or the furtherance of any of the
provisions herein set forth and to do every other act and thing incident thereto or connected therewith, including investing
of funds of the Partnership pending their utilization or disbursement, and any and all of the other powers that may be
exercised on behalf of the Partnership by the General Partner pursuant to the Partnership Agreement.

III. Registered Office
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
IV. Financial Year
The financial year end of the Partnership will be on 31 December of each year.

3. Designation of the manager and its signing authority. Subject to the provisions of the 1915 Law and any delegation

of its powers properly authorized hereunder, the business and affairs of the Partnership will be managed by the General
Partner acting honestly, in good faith and in the best interest of the Partnership. Without limiting the generality of the
foregoing, the General Partner will have the power and authority to do any act, take any proceeding, make any decision
and execute and deliver any instrument, deed, agreement or document necessary for or incidental to carrying on the business
of the Partnership.

4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commenced on 20 May

2016 and will continue, unless otherwise terminated in accordance with the Partnership Agreement, until dissolved by the
written agreement of the General Partner and the Limited Partners. For greater certainty, the admission, resignation, with-
drawal or dissolution of any Partner will not dissolve the Partnership.

Suit la traduction française du texte qui précède:

<i>Extrait du contrat social (le “Contrat”) de la société conclu le 20 mai 2016

1. Associés conjointement et solidairement responsables. UK SAIF GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée

constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-), ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et en
cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (l'«Associé Commandité»).

2. Dénomination, objet social et siège social de la Société.
I. Dénomination
«UK Strategic Alternative Income Fund SLP», une société en commandite spéciale.
II. Objet social
L'objet de la Société est d'identifier, acquérir, détenir, gérer et disposer des titres de créance et de capital à travers d'un

grand nombre de classes d'actifs, y compris du capital d'immobilier de location à long terme, la dette immobilière, capital
de l'infrastructure, la dette de l'infrastructure et d'autres opportunités tactiques en conformité avec les termes du Contrat et
de se livrer à d'autres activités qui peuvent être directement ou indirectement liés ou accessoire à tout ce qui précède. La
Société aura tous les pouvoirs nécessaires pour conclure, faire et exécuter tous les contrats et d'autres entreprises et de
participer à toutes les activités et les transactions et prendre toutes les mesures nécessaires, adéquate, souhaitable, accessoire
ou pratique pour ou pour la poursuite ou l'accomplissement des fins ci-dessus ou de toute autre fin ou la réalisation de
toutes les dispositions énoncées aux présentes et à faire tout autre acte et chose incident à celui-ci ou qui s'y rapportent, y
compris l'investissement des fonds de la Société en attendant leur utilisation ou de décaissement, et tout et tous les autres
pouvoirs qui peuvent être exercés au nom de la Société par l'Associé Commandité en vertu du Contrat.

III. Siège social
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
IV. Exercice social
L'exercice social de la Société prend fin au 31 décembre de chaque année.

3. Désignation du gérant et de son pouvoir de signature. Sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et toute délégation

de ses pouvoirs en vertu des présentes dûment autorisés, l'entreprise et les affaires de la Société seront gérées par l'Associé
Commandité agissant avec honnêteté, de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la Société. Sans limiter la généralité de ce
qui précède, l'Associé Commandité aura le pouvoir et l'autorité d'accomplir tout acte, faire toute procédure, prendre toute
décision et d'exécuter et de remettre tout instrument, acte, contrat ou document nécessaire ou accessoire à l'exploitation de
l'entreprise de la Société.

105614

L

U X E M B O U R G

4. Date à laquelle la Société commence et date à laquelle elle se termine. La Société a été établie le 20 mai 2016 et

continuera d'exister, sauf en cas de résiliation conformément aux dispositions du Contrat, jusqu'à dissolution par l'accord
écrit de l'Associé Commandité et les Associés Commanditaires. Pour une plus grande certitude, l'admission, de démission,
de retrait ou de dissolution d'une Associé Commanditaire ne dissoudra pas la Société.

Référence de publication: 2016114040/75.
(160086990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

Yacuba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.106.

L'an deux mille seize, le neuf mai.
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, en remplacement de Maître Henri

HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera le dépositaire de la présente minute,

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «YACUBA S.A.», avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 septembre 2008, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2581 du 22 octobre 2008 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte notarié du 15 avril 2015, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1647 du 3 juillet 2015.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée,

avec adresse professionnelle à Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social d’un montant total de EUR 30.000 (trente mille euros) par versement en numéraire

et par émission de 3.000 (trois mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune. Le capital
est ainsi porté de son montant actuel de EUR 200.000.- (deux cent mille euros) à un montant de EUR 230.000.- (deux cent
trente mille euros).

2) Souscription et libération des 3.000 nouvelles actions ainsi créées.
3) Modification subséquente des statuts.
4) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 30.000 (trente mille euros) par versement en

numéraire et par émission de 3.000 (trois mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.
Le capital est ainsi porté de son montant actuel de EUR 200.000.- (deux cent mille euros) à un montant de EUR 230.000.-
(deux cent trente mille euros).

<i>Souscription et libération

Les 3.000 (trois mille) actions nouvelles sont ensuite souscrites par l’actionnaire unique la société FINDI S.à r.l. avec

siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, RCS Luxembourg B 107315,

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un apport en espèces, de sorte que la somme de EUR

30.000.- (trente mille euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

105615

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Capital Social.
«5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 230.000.- (deux cent trente mille euros) représenté par 23.000 (vingt-trois

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.000.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET et D. KOLBACH.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 11 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/15292. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 mai 2016.

Référence de publication: 2016114073/66.
(160086913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

AviaRent Capital Management, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 146.519.

Im Jahre zweitausendundsechzehn, am elften Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, in Vertretung von Notar Henri

HELLINCKX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt,

Sind erschienen:

1) Herr Dan-David GOLLA, beruflich ansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
2) Herr Mathias GIEBKEN, beruflich ansässig 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
3) Frau Susan WINTER, beruflich ansässig in D-60594 Frankfurt am Main, 43, Gutzkowstrasse,
alle hier vertreten durch Frau Caroline EGRY, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach, aufgrund von 3 ihr erteilten Vollmachten.

Die  von  dem  Erschienenen  und  dem  unterzeichneten  Notar  "ne  varietur"  gezeichneten  Vollmachten  bleiben  dieser

Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen handeln in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft AviaRent Capital Manage-

ment, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 26. Mai 2009,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1259 vom 1. Juli 2009.

Die erschienenen Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten beschließen über folgende Tagesordnung
1) Abänderung des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft.
2) Verlegung des Gesellschaftssitzes von 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxemburg nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach mit Wirkung ab dem 1. Mai 2016

3) Entsprechende Abänderung des Artikels 5 der Satzung
4) Verschiedenes,
und haben die folgenden Beschlüsse getroffen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
„Zweck der Gesellschaft ist es als persönlich haftender Gesellschafter (associé commandité) und Geschäftsführer (gé-

rant) der AviaRent S.C.A. SICAV-FIS, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d’investissement à
capital variable) gemäss dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in der Form einer Kom-
manditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) tätig zu werden.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, den Gesellschaftssitz von 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxemburg nach 1c, rue Gabriel

Lippmann, L-5365 Munsbach mit Wirkung ab dem 1. Mai 2016 zu verlegen.

105616

L

U X E M B O U R G

<i>Dritter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses beschließen die Gesellschafter Artikel 5 der Satzung wie folgt abzuändern:
„Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schuttrange. Er kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen

Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.“

WORUEBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat diese mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. EGRY und C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 19 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/16105. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 24. Mai 2016.

Référence de publication: 2016114145/50.
(160087855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

AHead, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 16, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 176.691.

Im Jahre zweitausendsechzehn, den vierten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Elisabeth REINARD, mit dem Amtssitz in Ettelbruck (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Frau Stéphanie König-Felten, Freiberuflerin, geboren am 11. Februar 1971 in Trier, wohnhaft in Gallstr. 21, D-54290

Trier,

hier vertreten durch Nadine Closter, Angestellte, berufsansässig in 2, Place de l’Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck,
mittels einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 28. April 2016 in Luxemburg erstellt wurde und dieser Urkunde

zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt bleibt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, ersucht den instrumentierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die erschienene Partei, vorbenannt, ist alleinige Gesellschafterin der anonymen Gesellschaft AHead, société ano-

nyme, mit Sitz in L-5834 Hesperange, 4, rue Jean-Pierre Hippert, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in
Luxemburg, unter Sektion B mit der Nummer B 176.691, gegründet gemäß Urkunde von Notar Camille Mines, mit dem
Amstsitz in Capellen vom 16. April 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
973 vom 24. April 2013 (hiernach die Gesellschaft).

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt einundreizigtausend Euro (EUR 31.000,-), aufgeteilt in dreihundertzehn (310) Ak-

tien von jeweils hundert Euro (EUR 100,-), alle Frau Stéphanie König-Felten (die Alleinige Gesellschafterin), vorbenannt,
zugeteilt.

III.- Die Alleinige Gesellschafterin, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, erklärt die der Hauptversammlung

vorbehaltenen Befugnisse auszuüben und ersucht den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse wie folgt zu beurkun-
den:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, den Gesellschaftssitz von L-5834 Hesperange, 4, rue Jean-Pierre Hippert nach

L-5365 Münsbach, 16, rue Gabriel Lippmann zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 und von Artikel 12 der

Statuten wie folgt abzuändern:

Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

Art. 12. (Absatz 1). Die jährliche Hauptversammlung findet am zweiten Dienstag des Monats Mai um 11h30 Uhr am

Gesellschaftssitz, oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung der gegenwärtigen Urkunde an den Vertreter des Komparenten hat derselbe mit dem unterzeich-

nenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Nadine CLOSTER, Elisabeth REINARD.

105617

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 6 mai 2016. Relation: DAC/2016/6790. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung

im Memorial erteilt.

Ettelbruck, den 24. Mai 2016.

Référence de publication: 2016114168/46.
(160087641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

ATRC SC, Société Civile.

Siège social: L-8009 Strassen, 19/21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg E 5.920.

STATUTS

L'an deux mille seize, le 24 Mai
1. Monsieur Clément RECEVEUR, né le 18 Juillet 1975 à Montbélliard (France), demeurant au 9, Rue du Clos de

Chèvre, F-54000 NANCY

2. Monsieur Thierry ARSENA, né le 31 Mars à Nancy (France), demeurant au 69, Rue Isabey, F-54000 NANCY
Lesquels comparants ont décidé d'acter les statuts d'une Société Civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit

le 24 Mai 2016.

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les associés ci-avant une société civile particulière qui prend la dénomination «ATRC

SC» (ci-après, la «Société»).

Art. 2. La Société a pour objet la détention, l'utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indi-

rectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. Le siège social est établi à Strassen. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg

sur simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 5. Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 100 parts de 50,00 EUR chacune et constitué par l'apport en

numéraire sur un compte ouvert pour la société.

Art. 6. En raison de leur apport, il est attribué 50 parts à Monsieur Clément RECEVEUR, 50 part à Thierry ARSENA,

les comparants ci-dessus mentionnés.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non-associés sans l'accord unanime de tous les associés

restants.

La cession des parts s'opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code civil.

Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants

n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé.
Toutefois, les héritiers devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation, désigner dans
les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.

Art. 9. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l'unanimité de tous les associés.

Art. 10. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour compte

de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de son gérant.

Art. 11. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le bilan est soumis à l'approbation des associés, qui décident de l'emploi des bénéfices. Les bénéfices sont répartis entre

les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 12. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du

Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans
la Société.

Art. 13. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du gérant

ou sur convocation d'un des associés.

105618

L

U X E M B O U R G

L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des

voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.

Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée

n'en décide autrement.

Art. 15. Les articles 1832 à 1872 du Code civil auront vocation à s'appliquer partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 100,-EUR.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

A l'instant, les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale

extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1. Monsieur Clément RECEVEUR, précité, est nommé gérant,
2. Le siège de la Société est établi à L-8009 Strassen, 19/21 Route d'Arlon.

Monsieur Clément RECEVEUR / Monsieur Thierry ARSENA.

Référence de publication: 2016114188/64.
(160088138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

EventClearing Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6186 Gonderange, 2, Massewee.

R.C.S. Luxembourg B 206.254.

STATUTEN

Im Jahr zweitausendsechzehn, am elften Tag des Monats Mai.
Vor uns, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

EventClearing S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend nach dem Recht von Luxem-

burg, noch nicht eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, mit Sitz in 2, Massewee, L-6186 Gonderange,
Großherzogtum Luxemburg,

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page,
aufgrund einer in Luxemburg am 11. Mai 2016 privaschriftlichen ausgestellten Vollmacht;
Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar ne varietur paraphiert

wurden, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu
werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit

dem Namen EventClearing Service S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen bei Sportveranstaltungen im Zusammenhang mit

Anmeldeverfahren, Abrechnung von Kosten und Berechnung der von den Sportveranstaltern zu zahlenden Gewinngeldern.
Diesbezüglich ist die Gesellschaft befugt, Zahlungsvorgänge im Zusammenspiel zwischen Sportlern und Sportveranstaltern
durchzuführen.

2.2 Desweiteres ist der Zweck der Gesellschaft das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und

ausländischen Gesellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf,
Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Ver-
waltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen

2.3 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise
unterstützen.

105619

L

U X E M B O U R G

2.4 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch  Aufnahme  von  Darlehen  in  jeglicher  Form  oder  mittels  Ausgabe  aller  Arten  von  Anleihen,  Wertpapieren  oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.

2.5  Die  Gesellschaft  kann  jedwede  Maßnahmen  ergreifen,  sämtliche  Geschäfte  tätigen  und  jegliche  Transaktionen

durchführen, die sie zur Erfüllung, Förderung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für nützlich erachtet und die im
Einklang mit dem Gesetz von 1915 stehen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt

werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art
und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  Beschluss  des  Geschäftsführungsrates  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500),  bestehend  aus

zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sa-

tzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Aussetzung der Bürgerrechte, die Auflösung, den Konkurs, die

Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der

überlebenden Gesellschafter mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden.
Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile den Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden
Ehepartner/in übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

105620

L

U X E M B O U R G

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und diese Satzung aus-

drücklich vorbehalten sind.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, können gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein Stimmrecht
schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in

der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder
vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch
ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Gesellschafter ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, (ii) die mindestens eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den „Einzelgeschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche
Amtszeit des zu ersetzenden Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversamm-
lung  ausgefüllt  werden,  welche  im  Einklang  mit  den  anwendbaren  gesetzlichen  Bestimmungen  über  die  endgültige
Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-

züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Geschäftsfüh-

rungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

105621

L

U X E M B O U R G

16.2 Die Geschäftsführer werden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungs-

rats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen
sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines
vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie einer solchen unterzeich-
neten  Zustimmung  ein  hinreichender  Nachweis  ist.  Eine  Einladung  zu  Sitzungen  des  Geschäftsführungsrats  ist  nicht
erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind,
welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-

ladungsvoraussetzungen  abbedingen  oder  im  Fall  von  schriftlichen  Umlaufbeschlüssen,  wenn  alle  Mitglieder  des  Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat

kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats

geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es

ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-

deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.

17.5  Der  Geschäftsführungsrat  kann  nur  dann  wirksam  beraten  oder  handeln,  wenn  zumindest  die  Mehrheit  seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden, hat
im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per

Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt  erteilen,  wobei  die  Gesamtheit  aller  schriftlichen  Zustimmungen  die  Annahme  des  betreffenden  Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats; Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird (i) vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, falls

vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhan-
den), oder (ii) von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in
einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsfüh-
rungsrates, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-

schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige
Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäfte mit Dritten.
19.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des Einzelgeschäftsfüh-

rers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2)
beliebigen Geschäftsführern, oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, im Rahmen dieser Be-
fugnis wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

105622

L

U X E M B O U R G

20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsund Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen,
in seiner geänderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréés) ernennen,
entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 In andere Rücklagen erbrachte Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz

von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehal-

tenen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom

Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für welches
der Jahresabschluss genehmigt wurde, angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die nach dem Gesetz
von 1915 oder dieser Satzung einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an

die Gesellschafter pro rata zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreißigs-

ten Dezember 2016.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

105623

L

U X E M B O U R G

- Zeichnung von zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen durch EventClearing S.A., vorbenannt, zum Preis von

einem Euro (EUR 1).

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ab sofort ein Betrag

in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nach-
gewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftska-

pital zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

oder Auslagen werden auf eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400) geschätzt.

<i>Beschlüsse des Gesellschafters

Der Gründer, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle Einberufungsbe-

kanntmachung verzichtet, hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Massewee 2 in L-6186 Gonderange, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
1) Fairfax-Jones, Thomas, geboren am 02.04.1971 in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, geschäftsansässig

in Massewee 2, L-6186 Gonderange, Großherzogtum Luxemburg; und

2) Joelle Beier-Kinnen, geboren am 26.06.1971 in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in

40, rue de Syren, L-5316 Contern, Großherzogtum Luxemburg.

Die Mandate der Geschäftsführer enden mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2018.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, zum eingangs er-

wähnten Datum aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welcher dem Notar mit

Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte diese Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 13 mai 2016. GAC/2016/3784. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 24 mai 2016.

Référence de publication: 2016114358/285.
(160087880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

EOS REAL ESTATE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1923 Luxembourg, 23A, rue de la Lavande.

R.C.S. Luxembourg B 206.272.

STATUTS

L’an deux mil seize, le douze mai.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Madame France RIALLOT, agent immobilier, née le 13 septembre 1987 à Saint-Nazaire (France), demeurant à

L-1923 Luxembourg, 23A, rue de la Lavande, et

2.- Monsieur David MEIRELES, agent commercial, né le 28 juillet 1971 à Courbevoie (France), demeurant à L-4575

Differdange, 65, Grand-Rue.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «EOS REAL

ESTATE»

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

105624

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d’une agence immobilière comportant l'acquisition, la vente, la gérance, la

location, l'administration et la promotion de tous biens mobiliers et immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg
ou  à  l'étranger,  ainsi  que  toutes  opérations  industrielles,  commerciales  ou  financières,  mobilières  ou  immobilières,  se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développe-
ment.

Elle peut à cet effet affecter ses immeubles en hypothèque, contracter des prêts et ouvertures de crédit ainsi que mettre

à disposition et consentir des sûretés et se porter caution.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'ac-

complissement de ses objets.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir

l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées géné-

rales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par

l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l'étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu’à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du
capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

105625

L

U X E M B O U R G

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1.- Madame France RIALLOT, prénommée,
Cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur David MEIRELES, prénommé,
Cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit est évalué sans nul préjudice

à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.
Elle s’engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions

suivantes:

1.- Est nommé gérant technique et gérant administratif de la société:
- Madame France RIALLOT, prénommée, gérante technique, et
- Monsieur David MEIRELES, prénommé, gérant administratif.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif. Ils

peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.

2.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
L-1923 Luxembourg, 23A, rue de la Lavande.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire

soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: France Riallot, David Meireles, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 19 mai 2016. 1LAC / 2016 / 16139. Reçu 75.- €.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 24 mai 2016.

Référence de publication: 2016114371/119.
(160088307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

105626

L

U X E M B O U R G

L.C.L. S.A. - La Centrale Luxembourgeoise, Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, 24, rue Geespelt.

R.C.S. Luxembourg B 101.185.

L'an deux mille seize, le treize mai;
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S’est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de la société anonyme “L.C.L. S.A. - LA CEN-

TRALE  LUXEMBOURGEOISE”,  établie  et  ayant  son  siège  social  à  L-3844  Schifflange,  Z.I.  Luxembourg  Heck,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 101185, (la “Société”),
constituée le 25 mai 2004 suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 801 du 5 août 2004.

L'Assemblée est présidée par Madame Carine GRUNDHEBER, employée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Carmela CIPRIANO, em-

ployée, demeurant professionnellement à Livange.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

- Transfert, avec effet rétroactif au 1 

er

 mars 2016, du siège social de la Société de L-3844 Schifflange, Z.I. Luxembourg

Heck à L-3378 Livange, 24, rue Geespelt, et modification subséquente de l'article 2, 1 

er

 alinéa, des statuts, afin de lui

donner la teneur suivante:

“Le siège social est établi dans la commune de Roeser.”
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, le nombre d’actions possédées par chacun d'eux et le nom des man-

dataires  des  actionnaires  représentés,  sont  portés  sur  une  liste  de  présence;  cette  liste  de  présence  est  signée  par  les
actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant
et restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  et  que  les  actionnaires,  présents  ou  représentés,

déclarant avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1 

er

 mars 2016, de transférer le siège social de la Société de L-3844 Schif-

flange, Z.I. Luxembourg Heck à L-3378 Livange, 24, rue Geespelt, et de modifier subséquemment l'article 2, 1 

er

 alinéa,

des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

“Le siège social est établi dans la commune de Roeser.”
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et plus personne ne demandant la parole, le Président a

ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, lesdits com-

parants ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: C. GRUNDHEBER, C. CIPRIANO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 mai 2016. 2LAC/2016/10287. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

105627

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 23 mai 2016.

Référence de publication: 2016114539/58.
(160088347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

Minassara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.967.

L'an deux mille seize, le onze mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MINASSARA S.A. (ci-après "la Société"),

avec siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg section B
numéro 127967, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 avril 2007, publié au Mémorial C
numéro 1393 du 7 juillet 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Junglinster.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé

privé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la Société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le
notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées "ne varietur" par les membres du
bureau et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est

régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu
connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Est nommé liquidateur de la Société la société anonyme de droit luxembourgeois CH INTERNATIONAL (LUXEM-

BOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, immatriculée au R.C.S. de
Luxembourg sous le numéro B 111687.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles

144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se conformer aux écritures de la Société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont pris fin au moment de

la mise en liquidation de la Société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 1.150, EUR, sont à la charge de la Société.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Françoise HÜBSCH, Max MAYER, Jean SECKLER.

105628

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 mai 2016. Relation GAC/2016/3829. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016114630/53.
(160087763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

NAEV Lime Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, Avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 171.535.

Im Jahre zweitausendsechszehn, am elften Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Meyers, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft „NAEV-Immo S.C.S. SICAV-FIS“, mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler, einge-

tragen im Handelsregister Luxembourg unter der Nummer B203847

Hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Serge BERNARD, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer „ad hoc“

Vollmacht unter Privatschrift.

Diese Vollmacht bleibt, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet

wurde, dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung als Anlage beigefügt.

Die Komparentin, hier vertreten wie eingangs erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft „NEAV-Immo S.C.S. SICAV-FIS“, handelnd durch ihre Komplementärin „Universal 3 Alternative

Management S.à r.l.“, ist die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „NAEV Lime Street S.à
r.l.“ mit Sitz zu L - 6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler, eingetragen im Handelsregister Luxembourg unter der
Nummer B171535, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Francis KESSELER aus Esch-sur-Alzette
am 12. September 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil spécial des Sociétés et Association, Nummer 2566 vom
16. Oktober 2012, welche Statuten zum letzten Mal abgeändert wurden am 8. Oktober 2014, veröffentlich im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3437 am 18. November 2014.

Die alleinige Gesellschafterin, wie oben erwähnt vertreten, ersucht den amtierenden Notar, die gefassten Beschlüsse

wie folgt zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-1855 Luxembourg, 37A, Avenue

J.F. Kennedy, mit sofortiger Wirkung.

Infolgedessen wird der erste Absatz von Artikel 2 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung:
- Frau Venetia Budgen,, und
- Herrn Erich Hein,
als Geschäftsführer abzuberufen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung:
- Frau Jane HARRISON, geboren am 30 November 1973 in Hereford, Großbritannien, geschäftlich ansässig in 43-45

Portman Square, London, W1H 6LY, Großbritannien, un

- Frau Simone SCHMITZ, geboren am 01 August 1979 in Bernkastel-Kues, Deutschland, geschäftlich ansässig in 37A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

als Geschäftsführerinnen auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Esch-sur-Alzette, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Mandanten der Erschienenen, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.

Gezeichnet: S. Bernard, Jean-Paul Meyers.

105629

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 mai 2016. Relation: EAC/2016/11348. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni AUSFERTIGUNG.

GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Eintragung beim Ge-

sellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, den 13. Mai 2016.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2016114668/55.
(160088040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

Redbrick Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 205.086.

In the year two thousand sixteen, on the seventeenth day of May.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing at Redange-sur-Attert (Grand-Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Terasta Enterprises Limited, a limited liability company duly existing under the laws of the Republic of Cyprus, incor-

poration number HE309943, having its registered office at Nikis &amp; Kastoros, 1087 Nicosia, Cyprus,

here represented by Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, with professional residence in Redange/Attert, by virtue of a

proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforesaid, is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “Redbrick Holding

S.à r.l.” having its registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 luxembourg, incorporated pursuant a deed of
the undersigned notary on March 30 

th

 , 2016, not yet published at the Memorial C, registered to the Register of Trade and

Companies of Luxembourg section B number 205086 (the “Company”).

The Sole Shareholder, represented as aforesaid and representing the entire share capital, has requested the undersigned

notary to act the resolutions contained into the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase the share capital by an amount of Two Millions Two Hundred and Seventy Seven Thousand U.S. Dollars

(USD 2,277,000.-) in order to raise it from its present amount of Fifteen Thousand U.S. Dollars (15,000.- U.S. Dollars)
represented by One Hundred and Fifty (150) shares with a par value of One Hundred U.S Dollars (100.-U.S. Dollars) each,
to Two Millions Two Hundred and Ninety Two Thousand U.S. Dollars (USD 2,292,000.-) by the creation and the issuing
of Twenty Two Thousand Seven Hundred and Seventy (22'770.-) new shares with a nominal value of One Hundred U.S
Dollars (100.- U.S. Dollars) each, having the same rights and privileges as existing shares (the “New Shares”); Subscription
and liberation of the New Shares.

2. Amendment of Article 6 of articles of association of the Company in order to reflect the aforesaid increasing share

capital.

3. Miscellaneous.

<i>First resolution:

The Sole Shareholder decides increase to the share capital by an amount of Two Millions Two Hundred and Seventy

Seven Thousand U.S. Dollars (USD 2,277,000.-) in order to raise it from its present amount of Fifteen Thousand U.S.
Dollars (15,000.- U.S. Dollars) represented by One Hundred and Fifty (150) shares with a par value of One Hundred U.S
Dollars (100.- U.S. Dollars) each, to Two Millions Two Hundred and Ninety Two Thousand U.S. Dollars (USD 2,292,000.-)
by the creation and the issuing of Twenty Two Thousand Seven Hundred and Seventy (22'770.-) new shares with a nominal
value of One Hundred U.S Dollars (100.- U.S. Dollars) each, having the same rights and privileges as existing shares (the
“New Shares”).

<i>Subscription and liberation of the New Shares

The Sole Shareholder, represented as aforesaid, decides to subscribe the New Shares and fully paid-up the New Shares

by contribution in cash, so the amount of Two Millions Two Hundred and Seventy Seven Thousand U.S. Dollars (USD
2,277,000.-) is now at the disposal of the Company, proof was given to the undersigned notary to states it.

<i>Second resolution:

As a consequence of such increase of capital, the Sole Shareholder decides to amend the Article 6 of the articles of

association of the Company, as follows:

105630

L

U X E M B O U R G

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at Two Millions Two Hundred and Ninety Two Thousand U.S. Dollars

(USD 2,292,000.-) represented by Twenty Two Thousand Nine Hundred and Twenty (22'920) shares with a par value of
one hundred U.S Dollars (100.- U.S. Dollars) each, all subscribed and fully paid-up.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surnames, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil seize, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Terasta Enterprises Limited, une société de droit chypriote, numéro de constitution HE309943, ayant son siège social

à Nikis &amp; Kastoros, 1087 Nicosia, Cyprus,

ici représentée par Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, résidant professionnellement à Redange/Attert, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé; laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la compa-
rante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante, représentée comme ci-avant, est l'associé unique («l'Associé Unique») de “Redbrick Holding S.à r.l.”

ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant le 30 mars 2016, non encore publié au Memorial C, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg section B numéro 205086 (la «Société»).

L'Associé Unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instru-

mentant d'acter les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de Deux Millions Deux Cent Soixante Dix Sept Mille U.S. Dollars

(2.277.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de Quinze Mille U.S. Dollars (15.000,- U.S. Dollars) représenté
par Cent Cinquante (150) parts sociales d'une valeur nominale de cent U.S. Dollars (100,- U.S. Dollars) chacune, à Deux
Millions Deux Cent Quatre Vingt Douze Mille U.S. Dollars (2.292.000,- USD) par la création et l'émission de Vingt Deux
Mille Sept Cent Soixante Dix (22.770) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de Cent U.S Dollars (100,-USD)
chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»); Souscription
et libération des Nouvelles Parts Sociales.

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter la prédite augmentation de capital social.
3. Divers.

<i>Première résolution:

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de Deux Millions Deux Cent Soixante Dix Sept

Mille U.S. Dollars (2.277.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de Quinze Mille U.S. Dollars (15.000,- U.S.
Dollars) représenté par Cent Cinquante (150) parts sociales d'une valeur nominale de cent U.S. Dollars (100,- U.S. Dollars)
chacune, à Deux Millions Deux Cent Quatre Vingt Douze Mille U.S. Dollars (2.292.000,- USD) par la création et l'émission
de Vingt Deux Mille Sept Cent Soixante Dix (22.770) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de Cent U.S Dollars
(100,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»).

<i>Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales

L'Associé Unique, représenté comme ci-avant, décide de souscrire toutes les Nouvelles Parts Sociales et de les libérer

moyennant apport en numéraire d'un montant de sorte que le montant de Deux Millions Deux Cent Soixante Dix Sept Mille
U.S. Dollars (2.277.000,- USD) est à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant qui
le constate.

<i>Seconde résolution:

Suite à l'augmentation de capital réalisée, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, comme

suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à Deux Millions Deux Cent Quatre Vingt Douze Mille U.S. Dollars (2.292.000,- USD)

représenté par Vingt Deux Mille Neuf Cent Vingt (22'920) parts sociales d'une valeur nominale de cent U.S. Dollars (100,-
U.S. Dollars) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

105631

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante,

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 19 mai 2016. Relation: DAC/2016/7208. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 24 mai 2016.

Référence de publication: 2016114789/111.
(160088164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

Société Immobiliere Oestreicher, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9559 wiltz, Zone Artisanale Salzbaach D.

R.C.S. Luxembourg E 2.930.

L'an deux mil seize, le vingt-huit avril.
Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1) Monsieur Lucien OESTREICHER, demeurant à L-9556 Wiltz, 97, rue des Rochers
2) Madame Angèle NANQUETTE, épouse OESTREICHER, demeurant à L-9556 Wiltz, 97, rue des Rochers
3) Monsieur Edouard OESTREICHER, demeurant à L-9674 Nocher, 2, Kautebacherwee.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont exposé au notaire:
- que la société société civile immobilière SOCIETE IMMOBILIERE OESTREICHER, avec siège social à L-9559

Wiltz, Zone Artisanale Salzbaach D, a été constituée suivant acte reçu par Me Paul BETTINGEN, notaire de résidence à
Niederanven, en date du 3 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 352 en date du
29 juillet 1995.

Les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
La société est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro E 2930.
- qu'elle a un capital de deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-treize cents (2.478,93 EUR) divisé

en cent (100) parts sociales de vingt-quatre euros soixante-dix-huit cents (24,78 EUR) chacune,

- que les comparants sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital de la société civile immobilière SOCIETE

IMMOBILIERE OESTREICHER, avec siège social à L-9559 Wiltz, Zone Artisanale Salzbaach D.

Ensuite les comparants, agissant comme prédit, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’adopter le bilan de clôture au 15 mars 2016 qui restera annexé aux présentes.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Troisième résolution

Les associés nomment aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation Monsieur Edouard OESTREICHER,

demeurant à L- 9674 Nocher, 2, Kautebacherwee.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants des lois sur les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

Les associés donnent décharge aux gérants, à savoir Monsieur Lucien OESTREICHER, Madame Angèle NANQUET-

TE, épouse OESTREICHER, et Monsieur Edouard OESTREICHER, préqualifiés.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à

sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

DONT ACTE, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.

105632

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Oestreicher L., Oestreicher E., Nanquette A., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Diekirch, le 2 mai 2016. Relation: DAC/2016/6415. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Diekirch, le 24 mai 2016.

Référence de publication: 2016114883/47.
(160087616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

TAXolution Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, Aerogolf Center.

R.C.S. Luxembourg B 149.181.

Im Jahre zweitausend und sechzehn, den achtzehnten Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Thomas GÖRRES, Steuerfachwirt, geboren in Trier (Deutschland), am 25. Juni 1979, wohnhaft in D-54536

Kröv, 191, Robert-Schuman Straße (Deutschland);

2.- Die Gesellschaft TAXolution Networking GmbH, eine sich in Gründung befindliche Gesellschaft mit beschränkter

Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in D-54536 Kröv, 89, Plenterstrasse (Deutschland), eingetragen im Handelsregister
beim Amtsgericht Wittlich, unter der Nummer-HRB 41292, hier vertreten durch Herr Thomas GÖRRES, vorbeannt, auf
Grund einer ihm ausgestellten Vollmacht.

Besagte Vollmacht wird nach gehöriger „ne varietur“ Unterzeichnung, durch den Erschienenen, Vollmachtnehmer und

den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen.

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchen, Folgendes zu beurkunden:
Herr Thomas GÖRRES, und TAXolution Networking GmbH, beide vorbenannt, sind die alleinigen Gesellschafter der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung TAXolution Consulting S.à r.l., mit Sitz in L-6647 Wasserbillig, 6, Rue des Roses,
eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 149.181, gegründet gemäss Urkunde,
aufgenommen durch den amtierenden Notar am 29. Oktober 2009, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2364 vom 3.
Dezember 2009, (die „Gesellschaft“).

In ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter erklären die vorgenannten Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, dem

instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tage-
sordnung:

<i>Tagesordnung

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6647 Wasserbillig, 6, Rue des Roses, nach L-1736 Senningerberg, 1B,

Heienhaff, Aerogolf Center.

2.- Abänderung von Artikel 2, Absatz 1 der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung haben die Komparenten folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6647 Wasserbillig, 6, Rue des Roses, nach L-1736

Senningerberg, 1B, Heienhaff, Aerogolf Center, zu verlegen.

<i>Zweiter und Letzter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikel 2, Absatz 1 der Satzung wie folgt umzuändern:

Art. 2. (Absatz 1). „Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Niederanven“.

<i>Kosten

Die Kosten werden auf EINTAUSENDEINHUNDERT EURO (EUR 1.100.-) abgeschätzt.
Die  Gebühren  und  Kosten  hierfür  werden  von  der  Gesellschaft  getragen.  Sie  verpflichtet  sich  gemeinsam  mit  den

Erschienenen mit der Zahlung der Gebühren und Kosten.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

105633

L

U X E M B O U R G

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet : Thomas Görres, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 19 mai 2016. 1LAC / 2016 / 16152. Reçu 75.- e

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 24. Mai 2016.

Référence de publication: 2016114932/53.
(160088434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

Universum F.O. Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 97, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 133.655.

Im Jahre zweitausendsechszehn, den.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxembourg);
hat sich eine außerordentliche Aktionärsversammlung der Aktiengesellschaft - UNIVERSUM F.O. SOPARFI S.A.",

Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-5440 Remerschen, 34, Waïstrooss, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in
Luxemburg  unter  Sektion  B  und  Nummer  133.655,  gegründet  gemäß  Urkunde  aufgenommen  durch  den  Notar  Emile
SCHLESSER, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 22. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 2914 vom 14. Dezember 2007,

deren Satzungen wurden mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar

Emile SCHLESSER, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg am 22. Februar 2008, veröffentlicht im „Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 845 vom 7. April 2008,

Den Vorsitz der Versammlung hat Herrn Henri DA CRUZ, Privatbeamter, berufsansässig in Junglinster.
Der Vorsitzende beruft zur Schriftführer Herrn Bob PLEIN, Privatbeamter, berufsansässig in Junglinster.
Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Cristiana VALENT, Privatbeamtin, berufsansässig in Junglinster.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern,  beziehungsweise  deren  Vertretern,  sowie  den  Mitgliedern  der  Versammlung  und  dem  amtierenden  Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung

"ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit dem-
selben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Sitzverlegung von L-5440 Remerschen, 34, Waïstrooss nach L-5445 Schengen, 97, route du Vin.
2. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel zwei (2), der Satzungen.
3. Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz, mit Wirkung zum 1. Februar 2016, von L-5440 Remerschen,

34, Waïstrooss nach L-5445 Schengen, 97, route du Vin, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel
2 der Satzungen abzuändern wie folgt:

Art. 2. (erster Absatz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schengen, (Großherzogtum Luxem-

burg)."

<i>Kosten

Die  der  Gesellschaft  aus  Anlass  dieser  Urkunde  anfallenden  Kosten,  Honorare  und  Auslagen  werden  auf  ungefähr

eintausend Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

105634

L

U X E M B O U R G

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Bob PLEIN, Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 mai 2016. Relation GAC/2016/3827. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016114957/52.
(160088118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2016.

Europe Property Fund IV Feeder S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 194.489.

In the year two thousand sixteen, on the eleventh day of May.
Before Maître Karine REUTER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of
EUROPE PROPERTY FUND IV FEEDER S.A. SICAV-SIF,
having its registered office in L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 194.489,
The extraordinary general meeting is opened by M. Damien BARBOSA, with professional address in Luxembourg, in

the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Kathy FERNANDEZ, with professional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr. Damien BARBOSA, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance

list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II) It appears from the said attendance-list that the shares representing 88% of the total subscribed capital are represented

at this meeting. All the shareholders represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior
to this meeting.

III) After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolution:

<i>Single resolution

The Meeting resolves to amend and restate the articles of the Company, which will henceforth read as follows:

Art. 1. Name. Between the undersigned and all persons that may become shareholders there exists a company in the

legal form of a public limited company under the name of "Europe Property Fund IV Feeder S.A. SICAV-SIF" (the “Fund")
qualifying as an “investment company with variable capital - specialised investment fund“.

All terms not defined in these Articles of Association shall have the meaning given to such terms in the PPM (as defined

below).

Art. 2. Duration. The Fund is established for a limited duration and will be terminated at the termination of the Master

Fund (as defined below) as set forth in the confidential private placement memorandum of the Fund (the “PPM”).

The Fund may be dissolved at any time upon resolution of the Fund's shareholders, provided that the resolution has been

passed in the form required for amendments to the Articles of Association.

The Master Fund Initial Closing Date being 15 October 2015, the Fund shall terminate on 14 March 2028 at the latest.

Art. 3. Corporate Object. The Fund's exclusive object is to carry out the business of a specialised investment fund

pursuant to the Law on Specialised Investment Funds dated 13 February 2007, as amended (“2007 Law“) and to achieve
the investment strategy laid down in the PPM.

The Fund will invest substantially all of its assets in Europe Property Fund IV S.à r.l. SICAV-SIF (the “Master Fund”).
Within the framework of the 2007 Law, the Fund may take all measures and carry out all business activities it deems

helpful to fulfil and to promote its company purpose.

Art. 4. Registered Office.  The  Fund's  registered  office  is  in  Luxembourg-City,  Grand  Duchy  of  Luxembourg.  The

registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of

105635

L

U X E M B O U R G

directors (the “Board”). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the
Board.

In the event that the Board determines that events of force majeure have occurred or are imminent that would interfere

with the normal activities of the Fund at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal
circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Fund which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital. The capital of the Fund, expressed in Euro, shall be represented by fully paid-up shares (the “Shares”)

of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Fund pursuant to Articles 27 and 28 hereof.

The initial capital of the Fund is thirty-one thousand euro (EUR 31,000).
The minimum capital shall be as provided by the 2007 Law i.e. one million two hundred and fifty thousand euro (EUR

1,250,000). The minimum capital of the Fund must be achieved within 12 months after the date on which the Fund has
been authorised under the 2007 Law.

Art. 6. Issue of Shares. The Board is entitled, within the limits set out in these Articles, to issue an unlimited number of

fully paid up Shares at any time and at such value as shall be determined in the PPM, without being required to grant
existing shareholders a preferential right of subscription.

The Board may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued. The Board may, in particular,

decide that Shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other periods as determined by the
Board and in accordance with the PPM.

The Board is authorised to issue different classes of Shares (each a “Share Class”) which may differ, inter alia, as regards

the fee structure, distribution policy, hedging strategies, minimum investment capital, shareholders' qualifications, payment
structures or other specific features and that can be denominated in different currencies, as may be determined by the Board
and laid down in the PPM from time to time. The Board may decide if and when Shares of such Share Classes are to be
offered for subscription, as well as the conditions of such issuance.

Shares will be issued after the acceptance of the subscription and subject to payment of the issue price, pursuant to

Articles 7 and 8 hereof. Upon acceptance of the subscription and receipt of the issue price, the shareholder will receive a
confirmation of its shareholding, within a period customary in financial affairs.

Fractions of Shares may be issued. In the event that a shareholder becomes entitled to a shareholding, such shareholding

shall be registered in the share register with up to four (4) decimals. Fractional Shares do not grant any voting rights:
however, the shareholder is entitled to distributions pro rata to its shareholding.

The proceeds from the issuance of Shares will be invested in securities and/or other permitted assets pursuant to Article

3 hereof.

The shareholders of all issued Shares will be listed in the share register that is kept by the Fund or by one or more entities

to whom the Board has delegated such task. The share register shall contain the names of all shareholders, their address as
well as the number of Shares held in the Fund and in each Share Class, if applicable. Ownership of a Share is evidenced
prima facie by the registration of the holder of such Share in the share register.

Every shareholder registered in the share register must provide the Fund with an address for the reception of notifications

and announcements by the Fund. This address will be listed in the share register. A shareholder may at all times change its
registered address by written notice sent to the Fund's registered office or such other address as may be indicated by the
Fund from time to time.

Subject to the consent of the shareholders and if permitted by the PPM and permitted by law, notifications and announ-

cements by the Fund can be sent electronically to the shareholders.

The registration of a person as a shareholder of the Fund in the share register is subject to the shareholder's qualification

as an Eligible Investor as defined in Article 10. For that purpose, the Fund may request evidence that the acquirer qualifies
as an Eligible Investor within the meaning of the 2007 Law. If need be, the Fund may request additional documents it
deems necessary for the registration in the share register.

Art. 7. Subscription of Shares / Capital Commitments. The Board or duly authorised persons may - at their sole discretion

- accept or reject subscriptions and payments for new Shares as well as issue new Shares to Eligible Investors (as defined
below).

Subscriptions may be made in the form of capital commitments (“Commitments”) and will become due and payable

either immediately in full or in several instalments upon receipt of drawdown notices, as further provided in the following
Article 8.

Subject to any specific provision in the PPM, the Board may allow assets to be contributed in kind, to the extent permitted

by Luxembourg law (in particular with respect to the requirement of a special audit report from the auditors of the Fund,
confirming the value of any assets contributed in kind) and the PPM, and provided that such assets are consistent with the
investment strategy of the Fund and the Master Fund. The costs of such contribution in kind shall be borne by the contri-
buting shareholder.

105636

L

U X E M B O U R G

Unless otherwise determined in the PPM, whenever the Fund offers Shares for subscription, the price of the offered

Shares shall be based on the issue price per Share of the relevant Share Class, if applicable, as determined in the PPM.

Subject to any specific provision in the PPM, the Board may, in its sole discretion, accept Commitments, or additional

Commitments from existing shareholders, after the date on which Commitments are first accepted from shareholders of
the Master Fund (the “Master Fund Initial Closing Date”) until the date set forth in the PPM (the “Final Closing Date”). If
a shareholder (a “Subsequent Shareholder”) is admitted to the Fund, or increases its Commitment, on a date after the Master
Fund Initial Closing Date (a “Subsequent Closing Date”), the following provisions shall apply in respect of the first draw-
down following such Subsequent Closing Date:

(i) drawdowns will be of such amounts and in such proportions so as to ensure that following the application of paragraph

(iii) and this paragraph (i) and equivalent provisions of each of the Master Fund Documents and the constitutional documents
of each of the Other Feeders, the aggregate amount drawn down from each shareholder (other than for the purposes of
paying the Additional Amounts (as defined below) and the Base Fee and that portion of the Master Fund Base Fee calculated
by reference to Total Fund Commitments) is in proportion to the shareholders' respective Total Fund Commitments as at
the date of such drawdown;

(ii) each Subsequent Shareholder shall pay to the Fund and each Other Subsequent Investor (as defined in paragraph

(iii) below) shall pay to the relevant Other Feeder an additional amount equal to interest at a rate equal to 9 per cent per
annum on amounts drawn down from the Subsequent Shareholder and Other Subsequent Investors (other than for the
purpose  of  paying  the  Base  Fee  and  that  portion  of  the  Master  Fund  Base  Fee  calculated  by  reference  to  Total  Fund
Commitments) from the date that such amounts would have been drawn down from it had such Subsequent Shareholder
or Other Subsequent Investor been admitted on or held its increased commitment on the Master Fund Initial Closing Date
to the date of actual draw down, calculated on a daily basis and compounding annually on the anniversary of the due date
of the prior draw down (the “Additional Amount”);

(iii) each shareholder from whom prior drawdowns had been made shall be allocated and paid such amount equal to the

excess of: (a) the amount drawn down from such shareholder and not previously returned (excluding Additional Amounts
and Base Fees); and (b) the amount which would have been drawn down from such shareholder (excluding Base Fees) had
all Subsequent Shareholders and their equivalent in each of the Other Feeders (the “Other Subsequent Investors” and each
an “Other Subsequent Investor”) been admitted to the Fund or the Other Feeders (as the case may be) or made their increased
Commitment on the Master Fund Initial Closing Date. Any amounts so returned to a shareholder shall be treated as having
never been drawn down (and accordingly such shareholder's undrawn Commitment shall be increased by such amount);

(iv) each of the shareholders other than the Subsequent Shareholder and each of the Other Feeder Fund Investors other

than the Other Subsequent Investors shall be entitled to receive such proportion of the Additional Amount as represents
the proportion which the amount drawn down from each of them prior to the relevant Subsequent Closing Date bears to
the aggregate amount so drawn down. Additional Amounts are paid in addition to the Commitment of a shareholder and
the shareholder will not receive any Shares in respect of such amounts; and

(v)  a  further  amount  shall  be  drawn  down  from  each  Subsequent  Shareholder  equal  to  the  Base  Fee  calculated  by

reference to the Subsequent Shareholders' respective Commitments plus that portion of the Master Fund Base Fee calculated
by reference to Total Fund Commitments to be borne by such Subsequent Shareholder each calculated as if such Subsequent
Shareholder had been admitted to the Fund or made its increased Commitment on the Master Fund Initial Closing Date.

With respect to any rebalancing of Shares to be effected on a Subsequent Closing Date, the Board shall, having regard

to the best interests of the shareholders as a whole, be entitled to effect such rebalancing by:

(a) transferring Shares between the shareholders;
(b) issuing new Shares; and
(c) redeeming and reissuing Shares.

Art. 8. Drawdowns.  If  subscriptions  are  made  in  the  form  of  Commitments,  such  shareholder's  Commitments  will

become due and payable in one or several instalments by subscription of the relevant number of fully paid-up Shares
pursuant to a drawdown (the “Drawdown”). For each Drawdown, the Fund or other authorised person will send a drawdown
notice to the shareholder with the request to arrange for payment of the respective amount via bank transfer. Pursuant to
the payment of the relevant amount in accordance with the PPM, the corresponding number of Shares will be issued to the
respective shareholder.

When Commitments are called in several instalments, except in relation to Drawdowns made following a Subsequent

Closing Date as described in Article 7, each Drawdown will be made on a pro rata basis with respect to the Commitments
made by each shareholder, unless otherwise provided in the PPM. Unless otherwise determined, each Drawdown, shall
amount to a percentage of the relevant shareholder's total Commitment, determined by the Board in its sole discretion.

The offering period (and any possible extension(s) thereof), as well as the issue price of Shares shall be defined in the

PPM.

Art. 9. Defaulting Investor. Subject to any specific provision in the PPM, a shareholder who fails to comply with a

drawdown notice by the date of its expiry (a “Defaulting Shareholder“) may be requested to pay interest on the amount it
failed to pay in such amount as determined in the PPM.

105637

L

U X E M B O U R G

In addition, the Defaulting Shareholder will also be liable for (i) any additional amount sufficient to reimburse the

Manager, the Portfolio Manager and/or the Fund with respect to any other fees, costs and expenses (including in respect
of borrowings) or Tax incurred by the Manager, the Portfolio Manager and/or the Fund as a result of the shareholder's
failure to pay the full amount due and (ii) any additional penalties as set forth in the PPM.

Further details with respect to this Article 9 of the Articles of Association are provided in the PPM.

Art. 10. Restrictions on shareholders. Shares shall be issued only to well-informed investors within the meaning of

Article  2  of  the  2007  Law  (each  an  "Eligible  Investor"),  upon  verification  of  such  status  and  upon  acceptance  of  the
subscription and subject to payment of the price as set forth in Articles 7 and 8 hereof. Every shareholder must provide the
Fund with the confirmation or, as the case may be, evidence of its status of Eligible Investor.

The conditions set forth above shall not apply to the directors and other persons who are involved in the management

of specialised investment funds and hence are not applicable to the Directors.

In addition to the above, the Board shall have power (but not the obligation) to refuse to issue or register any transfer

of Shares, or to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as it, in its discretion, may think
necessary for the purpose of ensuring that no Shares are acquired or held by or on behalf of any person, firm or corporate
entity, determined in the sole discretion of the Board as being not entitled to subscribe for or hold Shares,

(i) if in the opinion of the Board such holding may be detrimental to the Fund,
(ii) if as a result thereof the Fund would breach any applicable material law, regulation or interpretation, Luxembourg

or foreign,

(iii) if as a result thereof the Fund or any shareholder may become exposed to disadvantages of a tax, legal, economic

or financial nature that it would not have otherwise incurred, or

(iv) if such person would not comply with the eligibility criteria of the Shares, and notably if such person is a U.S. Person

and not a “qualified purchaser” within the meaning of Section 2(a)(51) of the U.S. Investment Company Act (each indi-
vidually, a "Prohibited Person").

More specifically, the Fund may restrict or prevent the ownership of Shares by any person, firm or corporate body. For

such purposes, the Fund may:

decline to issue any Share, and decline to register any transfer, where it appears to it that such issue or transfer would

or might result in such Share being directly or beneficially owned by a Prohibited Person,

at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares on the

register of shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the
purpose of determining whether or not the beneficial ownership of Shares rests in Prohibited Person,

request the shareholder to dispose of its Shares pursuant to the transfer provisions contained herein and in the PPM and

to provide evidence of the disposal vis-à-vis the Fund within thirty (30) days of such request if in the Board's assessment
a Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner of Shares. Should
the respective shareholder fail to comply with this request in due time, the Board may - in its sole discretion - treat such
shareholder as a Defaulting Investor.

where it appears to the Fund that any Prohibited Person, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial

or registered owner of Shares, compulsorily redeem from any such shareholder all Shares held by such shareholder in the
following manner:

A. the Fund shall serve a notice (hereinafter referred to as the "Redemption Notice") upon the shareholder holding such

Shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be
redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as defined below)
in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such shareholder by posting the
same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known or appearing in the register
of shareholders. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice, such shareholder
shall cease to be a shareholder and the Shares previously held by him shall be cancelled. The said shareholder shall thereupon
forthwith be obliged to deliver to the Fund the Share certificate or certificates (if issued) relating to the Shares specified in
the Redemption Notice;

B. the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed shall be determined in accordance

with Article 26 hereof (hereinafter referred to as the "Redemption Price");

C. payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner of such Shares and will be

deposited by the Fund with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to
such person upon verifications in accordance with the relevant laws and regulations. Upon deposit of the monies corres-
ponding to the Redemption Price as aforesaid no person specified in such Redemption Notice shall have any further interest
or claim in such Shares or any of them, or any claim against the Fund or its assets in respect thereof, except the right of the
shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without any interest) from such bank as
aforesaid;

D. the exercise by the Fund of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case,

on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of any

105638

L

U X E M B O U R G

Shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any Redemption Notice, provided that in such case the said
powers were exercised by the Fund in good faith; and

E. decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Fund.

Art. 11. Rights and duties attached to the Shares. Each Share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Fund and to one vote at shareholder general meetings, except as may be determined in the PPM.

If the Fund is composed of a single shareholder, that shareholder exercises all those powers granted to all shareholders

by the law of 10 August 1915 on commercial companies (the “1915 Law”) and these Articles.

Ownership of a Share carries implicit acceptance of these Articles and of any decision made by resolution of the sha-

reholders.

The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event request that a seal

be affixed to the assets and documents of the Fund or an inventory of assets be ordered by court. They must, for the exercise
of their rights, refer to the Fund's inventories and resolutions.

Art. 12. Indivisibility of Shares. Co-owners of Shares must be represented by a common attorney-in-fact, whether or

not jointly appointed.

Art. 13. Transfer of Shares. Shares may only be transferred subject to: (i) the provisions of the 2007 Law according to

which every shareholder must qualify as an Eligible Investor; (ii) these Articles of Association; (iii) the provisions contained
in the PPM and (iv) the prior written consent of the Portfolio Manager.

Transfers of Shares may only be made by any existing shareholder to Eligible Investors.

Art. 14. Incapacity, bankruptcy or insolvency of shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar

event affecting a shareholder will not cause the Fund to go into liquidation.

Art. 15. Director. The Fund is managed and administered by a Board composed of at least four (4) directors who do not

have to be shareholders (each a "Director").

The Board is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Fund's

corporate object.

All powers not expressly reserved by the Articles or by the 1915 Law to the general meeting of shareholders or to the

auditor(s) are in the competence of the Board.

Each Director is appointed annually by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may

elect to remove, replace or appoint additional Directors to the Board from time to time. Each Director shall be subject to
re-appointment on an annual basis, such re-appointment together with the appointment of any new or additional Directors
and any decision not to replace a Director who does not wish to be re-appointed, has resigned or has been removed (provided
there are sufficient numbers of Directors remaining to comply with the requirements of this Article with respect to com-
position of the Board) shall require the approval of the general meeting of shareholders.

Any Director may be removed at any time, with or without cause, by the general meeting of shareholders taking an

Ordinary Resolution. Any Director may resign at any time on providing advance notice to the Fund.

The general meeting of shareholders shall decide by Ordinary Resolution upon the compensation of each Director.
The Board shall appoint, from among its members, a chairman. The Board shall choose a secretary, who need not be a

Director, who shall be responsible for keeping board meeting minutes and other Fund records.

The Board may also appoint officers of the Fund considered necessary for the operation and management of the Fund.

Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be Directors or shareholders of the
Fund. The officers appointed shall have the powers and duties entrusted to them by the Board.

Art. 16. Meetings of the Board. Meetings of the Board shall be held at the place indicated in the notice of the meeting.
Written notice of any Board meeting shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the time set for such

meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the
notice of the meeting. This notice may be waived with the consent of each Director in writing, by facsimile or e-mail.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by

resolution of the Board.

The Board will meet upon call by the chairman. A meeting of the Board must be convened if any two (2) of its members

so require.

The chairman will preside at all meetings of the Board, except that in his absence the Board may appoint another member

of the Board as chairman pro tempore by majority vote of the directors present or represented at such meeting.

Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing, by facsimile or e-mail, another director as

his proxy. Directors may also cast their vote in writing, by facsimile or e-mail. Meetings of the Board may be held by way
of conference call, video conference or any other similar means of communication, in which case the Directors participating
by such means shall be deemed to be present in Luxembourg.

105639

L

U X E M B O U R G

The Board shall act validly only if at least three directors are present or represented at a meeting of the Board. Decisions

shall be taken by a majority vote of the Directors present or represented. The chairman of the Board shall have a casting
vote.

The minutes of any meeting of the Board will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached

thereto. Copies or extracts of written resolutions or minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise may be
signed by any two Directors.

Resolutions may also be passed in the form of a written consent resolution. This may be signed jointly or by the use of

counterpart signatures by all the directors.

Art. 17. Powers of representation. In dealing with third parties, any two Directors shall have the power to act jointly in

the name of the Fund in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations. The Fund is bound in all
circumstances by the signature of two Directors. Notwithstanding the foregoing, any one Director shall have the power to
act alone in the name of the Fund in all circumstances, to carry out and authorize all acts and operations, and to bind the
Fund in all circumstances by only such Director's signature, if so authorised by the Board.

Art. 18. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a Director.  The  death,  incapacity,  bankruptcy,  insolvency,

resignation, removal or any other similar event affecting a Director will not cause the Fund to go into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a Director may in no event have seals affixed to the assets and documents of the Fund.

Art. 19. Liability of Director. A Director will not incur any personal liability arising out of the functions performed on

behalf of the Fund. He is only liable for the performance of his mandate.

Art. 20. Conflicts of interest and indemnity. No contract or other transaction between the Fund and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that a Director, officer or employee of the Fund has a personal interest
in, or is a shareholder, director, director, officer or employee of such other company or firm. Any person related, as described
above, to any company or firm with which the Fund shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason
solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon
any matters with respect to such contract or business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director has or may have any vested interest or personal interest in any

transaction of the Fund, such Director shall make known such personal interest to the Board of Directors and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such interest of the Director therein shall be reported to
the next general meeting of shareholders.

The  above  paragraph  of  this  Article  does  not  apply  if  (i)  the  relevant  transaction  is  entered  into  under  fair  market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Fund.

The  term  “vested  interest“  as  used  herein  does  not  comprise  every  interest  merely  resulting  from  the  fact  that  the

transaction relates to BlackRock (or a company directly or indirectly associated with BlackRock respectively) or another
company as determined by the Fund.

None of the members of the Investor Advisory Committee (acting solely in their capacity as such), any shareholders

who have appointed a member of the Investor Advisory Committee (solely in relation to the appointment and conduct of
the relevant Investor Advisory Committee member), the Board, the Manager, the manager of the Master Fund, the Portfolio
Manager, the portfolio manager of the Master Fund, the members of the Investment Committee, BlackRock or any of their
respective partners, officers, members, shareholders, directors, employees, agents or affiliates or board member of any
Holding Company or Property Company (each an “Indemnified Person”) will be liable to the Fund or any of the shareholders
for any act or omission performed or omitted by any such Indemnified Person and the Fund shall indemnify such Indem-
nified Persons on an after-Tax basis for any loss or damage incurred by any of them, except where such liability or claim
is the result of, (i) in the case of an Indemnified Person other than members of the Investor Advisory Committee, or any
shareholder who has appointed a member of the Investor Advisory Committee, (a) gross negligence, (b) wilful misfeasance,
(c) bad faith, (d) fraud or (e) a knowing breach of the terms of the Lux Documents, which in each case results in the Fund
and/or the shareholders suffering material financial disadvantage; and (ii) in the case of members of the Investor Advisory
Committee, or any shareholder who has appointed a member of the Investor Advisory Committee, bad faith as determined
by the final judgment of a court.

Art. 21. Appointment, powers and removal of the Manager. The Board may appoint an external alternative investment

fund manager (“Manager”) within the meaning of the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund
managers (the “AIFM Law”).

The Manager of the Fund shall be responsible for the portfolio and risk management of the Fund in accordance with the

PPM and subject to ultimate oversight of the Board. The Manager may be allowed to delegate portfolio management to
one or more portfolio managers in accordance with the PPM.

The Board may remove the Manager at any time where it considers it to be in the best interest of the shareholders, and

in accordance with the conditions set forth in the PPM.

The Board shall also remove the Manager under such circumstances and conditions as may be further set forth in the

PPM.

105640

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Voting Rights. Each Share will grant one vote, independent from the Net Asset Value of such Share but subject

to limitations, if any, pursuant to applicable law, the Articles of Association and the PPM.

Each shareholder may be represented by another shareholder or another person at any meeting of shareholders by virtue

of a written proxy (including facsimile). Such proxy holder does not need to be a shareholder and may be a Director or a
representative thereof.

Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Fund. Voting forms contain the date, place and

agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution three boxes allowing to (a) vote
in favour, (b) vote against, or (c) abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered
office of the Fund. Only voting forms received prior to the meeting of the shareholders are taken into account for the
calculation of the quorum. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an
abstention are void.

In cases where votes are related to (an) individual Share Class(es), only the shareholders of such relevant Share Class

(es) will be entitled to vote.

The Board may determine further conditions to be fulfilled by the shareholders in order to be admitted to a meeting of

the shareholders.

Should the Fund be requested to exercise voting rights in relation to the Master Fund, the Board shall consult with the

shareholders of the Fund prior to exercising any vote at the Master Fund level, to the extent such consultation is required
by the PPM. Further details of the relevant consultation mechanism may be determined in the PPM.

To the extent permitted by the constitutive documents of the Master Fund, the Board shall exercise a split vote at the

Master Fund level so as to vote the interest of the Fund in the Master Fund in proportion to the responses received from
the shareholders of the Fund. Absent direction from a shareholder, the Board will abstain from voting with respect to such
shareholder's pro rata interest.

Art. 23. General meetings of shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Fund shall

represent the entire body of shareholders of the Fund. Its resolutions shall be binding upon all shareholders regardless of
the Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Fund.

In the event that the Fund is composed of one sole shareholder, the sole shareholder will be vested with all powers of

the general meeting of shareholders.

When  the  Fund  is  composed  of  several  shareholders,  shareholders'  decisions  are  taken  by  resolutions  in  a  general

meeting, the text of which will be sent by the Board to the shareholders by simple letter or by email for a first consultation,
and sent by registered letter for a second consultation. In the latter case, shareholders are under the obligation to cast their
written vote and send it by registered letter to the Fund within 15 days of receiving the text of the resolution to be decided
upon.

When the Fund is composed of several shareholders, unless otherwise specified in these Articles or in the 1915 Law,

shareholder decisions are only validly taken if they are adopted by shareholders representing more than half (50%) of the
corporate capital. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted a
second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes cast validly, regardless of the
portion of capital represented.

However, resolutions to amend these Articles and to liquidate the Fund may only be taken by a majority of shareholders

representing three quarters (75%) of the Fund's corporate capital.

In line with Luxembourg law, the annual general meeting of shareholders will be held at the Fund's registered office in

Luxembourg or any other place in the municipality of Luxembourg-city as may be indicated in the convening notice, at
midday on the last day on which banks in Luxembourg are open for business in June of each year or, if such day is a public
holiday, on the last preceding Luxembourg bank business day. The annual general meeting of shareholders may be held
abroad should extraordinary circumstances so require in the sole discretion of the Board.

Other shareholders' meetings of the Fund may be held at such place and date as stated in the respective convening notice.
Upon the written request of shareholders jointly representing one tenth (1/10) of the share capital, a shareholders' meeting

has to be convened.

Art. 24. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the shareholders will be documented in writing, recorded

in a register and kept at the registered office of the Fund. Shareholder votes and any powers of attorney will be attached to
the minutes of the meeting, if applicable.

Art. 25. Determination of investment policies. The Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have

power to determine the investment policies and the course of conduct of the management and business affairs of the Fund,
within the restriction set forth in the PPM and in compliance with applicable laws and regulations.

Art. 26. Redemption and Compulsory Transfer. The Fund is a closed-ended specialised investment fund. Consequently,

Shares in the Fund shall not be redeemable at the request of a shareholder unless specified otherwise in the PPM.

Shares may be called by the Fund for redemption or may be subject to compulsory transfer to a third party:

105641

L

U X E M B O U R G

(a) in the circumstances listed under Articles 7 and 10 of the Articles of Association;
(b) if such shareholder has materially breached any provision of these Articles or the PPM; or
in such other circumstances as set forth in the PPM or as the Fund may determine where continued ownership would

be materially prejudicial to the interests of the Fund or its shareholders.

Shares which are to be redeemed by the Fund may be redeemed by the Fund upon the Fund giving to the registered

holder of such Shares not less than 30 days' notice in writing of the intention to redeem such Shares specifying the date of
such redemption, which must be any day (other than a Saturday or Sunday) when banks are open in Luxembourg, London
and New York (a “Business Day”).

The amount payable on such redemption of Shares shall be the Net Asset Value of the Shares on the most recent Valuation

Date, except as otherwise provided in the PPM. Costs associated with the redemption may, if the Fund so decides, be
charged to the shareholder whose Shares are redeemed and such costs may be deducted from the redemption proceeds
payable to the shareholder in circumstances where the Fund has exercised its power to redeem Shares pursuant to paragraph
(a) or (b) of this Article 26.

Any Shares in respect of which a notice of redemption has been given shall not be entitled to participate in the profits

of the Fund in respect of the period after the date of redemption.

No Shares of a relevant Share Class may be converted into Shares of another Share Class upon request of a shareholder,

but the Board may be entitled to proceed to such conversions under the conditions set forth in the PPM.

Art. 27. Valuation and Deposit of assets.
27.1 Calculation method
The net asset value per Share shall be expressed in Euro and shall be determined as of each Valuation Date by dividing

(i) the net assets of the Fund , by (ii) the number of outstanding Shares, in accordance with the valuation rules set forth
below, provided that the assets shall be determined in accordance with the rules set forth below (the “Net Asset Value”).

The Net Asset Value per Share is quoted with up to four (4) decimal places as one amount per Share in the reference

currency. If since the time of determination of the Net Asset Value there has been a material change in relation to a substantial
part of the Investments of the Fund, the Fund may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Fund,
cancel the first valuation and carry out a second valuation with prudence and in good faith.

27.2 Determination of assets and liabilities
Subject to compliance with Lux GAAP, or as may otherwise be agreed with the Auditors, the assets and liabilities of

the Fund shall be determined in the following manner:

27.2.1 The assets of the Fund shall include:
a) shares in the Master Fund;
b) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
c) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of properties, property rights, securities

or any other assets sold but not delivered);

d) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants,

options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Fund (provided that
the Manager may make adjustments in a manner with regard to fluctuations in the market value of securities caused by
trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);

e) stock dividends, cash dividends and cash payments receivable (including drawn but unpaid capital) by the Fund to

the extent information thereon is reasonably available to the Fund;

f) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Fund except to the extent that the same is included or

reflected in the value attributed to such asset;

g) the formation expenses of the Fund, including the cost of issuing and distributing Shares of the Fund, insofar as the

same have not been written off; and

h) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
Subject to compliance with Lux GAAP, or as may otherwise be agreed with the Auditors, the value of such assets shall

be determined as follows:

The value of the Master Fund Investments shall be determined by reference to the net asset value of such Master Fund

Investments as most recently reported by the Master Fund,

The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable (including VAT receivables),

prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full
amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is
arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.

All other securities and other assets, including debt securities and securities for which no market quotation is available,

are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by a pricing service approved by the Board or the Manager or, to
the extent such prices are not deemed to be representative of market values, such securities and other assets shall be valued
at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Manager. Money market instruments

105642

L

U X E M B O U R G

held by the Fund with a remaining maturity of 90 days or less will be valued by the amortised cost method, which ap-
proximates market value.

The value of all assets and liabilities not expressed in Euro will be converted into such currency at the relevant rates of

exchange ruling on the relevant Valuation Date. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined
with prudence and in good faith by or under procedures established by the Manager.

The Manager may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects

the fair value of any asset of the Fund.

27.2.2:
Subject to compliance with Lux GAAP, or as may otherwise be agreed with the Auditors and subject to Article 27.2.3,

the liabilities of the Fund shall include:

a) all loans and other indebtedness for borrowed money (including convertible debt), bills and accounts payable;
b) all accrued interest on such loans and other indebtedness for borrowed money (including accrued fees for commitment

for such loans and other indebtedness);

c) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, advisory fees, custodian fees, and domiciliary

and corporate agents' fees);

d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or in

respect of property, including the amount of any unpaid distributions declared by the Fund, where the Valuation Date falls
on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

e) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from time

to time by the Board, as well as such amount (if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect
of any contingent liabilities of the Fund, provided, for the avoidance of doubt, that such provision shall include any deferred
taxation calculated as if the relevant real estate had been directly or indirectly realised on the relevant Valuation Date in a
manner determined from time to time in the discretion of the Board; and

f) all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law and Lux

GAAP. In determining the amount of such liabilities, the Fund shall take into account all expenses payable by the Fund.
The Fund may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount
rateably for yearly or other periods.

27.2.3 For the purpose of this Article 27:
(i) Shares to be issued by the Fund shall be treated as being in issue as from the date the relevant amount is paid pursuant

to a Drawdown and from such time and until received by the Fund the price therefore shall be deemed to be a debt due to
the Fund;

All Investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than Euro shall be valued after taking into

account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value; and

Subject to compliance with Lux GAAP, or as may otherwise be agreed with the Auditors, where on any Valuation Date

the Fund has contracted to:

a) purchase unconditionally any asset, the value of the consideration to be paid and any costs associated with such asset

on the relevant Valuation Date shall be shown as a liability of the Fund and the value of the asset to be acquired less any
costs associated with the asset on the relevant Valuation Date shall be shown as an asset of the Fund; or

b) sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Fund and

the asset to be delivered by the Fund shall not be included in the assets of the Fund;

provided, however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation

Date, then its value shall be estimated by the Manager in good faith.

27.2.4 For the avoidance of doubt, the provisions of this Article 27 (including, in particular, Article 27.2.3 hereof) are

rules for determining the Net Asset Value per Share and are not intended to affect the treatment for accounting or legal
purposes of the assets and liabilities of the Fund or any Shares issued by the Fund.

27.2.5 Subject to any decision of the Board to the contrary, every decision of the Manager with regard to the determination

of the Net Asset Value (and for the avoidance of doubt, the Manager may amend, in its sole discretion, any decisions made
by service providers appointed by the Board or the Manager) will be final and binding on the Fund as well as for all current,
former and future shareholders, provided that there is no violation of the principle of good faith, no gross negligence or no
obvious error at hand.

27.3 Appointment of Depositary
The Fund and the Manager shall appoint a depositary in relation to the supervision, deposit and safekeeping of the assets

of the Fund in accordance with the 2007 Law and the AIFM Law.

Where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and there

are no local entities that are subject to effective prudential regulation and supervision as well as external periodic audit, the
depositary can discharge itself of liability provided that the conditions laid down in the AIFM Law are met and subject to
the terms of the depositary agreement between the Fund, the Manager and the depositary.

105643

L

U X E M B O U R G

Art. 28. Frequency and temporary suspension of calculation of Net Asset Value.
28.1 Frequency of calculation
The Net Asset Value per Share of a respective Share Class shall be calculated by the Central Administration Agent

based on the Net Asset Value as at the Valuation Date. Where the Net Asset Value is calculated at the initiative of the
shareholder, the costs related to such additional calculation of Net Asset Value will be borne by such shareholder.

28.2 Temporary suspension
The Board may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue of Shares:
a) in the event that the determination of the net asset value of the Master Fund has been suspended;
b) during any period when one or more exchanges which provide the basis for valuing a substantial portion of the assets

of the Fund are closed or if dealings therein are restricted or suspended or where trading is restricted or suspended;

c) during any period when, as a result of the political, economic, military, terrorist or monetary events or any circumstance

outside the control, responsibility and power of the Board, disposal of the assets of the Fund is not reasonably practicable
without materially and adversely affecting and prejudicing the interests of shareholders or if, in the opinion of the Board,
a fair price cannot be determined for the assets of the Fund;

d) in the case of a breakdown of the means of communication normally used for valuing any asset of the Fund which is

material or if for any reason the value of any asset of the Fund which is material in relation to the Net Asset Value (as to
which the Board shall have sole discretion) may not be determined as rapidly and accurately as required;

e) if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of

the Fund are rendered impracticable, or if purchases, sales, deposits and withdrawals of the assets of the Fund cannot be
effected at the normal rates of exchange;

f) when the value of a substantial part of the assets of any consolidated subsidiary of the Fund may not be determined

accurately;

g) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of considering a reso-

lution to wind up the Fund; or

h) when for any other reason, the prices of any Investments or Master Fund Investments cannot be promptly or accurately

determined.

The Board shall give notice of any such suspension to the shareholders.

Art. 29. Issue Price. Shares will be issued at a fixed price of 10 Euro (the “Issue Price”).
After the Initial Closing Date, shareholders shall pay for the subscription of new Shares the Issue Price plus any charges

or fees as may be decided by the Board from time to time and described in Article 7 of these Articles of Association.

Art. 30. Auditor. The shareholders' meeting of the Fund will appoint an auditor (“réviseur d'entreprise agréé”) who will

perform such duties vis-à-vis the Fund as described in Article 55 of the 2007 Law.

Art. 31. Financial year. The financial year of the Fund shall begin on 1 January of each year and end on 31 December

provided that (i) the first financial year of the Fund, shall commence on the date of incorporation of the Fund and end on
31 December 2015; and (ii) the last financial year of the Fund will end on the date on which the winding up of the Fund is
completed.

The accounts of the Fund shall be expressed in Euro. The annual accounts, including the balance sheet and profit and

loss account, the Directors report and the notice of the annual general meeting will be sent and/or published and made
available in accordance with applicable law.

Art. 32. Balance-sheet. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board will produce an inventory

of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the 1915 Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to each of the shareholders

for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may consult the financial documents at the registered office of the Fund.

Art. 33. Distribution of income. The general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board, subject to

any interim distributions having been declared or paid, determine how the annual net investment income shall be disposed
of.

Interim distributions may, at the discretion of the Board and in accordance with the PPM, be declared subject to such

further conditions as set forth by law, and be paid out on the Shares out of the income of assets upon decision of the Board.

Distributions may include an allocation from a dividend equalisation account which, in such event, will be credited upon

issue of Shares to such dividend equalisation account and upon redemption of Shares, the amount attributable to such Share
will be debited to an accrued income account.

The distributions declared, if any, will normally be paid in Euro, in the currency of the relevant Share Class or in such

other currencies as selected by the Board and may be paid at such places and times as may be determined by the Board.
The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend monies into the currency
of their payment. Stock dividends may be declared.

105644

L

U X E M B O U R G

Distributions may be made in kind to the extent permitted in the PPM.
If and to the extent set forth in the PPM, distributions made to shareholders may be subject to a clawback obligation,

allowing the Board to call back the respectively distributed assets.

Any distributions to shareholders that were declared by the Fund but for any reasons cannot be paid, may not be claimed

after five (5) years and will then be attributed to the respective Share Class or to the Fund. No interest will be paid on
distributions declared by the Fund.

Distributions may not be made if pursuant to such distribution the Fund's minimum capital would fall below the statutory

minimum capital.

Art. 34. Dissolution and liquidation. The decision to dissolve the Fund may be validly adopted only with the consent of

a majority of shareholders representing three quarters (75%) of the Fund's corporate capital.

Upon dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by the Manager or by one or several other liquidators (who

may be physical persons or legal entities) (together with the Manager the “Liquidators”) named by the meeting of share-
holders resolving to commence such dissolution and which shall determine their powers and their fees. The net proceeds
of liquidation shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares relating in proportion of their holding of Shares,
and subject to the specifities of each Share Class, as set forth in the PPM.

Moneys available for distribution to shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by shareholders

will at the close of liquidation be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance with the 2007
Law.

If at any time the capital of the Fund falls below two thirds of the minimum capital required by Luxembourg law, the

Board must submit the question of dissolution of the Fund to a general meeting of shareholders acting, without quorum
requirements, by a simple majority decision of the Shares present or represented at such meeting.

Art. 35. General All. matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with applicable law.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

<i>Declaration

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with Us notary this original

deed.

Signés: K. FERNANDEZ, D. BARBOSA, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/10280. Reçu soixante-quinze euros 75.-.

<i>Le Receveur (signé): MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 25 mai 2016.

Référence de publication: 2016115261/592.
(160089100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.

Bati Expansion, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 104.023.

L'an deux mille seize, le dix-huit mai.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée;

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de la société anonyme «BATI EXPANSION»,

ayant son siège social au 36, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104023, (la «Société»), constituée en
date du 28 octobre 2004 suivant un acte de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 64 du 22 janvier 2005.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 13 janvier 2009 suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER,

alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
490 du 6 mars 2009.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Luc HILGER, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Emilia LOUREIRO, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

105645

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy LANNERS, expert-comptable, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence, ainsi que les procurations signées «ne varietur», resteront annexées au présent acte pour être

enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les trente-six mille trois cent soixante-quatre (36.364) actions d'une valeur

nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir
eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la renonciation au (i) rapport d'expert dans le but de s'exprimer sur le bien-fondé et la pertinence de

l'opération de fusion, conformément à l'article 266 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), et au (ii) rapport des organes de gestion et d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent
expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport
d'échange des parts, conformément à l'article 265 (3) de la Loi;

2. Présentation et approbation du projet de fusion (le «Projet de Fusion») par absorption de la Société par la société

FIBATIM S.à r.l., sa 100% filiale, tel qu'arrêté le 25 mars 2016 et publié au Mémorial C (la «Fusion»);

3. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la Loi;
4. Décision de procéder à la Fusion, et ce conformément au rapport d'échange établi dans le Projet de Fusion, moyennant

l'apport universel de tous les actifs et passifs de la Société à la société absorbante FIBATIM S.à r.l. et dissolution sans
liquidation de la Société par l'effet de la Fusion;

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
6. Décision quant à la conservation des registres et documents de la Société;
7. Divers;
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Assemblée constate que les associés et actionnaires de chacune des sociétés participant à la Fusion ont renoncé au (i)

rapport d'expert dans le but de s'exprimer sur le bien-fondé et la pertinence de l'opération de fusion, conformément à l'article
266 (5) de la Loi, et au (ii) rapport des organes de gestion et d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent
expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport
d'échange des parts, conformément à l'article 265 (3) de la Loi.

<i>Deuxième résolution:

L'Assemblée constate que le Projet de Fusion par absorption de la Société, (la «Société Absorbée»), par sa filiale détenue

à 100%, la société à responsabilité limitée FIBATIM S.à r.l., immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B106654, ayant son siège social au 36, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, avec
capital social souscrit fixé à cent cinquante-huit mille euros (EUR 158.000,-), (la «Société Absorbante»), arrêté le 25 mars
2016 par acte du notaire instrumentant, a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1009 du
6 avril 2016, conformément aux articles 9 et 262 de la Loi au moins un mois avant la date de la réunion de la présente
assemblée générale appelée à se prononcer sur le Projet de Fusion.

L'Assemblée approuve intégralement le Projet de Fusion, tel que publié au Mémorial C, sous réserve d'approbation du

Projet de Fusion par l'assemblée générale de la Société Absorbante, aux conditions prévues par ledit Projet de Fusion, avec
prise d'effet de la fusion au 31 décembre 2015 sur le plan comptable.

<i>Troisième résolution:

L'Assemblée constate que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi, ont été tenus à la disposition des ac-

tionnaires au siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente assemblée.

Une lettre de confirmation établi à cet effet par le conseil d'administration de la Société en date du 10 mai 2016, après

signature «ne varietur», restera annexée au présent acte.

<i>Quatrième résolution:

L'Assemblée, sous réserve d'approbation du Projet de Fusion par l'assemblée générale de la Société Absorbante, décide

donc de procéder à la réalisation de la Fusion, conformément au rapport d'échange établi dans le Projet de Fusion, moyennant

105646

L

U X E M B O U R G

l'apport universel de tous les actifs et passifs de la Société à la société absorbante FIBATIM S.à r.l., sa filiale détenue à
100%, et dissolution sans liquidation de la Société par effet de la Fusion.

L'Assemblée approuve la rémunération de l'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de la Société à la Société

Absorbante par l'émission de nouvelles parts dans la Société Absorbante, attribuées aux actionnaires de la Société confor-
mément au rapport d'échange fixé dans le Projet de Fusion.

L'Assemblée approuve et décide la dissolution sans liquidation de la Société, laquelle cessera d'exister par l'effet de la

Fusion.

<i>Cinquième résolution:

L'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes de la Société

pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Sixième résolution:

L'Assemblée décide que les registres et documents de la Société seront conservés au siège de la Société Absorbante

pendant la durée légale.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises sous la condition suspensive de l'approbation de la fusion dans les

mêmes termes par l'assemblée de la Société Absorbante.

<i>Certification

Le notaire instrumentant certifie et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbée

et du projet de fusion.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont tous signé avec

Nous notaire la présente minute.

Signé: L. HILGER, E. LOUREIRO, G. LANNERS, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/16197. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016115119/107.
(160088739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.

Bionext, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean -Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 140.641.

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE DIX-HUIT MAI.
Devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Jean-Luc DOURSON, pharmacien, né le 5 décembre 1969 à Sarreguemines (France), et demeurant au 73,

route de Luxembourg, L-8140 Bridel,

ici représenté par Madame Emmanuelle FRATTER, employée privé, demeurant professionnellement à L-1258 Luxem-

bourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 17 mai 2016.
Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire signataire, et restera annexée

au présent acte pour les formalités de l'enregistrement

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. qu'il est l'actionnaire unique de la société BIONEXT (anciennement CORSO INVEST S.A.), société anonyme de droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, enregistrée au Registre
de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 140.641. (la «Société»), constituée suivant acte reçu par

105647

L

U X E M B O U R G

Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 juillet 2008 et dont les statuts ont été publiés au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2057 en date du 25 août 2008. Les statuts de la Société ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 avril 2016, en cours de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

II. qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer l'objet de la société afin d'y inclure l'activité de l'exploitation d'un laboratoire d'ana-

lyses médicales en premier alinéa de son objet.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 3 des statuts qui aura à présent

la teneur suivante:

«La Société a pour objet l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, comprenant notamment toutes prestations

constitutives d'examens de laboratoires et d'analyses de biologie médicale.

La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou
de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu'elle
possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences y rattachées.

La Société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes

opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social
ou susceptibles d'en favoriser l'extension et le développement.».

Il n'y a plus d'affaires sur l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Coûts

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou pour lesquels il est responsable en raison de sa constitution, à environ EUR 1.500,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état

et demeure, ledit mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. FRATTER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/16201. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016115131/57.
(160088606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.

Alpes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.644.

EXTRAIT

La nouvelle adresse de l'Associé unique Alpes Holdings Limited est désormais la suivante:

- 3 

rd

 Floor, 62/64 Irish Town, GX11 1AA Gibraltar

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2016112197/13.
(160085970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

105648


Document Outline

AHead

Alpes S.à r.l.

ATRC SC

AviaRent Capital Management

Bati Expansion

Bionext

BMVA S.A.

BOC Frankfurt GP S.à r.l.

Cavalia International Sàrl

C. Prestige Investissements S.A.

EOS REAL ESTATE

Europe Property Fund IV Feeder S.A. SICAV-SIF

EventClearing Service S.à r.l.

HACA Partners S.à r.l.

Haplus

Harsco Luxembourg S.à r.l.

Healix Financial Corporation S.à r.l.

Hellaby S.A.

Henderson Diversified Income (Luxembourg) S.à r.l.

Holdicam

Holdun S.A.

Hotel &amp; Co II S.à r.l.

Hotel &amp; Co I S.à r.l.

IK Investment Partners AIFM

Immo-Ardennes s.à.r.l.

Immobilière du 3 Joseph II

Intermediate Finance Europe II SICAR

Inteuro S.A.

Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.àr.l.

JG, Jean GEORG S.à. r.l.

Keytrade Bank Luxembourg S.A.

L.C.L. S.A. - La Centrale Luxembourgeoise

Lux Ministore

Malva S.à r.l.

Minassara S.A.

NAEV Lime Street S.à r.l.

Redbrick Holding S.à r.l.

Silva &amp; Rolo S.à r.l.

Société Immobiliere Oestreicher

TAXolution Consulting S.à r.l.

Thor 11 Puerta del Sol S.à r.l.

Thor 16 Fuencarral S.à r.l.

UK Strategic Alternative Income Fund SLP

Universum F.O. Soparfi S.A.

Virelux Inspection Systems S.à r.l.

Yacuba S.A.