logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2194

22 juillet 2016

SOMMAIRE

Astorg VI Co-Invest Parkeon  . . . . . . . . . . . . . .

105306

Basler HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105272

Cardif Lux Vie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105274

Chimtex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105282

DREF SECURITIZATION SA  . . . . . . . . . . . .

105289

EVRAZ Greenfield Development S.A.  . . . . . .

105280

Familiar S.A., SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . .

105284

Global Bond Series III, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

105304

Global Bond Series I, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

105277

IPA Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105267

J.D. Farrods Group (Luxembourg) SA  . . . . . .

105267

JLC Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105268

J.Net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105267

Kalnis International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

105269

Kanter Consolidated Investments  . . . . . . . . . .

105268

Karabay Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105270

Kashevarmorneftegaz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

105268

Kebec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105270

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105269

Kiowatt Pellets S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105271

KM Licensing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105271

Kropz International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

105271

L'adresse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105272

Lappara Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105273

LaSalle AIFM Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

105274

Lauriston Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

105274

LB Immo Invest LUX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

105277

Lending Opportunities Holdings S.à r.l.  . . . . .

105275

L-GAM Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105272

LGT Fund Management (Lux) S.A.  . . . . . . . .

105278

LHF Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

105278

L'ilot S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105273

Locasierra S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105275

Logicor Topco II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105275

Logiver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105279

Logix XV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105276

Lombard Intermediation Services S.A. . . . . . .

105276

Lorac Investment Management S.à r.l.  . . . . . .

105277

Lucbeteiligung AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105280

Lucbeteiligung AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105279

Lucbeteiligung AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105280

LuxCo UK S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105277

Luxempart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105280

Luxonen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105281

Luxonen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105281

LVS II Lux VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105281

Mafrem Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105286

Magadanmorneftegaz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

105283

Magadanmorneftegaz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

105282

MainFirst SICAV II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105283

Meerapfel Management Services S.A.  . . . . . . .

105286

Melmal Newmedia Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105286

MGE Vancouver S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105287

MGE Vernon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105287

MGM Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

105288

Mistral Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105285

M.M Management s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

105282

Mont Cervin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105284

Moorea Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105284

Morninglight Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . .

105285

Mosaic Trading  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105285

MultiConcept Fund Management S.A.  . . . . . .

105281

Murex Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105288

Must Properties and Investments S.A.  . . . . . .

105288

My-Next-Home S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105288

NAC Luxembourg I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105303

Nashorn Logistics Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

105279

Nashorn Logistics Pledgeco S.à r.l  . . . . . . . . . .

105286

Nashorn Logistics Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

105287

Natural Le Coultre Luxembourg S.A. . . . . . . .

105289

Nemab S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105289

Network Plus Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

105302

Newluxco 4 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105275

105265

L

U X E M B O U R G

Nezu Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105302

NHC Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105304

NII International Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

105304

Nizi International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105305

Nizi Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105305

Novadelta Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105303

Nova Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105306

NuLand Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105303

OA Consulting, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105312

Ochtrup Phase 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105306

Onex BP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105305

Onex Jack's Holding Limited  . . . . . . . . . . . . . .

105306

Paris Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105311

Pavinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105312

Pilenga Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105312

PM-International AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105270

Polypin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105312

Psyrion Trading S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105312

SAF-Holland S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105269

Santander European Investments Lux S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105302

Triton Masterluxco 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

105276

Triton Masterluxco 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

105278

UBI SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105273

UBI SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105283

York Global Finance 51 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

105268

York Global Finance 52 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

105271

York Global Finance Offshore BDH (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105267

105266

L

U X E M B O U R G

IPA Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 182.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111749/9.
(160084984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

J.D. Farrods Group (Luxembourg) SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 53.195.

Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2016111757/12.
(160084732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

J.Net, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 193.526.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016111758/10.
(160084891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 150.769.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 3 mai 2016

En date du 3 mai 2016, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de révoquer Monsieur Jorrit CROMPVOETS, Monsieur Ramon VAN HEUSDEN et Luxembourg Corporation Com-

pany S.A. de leurs mandats de gérants de la Société avec effet au 9 mai 2016.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:
- Monsieur Andrew REID, gérant
- Monsieur Christian REYNTJENS, gérant
- Monsieur John FOSINA, gérant
- Monsieur Christophe AURAND, gérant
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant
- Madame Sonia BALDAN, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016112149/23.
(160084886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105267

L

U X E M B O U R G

JLC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 8, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 167.200.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111762/9.
(160084353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Kanter Consolidated Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 169.762.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016111765/10.
(160084707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Kashevarmorneftegaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 177.367.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Kashevarmorneftegaz S.à r.l
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2016111766/13.
(160084833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

York Global Finance 51 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 52.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.093.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 3 mai 2016

En date du 3 mai 2016, les associés de la Société ont pris la résolution suivante:
- de révoquer Monsieur Jorrit CROMPVOETS, Monsieur Ramon VAN HEUSDEN et Luxembourg Corporation Com-

pany S.A. de leurs mandats de gérants de la Société avec effet au 9 mal 2016.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:
- Monsieur Andrew REID, gérant
- Monsieur Christian REYNTJENS, gérant
- Monsieur John FOSINA, gérant
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant
- Madame Sonia BALDAN, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

York Global Finance 51 SARL
Signature

Référence de publication: 2016112151/22.
(160084887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105268

L

U X E M B O U R G

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.605.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 Mai 2016.

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings S.à.r.l.
Jack Mudde
<i>Gérant

Référence de publication: 2016111767/14.
(160084321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Kalnis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 61.873.

Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016111768/12.
(160084307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

SAF-Holland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.090.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société en date du 28

<i>avril 2016

Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 avril 2016, il a été décidé

de:

1. Nommer PricewaterhouseCoopers, société coopérative dont le siège social est situé au 2, rue Gerhard Mercator,

L-2182 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société, pour une période qui prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2016.

2.  Réélire,  en  qualité  d'administrateur  de  la  Société,  Madame  Anja  KLEYBOLDT,  résidant  au  38,  Brendelstrasse,

D-61381 Friedrichsdorf-Seulberg, Allemagne, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018.

3. Réélire, en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Martin KLEINSCHMITT, résidant au 57, Charlottens-

trasse,  D-10117  Berlin,  Allemagne,  pour  une  période  qui  prendra  fin  à  l'issue  de  l'assemblée  générale  annuelle  des
actionnaires pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018.

4.  Etendre  la  nomination,  en  qualité  d'administrateur  de  la  Société,  de  Madame  Martina  MERZ,  résidant  au  89,

Dorfstraße, D-78591 Durchhausen, Allemagne, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2016.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2016116473/28.
(160090434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2016.

105269

L

U X E M B O U R G

Karabay Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 52, rue du Fort Neipperg.

R.C.S. Luxembourg B 73.213.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016111769/10.
(160084405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Kebec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 145.156.

<i>Extrait de procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 1 

<i>er

<i> avril 2016

<i>Résolution:

Le Conseil a décidée de nommer, pour une période expirant lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2020:
- Madame Meriem Agrebi, demeurant professionnellement à 16 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, en tant qu'ad-

ministrateur en remplacement à Madame Virginie Derains.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Référence de publication: 2016111770/15.
(160084586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

PM-International AG, Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 15, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 46.582.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates der PM-INTERNATIONAL AG Aktiengesellschaft vom 20.

<i>Mai 2016

Der Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft PM-INTERNATIONAL AG (die „Gesellschaft“) hat am 20. Mai 2016 unter

anderem die folgenden Beschlüsse gefasst:

<i>Beschluss

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Herrn Christian STOCK als Delegierten zurtaglichen Geschäftsführung der

Gesellschaft abzuberufen.

<i>Beschluss

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig,
Herrn  Wolfgang  KLAER,  geboren  am  28.  Oktober  1977  in  SPEYER,  Deutschland,  beruflich  ansassig  in  L-5445

SCHENGEN; 15, Wäistrooss,

zum Delegierten zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit zu ernennen.

<i>Beschluss

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Zeichnungsberechtigung des neuen Delegierten für die Gesellschaft nach

folgendem Modus nichtstatutarisch zu erganzen:

„Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft des Weiteren im Rahmen der ihnen erteilten Vollmacht wirksam verp-

flichtet, entweder durch die gemeinsame Unterschrift eines Delegierten mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder die
gemeinsame Unterschrift mit einem anderen Delegierten.”

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 30. Mai 2016.

<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2016117433/29.
(160091698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2016.

105270

L

U X E M B O U R G

Kiowatt Pellets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7795 Bissen, 8, Op der Poukewiss.

R.C.S. Luxembourg B 167.858.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111772/9.
(160084421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

KM Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 180.150.

Les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016111774/11.
(160084484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Kropz International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 191.463.

Les comptes annuels de la société pour la période du 26 Septembre 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016111775/12.
(160084556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

York Global Finance 52 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 175.364.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 9 mai 2016

En date du 9 mai 2016, les associés de la Société ont pris la résolution suivante:
- de révoquer Monsieur Jorrit CROMPVOETS, Monsieur Ramon VAN HEUSDEN et Luxembourg Corporation Com-

pany S.A. de leurs mandats de gérants de la Société avec effet au 9 mai 2016.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:
- Monsieur Andrew REID, gérant
- Monsieur Christian REYNTJENS, gérant
- Monsieur John FOSINA, gérant
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant
- Madame Sonia BALDAN, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

York Global Finance 52 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016112152/22.
(160084867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105271

L

U X E M B O U R G

L-GAM Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 181.223.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 9 mai 2016

L'Associé Unique de la Société décide de renouveler le mandat de ERNST &amp; YOUNG, avec siège social au 35E, Avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (anciennement domicilié au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach), enregistré
sous le numéro B47771 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société
concernant l'audit des comptes annuels se clôturant le 30 septembre 2016.

A Luxembourg, le 13 mai 2016.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2016111776/17.
(160084769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

L'adresse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 32, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 175.070.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2016111777/13.
(160084441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Basler HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 74.225.900,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 117.112.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 13 mai 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer en tant que gérants de la Société
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de

Luxembourg;

- Monsieur Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-

Duché de Luxembourg.

Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant
Andreas Neugebauer, gérant
Heiko Dimmerling, gérant
Antonis Tzanetis, gérant
Mats Eklund, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Basler Holdco S.à r.l.

Référence de publication: 2016112273/24.
(160086138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

105272

L

U X E M B O U R G

L'ilot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 202.771.

<i>Extrait de la résolution du gérant unique en date du 26 avril 2016

Conformément à l'article 2.1 des statuts, le gérant unique a décidé de transférer le siège social de L'Ilôt des 4-6, rue de

la Loge, L-1945 Luxembourg, au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 26 avril 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2016111778/12.
(160084690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Lappara Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 182.363.

Les comptes annuels pour la période du 28 novembre 2013 (date de la constitution) au 31 décembre 2014 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2016111779/13.
(160084437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

UBI SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 36.503.

<i>Rectificatif des documents déposés en date du 27 mai 2016 sous la référence L160090192

L'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue le 26 mai 2016:
- a pris note de la démission en tant qu'administrateur de:
Monsieur Andrea PENNACCHIA ayant pour adresse professionnelle 5, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan, en date du

28 juillet 2015

Madame Suzanne ROHE ayant pour adresse professionnelle 5, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan, en date du 25 mars

2016

- a décidé de ratifier la cooptation de:
Monsieur Andrea GUIDONI ayant pour adresse professionnelle 5, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan
Monsieur Marco PASSAFIUME ALFIERI ayant pour adresse professionnelle 5, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan
en sa qualité d'administrateur pour une période de deux ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se

tiendra en 2018.

- a pris note que le mandat de:
Monsieur Sergio PACI ayant pour adresse professionnelle 1, Via Roentgen, Bâtiment Università Commerciale Luigi

Bocconi, I-20136 Milan

en sa qualité d'administrateur prend fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018.
- a décidé de renouveler le mandat de Deloitte Audit, RCS B-67 895, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en sa

qualité de réviseur d'entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2017.

<i>Pour UBI SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2016117585/29.
(160091537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2016.

105273

L

U X E M B O U R G

Lauriston Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 203.257.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 17 mai 2016

L’associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Karl Heinz Horrer de ses fonctions du gérant de la Société avec effet au 17 mai 2016;
- de nommer John Lhoest, né le 12 août 1984 à Huy, Belgique et résidant professionnellement au 23, rue Aldringen, L

- 1118 Luxembourg, aux fonctions du gérant de la Société avec effet au 17 mai 2016 et ce pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Référence de publication: 2016111780/15.
(160084323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

LaSalle AIFM Europe S.à r.l., Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 157.540.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111782/9.
(160085185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Cardif Lux Vie, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23-25, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 47.240.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle de la société prises en date du 25 avril 2016

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 25 avril 2016 que:
- Monsieur Jacques FAVEYROL a été élu administrateur de catégorie A avec pouvoir de signature A jusqu'à l'assemblée

générale annuelle délibérant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.

- Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle délibérant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2016:

Monsieur Fabrice BAGNE
Monsieur Stanislas CHEVALET
Monsieur Eric BEQUET
Administrateurs de catégorie A avec pouvoir de signature A
Monsieur Carlo THILL
Monsieur Hubert MUSSEAU
Monsieur Jean-Claude SCHNEIDER
Administrateur de catégorie B avec pouvoir de signature B
Monsieur Emmanuel VAN GRIMBERGEN
Monsieur Christophe BOIZARD
Monsieur Hans PLETINCKX
Administrateurs de catégorie C avec pouvoir de signature C
- La société Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560

rue de Neudorf, RC.S. Luxembourg B 67.895 a été nommée comme réviseur des comptes jusqu'à l'assemblée générale
annuelle délibérant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Cardif Lux Vie

Référence de publication: 2016113407/30.
(160086634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

105274

L

U X E M B O U R G

Lending Opportunities Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 184.236.

Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant de votre

société et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 décembre 2015.

Alexandre Taskiran.

Référence de publication: 2016111783/10.
(160085126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Locasierra S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 72.468.

Les comptes annuels au 30 novembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111784/9.
(160084340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Logicor Topco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 182.917.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du I5 avril 2016 que la société BRE/Management 7

S.A. a démissionné en tant que gérant (geschäftsführer) de la Société avec effet au 15 avril 2016.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société Logicor Europe Management S.A., société anonyme de

droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 205.393, en tant que gérant (geschäftsführer) de la Société, avec
effet au 15 avril 2016 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société Logicor Europe Management S.A. en qualité de gérant (geschäftsführer).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2016111786/20.
(160085095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Newluxco 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 138.081.

<i>Extrait de procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 1 

<i>er

<i> avril 2016

<i>Résolution:

Le Conseil a décidé de nommer, pour une période expirant lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2020:
- Madame Meriem Agrebi, demeurant professionnellement à 16 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, en tant qu'ad-

ministrateur en remplacement à Madame Virginie Derains.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Référence de publication: 2016111871/15.
(160084606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105275

L

U X E M B O U R G

Logix XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 170.629.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016111787/10.
(160084925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.671.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 27 avril 2016 au siège social de la société

L'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes en date du 27 avril 2016:
Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé comme suit:

Administrateurs

Fin de mandat

1. Florent Albert, président

AGO 2017

2. Dominique Perilleux

AGO 2017

3. Jurgen Vanhoenacker

AGO 2017

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Audrey Coque

Référence de publication: 2016111788/17.
(160084344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Triton Masterluxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.235,60.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.926.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 13 mai 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg en tant que gérant de catégorie A de la Société et Michiel Kramer et

Heiko Dimmerling en tant que gérants de catégorie B de la Société

2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de Luxem-

bourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société;

- Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-Duché de

Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société;

- Monique Bachner, demeurant professionnellement 8, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duché de Luxem-

bourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société

Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant de catégorie A
Andreas Neugebauer, gérant de catégorie B
Monique Bachner, gérant de catégorie B
Antonis Tzanetis, gérant de catégorie B
Mats Eklund, gérant de catégorie A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Triton Masterluxco 3 S.à r.l.

Référence de publication: 2016113213/27.
(160086026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

105276

L

U X E M B O U R G

Lorac Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 137.635.

Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016111790/12.
(160084758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

LuxCo UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 73.330.

Les comptes annuels au 30 novembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111796/9.
(160084336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

LB Immo Invest LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 107.783.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111802/9.
(160084382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Global Bond Series I, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.181.

Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du

11 mai 2016:

- acceptation de la démission de Madame Marketa Stranska en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 4 mai

2016;

- nomination, en tant que nouvel administrateur de la Société, de Monsieur Domenico Latronico, né le 14 septembre

1969 à Potenza, Italie et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet
au 4 mai 2016. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020;

-  confirmation  que  le  conseil  d'administration  de  la  Société  est  depuis  le  4  mai  2016  composé  des  administrateurs

suivants:

* Monsieur Fabrice Rota;
* Monsieur Shehzaad Atchia; et
* Monsieur Domenico Latronico.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2016.

<i>Pour la Société
Domenico Latronico
<i>Administrateur

Référence de publication: 2016112587/24.
(160085939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

105277

L

U X E M B O U R G

LGT Fund Management (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 159.463.

<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 5 avril 2016

- Reconduction des mandats des administrateurs à savoir Madame Brigitte ARNOLD, née le 17/11/1969 à Triengen LU

(Suisse) et demeurant au 19, Rebackerstrasse CH-8810 HORGEN (Suisse); Monsieur Roger GAUCH, né le 26/07/1966 à
Niederwil AG (Suisse) et demeurant au 17, Fürst-Johannes-Strasse CH-9490 VADUZ (Lichtenstien); Monsieur André
SCHMIT, né le 13/12/1951 à Ettlebrück et demeurant au 28, rue Lehberg L-9124 Schieren ainsi que le mandat du Réviseur
d'entreprise agréé, à savoir la société PriceWaterhouseCoopers, ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator à L-2182
Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le n° B 65477, jusqu'à
l'Assemblée Générale Annuelle de 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
LGT FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.

Référence de publication: 2016111805/18.
(160084872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

LHF Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 163.892.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111806/9.
(160085035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Triton Masterluxco 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,08.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 177.725.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 13 mai 2016, ont décidé, avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Thomas Sonnenberg en tant que gérant de catégorie A de la Société et Michiel Kramer et

Heiko Dimmerling en tant que gérants de catégorie B de la Société

2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- John David Sutherland, demeurant professionnellement 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Grand-Duché de Luxem-

bourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société;

- Andreas Neugebauer, demeurant professionnellement 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-Duché de

Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société;

- Monique Bachner, demeurant professionnellement 8, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société

Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
John David Sutherland, gérant de catégorie A
Andreas Neugebauer, gérant de catégorie B
Monique Bachner, gérant de catégorie B
Antonis Tzanetis, gérant de catégorie B
Mats Eklund, gérant de catégorie A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Triton Masterluxco 4 S.à r.l.

Référence de publication: 2016113214/27.
(160086025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

105278

L

U X E M B O U R G

Logiver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 87.518.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 17 mars 2016

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs sortant pour un terme annuel, leur mandat expirant lors

de l'assemblée générale de 2017:

- Monsieur André VERDICKT, ingénieur, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling;
- Monsieur Jean-Jacques VERDICKT, ingénieur, demeurant à B-1428 Braine-l'Alleud, 16, rue Comte Jacques de Meeus

(Belgique);

- Monsieur Daniel VAN HOVE, ingénieur, demeurant à L-1314 Luxembourg, 6, rue G. Capus.
L'assemblée  décide  de  nommer  à  la  fonction  d'administrateur,  jusqu'à  l'assemblée  générale  qui  se  tiendra  en  2017,

Monsieur Gaëtan HERINCKX, maître en Business Engineering, demeurant à B-1150 Bruxelles, 196, avenue de Tervueren
(Belgique).

L'assemblée décide de nommer Monsieur Alain GEORGES, docteur en droit, demeurant à L-1457 Luxembourg, 72A,

rue des Eglantiers, à la fonction de Président Honoraire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2016111807/21.
(160084528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Lucbeteiligung AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 61.325.

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 26 avril 2016.

FMS SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Michel Di BENEDETTO
<i>Représentant permanent

Référence de publication: 2016111811/13.
(160084452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Nashorn Logistics Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.329.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 15 avril 2016 que la société BRE/Management 7

S.A. a démissionné en tant que gérant (geschäftsführer) de la Société avec effet au 15 avril 2016.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société Logicor Europe Management S.A., société anonyme de

droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 205.393, en tant que gérant (geschäftsführer) de la Société, avec
effet au 15 avril 2016 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société Logicor Europe Management S.A. en qualité de gérant (geschäftsführer).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2016111865/20.
(160085092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105279

L

U X E M B O U R G

Lucbeteiligung AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 61.325.

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2016.

Tazia BENAMEUR.

Référence de publication: 2016111812/9.
(160084452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Lucbeteiligung AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 61.325.

Par la présente, nous vous informons de notre décision de démissionner en tant que délégué à la gestion journalière de

votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 26 avril 2016.

BPH FINANCE S.A.

Référence de publication: 2016111813/11.
(160084452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Luxempart, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 27.846.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111819/9.
(160084764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

EVRAZ Greenfield Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 13, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 168.803.

Les décisions suivantes ont été approuvées et ratifiées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société

qui s'est tenue en date du 20 mai 2016:

- Confirmation que le conseil d'administration de la Société est composé par les administrateurs suivants:
* Monsieur Alexander Gehrke
* Monsieur Giacomo Baizini
* Monsieur Kurt Nauer
pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018
- Renouvellement du mandat d'Ernst &amp; Young en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une période

se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

- Renouvellement du mandat de Madame Natalia Gulyaeva en tant que commissaire aux comptes de la Société pour

une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Il est à noter que l'adresse professionnelle du commissaire aux comptes de la Société Madame Natalia Gulyaeva est

désormais la suivante: 13, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2016.

<i>Pour la Société
Giacomo Baizini
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2016113530/25.
(160086744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

105280

L

U X E M B O U R G

Luxonen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 30.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111823/9.
(160084811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Luxonen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 30.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111824/9.
(160084812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

LVS II Lux VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 178.079.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Référence de publication: 2016111826/10.
(160084626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

MultiConcept Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 98.834.

L'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 9 mai 2016 a décidé de renouveler les mandats des administrateurs pour

une nouvelle période d'une an jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra
en 2017.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale

ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017:

- Thomas Federer, Membre du Conseil d'Administration
231 Uetlibergstr., CH-8045 Zurich
- Patrick Tschumper, Membre du Conseil d'Administration
231 Uetlibergstr., CH-8045 Zurich
- Daniel Siepmannn, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Cindyrella Amistadi, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Robert Archbold, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
KPMG Luxembourg S.à r.l., sise à 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été réélu comme réviseur d'entreprises, et

ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MultiConcept Fund Management S.A.

Référence de publication: 2016115519/26.
(160089217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.

105281

L

U X E M B O U R G

M.M Management s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 40, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 150.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016111828/10.
(160085202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Magadanmorneftegaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 177.369.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 April 2016.

Magadanmorneftegaz S.à r.l.
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2016111830/13.
(160084885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Chimtex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 19, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 23.528.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 23 mai 2016

1. Acceptation de la démission de Monsieur Geert DIRKX, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique) et demeurant

professionnellement au 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, de son poste d’administrateur unique de la société avec
effet immédiat;

2. Nomination de Monsieur Geert DIRKX, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique) et demeurant professionnellement

au 19 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, au poste d’administrateur B de la société avec effet immédiat et pour une
période qui se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021;

3. Nomination de Monsieur Thomas DEWAELE, né le 14 juin 1986 à Kortrijk (Belgique) et demeurant professionnel-

lement au 19 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, au poste d’administrateur A et de délégué à la gestion journalière
de la société avec effet immédiat et pour une période qui se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2021;

4. Nomination de Monsieur Marc DEWAELE, né le 17 septembre 1955 à Waregem (Belgique) et demeurant profes-

sionnellement  au  19  rue  du  Commerce,  L-1351  Luxembourg,  au  poste  d’administrateur  A  et  Président  du  Conseil
d’Administration de la société avec effet immédiat et pour une période qui se terminera lors de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2021;

5. L’assemblée note que suite à la décision du Service de la Topographie et de la Géomatique de la Ville de Luxembourg,

l’adresse du siège social de la société est modifiée du 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg au 19 rue du Commerce,
L-1351 Luxembourg.

6. L’assemblée note la nouvelle adresse du Commissaire aux Compte qui est dorénavant le 19 rue du Commerce, L-1351

Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2016.

Certifié conforme
Chimtex S.A.
Représenté par Geert DIRKX

Référence de publication: 2016116046/31.
(160090514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2016.

105282

L

U X E M B O U R G

Magadanmorneftegaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 177.369.

<i>Extrait des résolutions des associés du 25 mars 2016

En date du 25 mars 2016 les associés de la Société ont décidé de:
- remplacer Monsieur Victor Obmetko, gérant de catégorie A, par Monsieur Nikolay Malyshev, citoyen Russe, né le 8

octobre 1953 en URSS et demeurant au 53, Kastanaevskaya street, appartement 140, Moscou, Fédération de Russie, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- remplacer Terje Dahl, gérant de catégorie B, par Madame Hedda Felin, citoyenne Norvégienne, née le 6 mars 1978 à

Oslo et demeurant au 9, Plataveien, 1369 Stabekk, Norvège, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Luxembourg, le 19 mai 2016.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2016111831/17.
(160085180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

MainFirst SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 197.763.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111832/9.
(160084333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

UBI SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 36.503.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 26 mai 2016:
- a pris note de la démission en tant qu'administrateur de:
Monsieur Andrea PENNACCHIA ayant pour adresse professionnelle 5, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan, en date du

28 juillet 2015

Madame Suzanne ROHE ayant pour adresse professionnelle 5, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan, en date du 25 mars

2016

- a décidé de ratifier la cooptation de:
Monsieur Andrea GUIDONI ayant pour adresse professionnelle 5, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan
Monsieur Marco PASSAFIUME ALFIERI ayant pour adresse professionnelle 5, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan
en sa qualité d'administrateur pour une période de deux ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se

tiendra en 2018.

- a pris note que le mandat de:
Monsieur Sergio PACI ayant pour adresse professionnelle 1, Via Roentgen, Bâtiment Università Commerciale Luigi

Bocconi, I-20136 Milan

en sa qualité d'administrateur prend fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018.
- a décidé de renouveler le mandat de Deloitte Audit, RCS B-67 895, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en sa

qualité de réviseur d'entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2017.

<i>Pour UBI SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2016116550/28.
(160090192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2016.

105283

L

U X E M B O U R G

Mont Cervin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 199.366.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

C.W. Karsten
<i>Gérante

Référence de publication: 2016111840/12.
(160084666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Moorea Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.927.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 28 avril 2016

L'assemblée générale annuelle des actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine as-

semblée générale annuelle qui se tiendra en Avril 2017, les mandats d'Administrateurs de Messieurs Alexandre CEGARRA,
Serge DAHM, Mathieu VEDRENNE, Stéphane DE VAULX.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine as-

semblée générale annuelle qui se tiendra en Avril 2017, Deloitte Audit S.à.r.l. en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé,
résidant professionnellement au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 30 avril 2015

Démission de M. Brendan ROBIN de ses fonctions d'administrateur du conseil d'administration
L'assemblée générale annuelle des actionnaires prends note de la démission du mandat d'Administrateur de Messieur

Brendan ROBIN de sa fonction d'Administrateur du conseil d'administration avec effet au 30 avril 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111841/19.
(160084679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Familiar S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 160.547.

Les administrateurs ont pris la résolution suivante:
- Le conseil d'administration décide de remplacer le commissaire aux comptes Grant Thornton Lux Audit S.A. par le

reviseur d'entreprises agréé Artemis Audit &amp; Advisory S.A.R.L. ayant son siège social 25 A, Boulevard Royal a L-2449,
avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2015, et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Selon la décision de gestion de l'entreprise de 29 May 2015, Mrs. Agnieszka Anna Plenikowska a été nommé comme

un Administrateur de Familiar S.A., SICAV-SIF avec effet rétroactif au 18 septembre 2015.

Agnieszka Anna Plenikowska
Né le 17/11/1972
Fonction: Administrateur
Adresse professionnelle:
rue Zytnia 13/31
01-014 Varsovie
Pologne
Durée de mandat: indéterminée
Date de nomination: 18/09/2015

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016112547/23.
(160085783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

105284

L

U X E M B O U R G

Morninglight Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: IDR 1.843.040.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 171.195.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

<i>Pour Morninglight Investments S.à.r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016111843/11.
(160084931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Mosaic Trading, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 107.239.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 19 avril 2016 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L'assemblée a reconduit les mandats d'administrateurs de:
- M. Francesco Ilardi, 60 route des Acacias - CH -1211 Genève
- M. Nicolas Tschopp, 60 route des Acacias - CH -1211 Genève
- M Justin Egan, 6B route de Trèves - L-2633 Senningerberg
- M Thomas Nummer, 6B route de Trèves - L-2633 Senningerberg
- M Anil Kumar Singh, 6B route de Trèves - L-2633 Senningerberg
pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2017.
2. L'Assemblée a reconduit le mandat de Deloitte Audit S.à.r.l à la fonction de «réviseur d'entreprises agréé» pour une

période d'une année jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2017.

Référence de publication: 2016111844/18.
(160084713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Mistral Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 106.491.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20 mai 2016

1/ Le siège social de la société est transféré du 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,

L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.

2/  L'assemblée  a  accepté  la  démission  de  Messieurs  Marco  LAGONA  et  Samir  EL  MOUSSAOUI  de  leur  mandat

d'administrateur de la société.

3/ Sont nommés nouveaux administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2019:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 1, rue Jean

Piret, L-2350 Luxembourg.

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement 1, rue Jean Piret, L-2350

Luxembourg.

4/ L'assemblée a accepté la démission de EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) SARL de son mandat

de commissaire.

5/ Est nommée nouveau commissaire, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2019:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 1, rue Jean Piret, L - 2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2016.

Référence de publication: 2016113806/25.
(160086599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2016.

105285

L

U X E M B O U R G

Mafrem Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 187.698.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111846/9.
(160084878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Meerapfel Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV.

R.C.S. Luxembourg B 119.470.

Les adresses des administrateurs suivants ont été modifiées:
Monsieur Jeremiah MEERAPFEL 8a,clos de la Commanderie B-1410 Waterloo
Monsieur Joshua MEERAPFEL
56, clos de Berine
B-1410 Waterloo
Madame Ginette BRZEZINSKI
8, rue Charles IV - Résidence Georges V
L-1309 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111847/16.
(160084696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Melmal Newmedia Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Z.A.R.E Ilot Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 181.187.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111849/9.
(160084828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Nashorn Logistics Pledgeco S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.320.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 15 avril 2016 que la société BRE/Management 7

S.A. a démissionné en tant que gérant (geschäftsführer) de la Société avec effet au 15 avril 2016.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société Logicor Europe Management S.A., société anonyme de

droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 205.393, en tant que gérant (geschäftsführer) de la Société, avec
effet au 15 avril 2016 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société Logicor Europe Management S.A. en qualité de gérant (geschäftsführer).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2016111866/20.
(160085108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105286

L

U X E M B O U R G

MGE Vancouver S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 169.013.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 17 mai 2016

1. Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Monsieur Douwe Terpstra, administrateur de sociétés, né le 31 octobre 1958 à Leeuwarden, Pays-Bas, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indé-
terminée.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour MGE Vancouver S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016111852/17.
(160084602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

MGE Vernon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 121.951.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 17 mai 2016

1. Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Monsieur Douwe Terpstra, administrateur de sociétés, né le 31 octobre 1958 à Leeuwarden, Pays-Bas, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indé-
terminée.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MGE Vernon S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016111853/17.
(160084601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Nashorn Logistics Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.276.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 15 avril 2016 que la société BRE/Management 7

S.A. a démissionné en tant que gérant (geschäftsführer) de la Société avec effet au 15 avril 2016.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société Logicor Europe Management S.A., société anonyme de

droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 205.393, en tant que gérant (geschäftsführer) de la Société, avec
effet au 15 avril 2016 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société Logicor Europe Management S.A. en qualité de gérant (geschäftsführer).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2016111867/20.
(160085107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105287

L

U X E M B O U R G

Murex Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 164.673.

Les comptes annuels au 30.09.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111862/9.
(160084289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Must Properties and Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 122.007.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111863/9.
(160084302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

My-Next-Home S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Waïstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 134.651.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2016111864/10.
(160084996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

MGM Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 196, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 186.670.

EXTRAIT

Il résulte d’une cession de parts signée par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 10 novembre 2015, acte enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 novembre 2015, 2LAC/2015/26338, aux
droits de 12.- € que:

- Monsieur Nuno Miguel MATEUS MARQUES, né le 19 septembre 1975 à Gloria Aveiro (Portugal), demeurant au 9,

Rue Arthur Thinnes, L-3919 Mondercange a cédé cinquante-deux (52) de ses parts sociales qu’il possède dans la Société
«MGM Constructions S.à r.l.» avec siège social à L-4451 Belvaux, 196, route d'Esch et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.670 à la société Building Evolution S.A., une société
anonyme luxembourgeoise ayant son siège social au 196, route d’Esch, L4451 Belvaux, enregistre auprès du R.C.S. Lu-
xembourg sous le numéro B179.917.

- Suite à la cession qui précède, les parts sociales dans la Société seront désormais détenues comme suit:

ASSOCIES

NOMBRE

DE PARTS

SOCIALES

Monsieur Nuno Miguel MATEUS MARQUES, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Building Evolution S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2016.

Référence de publication: 2016115541/26.
(160089438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.

105288

L

U X E M B O U R G

Natural Le Coultre Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2315 Senningerberg, Parishaff.

R.C.S. Luxembourg B 164.567.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111868/9.
(160084850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Nemab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.536,00.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 153.353.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 28 avril 2016, les gérants ont pris connaissance de la décision de la ville de

Luxembourg de modifier le nom et le code postal de la rue Robert Stümper.

En conséquence, le siège social de la Société est au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2016.

Référence de publication: 2016111869/13.
(160084392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

DREF SECURITIZATION SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 206.367.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of May.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxemburg.

There appeared

1) Gemini Holdings (Guernsey) Limited, a limited company, established under the laws of Guernsey, with registered

office at Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, Channel Island GY4 6AD, and registered with the
Guernsey Registry under number 59726,

duly represented by Mr. Kai Gräff with professional address at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
by virtue of a proxy given on 13 May 2016;
2) Internos Global Investments Limited, a limited company, established under the laws of England and Wales, with

registered office at 65 Grosvenor Street, London W1K 3JH, United Kingdom, and registered with the Registrar of Com-
panies House for England and Wales under number 07982302,

duly represented by Mr. Kai Gräff with professional address at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
by virtue of a proxy given on 16 May 2016;
3) Somerston GSH Limited, a limited company, established under the laws of Jersey, with registered office at 45 Es-

planade, St Helier, Jersey, JE2 3QB, and registered with the Jersey Financial Services Companies Registry under number
117820, duly represented by Mr. Kai Gräff with professional address at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

by virtue of a proxy given;
each referred to as a Shareholder and collectively referred to as the Shareholders.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its capacity as representative of the Shareholders, has requested the officiating notary

to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "DREF

SECURITIZATION SA" (the Company) qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning
of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended (the Securitisation Act 2004).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dis-

solved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder or, as the case
may be, of any of the shareholders.

105289

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand

Duchy of Luxembourg (Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the same municipality by a resolution
of the board of directors of the Company (the Board).

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are im-

minent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the

manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 22 below.

Art. 4. Corporate objects. The corporate objects of the Company are to enter into, perform and serve as a vehicle for

any securitisation transactions as permitted under the Securitisation Act 2004.

The Company may acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding or

ownership of claims, receivables and/or other goods, either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks
relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third
parties, by issuing securities (valeurs mobilières) of any kind whose value or return is linked to these risks. The Company
may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, structured deposits, receivables and/or other goods,
structured products relating to commodities or assets, by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by
binding itself in any other way. The method that will be used to determine the value of the securitised assets will be set out
in the relevant issue documents entered into by the Company.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, proceed, so far as they relate to securitisation

transactions, to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of
participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by pur-
chase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds,
debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by
Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and exchangeable or convertible securities), structured pro-
ducts relating to commodities or assets (including debt or equity securities of any kind), receivables, claims or loans or
other credit facilities (and the agreements relating thereto) as well as all other types of assets, and (iii) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above) in accordance with the provisions of the relevant issue documentation.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004 and for as long as it is necessary to facilitate the

performance of its corporate objects, borrow in any form and enter into any type of loan agreement. It may issue notes,
bonds (including exchangeable or convertible securities and securities linked to an index or a basket of indices or shares),
debentures, certificates, shares, beneficiary shares or parts, warrants and any kind of debt or equity securities, including
under one or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or
issues of securities, within the limits of the Securitisation Act 2004 and provided such lending or such borrowing relates
to securitisation transactions, to its subsidiaries or affiliated companies or to any other company.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, give guarantees and grant security over its assets

in order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of those assets or for the benefit of investors (including
their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity participating in a securitisation transaction of the Company.
The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets or transfer its
assets for guarantee purposes, unless permitted by the Securitisation Act 2004.

The  Company  may  enter  into,  execute  and  deliver  and  perform  any  swaps,  futures,  forwards,  derivatives,  options,

repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to facilitate
the performance of the Company's corporate objects. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instru-
ments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004 and in accordance with the provisions of the relevant

issue documentation of the securities, assign or arrange for the assignment of the underlying assets and risks which guarantee
the rights of the relevant investors.

The Board is entitled to create one or more compartments (referencing the assets of the Company relating to an issue

by the Company of securities), in each case, corresponding to a separate part of the Company's estate. The Company may
appoint one or more fiduciary representatives as described in articles 67 to 84 of the Securitisation Act 2004.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate

objects of the Company shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided that it
is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

105290

L

U X E M B O U R G

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects to the largest extent
permitted under the Securitisation Act 2004.

Art. 5. Share capital.  The  subscribed  share  capital  is  set  at  EUR  31,000  (thirty-one  thousand  euros)  consisting  of

3,100,000 (three million one hundred thousand) ordinary shares in registered form with a par value of EUR 0.01 (one Euro
cent) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 22 below.

Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be

available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or
elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on each such share, and the transfer of shares and
the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee
or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims
provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The  Company  may  also  accept  as  evidence  of  transfer  other  instruments  of  transfer  evidencing  the  consent  of  the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Debt securities. Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may, under

no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).

Art. 9. Meetings of the shareholders of the Company. In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes

all powers conferred on the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting
shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one
shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the

General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the

registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in
the convening notice of the meeting, on the third Wednesday in June of each year at 11:30 a.m. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional cir-

cumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and
(iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

Art. 10. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum provided for by law

shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed

by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing. Copies of written

proxies may be transmitted either in original, by telefax, cable, telegram, telex or by e-mail.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being

duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (i) the name (including the first name), address and the signature of the
relevant shareholder, (ii) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as
set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda.
The original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

105291

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Management. The Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need

not be shareholders of the Company. The members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and
shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a member of the Board (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as member of the Board in accor-
dance  with  article  51bis  of  the  Luxembourg  act  dated  10  August  1915  on  commercial  companies,  as  amended  (the
Companies Act 1915).

The directors shall be elected by the General Meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/
or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may

elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting.

Art. 12. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman
will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other
members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant
meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting

which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if

they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing. Such written consent of each member of the Board may be transmitted either in
original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail. Separate written notice shall not be required for meetings that are held
at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing another director as his or her

proxy. Such appointment may be transmitted in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail.

One member of the Board may represent one prevented member at a meeting of the Board and there must always be at

least two members who are either present in person or who assist at such meeting by way of conference call, video conference
or any means of communication that complies with the requirements set forth in the next following paragraph, participate
in a meeting of the Board.

Any director may participate in a meeting of the Board, and will be considered as having been personally present at

such meeting, by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors
attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii)
the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented

at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such
meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist

of one or more documents containing the resolutions, signed by each director manually. The date of such resolution shall
be the date of the last signature.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman

or a member of the Board who presided at such meeting and shall be held at the Company’s registered office.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman or any two members of the Board.

Art. 14. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts

of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of the assets
of the Company in accordance with the Securitisation Act 2004 and the relevant issue documentation. All powers not
expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the
Board.

Art. 15. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder

or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.

105292

L

U X E M B O U R G

The Board may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for

any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act
with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member
of the board of directors of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions

at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures.  The  Company  shall  be  bound  towards  third  parties  in  all  matters  (including  the  daily

management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board, or (ii) the joint signatures of any persons or sole
signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such
power.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which

the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote
upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following
annual General Meeting.

The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course

of business of the Company and which are entered into on arm's length terms.

Art. 18. Statutory Auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors

(réviseurs d'entreprises agréés). The statutory auditor(s) shall be appointed by the Board in accordance with the Securiti-
sation Act 2004. The Board will determine their number, their remuneration and the term of their office.

Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31

December of each year.

Art. 20. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may, in its

sole discretion, decide to pay dividends from time to time, as it believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and

times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within
the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 21. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted  in  the  manner  required  for  amendment  of  these  Articles,  as  prescribed  in  article  22  below.  In  the  event  of  a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 22. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject

to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

Art. 23. Segregation of assets. If as of any payment date of the assets relating to a compartment (including a hedging

agreement entered into by the Company in connection with a compartment) the total amount of monies received under the
assets of that compartment exceeds the payments to be made by the Company under the same compartment, the Board may
use the excess amount to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims cannot be allocated to a
particular compartment.

The assets allocated to a compartment are exclusively available to (1) the investors in that compartment (the Investors),

(2) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment
and who are provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the Transaction
Creditors), (3) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that
compartment and who are not provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the
Compartment-Specific Claims Creditors and, together with the Transaction Creditors, the Creditors) and (4), subject to the
provisions of the next following paragraph, the creditors whose claims have not arisen in connection with the creation,
operation or liquidation of a compartment and who have not waived their recourse to the assets of any compartment of the
Company (the Non Compartment-Specific Claims Creditors).

105293

L

U X E M B O U R G

The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the Company, on a half year basis

in arrears, to all the compartments, on an equal basis and pro rata temporis for compartments created within such half year,
where the relevant issue documentation expressly authorises Non Compartment-Specific Claims Creditors to have recourse
against the assets allocated to such compartments. Such right of a Non Compartment-Specific Claims Creditor against a
compartment are hereinafter referred to as the Pro Rata Rights.

The Investors and the Creditors acknowledge and accept that once all the assets allocated to the compartment under

which they have invested or in respect of which their claims have arisen, have been realised, they are not entitled to take
any further steps against the Company to recover any further sums due and the right to receive any such sum shall be
extinguished. Each Non Compartment-Specific Claims Creditor acknowledges and accepts that once all the assets allocated
to a compartment in respect of which it has Pro Rata Rights, have been realised, it is not entitled to take any further steps
against the Company to recover such Pro Rata Rights and the right to receive any sum in respect of the Pro Rata Rights
shall be extinguished.

The Compartment-Specific Claims Creditors and the Non Compartment-Specific Claims Creditors expressly accept,

and shall be deemed to have accepted by entering into contractual obligations with the Company, that priority of payment
and waterfall provisions will be included in the relevant issue documentations and they expressly accept, and shall be
deemed to have accepted the consequences of such priority of payments and waterfall provisions.

The rights of the shareholders of the Company are limited to the assets of the Company which are not allocated to a

compartment.

Art. 24. Prohibition to petition for bankruptcy of the Company or to seize the assets of the Company. In accordance

with article 64 of the Securitisation Act 2004, any Investor in, and any Creditor and shareholder of, the Company and any
person which has entered into a contractual relationship with the Company (the Contracting Party) agrees, unless expressly
otherwise agreed upon in writing between the Company and the Investor, the Creditor or the Contracting Party, not to (1)
petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation proceedings against
the  Company  or  (2)  seize  any  assets  of  the  Company,  irrespective  of  whether  the  assets  in  question  belong  to  (i)  the
compartment in respect of which the Investor has invested or in respect of which the Creditor or the Contracting Party have
contractual rights against the Company, (ii) any other compartment or (iii) the assets of the Company which have not been
allocated to a compartment (if any).

Art. 25. Subordination. Any claims which the shareholders of the Company may have against the Company (in such

capacity) are subordinated to the claims which any creditors of the Company (including the Creditors) or any investors in
the Company (including the Investors) may have.

The Investors accept and acknowledge that their rights under a compartment may be subordinated to the rights of other

Investors under, and/or Creditors of, the same compartment.

Art. 26. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act 1915 and the Securitisation Act 2004.

<i>Transitory provisions

The first business year begins today and ends on 31 December 2016.
The first annual General Meeting will be held in 2017.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that the 3,100,000 (three

million one hundred thousand) shares representing the total share capital of the Company will be subscribed as follows:

Shareholder

Shares

Value

Gemini Holdings (Guernsey) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,204,875 22,048.75 €
Internos Global Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244,125 2,441.25 €

Somerston GSH Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

651,000 6,510.00 €

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100,000 31,000.00 €

All these shares have been paid up by the Shareholders to an extent of 100% (one hundred per cent) by payment in cash,

so that the sum of EUR 31,000 (thirty-one thousand euros) paid by the Shareholders is from now on at the free disposal of
the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26, 26-3 und 26-5 of the Companies

Act 1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms
that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 3,000.-.

105294

L

U X E M B O U R G

<i>Resolutions of the general meeting of shareholders

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. the number of directors is set at three (3) directors;
2. the following persons are appointed as directors:
- Mrs. Gisèle Galhano, with professional address at 151, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- Mr. Stéphane Weyders, with professional address at 151, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg; and
- Mr. Fabien Rossignol-Burgos Leon, with professional address at 151, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
3. that the terms of office of the members of the Board will expire after the annual General Meeting of the year 2019;

and

4. that the address of the registered office of the Company is at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between English and the German versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and

residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechzehn, am zwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Gemini Holdings (Guernsey) Limited, eine limited company, gegründet nach dem Recht von Guernsey, mit Gesell-

schaftssitz in Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, Channel Island GY4 6AD, und eingeschrieben im
Guernsey Registry unter Nummer 59726,

hier wirksam vertreten durch Herrn Kai Gräff geschäftlich ansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht vom 13. Mai 2016;
2) Internos Global Investments Limited, eine limited company, gegründet nach dem Recht von England und Wales, mit

Gesellschaftssitz in 65 Grosvenor Street, London W1K 3JH, United Kingdom, und eingeschrieben im Register Companies
House für England und Wales unter Nummer 07982302,

hier wirksam vertreten durch Herrn Kai Gräff geschäftlich ansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht vom 16. Mai 2016;
3) Somerston GSH Limited, eine limited company, gegründet nach dem Recht Jersey, mit Gesellschaftssitz in 45 Es-

planade, St Helier, Jersey, JE2 3QB, und eingeschrieben im Jersey Financial Services Companies Register unter Nummer
117820,

hier wirksam vertreten durch Herrn Kai Gräff geschäftlich ansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht;
jeder einzelne ein Aktionär und zusammen die Aktionäre.
Die genannten Vollmachten bleiben nach ihrer Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Person und den un-

terzeichneten Notar zum Zweck der gleichzeitigen Vorlage bei den Registrierungsbehörden mit dieser notariellen Urkunde
verbunden.

Die erschienene Partei, als Vertreter der Aktionäre handelnd, hat den Notar beauftragt, die folgende Gesellschaftssatzung

(die Satzung) eines Unternehmens aufzunehmen, das sie wie folgt zu gründen wünscht:

Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Namen "DREF

SECURITIZATION SA" (das Unternehmen), eine Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) im Sinne des Luxem-
burger Verbriefungsgesetzes vom 22. März 2004 in der jeweils gültigen Fassung (das Verbriefungsgesetz 2004).

Das Unternehmen kann einen (der alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Der Tod, die Aberkennung der

bürgerlichen Ehrenrechte, die Insolvenz, Abwicklung oder der Konkurs des alleinigen Aktionärs oder gegebenenfalls eines
der Aktionäre führt nicht zur Auflösung des Unternehmens.

Art. 2. Eingetragener Firmensitz. Der eingetragene Firmensitz des Unternehmens befindet sich in der Gemeinde Schutt-

range, im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg). Der Sitz kann innerhalb des Bezirks der Gemeinde Schuttrange durch
einen Beschluss des Verwaltungsrats des Unternehmens (der Verwaltungsrat) verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außerordentliche politische oder militärische Ereignisse aufgetreten sind oder

unmittelbar bevorstehen, die den normalen Geschäftsbetrieb des Unternehmens an seinem Firmensitz oder die Reibungs-
losigkeit der Kommunikation zwischen diesem Firmensitz und Personen im Ausland beeinträchtigen würden, kann der
Geschäftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis diese außergewöhnlichen Umstände vollständig beendet sind.

105295

L

U X E M B O U R G

Derartige vorläufige Maßnahmen wirken sich nicht auf die Nationalität des Unternehmens aus, das trotz zeitweiser Ver-
legung des Firmensitzes, eine in Luxemburg eingetragene Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Dauer. Das Unternehmen wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Das Unternehmen kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung (wie unten dargelegt) aufgelöst werden,

der gemäß den für Satzungsänderungen geltenden Erfordernissen, wie in Artikel 22 unten dargelegt, gefasst wurde.

Art. 4. Unternehmenszweck. Der Zweck des Unternehmens liegt darin Verbriefungstransaktionen im Rahmen des Ver-

briefungsgesetzes 2004 einzugehen, durchzuführen und als Vehikel für Verbriefungstransaktionen zu dienen.

Das Unternehmen kann die mit der Beteiligung oder Ansprüchen, Forderungen und/oder anderen Waren, ob beweglich

oder unbeweglich, materiell oder immateriell, in Verbindung stehenden Risiken, und/oder Risiken, die sich auf Verbind-
lichkeiten oder Verpflichtungen Dritter beziehen, oder Risiken, mit denen Aktivitäten Dritter ganz oder teilweise behaftet
sind, direkt oder über eine andere Körperschaft oder ein anderes Vehikel durch die Ausgabe von Wertpapieren (valeurs
mobilières) jeglicher Art, deren Wert oder Rendite mit diesen Risiken verbunden ist, erwerben oder übernehmen. Das
Unternehmen kann diese Risiken durch den Erwerb von Ansprüchen, strukturierten Einlagen, Forderungen und/oder an-
deren Waren, strukturierte Produkte in Bezug auf Verbrauchsgüter oder Vermögenswerte auf jegliche Weise übernehmen
oder erwerben, indem sie die Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen Dritter verbürgt oder sich auf andere Weise bindend
verpflichtet. Das zur Bestimmung des Werts von verbrieften Vermögenswerten eingesetzte Verfahren wird in den ent-
sprechenden Emissionspapieren des Unternehmens dargelegt.

Im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004 kann das Unternehmen, insofern es sich um Verbriefungstransaktionen

handelt, Anteile, Rechte, Beteiligungen an und Verpflichtungen gegenüber luxemburgischen und ausländischen Unter-
nehmen (i) in jeglicher Form, auf jeglichem Wege, ob direkt oder indirekt, erwerben, verwalten und veräußern, (ii) Aktien,
Anleihen,  Obligationen,  Schuldscheine  und  andere  Wertpapiere  oder  Finanzinstrument  jeglicher  Art  (einschließlich
Schuldscheinen oder Teilen oder Einheiten, die in Luxemburg ausgegeben werden, oder ausländische Investmentfonds,
oder ähnliche Unternehmungen und umtauschbare oder wandelbaren Wertpapiere), strukturierte Produkte, die sich auf
Waren oder Vermögenswerte beziehen (einschließlich Schuld- und Dividendenpapiere jeglicher Art), Forderungen, An-
sprüche oder Darlehens- oder Kreditfazilitäten (und die damit in Zusammenhang stehenden Vereinbarungen), sowie alle
anderen Arten von Vermögenswerten käuflich erwerben, zeichnen oder auf jeglichem anderen Wege erwerben, sowie durch
Verkauf, Austausch oder auf jede andere Art übertragen, und (iii) Anlagenbestände (unter anderem einschließlich der in
(i) und (ii) beschriebenen Vermögenswerte) gemäß der in den entsprechenden Emissionsunterlagen enthaltenen Bestim-
mungen besitzen, entwickeln und verwalten.

Das Unternehmen kann im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004, und solange es für die Erfüllung seiner Unterneh-

menszwecke erforderlich ist, Kredite in jeglicher Form aufnehmen und jegliche Art von Darlehensvereinbarung eingehen.
Es kann Schuldscheine, Anleihen (einschließlich umtauschbarerer oder wandelbarer Wertpapiere und an einen Börsenindex
oder einen Indexkorb oder Aktien gebundene Wertpapiere), Obligationen, Zertifikate, Aktien, Gewinnanteilscheine (parts
bénéficiaires) oder Anteilen, Bürgschaften und jegliche Art von Schuld- oder Dividendenpapieren, einschließlich derer aus
einem oder mehreren Emissionsprogrammen. Das Unternehmen kann im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004, und
unter der Voraussetzung, dass sich diese Kreditgewährung oder Kreditverbindlichkeiten auf Verbriefungstransaktionen
beziehen, Finanzmittel, einschließlich der Erträge aus Kreditverbindlichkeiten und/oder der Emission von Wertpapieren,
an seine Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen oder jegliches andere Unternehmen verleihen.

Das  Unternehmen  kann  im  Rahmen  des  Verbriefungsgesetzes  2004  Garantien  und  Sicherheiten  hinsichtlich  seiner

Vermögenswerte gewähren, um die von ihr für die Sicherung dieser Vermögenswerte oder zu Gunsten der Anleger (ein-
schließlich deren Treuhänder oder Vertreter, falls zutreffend) und/oder jeglicher emittierenden Körperschaft, die an einer
Verbriefungstransaktion des Unternehmens beteiligt ist, eingegangenen Verpflichtungen abzusichern. Das Unternehmen
darf keine Sicherheiten durch Verpfändung, Übertragung, Belastung oder sonstiges im Hinblick auf Teile oder die Ge-
samtheit seiner Vermögenswerte schaffen oder seine Vermögenswerte zu Garantiezwecken übertragen, es sei denn, dies
ist im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004 zulässig.

Das Unternehmen kann jegliche Swap-Geschäfte, Termingeschäfte, Terminkontrakte, Derivate, Optionen, Rückkäufe,

Effektenkredite  und  ähnliche  Rechtsgeschäfte  tätigen,  ausführen  und  andienen,  solange  solche  Vereinbarungen  und
Rechtsgeschäfte für die Erfüllung der Unternehmenszwecke erforderlich sind. Im Allgemeinen kann das Unternehmen
zum Zweck der effizienten Verwaltung jegliche Technik und jegliches Instrument in Bezug auf die Investitionen anwenden,
unter anderem Techniken und Instrumente, deren Beschaffenheit vor Kredit-, Wechselkurs-, Zinssatz- und andere Risiken
schützt.

Das Unternehmen kann im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004, und gemäß der in den entsprechenden Emissions-

unterlagen  enthaltenen  Bestimmungen,  die  zugrunde  liegenden  Vermögenswerte  und  Risiken,  die  die  Rechte  der  ent-
sprechenden Anleger verbürgen, abtreten oder deren Abtretung veranlassen.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, ein oder mehrere Teilvermögen (unter Bezugnahme auf die Vermögenswerte des

Unternehmens, die sich auf eine Wertpapieremission des Unternehmens beziehen) zu bilden, die in jedem Fall einem
gesonderten Teil des Vermögens des Unternehmens entsprechen. Das Unternehmen kann einen oder mehrere treuhänder-
ische Vertreter, wie in den Artikeln 67 bis 84 des Verbriefungsgesetzes 2004 beschrieben, bestellen.

105296

L

U X E M B O U R G

Die obenstehenden Beschreibungen sind in ihrem weitesten Sinne zu verstehen und deren Auflistung ist nicht ein-

schränkend. Die Geschäftszwecke des Unternehmens beinhalten jegliche von dem Unternehmen eingegangenen Rechts-
geschäfte oder Vereinbarungen, vorausgesetzt, dass sie den vorstehend benannten Gegenständen nicht widersprechen.

Im Allgemeinen kann das Unternehmen jegliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jegliche Ge-

schäfte oder Transaktionen durchführen, die sie für das Erreichen und die Entwicklung ihres Unternehmensgegenstands,
im weitesten Sinne des im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004 Zulässigen, für erforderlich oder nützlich erachtet.

Art. 5. Aktienkapital. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro), bestehend

aus 3.100.000 (drei Millionen hunderttausend) eingetragenen Stammaktien zu einem Nennwert von jeweils EUR 0,01 (ein
Euro-Cent), festgelegt.

Das gezeichnete Aktienkapital des Unternehmens kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, der gemäß den

für Satzungsänderungen geltenden Erfordernissen, wie in Artikel 22 unten dargelegt, gefasst wurde, erhöht oder gesenkt
werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien sind und bleiben Namensaktien (actions nominatives).
Am eingetragenen Sitz des Unternehmens wird ein Aktienbuch des Unternehmens geführt, wo es den Aktionären zur

Einsicht zur Verfügung steht. Das Aktienbuch enthält den Namen jedes Aktionärs, dessen Anschrift oder gewählter Wohn-
sitz, die Anzahl der in seinem Besitz befindlichen Aktien, die auf jede dieser Aktien eingezahlten Beträge, sowie die
Übertragung von Aktien und das Übertragungsdatum. Das Eigentum an den Aktien wird durch die Eintragung in das
Aktienbuch begründet.

Das Unternehmen kann seine eigenen Aktien im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften einziehen.

Art. 7. Übertragung von Aktien. Aktien können durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung erfolgen, die in das

Aktienbuch des Unternehmens eingetragen wird; Übertragungserklärungen müssen von dem Übertragenden und dem Er-
werber oder von Personen, die ausreichend bevollmächtigt sind, oder nach Maßgabe der für die Abtretung von Ansprüchen
geltenden Bestimmungen gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuchs unterzeichnet werden.

Zudem kann das Unternehmen, als Nachweis für die Übertragung, andere Abtretungsinstrumente akzeptieren, die das

Einverständnis des Übertragenden und des Erwerbers zur Zufriedenstellung des Unternehmens belegen.

Art. 8. Schuldverschreibungen. Die von dem Unternehmen in registrierter Form emittierten Schuldverschreibungen

(obligations nominatives) dürfen unter keinen Umständen in Inhaberschuldverschreibungen (obligations au porteur) um-
gewandelt werden.

Art. 9. Generalversammlungen des Unternehmens. Im Fall eines alleinigen Aktionärs übernimmt der alleinige Aktionär

sämtliche auf Grundlage der Hauptversammlung übertragenen Befugnisse. In diesen Satzungsartikeln gelten die von der
Hauptversammlung beschlossenen Entscheidungen oder vor ihr ausgeübte Befugnisse solange, wie das Unternehmen nur
einen Aktionär hat, als Bezugnahme auf von dem alleinigen Aktionär getroffene Entscheidungen oder von ihm ausgeübte
Befugnisse. Die von dem alleinigen Aktionär gefassten Entscheidungen sind zu protokollieren.

Im Fall mehrerer Aktionäre repräsentiert jede regelmäßig einberufene Versammlung der Aktionäre des Unternehmens

(die Hauptversammlung) die Gesamtheit der Aktionäre des Unternehmens. Sie verfügt über die weitestreichenden Befug-
nisse zur Anordnung, Durchführung oder Ratifizierung von Handlungen, die mit den Tätigkeiten des Unternehmens in
Verbindung stehen.

Die Jahreshauptversammlungen finden nach luxemburgischem Recht, in Luxemburg, an dem eingetragenen Sitz des

Unternehmens oder an einem anderen Ort innerhalb des Bezirks des eingetragenen Firmensitzes statt, der in der Mitteilung
über die Einberufung der Versammlung am dritten Mittwoch im Juni eines jeden Jahres für 11:30 Uhr genannt ist. Falls
der Termin nicht auf einen Geschäftstag der Banken in Luxemburg fällt, findet die Hauptversammlung an dem nächsten
Geschäftstag statt.

Die Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn der Verwaltungsrat der absoluten und endgültigen Auffas-

sung ist, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dies erforderlich machen.

Sonstige Versammlungen der Aktionäre des Unternehmens können an dem Ort und zu der Zeit stattfinden, die in den

entsprechenden Mitteilungen zur Einberufung der Versammlungen angegeben werden.

Alle  Aktionäre  können  durch  Konferenzschaltung,  Videokonferenz  oder  ähnliche  Kommunikationsmedien  an  den

Hauptversammlungen teilnehmen, wobei (i) die Identifizierung der an Versammlung teilnehmenden Aktionäre gegeben
ist, (ii) alle an der Versammlung teilnehmenden Personen sich gegenseitig hören und miteinander sprechen können, (iii)
die Übertragung der Versammlung auf kontinuierlicher Basis erfolgt und (iv) die Aktionäre sich ordentlich beraten und so
mit allen Mitteln an der Versammlung teilnehmen können, als seien sie persönlich bei einer solchen Versammlung anwe-
send.

Art. 10. Mitteilung, Beschlussfähigkeit, Vertretungsvollmachten und Einberufungsmitteilungen. Die gesetzlichen Ein-

berufungsfristen und die gesetzlich festgelegte Beschlussfähigkeit finden auf die Einberufung und die Durchführung der
Hauptversammlungen Anwendung, wenn in dieser Satzung nichts Gegenteiliges festgelegt ist.

Auf jede Aktie entfällt ein Stimmrecht.

105297

L

U X E M B O U R G

Mit Ausnahme anderslautender gesetzlicher Bestimmungen oder der in dieser Satzung festgelegten Bestimmungen,

werden Beschlüsse der ordentlich einberufenen Hauptversammlung auf Grundlage einer einfachen Mehrheit der anwe-
senden oder vertretenen Personen, die von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, angenommen.

Aktionäre können bei allen Hauptversammlungen durch eine andere, in Schriftform als ihren Vertreter ernannte Person

handeln. Das Schriftstück kann im Original, als Telefax, Depesche, Telegramm, Telex oder eMail vorgelegt werden kann.

Wenn alle Aktionäre des Unternehmens bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind, sich als ordnungs-

gemäß einberufen betrachten und über die Tagesordnung der Versammlung informiert sind, kann die Versammlung ohne
vorherige Mitteilung einberufen werden.

Die Aktionäre können schriftlich über Beschlüsse, die der Hauptversammlung vorgelegt werden, abstimmen (mittels

Stimmzetteln), vorausgesetzt, dass die in Schriftform verfassten Stimmzettel (i) den Namen (einschließlich des Vornamens,
die Adresse und die Unterschrift des jeweiligen Aktionärs, (ii) die Angabe der Aktien hinsichtlich derer der Aktionär dieses
Recht ausüben wird, (iii) die Tagesordnung laut Einberufungsmitteilung und (iv) die Informationen zur Stimmabgabe
(Genehmigung, Ablehnung, Enthaltung) für jedem Tagesordnungspunkt beinhalten. Die Originale der Stimmzettel müssen
72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der betreffenden Hauptversammlung bei dem Unternehmen eingehen.

Art. 11. Geschäftsführung.  Das  Unternehmen  wird  von  einem  Verwaltungsrat  geführt,  der  aus  mindestens  drei  (3)

Direktoren bestehen muss, die nicht Aktionäre des Unternehmens sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können
für maximal für einen Zeitraum von sechs Jahren gewählt werden, und sie können wiedergewählt werden.

Wenn eine Rechtspersönlichkeit zum Mitglied des Verwaltungsrats (die Körperschaft) ernannt wird, dann muss die

Körperschaft einen ständigen Vertreter (représentant permanent) ernennen, der die Körperschaft als Verwaltungsratsmit-
glied  nach  Maßgabe  der  in  Artikel  51bis  des  luxemburgischen  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  kommerzielle
Gesellschaften, in der jeweils gültigen Fassung (das Unternehmensgesetz 1915) vertritt.

Die Verwaltungsräte werden durch die Hauptversammlung gewählt. Der Aktionär/ Die Aktionäre des Unternehmens

bestimmen auch die Anzahl der Verwaltungsräte, deren Vergütung und Amtszeit. Verwaltungsräte können mit oder ohne
Angabe eines Grunds jederzeit durch einen von der Hauptversammlung angenommenen Beschluss abgesetzt und/oder
ersetzt werden.

Sollte die Position eines Verwaltungsrats wegen Ableben, Ausscheiden oder aus einem anderen Grund frei werden,

können  die  übrigen  Verwaltungsräte  durch  Mehrheitsbeschluss  einen  Verwaltungsrat  wählen,  der  die  Position  bis  zur
nächsten Hauptversammlung füllt.

Art. 12. Versammlungen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ernennt aus der Reihe seiner Mitglieder einen Vor-

sitzenden (der Vorsitzende) und er kann einen Schriftführer auswählen, bei dem es sich nicht um einen Verwaltungsrat
handeln muss, der für das Führen der Protokolle über die Versammlungen des Verwaltungsrats und die in den Hauptver-
sammlungen  von  den  Aktionären  angenommenen  Beschlüsse  oder  die  von  dem  alleinigen  Aktionär  angenommenen
Beschlüsse  verantwortlich  ist.  Der  Vorsitzende  führt  den  Vorsitz  bei  allen  Versammlungen  des  Verwaltungsrats  und
Hauptversammlungen. In seiner/ihrer Abwesenheit ernennt die Hauptversammlung oder ernennen die anderen Mitglieder
des Verwaltungsrats (je nach Lage des Falls) durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden Verwaltungsräte, oder
durch deren bei den Versammlungen anwesenden Vertreter, einen anderen vorläufigen Vorsitzenden, der den Vorsitz bei
der entsprechenden Versammlung führt.

Auf Anweisung des Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsräte versammelt sich der Verwaltungsrat an dem in der

Einberufung angegebenen Ort, der in Luxemburg liegen muss.

Alle Verwaltungsräte sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Versammlung anberaumten Termin

schriftlich über die Versammlung des Verwaltungsrats zu benachrichtigen, außer bei Notfällen, in welchem Fall die Art
solcher Umstände in der Benachrichtigung über die Einberufung einer Versammlung des Verwaltungsrats kurz zu be-
schreiben ist.

Das Erfordernis der schriftlichen Benachrichtigung entfällt bei Anwesenheit oder Vertretung aller Mitglieder des Ver-

waltungsrats  bei  Versammlungen,  und  wenn  sie  dabei  angeben,  dass  sie  ordnungsgemäß  informiert  worden  sind  und
vollständige Kenntnis der Tagesordnung der Versammlung besitzen. Auf schriftliche Benachrichtigung kann durch schrift-
liches Einverständnis verzichtet werden. Das Schriftstück kann im Original, als Telefax, Depesche, Telegramm, Telex oder
Email  vorgelegt  werden  kann.  Gesonderte  schriftliche  Benachrichtigungen  sind  nicht  für  die  Anberaumung  von  Ver-
sammlungen erforderlich, die an Orten und Terminen stattfinden, die auf Grundlage eines im Voraus durch Beschluss des
Verwaltungsrats angenommenen Terminplans festgelegt sind.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats können bei den Versammlungen des Verwaltungsrats durch schriftliche Ernennung

eines anderen Verwaltungsrats als ihren Vertreter handeln. Das Schriftstück kann im Original, als Telefax, Depesche,
Telegramm, Telex oder Email vorgelegt werden kann.

Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann ein an der Teilnahme an einer Versammlung des Verwaltungsrats verhindertes

Mitglied  vertreten,  und  es  muss  immer  mindestens  zwei  Mitglieder  geben,  die  entweder  persönlich  bei  einer  solchen
Versammlung anwesend sind oder einer solchen Versammlung auf dem Wege einer Konferenzschaltung, Videokonferenz
oder eines Kommunikationsmittels, das den in dem folgenden Absatz, Teilnahme an Verwaltungsratsversammlungen,
dargelegten Erfordernissen entspricht, beiwohnen.

105298

L

U X E M B O U R G

Die Verwaltungsräte können auf dem Wege einer Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikati-

onsmitteln an Versammlungen des Verwaltungsrats teilnehmen, und sie werden so gestellt, als wären sie persönlich bei
einer Versammlung anwesend, wobei (i) die Identifizierung der an Versammlung teilnehmenden Verwaltungsräte gegeben
ist, (ii) alle an der Versammlung teilnehmenden Personen sich gegenseitig hören und miteinander sprechen können, (iii)
die Übertragung der Versammlung auf kontinuierlicher Basis erfolgt und (iv) die Verwaltungsräte sich ordentlich beraten
und so mit allen Mitteln an der Versammlung teilnehmen können, als seien sie persönlich bei einer solchen Versammlung
anwesend.

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam beraten und handeln, wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungsräte

des Unternehmens bei den Versammlungen des Verwaltungsrats anwesend ist oder vertreten wird. Entscheidungen erfolgen
nach Mehrheitsbeschluss der bei solchen Versammlungen anwesenden oder vertretenen Verwaltungsräte. Im Fall einer
unentschiedenen Abstimmung hat der Vorsitzende der Versammlung eine entscheidende Stimme.

Unbeschadet des Vorstehenden können Beschlüsse des Verwaltungsrats auch schriftlich angenommen werden. Solche

Beschlüsse müssen ein oder mehrere Dokumente umfassen, die die Beschlüsse enthalten, und handschriftlich von jedem
der Verwaltungsräte unterzeichnet sind. Das Datum eines solchen Beschlusses ist das Datum der zuletzt geleisteten Un-
terschrift.

Art. 13. Protokoll über die Verwaltungsratsversammlungen. Die Protokolle der Verwaltungsratsversammlungen sind

von dem Vorsitzenden oder dem Mitglied des Verwaltungsrats zu unterzeichnen, der oder das bei der Versammlung den
Vorsitz geführt hat und werden am eingetragenen Firmensitz des Unternehmens hinterlegt.

Kopien oder Auszüge aus den Protokollen, die bei Gerichtsverfahren oder zu sonstigen Anlässen vorgelegt werden, sind

von dem Vorsitzenden oder zwei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrats zu unterzeichnen.

Art. 14. Vollmachten des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehende Vollmacht zur Durchführung

oder Veranlassung der Durchführung sämtlicher Handlungen hinsichtlich der Verfügung und Verwaltung im Interesse des
Unternehmens, einschließlich der Vollmacht zur Übertragung, Abtretung oder Veräußerung der Vermögenswerte des Un-
ternehmens gemäß dem Verbriefungsgesetz 2004 und der einschlägigen Emissionsunterlagen. Alle Vollmachten, die nicht
ausdrücklich durch das Unternehmensgesetz 1915 oder die Artikel über die Hauptversammlungen vorbehalten sind, fallen
in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

Art. 15. Übertragung der Vollmacht. Der Verwaltungsrat kann eine Person ernennen (délégué à la gestion journalière),

bei der es sich um einen Aktionär oder ein Mitglied des Verwaltungsrats handeln kann oder nicht, die mit der uneinge-
schränkten Vollmacht ausgestattet ist, im Namen des Unternehmens in allen Belangen der alltäglichen Geschäftsführung
und Angelegenheiten des Unternehmens zu handeln.

Der Verwaltungsrat kann eine Person, bei der es sich um einen Aktionär oder ein Mitglied des Verwaltungsrats handeln

kann oder nicht, als ständigen Vertreter einer Körperschaft ernennen, bei der das Unternehmen als Mitglied des Verwal-
tungsrats ernannt ist. Dieser ständige Vertreter handelt nach vollem Ermessen, aber im Namen und auf Rechnung des
Unternehmens, und kann das Unternehmen in seiner Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrats einer solchen Körper-
schaft verpflichten.

Der Verwaltungsrat ist zudem bevollmächtigt, eine Person, bei der es sich um ein Mitglied des Verwaltungsrats handeln

kann oder nicht, zum Zweck der Wahrnehmung bestimmter Funktionen auf jeder Ebene des Unternehmens zu ernennen.

Art. 16. Verbindliche Unterschriften. Das Unternehmen ist gegenüber Dritten in allen Belangen (einschließlich der

alltäglichen Geschäftsführung, durch (i) die gemeinsamen Unterschriften von zwei beliebigen Mitgliedern des Verwal-
tungsrats, oder (ii) die gemeinsamen Unterschriften von zwei Personen oder die Einzelunterschrift der Person, der eine
solche Unterschriftsvollmacht durch den Verwaltungsrat wurde, jedoch nur innerhalb der Grenzen einer solchen Bevoll-
mächtigung, bindend verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikt. Kein Vertrag oder sonstige Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmen und anderen Un-

ternehmen  oder  Firmen  soll  von  der  Tatsache,  dass  einer  oder  mehrere  der  Verwaltungsräte  oder  Führungskräfte  des
Unternehmens an einem solchen anderen Unternehmen oder einer solchen anderen Firma beteiligt, oder ein Verwaltungsrat,
ein Teilhaber, eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter dieses anderen Unternehmens oder dieser anderen Firma ist, berührt
oder entkräftet wird.

Die Verwaltungsräte oder Führungskräfte des Unternehmens, die als Verwaltungsrat, Führungskraft oder Mitarbeiter

eines Unternehmens oder einer Firma tätig sind, mit denen das Unternehmen Verträge abschließt oder anderweitig ge-
schäftlich tätig wird, darf nicht einzig auf Grund einer solchen Verbundenheit mit einem anderen Unternehmen oder einer
anderen Firma an der Betrachtung und Stimmabgabe oder dem Befassen mit jeglichen Angelegenheiten in Bezug auf solche
Verträge oder andere Geschäfte gehindert werden.

Falls einer der Verwaltungsräte des Unternehmens eine direktes persönliches und gegenteiliges Interesse an den Rechts-

geschäften des Unternehmens haben sollte, muss dieser Verwaltungsrat den Verwaltungsrat des Unternehmens über dieses
persönliche und gegenteilige Interesse in Kenntnis setzen, und er darf nicht an der Betrachtung oder Stimmabgabe hin-
sichtlich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen, und die betreffenden Rechtsgeschäfte und das Interesse des Verwaltungsrats
daran ist bei der nächsten folgenden Jahreshauptversammlung zu berichten.

105299

L

U X E M B O U R G

Der vorstehende Absatz gilt nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrats, die sich auf Rechtsgeschäfte beziehen, die im

gewöhnlichen Betriebsablauf des Unternehmens getätigt und unabhängig eingegangen werden.

Art. 18. Wirtschaftsprüfer. Die Tätigkeiten des Unternehmens werden von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern

(réviseurs d'entreprises agréés) überwacht. Der/Die Wirtschaftsprüfer werden von dem Verwaltungsrat gemäß dem Ver-
briefungsgesetz 2004 ernannt. Der Verwaltungsrat legt ihre Anzahl, ihre Vergütung und ihre Amtszeit fest.

Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr des Unternehmens beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines

jeden Jahres

Art. 20. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Nettogewinn des Unternehmens werden 5 % (fünf Prozent) der gesetz-

lich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Zuteilung ist nicht länger erforderlich, sobald die gesetzlich vorgeschrie-
bene Rücklage 10% (zehn Prozent) des wie in Artikel 5 oben angegebenen oder mitunter erhöhten oder gesenkten Kapitals
des Unternehmens beträgt.

Die  Hauptversammlung  bestimmt,  wie  über  den  übrigen  Jahresnettogewinn  verfügt  werden  soll  und  sie  kann  nach

eigenem Ermessen entscheiden, mitunter Dividenden auszuschütten, und zwar so, wie sie es für den Geschäftszweck und
die Geschäftspolitik als am besten angemessen erachtet.

Die Dividenden können in Euro oder jeder von dem Verwaltungsrat gewählten anderen Währung ausgeschüttet werden,

und sie werden an den von dem Verwaltungsrat festgelegten Orten und Terminen ausgezahlt. Der Verwaltungsrat kann
sich für die Auszahlung von Zwischendividenden nach Maßgabe und im Rahmen der in dem Unternehmensgesetz 1915
festgelegten Bestimmungen entscheiden.

Art. 21. Auflösung und Abwicklung. Das Unternehmen kann jederzeit durch einen nach Maßgabe der Bestimmungen

für Änderungen an dieser Satzung, wie in Artikel 22 unten dargelegt, gefassten Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst
werden. Im Fall der Auflösung des Unternehmens wird die Abwicklung von einem oder mehreren Abwicklern (bei denen
es sich um natürliche Personen oder Körperschaften handeln kann) durchgeführt, die von der Hauptversammlung ernannt
werden, die über die Abwicklung entscheidet. Diese Hauptversammlung bestimmt ebenso die Befugnisse und Vergütung
des Abwicklers oder der Abwickler.

Art. 22. Änderungen. Unter der Voraussetzung der Beschlussfähigkeit und des Erfordernisses einer Mehrheit laut Un-

ternehmensgesetz 1915, kann diese Satzung mitunter durch eine außerordentliche Hauptversammlung geändert werden.

Art. 23. Trennung der Vermögenswerte. Wenn ab einem der Zahlungstermine von Anlagevermögen, die sich auf ein

Teilvermögen (einschließlich Deckungsgeschäften, die das Unternehmen in Verbindung mit einem Teilvermögen einge-
gangen ist) beziehen, die Gesamtsumme der Gelder, die in das Anlagevermögen dieses Teilvermögens eingezahlt wurden,
die Zahlungen übersteigt, die von der Gesellschaft in dieses Teilvermögen eingezahlt werden müssen, kann der Verwal-
tungsrat den überschüssigen Betrag zur Begleichung von Forderungen von Gläubigern des Unternehmens, deren Forde-
rungen keinem bestimmten Teilvermögen zugeordnet werden können, einsetzen.

Die einem Teilvermögen zugeordneten Anlagevermögen stehen ausschließlich den (1) Anlegern in dieses Teilvermögen

(die  Anleger),  (2)  den  Gläubigern,  deren  Ansprüche  in  Verbindung  mit  der  Bildung,  Verwaltung  oder  Auflösung  des
Teilvermögens entstanden sind, und die in den Bestimmungen für die Rangfolge von Zahlungen der entsprechenden Emis-
sionsunterlagen vorgesehen sind (die Transaktionsgläubiger), (3) den Gläubigern, deren Ansprüche in Verbindung mit der
Bildung, Verwaltung oder Auflösung des Teilvermögens entstanden sind, und die nicht in den Bestimmungen für die
Rangfolge von Zahlungen der entsprechenden Emissionsunterlagen vorgesehen sind (die Gläubiger, deren Ansprüche aus
einem bestimmten Teilvermögen entstehen/ Compartment-Specific Claims Creditors und, gemeinsam mit den Transakti-
onsgläubigern,  die  Gläubiger)  und  (4),  den  Bestimmungen  des  nächsten  Absatzes  unterliegend,  die  Gläubiger,  deren
Ansprüche nicht in Verbindung mit der Bildung, Verwaltung oder Auflösung eines Teilvermögens entstanden sind und die
nicht auf ihr Rückgriffsrecht auf die Vermögenswerte eines Teilvermögens des Unternehmens verzichtet haben (die Gläu-
biger, deren Ansprüche nicht aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen/ Non Compartment-Specific Claims Credi-
tors) zur Verfügung.

Die Rechte der Gläubiger, deren Ansprüche nicht aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen (Non Compartment-

Specific Claims Creditors), werden allen Teilvermögen von dem Unternehmen halbjährlich im Nachhinein zugeteilt, auf
gleicher Basis und zeitanteilig (pro rata temporis) hinsichtlich der Teilvermögen, die innerhalb des Halbjahres gebildet
wurden, und in deren Emissionsunterlagen die Gläubiger, deren Ansprüche nicht aus einem bestimmten Teilvermögen
entstehen (Non Compartment-Specific Claims Creditors), ausdrücklich zur Ausübung des Rückgriffrechts auf die einem
solchen Teilvermögen zugeordneten Vermögenswerte bevollmächtigt. Dieses Recht der Gläubiger, deren Ansprüche nicht
aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen, gegenüber einem Teilvermögen werden im Folgenden als Pro-rata-Rechte
bezeichnet.

Die Anleger und die Gläubiger erkennen an und akzeptieren, dass sie, sobald alle Vermögenswerte, die dem Teilver-

mögen zugeordnet worden sind, in das sie investiert haben oder auf Grundlage derer ihre Ansprüche entstanden sind,
realisiert sind, keine Berechtigung haben, jegliche weiteren Schritte gegen das Unternehmen einzuleiten, um weitere fäl-
ligen Beträge zurückzuerlangen und das Recht auf den Erhalt solcher Beträge erlischt. Alle Gläubiger, deren Ansprüche
nicht aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen (Non-Compartment-Specific Claims Creditor) erkennen an und ak-
zeptieren, dass sie, sobald alle Vermögenswerte, die einem Teilvermögen zugeordnet sind, an dem sie Pro-rata-Rechte

105300

L

U X E M B O U R G

haben, realisiert sind, keine Berechtigung haben, jegliche weiteren Schritte gegen das Unternehmen einzuleiten, um diese
Pro-rata-Rechte zurückzuerlangen, und das Recht auf die Auszahlung von Beträgen in Zusammenhang mit den Pro-rata-
Rechten erlischt.

Die Gläubiger, deren Ansprüche aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen (Compartment-Specific Claims Cre-

ditors) und die Gläubiger, deren Ansprüche nicht aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen (Non Compartment-
Specific Claims Creditors) akzeptieren ausdrücklich, und werden bei dem Eingehen von Vertragspflichten gegenüber dem
Unternehmen so gestellt, als hätten sie dies akzeptiert, dass die Rangfolge der Zahlungen und die Bedingungen des Was-
serfall-Prinzips Teil der Emissionsunterlagen bilden, und sie akzeptieren die Folgen der Rangfolge der Zahlungen und der
Bedingungen des Wasserfall-Prinzips ausdrücklich und werden so gestellt, als hätten sie diese akzeptiert.

Die Rechte der Aktionäre des Unternehmens sind auf die Vermögenswerte beschränkt, die nicht einem Teilvermögen

zugeteilt sind.

Art. 24. Verbot des Konkursantrags für das Unternehmen und der Pfändung der Vermögenswerte des Unternehmens.

Gemäß Artikel 64 des Verbriefungsgesetzes 2004, verpflichten sich sämtliche Anleger, Gläubiger und Aktionäre des Un-
ternehmens, sowie sämtliche Personen, die ein Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen eingegangen sind (der Vertrags-
partner)  (1)  keinen  Konkursantrag  für  das  Unternehmen  zu  stellen  oder  die  Eröffnung  eines  anderen  Sammel-  oder
Sanierungsverfahrens gegen das Unternehmen zu beantragen und (2) keine Vermögenswerte des Unternehmens zu pfänden,
und zwar ungeachtet der Tatsache, ob die betreffenden Vermögenswerte (i) zu dem Teilvermögen, in das der Anleger
investiert hat, gehören oder ob die Gläubiger oder die Vertragspartei dem Unternehmen gegenüber Vertragsrechte über die
Vermögenswerte hat, (ii) oder zu anderen Teilvermögen oder (iii) den Vermögenswerten des Unternehmens gehören, die
noch keinem Teilvermögen zugeordnet worden sind (wenn überhaupt) gehören, es sei denn, Gegenteiliges wird ausdrück-
lich in Schriftform zwischen dem Unternehmen und dem Anleger, Gläubiger oder Vertragspartner vereinbart.

Art. 25. Unterordnung. Ansprüche, die die Aktionäre des Unternehmens ggf. gegenüber dem Unternehmen (in dieser

Eigenschaft) haben, werden den Ansprüchen von jeglichen Gläubigern des Unternehmens (einschließlich der Gläubiger)
oder Anleger des Unternehmens (einschließlich der Anleger) untergeordnet.

Die Anleger akzeptieren und erkennen an, dass ihre Rechte an einem Teilvermögen den Rechten anderer Anleger und/

oder Gläubiger an demselben Teilvermögen untergeordnet werden können.

Art. 26. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch die hierin enthaltenen Artikel ge-

regelt  werden,  unterliegen  der  Maßgabe  der  in  dem  Unternehmensgesetz  1915  und  dem  Verbriefungsgesetz  2004
festgelegten Bestimmungen.

<i>Übergangsregelungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.
Die erste Jahreshauptversammlung findet 2017 statt.

<i>Zeichnung

Nach Festlegung der Satzung des Unternehmens erklärt die erschienene Partei hiermit, dass die 3.100.000 (drei Millionen

hunderttausend) Aktien, die das gesamte Aktienkapital des Unternehmens repräsentieren, wie folgt gezeichnet werden:

Aktionär

Anzahl

Aktien

Gegenwert

Gemini Holdings (Guernsey) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.204.875 22.048,75 €
Internos Global Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244.125 2.441,25 €

Somerston GSH Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

651.000 6.510,00 €

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100.000 31.000,00 €

Sämtliche dieser Aktien sind von den Aktionären zu 100 % (hundert Prozent) durch Barzahlung voll einbezahlt worden,

so dass die von den Aktionären geleistete Summe in Höhe von EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) dem Unter-
nehmen von nun an frei zur Verfügung steht, was dem Notar gegenüber durch Nachweise belegt wurde.

<i>Abrechnung - Kosten

Der diese Urkunde errichtende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Unternehmensgesetzes 1915

vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind und er deren Erfüllung ausdrücklich bezeugt. Weiter bestätigt der diese Urkunde
errichtende Notar, dass die hierin enthaltenen Artikel im Einklang mit den Vorschriften laut Artikel 27 des Unterneh-
mensgesetzes 1915 stehen.

Die Höhe des, zumindest überschlagenen, Betrags an Kosten, Ausgaben, Gehältern oder Gebühren, die dem Unterneh-

men infolge seiner Gründung auf irgendeine Weise entstanden sind oder in Rechnung gestellt werden, werden auf circa
EUR 3.000,- geschätzt.

<i>Beschlüsse der Generalversammlung der Aktionäre

Die obengenannte Partei, die das gesamte gezeichnete Kapital repräsentiert, hat die folgenden Beschlüsse gefasst:

105301

L

U X E M B O U R G

1. die Anzahl der Verwaltungsräte wird auf drei (3) Verwaltungsräte festgelegt;
2. die folgenden Personen werden zu Verwaltungsräten (Verwaltungsratsmitglieder) ernannt:
- Frau Gisèle Galhano, mit beruflicher Anschrift in 151, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg;
- Herr Stéphane Weyders, mit beruflicher Anschrift in 151, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg; und
- Herr Fabien Rossignol-Burgos Leon, mit beruflicher Anschrift in 151, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg;
3. dass die Amtszeiten der Verwaltungsratsmitglieder nach der Jahreshauptversammlung im Jahr 2019 ablaufen; und
4. dass die Adresse des eingetragenen Firmensitzes des Unternehmens 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

ist.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen

der obengenannten, erschienenen Partei, in englischer Fassung errichtet wurde, gefolgt von einer deutschen Version. Auf
Verlangen der erschienenen Person und für den Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Ver-
sion, soll die englische Fassung Vorrang haben.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, an dem zu Beginn dieses Dokuments genannten

Datum.

Das Dokument wurde der erschienenen Person, die dem Notar mit Namen, Familienstand und Wohnanschriften bekannt

ist, vorgelesen, die benannte Person unterzeichnete die vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar.

Gezeichnet: K. GRÄFF und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 24 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/16674. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 27. Mai 2016.

Référence de publication: 2016116916/734.
(160091703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2016.

Network Plus Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5214 Sandweiler, 23, rue du Ciementiere.

R.C.S. Luxembourg B 118.503.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111870/9.
(160084715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Nezu Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 202.257.

La Société informe que l'adresse professionnelle de Madame Kerstin Lindgren a été modifiée comme suit avec effet au

4 avril 2016:

287-289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kerstin Lindgren
<i>Manager

Référence de publication: 2016111872/14.
(160085032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Santander European Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 133.110.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 20 mai 2016, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 24 mai 2016, 2LAC/2016/10794, aux droits de soixante-

105302

L

U X E M B O U R G

quinze euros (75.- EUR), que la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de " Santander
European Investments Lux S.à r.l., en liquidation volontaire ", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B
133.110, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-
Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 octobre 2007, publié u Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2758 du 29 novembre 2007 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2591 du 17 octobre 2013.

- Que la Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 mai 2015, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, SANTAN-

DER GESTIÓN INMOBILIARIA S.A., ainsi qu'au commissaire-vérificateur à la liquidation, Kohnen &amp; Associés S.à r.l.,
pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq (5) ans, à partir de la date de la publication des

présentes dans le Mémorial C, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, à
l'adresse suivante: 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2016.

Référence de publication: 2016116453/31.
(160090530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2016.

Novadelta Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 163.742.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111873/9.
(160084851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

NuLand Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 192.612.

Les comptes annuels de la société pou la période du 2 décembre 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016111874/12.
(160084448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

NAC Luxembourg I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 199.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111875/9.
(160084678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105303

L

U X E M B O U R G

Global Bond Series III, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.187.

Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du

11 mai 2016:

- acceptation de la démission de Madame Marketa Stranska en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 4 mai

2016;

- nomination, en tant que nouvel administrateur de la Société, de Monsieur Domenico Latronico, né le 14 septembre

1969 à Potenza, Italie et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet
au 4 mai 2016. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020;

-  confirmation  que  le  conseil  d'administration  de  la  Société  est  depuis  le  4  mai  2016  composé  des  administrateurs

suivants:

* Monsieur Fabrice Rota;
* Monsieur Shehzaad Atchia; et
* Monsieur Domenico Latronico.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2016.

<i>Pour la Société
Domenico Latronico
<i>Administrateur

Référence de publication: 2016112588/24.
(160086003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2016.

NHC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.902.725,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 202.207.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les Associés de la Société en date du 17 mai 2016 que:
- Monsieur Geoffrey Henry démissionne de son poste de gérant de classe A avec effet au 30 avril 2016;
- Madame Pamela Valasuo, née le 26 mai 1975 à Borga Ik, Finlande, demeurant professionnellement au 412F, Route

d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée en tant que nouveau gérant de classe A de la Société en remplacement du gérant
démissionnaire avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 1 7 mai 2016.

Référence de publication: 2016111880/16.
(160084808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

NII International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 149.229.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 2 mai 2016

1. Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 2 mai 2016.
2. Monsieur Christophe-Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés, né le 22 janvier 1985 à Ottignies-Louvain-la-

Neuve (Belgique), demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme
gérant de catégorie A pour une durée indéterminée avec effet au 2 mai 2016.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour NII International Holdings S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016111881/16.
(160084328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105304

L

U X E M B O U R G

Onex BP, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 37.919.619,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 197.873.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Munsbach, le 19 mai 2016.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2016111890/13.
(160084628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Nizi International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 69.587.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11/05/2016

Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société Nizi International S.A. tenue

en date du 11 mai 2016 que:

'1) Nomination administrateurs
L'assemblée générale des actionnaires a élu comme administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui

aura lieu en 2017:

M. Dag Teigland, domicilié au 30 Aasveien NO-1369 Stabekk (Norvège), jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017,
M. Kjetil Holta, domicilié (adresse professionnelle) Drammensveien 35 NO-0271 Oslo (Norvège), jusqu'à l'assemblée

générale annuelle de 2017

M. Olivier Le Bihan, domicilié (adresse professionnelle) au 26 Chemin Baraban CH-1256 Troinex (Suisse), jusqu'à

l'assemblée générale annuelle de 2017,

M. Arnfinn Holas, domicilié (adresse professionnelle) 3 Grønnegate, NO 0350 Oslo (Norvège), jusqu'à l'assemblée

générale annuelle de 2017,

Capellen, le 18 mai 2016.

Référence de publication: 2016111884/21.
(160084980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Nizi Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 48.213.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11/05/2016

Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la société Nizi Luxembourg S.A. tenue en date du

11 mai 2016 que:

1) Nomination administrateurs
L'assemblée générale des actionnaires a élu comme administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui

aura lieu en 2017:

Mr Dag Teigland, domicilié au 30 Aasveien NO-1369 Stabekk (Norvège), jusqu'à l'assemblée générale annuelle de

2017.

M. Kjetil Holta, domicilié (adresse professionnelle) Drammensveien 35 NO-0271 Olso (Norvège), jusqu'à l'assemblée

générale annuelle de 2017.

M.  Ulf  Berg,  domicilié  (adresse  professionnelle)  89e  rue  Pafebruch  L-8308  Capellen,  jusqu'à  l'assemblée  générale

annuelle de 2017.

Capellen, le 18 mai 2016.

Référence de publication: 2016111885/20.
(160084981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105305

L

U X E M B O U R G

Onex Jack's Holding Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 7.963.980,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 197.895.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Munsbach, le 19 mai 2016.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2016111891/13.
(160084656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Nova Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 100.079.

En date du 24 février 2016, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1 

er

 avril 2016.

Référence de publication: 2016111887/9.
(160084723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Ochtrup Phase 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.164.564,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 202.574.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 17 mai 2016

1. Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant C.
2. Monsieur Douwe Terpstra, administrateur de sociétés, né le 31 octobre 1958 à Leeuwarden, Pays-Bas, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant C pour une durée indé-
terminée.

Luxembourg, le 19 mai 2016.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Ochtrup Phase 3 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016111888/17.
(160084595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Astorg VI Co-Invest Parkeon, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 206.345.

<i>Excerpts of the limited parnership agreement of the fund

1. Members who are jointly and severally liable. Astorg VI (GP), a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Bâtiment
Forte F2 - 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of fifteen
thousand Euro (EUR 15,000), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 199.695,
being the non-managing general partner (associé commandité non-gérant) of the Fund (the “General Partner”).

2. Name, Purpose and registered office of the Fund.
(i) The name of the Fund is “Astorg VI Co-Invest Parkeon”.
(ii) The purposes of the Fund are (a) to make a direct or indirect investment and further direct or indirect investment(s),

if any, through an investment holding company if applicable in the portfolio company (as defined in the partnership agree-
ment  of  the  Fund)  as  a  co-investment  with  Astorg  VI,  SLP,  a  Luxembourg  special  limited  partnership  (société  en

105306

L

U X E M B O U R G

commandite spéciale) (“Astorg VI”) and/or any other funds managed or advised by the Manager (as defined below) or the
Manager’s affiliates, subject to the provisions of a co-investment agreement, and (b) to do everything necessary or desirable
for the accomplishment of the above purposes or the furtherance of any of the powers herein set forth and to do every other
act and thing incident thereto or connected therewith permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the “1915 Law”), and the law of 13 July 2014 on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”).

(iii) The registered office and business address of the Fund shall be maintained within the Grand Duchy of Luxembourg

at the Manager’s registered office or at such other address as the Manager shall determine in its sole discretion in which
case the Manager shall notify the partners of such other address. The Manager shall promptly give written notice of any
change of such address to the partners.

3. Management and Manager’s powers. The General Partner has appointed Astorg Asset Management to act as the

manager (gérant) (the “Manager”) of the Fund in compliance with the 1915 Law.

The Manager is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Bâtiment Forte F2 - 2, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one million three hundred thousand and two
Euro (EUR 1,300,002), and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 187.541.

The limited partners shall have no part in the conduct of business of the Fund or in the management or control of the

Fund and shall have no authority or right to act on behalf of the Fund in connection with any matter, or deal with any person
on behalf of the Fund who or that is not a partner. The exercise by any limited partner of any right conferred shall not be
construed to constitute participation by such limited partner in the conduct of the business of the Fund or in the control of
the investments or other activities of the Fund and shall, as a consequence, not make such limited partner liable as a general
partner (associé commandité) for the debts and obligations of the Fund for purposes of the 1915 Law or otherwise.

Subject to the other provisions of the limited partnership agreement, the Manager shall have the broadest powers and

authority to act on behalf of and in the name of the Fund and to carry out any and all of the objects and purposes of the
Fund in accordance with, and subject to the limitations contained in the limited partnership agreement and to perform all
acts which it may, in its sole discretion, deem necessary or desirable in connection therewith, without any further act,
approval or vote of any person, including any limited partner. In particular, the Manager shall be in charge of the mana-
gement and control of the Fund, including (without limitation):

(a) to receive applications for commitments to the Fund from prospective investors, to require prospective investors to

provide such information as the Manager thinks necessary or appropriate in order to comply with any applicable anti-money
laundering regulations and to admit, subject to the approval of the General Partner, such persons as limited partners by
accepting on behalf of the Fund a commitment agreement executed and delivered by such persons;

(b) to admit transferee to the Fund in accordance with the provisions of the limited partnership agreement of the Fund

and subject to the approval of the General Partner;

(c) to establish or acquire, and exercise rights in relation to, investment holding companies;
(d) to (or to agree to) acquire investments falling within the investment policy (either directly or through an investment

holding company), to make follow-on investments, to (or to agree to) sell, exchange or otherwise dispose of such invest-
ments and to prepare and execute investment agreements, subscription and shareholder’s agreements, sale and purchase
agreements and all other deeds documents and agreements in connection with the acquisition or disposal of investments
(either personally or through an attorney or other agent);

(e) to acquire investments in a syndicate with other investors, either directly or through an investment holding company;
(f) to borrow money (either directly or through an investment holding company) and to make, issue, accept, endorse

and execute promissory notes, drafts, bills of exchange, credit agreements and other instruments and evidences of indeb-
tedness;

(g) to mortgage, charge, pledge, assign or grant a security interest to a finance provider of a security trustee or otherwise

in all or any part of the Fund assets and to grant to any relevant lender power of attorney to issue draw-down notices or
otherwise deal with and enforce all rights in relation to the commitments on its behalf in each case, in connection with any
obligations of the Fund;

(h) to give guarantees, warranties and indemnities in relation to investments including any obligation of an investment

holding company and/or the portfolio company and/or any other entity owned directly or indirectly, wholly or partly by
the Fund as the Manager considers necessary or desirable;

(i) to monitor the performance of and, where appropriate, to appoint managers, executives, directors, members of ma-

nagement boards (directoire) or supervisory boards (conseil de surveillance), advisors (censeurs) or any other equivalent
position in the portfolio company, to exercise all rights conferred upon the Fund under the terms of any investment agree-
ment or otherwise in respect of the portfolio company, to liaise with, consult, assist or procure assistance to be given to the
portfolio company and investment holding companies and to receive fees from the latter and generally to take any action
the Manager considers appropriate for the protection of Fund assets;

(j) to enter into forward exchange contracts and to invest in currency or currency futures or currency options or contracts

for differences or other instruments (in each case whether directly or through an investment holding company) with a view
to hedging currency or interest rate risk, provided that the omission to hedge or otherwise enter into arrangements to cover

105307

L

U X E M B O U R G

the risk of losses as a result of exchange or interest rate movements shall not constitute a breach of any duty owed to any
person by the Manager and provided further that such hedge or arrangements are not entered into with a speculative purpose;

(k) pending the application of amounts drawn down pursuant to the limited partnership agreement of the Fund or received

by the Fund (as the case may be), to place such amounts in deposit accounts or invest them in short-term instruments;

(l) to open and maintain bank accounts for and in the name of the Fund, to give payment and other instructions to banks

in respect of such accounts and to receive and pay into such accounts commitments advanced by partners, investment
income, sums arising on the disposal of investments and any other amounts received by the Fund;

(m) to discharge any obligations of the Fund, including paying the fees and expenses referred to in the limited partnership

agreement of the Fund, and to provide against present or future contemplated obligations and contingencies;

(n) to pay or direct the Fund to pay all amounts of taxation for which the General Partner, the Manager, or any affiliates

of such entities or the Fund is liable on behalf of any limited partner, provided that the Manager shall first give notice to
such limited partner of such liability to taxation and shall use its reasonable endeavours at the expense of such limited
partner to ensure that the amount assessed is in fact due, and to pay any amount of taxation in respect of which any partner
or the Fund has been assessed in the name of the General Partner, the Manager, such affiliates or the Fund;

(o) to pay to any indemnified party or indemnified person (including the General Partner, the Manager and any Manager’s

affiliate) any amounts to which the Manager, acting in good faith, believes such person to be entitled pursuant to the
provisions of the limited partnership agreement of the Fund;

(p) to make distributions to the partners in accordance with the terms of the limited partnership agreement of the Fund;
(q) to appoint a depositary of the Fund assets and enter into a depositary agreement between the Fund and this depositary,

and to give settlement and other instructions to such depositary;

(r) to appoint an administrative, registrar and transfer agent and enter into an administrative, transfer agent and registrar

agreement between the Fund and this administrative, registrar and transfer agent, and to give settlement and other instruc-
tions to such administrative, registrar and transfer agent;

(s) to engage such employees, independent agents (including placement agents), custodians, depositaries, paying and

collecting agents and professional or financial advisers or consultants as the Manager considers necessary or desirable in
relation to the affairs of the Fund, who may be the Manager’s affiliates provided that such engagements are on arm’s length
terms;

(t) to commence, conduct, defend or settle litigation relating to the Fund or to any of the Fund assets;
(u) to register and publish all such notices, statements or other documents as may be required pursuant to the 1915 Law

to be registered and published in relation to the establishment of the Fund and in relation to any changes occurring in relation
to the Fund (to the extent the General Partner becomes aware of any such changes);

(v) to take any action necessary to cause the Fund to qualify or continue to qualify as a “VCOC” within the meaning of

the plan assets regulation or to cause the Fund to be treated, for US federal, state or local income tax purposes as a Fund
and not as an association taxable as a corporation, including, without limitation, the filing of any elections or statements
by the Fund with the applicable US authorities;

(w) to accept and retain for the Manager and/or the Manager’s affiliates own account any and all transaction fees,

investment related fees and abort fees;

(x) on behalf of and so as to bind the Fund as such, to enter into, make and perform such deeds, documents, contracts,

agreements, undertakings, guarantees and indemnities as the Manager may, in its reasonable opinion, consider necessary
or desirable in connection with the exercise of its powers pursuant to the limited partnership agreement of the Fund or
otherwise in the furtherance of the Fund’s business;

(y) to make, execute, sign and file (i) the limited partnership agreement of the Fund, instruments, documents, or any

counterparts thereof related to transfers of interests in the Fund made in accordance with the limited partnership agreement
of the Fund, (ii) any amendments to the limited partnership agreement of the Fund, and (iii) all such other instruments,
documents, statements and certificates which may from time to time be required by the 1915 Law and the AIFM Law, or
any other law, or deemed necessary by the Manager to effect, implement and continue the valid and subsisting existence
and the business of the Fund, or as otherwise provided for in the limited partnership agreement of the Fund;

(z) to enter into any side letter with limited partners subject to the provisions of the limited partnership agreement of

the Fund;

(aa) to communicate, use and disclose information regarding the Fund and the limited partners, including the names of

the limited partners and their respective interests in the Fund to prospective investors, to counter-parties, to lenders, to
service providers or to any person as required to comply with applicable laws, and as necessarily to appropriately administer
the Fund and its portfolio and in particular to comply with applicable laws and regulations, including any anti-money
laundering or anti-terrorist laws or regulations; the limited partner shall provide to the Manager, promptly upon request,
all information that the Manager reasonably deems necessary to comply with such laws and regulations;

(bb) provided that the Manager shall not have power or authority to do anything that would contravene any provision

of the limited partnership agreement of the Fund;

(cc) generally to do all other things on behalf of the Fund as may in the Manager’s opinion be required in connection

with or ancillary to the purposes or objectives of the Fund as described herein.

105308

L

U X E M B O U R G

The Fund is bound towards third parties in all matters by the Manager or, as the case may be, by any person to whom

such signatory authority shall be delegated by the Manager.

The Fund shall be exclusively represented by the Manager in accordance with its management authorities above-men-

tioned.

4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Fund commenced upon its formation,

on 27 April 2016, and shall expire on the earlier of the two (2) following dates: (i) expiration of the term of Astorg VI,
including if this term is extended, and (ii) the date on which the Fund has transferred or liquidated all its interests in the
investment and can be dissolved, except in the event of early dissolution as provided for in the limited partnership agreement
of the Fund. Notwithstanding the foregoing, the term of the Fund shall not exceed a period of ten (10) years as of the first
closing date of the Fund.

5. Financial year. The financial year of the Fund shall begin each year on the first (1 

st

 ) of January and end on the thirty-

first (31 

st

 ) of December of the same year. As an exception, the first financial year shall begin on the first closing date and

shall end on the thirty-first (31 

st

 ) of December 2016, and the last financial year shall end on the final liquidation date of

the Fund.

<i>Extrait du contrat social de la société

1. Associés solidairement responsables. Astorg VI (GP), une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du

Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au Bâtiment Forte F2 - 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, avec un capital social de quinze mille euros (EUR 15.000), inscrite auprès du Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.695, étant l’associé commandité non-gérant de la Société
(l’«Associé Commandité»).

2. Le nom, l’objet social et le siège social.
(i) Le nom de la Société est «Astorg VI Co-Invest Parkeon».
(ii) L’objet social de la Société est (a) de faire un investissement direct ou indirect et d’autre(s) investissement(s) direct

(s) ou indirect(s), le cas échéant, par l’intermédiaire d’une société holding d'investissement le cas échéant dans la société
de portefeuille (telle que définie dans le contrat social de la Société) en tant que co-investissement avec Astorg VI, SLP,
une société en commandite spéciale luxembourgeoise ("Astorg VI") et / ou d'autres sociétés gérées ou conseillées par le
Gérant  (tel  que  défini  cidessous)  ou  les  sociétés  affiliées  au  Gérant,  sous  réserve  des  dispositions  d'un  contrat  de  co-
investissement, et (b) de faire tout le nécessaire ou d’entreprendre toute action souhaitable pour l’accomplissement des
points ci-dessus ou la poursuite de tous pouvoirs mentionnés ci-après et de faire tout acte ou chose y incidente ou afférente
permise par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), ou la loi
du 13 juillet 2004 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (la «Loi GFIA»).

(iii) Le siège social et l‘administration centrale de la Société doivent être maintenus au Grand-Duché de Luxembourg,

au siège social du Gérant ou à toute adresse que le Gérant doit déterminer à sa seule discrétion, dans quel cas le Gérant doit
notifier aux associés cette adresse. Le Gérant devra rapidement notifier par écrit tout changement d’adresse aux associés.

3. Gérance et pouvoirs du gérant. L’Associé Commandité a désigné Astorg Asset Management comme gérant (le «Gé-

rant») de la Société conformément à la Loi de 1915.

Le Gérant est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée sous les lois du Grand-Duché du

Luxembourg, ayant son siège social au Bâtiment Forte F2 - 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché
du Luxembourg, avec un capital social d’un million trois cent mille deux euros (EUR 1.300.002), et inscrite auprès du
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.541.

Les associés commanditaires ne participent d’aucune façon à la conduite des activités de la Société ou à la gestion ou

au contrôle de la Société et n’ont aucun pouvoir ou droit d’agir pour le compte de la Société pour quelque sujet que ce soit,
ou de traiter avec toute personne qui ne serait pas un associé, au nom de la Société. L’exercice par tout associé commanditaire
d’un droit quelconque conféré par le contrat social ne constitue pas une participation par ledit associé commanditaire à la
conduite des activités de la Société ou au contrôle de l’investissement ou d’autres activités de la Société et, par conséquent,
ne rend pas ledit associé commanditaire responsable comme un associé commandité des dettes et obligations de la Société
aux fins de la Loi de 1915 ou de toute autre disposition réglementaire.

Sous réserve des autres dispositions du contrat social, le Gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

et pour le compte de la Société afin de réaliser les objectifs et les finalités de la Société, conformément à et sous réserve
des restrictions prévues au contrat social, et pour prendre, à sa seule discrétion, toute mesure qu’il juge nécessaire ou
souhaitable, sans autre action, approbation ou vote de toute personne, y compris de tout associé commanditaire. En parti-
culier, le Gérant sera en charge de la gestion et du contrôle de la Société, incluant les fonctions suivantes (sans limitation):

(a)  de  recevoir  les  demandes  d'engagements  pour  la  Société  des  investisseurs  potentiels,  d'exiger  des  investisseurs

potentiels de fournir des informations telles que le Gérant juge nécessaires ou appropriés afin de se conformer à toute
réglementation anti-blanchiment en vigueur et à admettre, sous réserve de l'approbation de l’Associé Commandité, ces
personnes comme associés commanditaires par acceptation au nom de la Société du contrat de souscription signé et remis
par ces personnes;

105309

L

U X E M B O U R G

(b) d'admettre tout cessionnaire en conformité avec les dispositions du contrat social de la Société et sous réserve de

l'approbation de l’Associé Commandité;

(c) de constituer ou d'acquérir, et d'exercer les droits en relation avec, des sociétés holding d'investissement;
(d) d’acquérir (ou accepter d’acquérir) des investissements relevant de la politique d'investissement (directement ou par

l'intermédiaire d'une société holding d'investissement), d’effectuer des investissements de suivi, de vendre (ou accepter de
vendre), d’échanger ou autrement de disposer de ces investissements (ou accepter d’agir ainsi) et de préparer et de signer
les contrats liés aux investissements, les contrats de souscription et les pactes d’actionnaires, les contrats de vente et d'achat
et tous les autres actes et contrats en relation avec l'acquisition ou la cession d’investissements (soit personnellement soit
par l'intermédiaire d'un représentant ou tout autre agent);

(e) d’acquérir des investissements dans un syndicat avec d'autres investisseurs, directement ou par l'intermédiaire d'une

société holding d'investissement;

(f) d’emprunter de l'argent (directement ou à travers une société holding d'investissement) et de faire, émettre, accepter,

endosser et signer les billets à ordre, traites, lettres de change, les contrats de crédit et autres instruments et titres de créance;

(g) d’hypothéquer, nantir, transférer ou octroyer une sûreté à un fournisseur de finances d’un fiduciaire de sûreté ou

autrement sur tout ou partie des actifs de la Société et d’octroyer à tout prêteur pertinent une procuration afin d'émettre des
avis d’appel de fonds ou autrement de traiter avec et de faire respecter tous les droits en relation avec les engagements en
son nom, dans chaque cas, en liaison avec toutes les obligations de la Société;

(h) de donner des garanties et des indemnités en relation avec les investissements, y compris toute obligation d'une

société  holding  d'investissement  et  /  ou  la  société  de  portefeuille  et  /  ou  de  toute  autre  entité  détenue  directement  ou
indirectement, en tout ou en partie par la Société que le Gérant estime nécessaire ou souhaitable;

(i) de surveiller la performance de et, le cas échéant, de nommer les gérants, les dirigeants, les administrateurs, les

membres du directoire ou du conseil de surveillance, les censeurs ou toute autre position équivalente dans la société de
portefeuille, d’exercer tous les droits conférés à la Société selon les termes de tout contrat lié à l'investissement ou autrement
à l'égard de la société du portefeuille, d’assurer la liaison avec, consulter, assister ou procurer une assistance à la société
de portefeuille et aux sociétés holding d'investissement et de recevoir des commissions de ce dernier et généralement de
prendre toutes mesures que le Gérant considère appropriées pour la protection des actifs de la Société;

(j) de conclure des contrats de change à terme et d'investir dans des devises ou des contrats de change à terme ou des

options sur devises ou des contrats pour différences ou autres instruments (dans chaque cas, directement ou par l'intermé-
diaire d'une société holding d'investissement) en vue de couvrir les risques liés aux taux de change ou aux taux d'intérêt,
étant entendu que l'omission de prendre couverture ou autrement, de conclure des arrangements pour couvrir le risque de
pertes en raison des mouvements des taux de change ou d'intérêt, ne constitue pas une violation d'une obligation par le
Gérant envers toute personne, et que de telles couvertures or arrangements ne sont pas effectués dans but spéculatif;

(k) en attendant l'utilisation des montants appelés conformément au contrat social de la Société ou reçus par la Société

(le cas échéant), de placer ces sommes dans des comptes de dépôt ou de les investir dans des instruments à court terme;

(l) d'ouvrir et de maintenir des comptes bancaires pour et au nom de la Société, de donner paiement et autres instructions

aux banques à l'égard de ces comptes et de recevoir et de payer sur ces comptes les engagements avancés par les associés,
les revenus des investissements, les sommes découlant de la cession des investissements et tous autres montants reçus par
la Société;

(m) de remplir toutes les obligations de la Société, y compris le paiement des commissions et dépenses visées dans le

contrat social de la Société, et de se prémunir contre des obligations et éventualités présentes ou futures envisagées;

(n) de payer ou d’ordonner à la Société de payer tous les montants des impositions pour lesquelles l’Associé Commandité,

le Gérant, tout affilié de ces entités ou la Société est responsable au nom de tout associé commanditaire, étant entendu que
le Gérant doit préalablement donner notice à cet associé commanditaire de cette obligation fiscale et fera ses meilleurs
efforts, aux frais de cet associé commanditaire, pour s’assurer que le montant calculé est dû en réalité, et de payer le montant
de l’imposition due par tout associé ou la Société au nom de l’Associé Commandité, le Gérant, leurs affiliés ou la Société;

(o) de payer à toute partie indemnisée ou toute personne indemnisée (y compris l’Associé Commandité, le Gérant et

toutes les sociétés affiliées au Gérant) les montants pour lesquels le Gérant, agissant de bonne foi, pense qu’une telle
personne ait droit conformément aux dispositions du contrat social de la Société;

(p) d'effectuer des distributions aux associés en conformité avec les termes du contrat social de la Société;
(q) de nommer un dépositaire des actifs de la Société et de conclure un contrat de dépositaire entre la Société et ce

dépositaire, et de donner l’ordre de règlement et toutes autres instructions à ce dépositaire;

(r) de nommer un agent administratif, de registre et de transfert et de conclure un contrat d’agent administratif, de transfert

et de registre entre la Société et cet agent administratif, de registre et de transfert, et de donner l’ordre de règlement et toutes
autres instructions à ce dépositaire;

(s) d’engager des employés, des agents indépendants (y compris des agents de placement), des dépositaires, des agents

payeurs et collecteurs et des conseillers professionnels ou financiers ou des consultants que le Gérant considère nécessaires
ou souhaitables en ce qui concerne les affaires de la Société, qui peuvent être des sociétés affiliées au Gérant à condition
que ces engagements soient conclus dans des conditions de concurrence normale;

(t) de commencer, de conduire, de défendre ou de régler tout litige concernant la Société ou l'un des actifs de la Société;

105310

L

U X E M B O U R G

(u) d’enregistrer et de publier tous les avis, déclarations ou autres documents qui peuvent être requis en vertu de la Loi

de 1915 qui doivent être enregistrés et publiés dans le cadre de la formation de la Société et en relation avec tous les
changements qui peuvent affecter la Société (dans la mesure où l’Associé Commandité est informé de ces modifications);

(v) de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Société d’être qualifiée ou de continuer à être qualifiée

comme un "VCOC" au sens du plan assets regulation ou pour permettre à la Société d’être traitée, à des fins fiscales
américaines fédérales, étatiques ou locales comme un fonds et non comme une association imposable comme une société,
y compris, sans limitation, le dépôt de toute élection ou déclaration faites par la Société auprès des autorités américaines
compétentes;

(w) d’accepter et de conserver pour le Gérant et / ou les sociétés affiliées au Gérant sur leur propre compte, l’intégralité

des commissions de transaction, commissions liés aux investissements et commissions d’interruption;

(x) au nom et de manière à lier la Société en tant que telle, de conclure, de faire et de réaliser des actes, documents,

contrats, engagements, garanties et indemnités que le Gérant peut raisonnablement juger nécessaires ou souhaitables dans
le cadre de l'exercice de ses pouvoirs en vertu du contrat social de la Société ou autrement dans la conduite de l'activité de
la Société;

(y) de faire, exécuter, signer et déposer (i) le contrat social de la Société, des instruments, documents, ou tout homologue

de ceux-ci liés aux transferts de participations dans la Société faits conformément au contrat social de la Société, (ii) les
modifications du contrat social, et (iii) tous les autres instruments, documents, déclarations et certificats qui peuvent de
temps à autre être requis par la Loi de 1915 et la Loi GFIA, ou toute autre loi, ou jugés nécessaires par le Gérant afin de
réaliser, mettre en oeuvre et de continuer l'existence valide et l’activité de la Société, ou requis par le contrat social de la
Société;

(z) de conclure tout accord annexe (side letter) avec des associés commanditaires, sous réserve des dispositions du

contrat social de la Société;

(aa) de communiquer, utiliser et divulguer des informations concernant la Société et les associés commanditaires, y

compris les noms des associés commanditaires et leurs parts d’intérêts respectifs dans la Société à des investisseurs po-
tentiels, à des contreparties, à des prêteurs, à des prestataires de services ou à toute personne ainsi que requis par les lois
applicables, et de gérer de manière adéquate la Société et son portefeuille, et en particulier de se conformer aux lois et
règlements applicables, y compris les lois ou règlements relatifs au blanchiment ou à la lutte contre le terrorisme; les associés
commanditaires doivent fournir au Gérant, rapidement sur demande, toutes les informations que le Gérant juge raisonna-
blement nécessaire pour se conformer à ces lois et règlements;

(bb) étant entendu que le Gérant ne doit pas avoir le pouvoir ou l'autorité de faire tout ce qui serait contraire à une

disposition du contrat social de la Société;

(cc) généralement faire toutes les autres choses pour le compte de la Société qui de l'avis du Gérant peuvent être né-

cessaires ou accessoires aux buts ou à l’objet de la Société, tels que décrits.

La Société est liée envers les tiers à tous égards par le Gérant ou, le cas échéant, par toute personne à laquelle le Gérant

déléguera le pouvoir de signature.

La Société sera exclusivement représentée par le Gérant conformément à ses pouvoirs de gestion mentionnés ci-dessus.

4. Date à laquelle la société doit commencer et celle où elle doit finir. Les activités de la Société ont débuté à sa création,

le 27 avril 2016, et devront prendre fin à la première des deux (2) dates suivantes: (i) l’expiration du mandat d’Astorg VI,
y compris si la durée du mandat est prolongée, et (ii) la date à laquelle la Société a transféré ou liquidé tous ses intérêts
dans l’investissement et peut être dissoute, sauf en cas de dissolution anticipée telle que prévue dans le contrat social de la
Société. Nonobstant ce qui précède, la durée de la Société ne doit pas dépasser une période de dix (10) ans à compter de
la première date de clôture de la Société.

5. Exercice social. L'exercice de la Société débute chaque année au premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente-et-un

(31) décembre de la même année. A titre d’exception, le premier exercice débutera à la date d’admission des premiers
investisseurs dans la Société (first closing) et prendra fin au trente-et-un (31) décembre 2016, et le dernier exercice prendra
fin à la date finale de liquidation de la Société.

Référence de publication: 2016116660/298.
(160091061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2016.

Paris Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 157.281.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111921/9.
(160084782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

105311

L

U X E M B O U R G

OA Consulting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 114.730.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016111901/9.

(160085067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Polypin S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 750.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 166.807.

Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016111929/9.

(160084280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Psyrion Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 157.978.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016111935/9.

(160084841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Pavinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 92.017.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016111940/9.

(160084442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Pilenga Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.508.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016111946/9.

(160085005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

105312


Document Outline

Astorg VI Co-Invest Parkeon

Basler HoldCo S.à r.l.

Cardif Lux Vie

Chimtex S.A.

DREF SECURITIZATION SA

EVRAZ Greenfield Development S.A.

Familiar S.A., SICAV-SIF

Global Bond Series III, S.A.

Global Bond Series I, S.A.

IPA Holding S.A.

J.D. Farrods Group (Luxembourg) SA

JLC Lux S.à r.l.

J.Net

Kalnis International S.A.

Kanter Consolidated Investments

Karabay Sàrl

Kashevarmorneftegaz S.à r.l.

Kebec S.A.

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl

Kiowatt Pellets S.A.

KM Licensing S.à r.l.

Kropz International S.à r.l.

L'adresse S.à r.l.

Lappara Holding S.à r.l.

LaSalle AIFM Europe S.à r.l.

Lauriston Holding S.à r.l.

LB Immo Invest LUX S.à r.l.

Lending Opportunities Holdings S.à r.l.

L-GAM Investments

LGT Fund Management (Lux) S.A.

LHF Management S.à r.l.

L'ilot S.à r.l.

Locasierra S.à.r.l.

Logicor Topco II S.à r.l.

Logiver S.A.

Logix XV S.à r.l.

Lombard Intermediation Services S.A.

Lorac Investment Management S.à r.l.

Lucbeteiligung AG

Lucbeteiligung AG

Lucbeteiligung AG

LuxCo UK S.à r.l.

Luxempart

Luxonen S.A.

Luxonen S.A.

LVS II Lux VII S.à r.l.

Mafrem Holding S.A.

Magadanmorneftegaz S.à r.l.

Magadanmorneftegaz S.à r.l.

MainFirst SICAV II

Meerapfel Management Services S.A.

Melmal Newmedia Sàrl

MGE Vancouver S.à r.l.

MGE Vernon S.à r.l.

MGM Constructions S.à r.l.

Mistral Finance S.A.

M.M Management s.à r.l.

Mont Cervin S.à r.l.

Moorea Fund

Morninglight Investments S.à r.l.

Mosaic Trading

MultiConcept Fund Management S.A.

Murex Group S.A.

Must Properties and Investments S.A.

My-Next-Home S.à r.l.

NAC Luxembourg I S.A.

Nashorn Logistics Holdco S.à r.l.

Nashorn Logistics Pledgeco S.à r.l

Nashorn Logistics Topco S.à r.l.

Natural Le Coultre Luxembourg S.A.

Nemab S.à r.l.

Network Plus Holding S.A.

Newluxco 4 S.A.

Nezu Group S.à r.l.

NHC Holding S.à r.l.

NII International Holdings S.à r.l.

Nizi International S.A.

Nizi Luxembourg S.A.

Novadelta Luxembourg

Nova Sicav

NuLand Limited

OA Consulting, S.à r.l.

Ochtrup Phase 3 S.à r.l.

Onex BP

Onex Jack's Holding Limited

Paris Immo S.à r.l.

Pavinvest S.A.

Pilenga Holding S.A.

PM-International AG

Polypin S.à r.l.

Psyrion Trading S.à r.l.

SAF-Holland S.A.

Santander European Investments Lux S.à r.l.

Triton Masterluxco 3 S.à r.l.

Triton Masterluxco 4 S.à r.l.

UBI SICAV

UBI SICAV

York Global Finance 51 S.à r.l.

York Global Finance 52 S.à r.l.

York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.à r.l.