This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2137
20 juillet 2016
SOMMAIRE
Imerys Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102537
Imerys Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102534
Imm. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102533
Immobilière Ecole Européenne Bertrange/Ma-
mer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102537
Immo Prime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102536
Indau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102534
Inesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102535
International Group Company S.A. . . . . . . . .
102535
Interstate Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102536
INVESCO European Hotel Real Estate S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102535
Invesco Hanover Hotel Investment S.à r.l. . . .
102536
Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102536
Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l. . . . .
102536
IPN Unternehmensberatung S.A. . . . . . . . . . .
102535
Jacaranda Investissements S.A. . . . . . . . . . . . .
102537
Jalor Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102537
Japan Real Estate Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . .
102534
K-Erlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102538
LB Immo Invest LUX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
102560
Les Résidences sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102538
Lhold S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102538
Lombard Intermediation Services S.A. . . . . . .
102538
Makena Capital Luxco B . . . . . . . . . . . . . . . . .
102539
M-Square Finance S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .
102539
PTC Essen Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102539
Qualtec S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102532
Reconsultholding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102531
Reconsult III Mainz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
102531
Robeq S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102532
RTL 9 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102532
Scubalux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102576
SDB Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102531
SOGEP spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102531
SouthBridge Europe Mezzanine S.C.A. SICAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102530
Stëftung Hëllef Doheem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102563
ST Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102530
St Martin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102540
Strategic Value Credit General Partner S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102550
Sword Group SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102530
Tamweelview European Holdings S.A. . . . . . .
102570
Tang Chu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102530
Telefónica Insurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
102531
T&F Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102531
THB JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102573
Tovra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102533
TreeTop Global Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102533
TreeTop Global Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102533
TreeTop Scolea SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102532
102529
L
U X E M B O U R G
SouthBridge Europe Mezzanine S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 186.773.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 4 mai 2016i>
En date du 4 mai 2016, l'Assemblée Générale Annuelle a décidé:
- de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé, jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Southbridge Europe Mezzanine SCA SICAR
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2016108895/16.
(160080782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
ST Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.500.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 198.197.
Suite aux résolutions du conseil de gérance prises en date du 23 mars 2016 avec effet au 4 avril 2016, il a été décidé que
la ST Holdings S.à r.l. a change d'adresse comme suit
Du: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Au: 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016108914/14.
(160080791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Sword Group SE, Société Européenne.
Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 168.244.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016108919/11.
(160081193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Tang Chu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 97, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 197.335.
En date du 14/03/2016, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:
- Xiuqing LI demeurant au 195, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg a cédé les trente (30) parts sociales qu'elle
détenait à Monsieur Xialong HE demeurant au 46, rue Demy Schlechter, L-2521 Bonnevoie,
Au terme de cette cession de parts sociales, la répartition du capital de la société est la suivante:
Monsieur Xiaolong HE détient les 100 (cent) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108922/13.
(160081373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
102530
L
U X E M B O U R G
SOGEP spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, Av. JF Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.544.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016108912/10.
(160080723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
T&F Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 152.573.
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration prises en date du 29 avril 2016i>
En date du 29 avril 2016, le Conseil d’administration a décidé de:
- Prendre acte de la démission de Pricewaterhousecoopers Sàrl de son mandat de réviseur d’entreprises agréé avec effet
immédiat.
- Nommer Deloitte Audit, ayant son siège social au 560 route de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en qualité de réviseur
d’entreprises agréé, avec effet immédiat, pour une période de deux ans, jusqu’à l’assemblée générale de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
T&F LUXEMBOURG SA
Référence de publication: 2016108921/16.
(160081258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Telefónica Insurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.162.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016108923/10.
(160081110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
SDB Benelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R.C.S. Luxembourg B 45.143.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108905/9.
(160081040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Reconsult III Mainz S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Reconsultholding S.à r.l.).
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 196.797.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108865/9.
(160081293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
102531
L
U X E M B O U R G
Qualtec S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, 6, Hauptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 114.143.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016108863/10.
(160080844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Robeq S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 129.933.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016108875/10.
(160081237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
RTL 9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 50.987.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2014 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 12 mai 2016.
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016108880/16.
(160081304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
TreeTop Scolea SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 134.098.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 19 avril 2016i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Jacques BERGHMANS, Hubert D'ANSEMBOURG, André BIRGET, François MAISSIN et
John PAULY, en qualité d'administrateurs, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2017,
2. de réélire la société PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative, en qualité de Réviseur d'Entreprises,
pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2017.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
<i>Pour TreeTop Scolea SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016108930/18.
(160081340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
102532
L
U X E M B O U R G
TreeTop Global Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.170.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 19 avril 2016i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Jacques BERGHMANS, Hubert D'ANSEMBOURG, André BIRGET, François MAISSIN et
John PAULY, en qualité d'administrateurs, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2017,
2. de réélire la société PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative, en qualité de Réviseur d'Entreprises,
pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2017.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
<i>Pour TreeTop Global SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016108928/18.
(160081356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Tovra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1A, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 172.794.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 28 avril 2016i>
Le siège social de la société est transféré du 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg au 1A, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016108926/12.
(160081223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
TreeTop Global Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.170.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
<i>Pour TreeTop Global SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016108927/13.
(160081292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Imm. Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 47.908.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IMM.LUX S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016110243/11.
(160082854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
102533
L
U X E M B O U R G
Imerys Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 32.615.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 15 avril 2016i>
- L'Assemblée décide de ratifier la cooptation en tant qu'administrateur de la société Risk & Reinsurance Solutions SA
en abrégé «2RS» représentée par Monsieur Alain Sougnez, tous deux demeurant professionnellement au 23 avenue Mon-
terey L-2163 à Luxembourg. L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateurs de Madame Laurence
BEYER et de Monsieur Denis MUSSON.
Les trois mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social
2016.
- L'Assemblée reconduit ERNST & YOUNG (B47 771), 35e Avenue John F. Kennedy à L-1855 Luxembourg en tant
que Réviseur d'Entreprises agréé de la société, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016110242/19.
(160082567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Indau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.946.079,82.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 42.253.
Veuillez prendre note des changements intervenus suite aux résolutions des associés de la Société prises le 11 mai 2016:
- Acceptation de la démission de Monsieur VAN RIJCKEVORSEL Jhr T.C. en qualité de Gérant de la Société à compter
du 11 mai 2016.
- Acceptation de la nomination de Madame Barcons Bellido Cristina, née le 16 janvier 1973 à Barcelona, Espagne, ayant
son adresse professionnelle au 23, Calle Canaries, 08017 Barcelona, Espagne, en qualité de Gérant unique de la Société à
compter du 11 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016110245/18.
(160083053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Japan Real Estate Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 173.924.
<i>Auszug aus den Beschluesse des Verwaltungsrates vom 10. Mai 2016i>
1. Der Gesellschaftssitz wird mit Wirkung zum 18. April 2016 von 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
nach 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg verlegt.
2. Die professionelle Anschrift der Kategorie A Verwaltungsratsmitglieder wird sich ebenfalls mit Wirkung vom 18.
April 2016 ändern:
- Herr Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, mit professioneller Anschrift 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg
- Herr Marc ALBERTUS, employé privé, mit professioneller Anschrift 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Luxemburg, den 17. Mai 2016.
Für die Richtigkeit des Auszugs
Référence de publication: 2016110258/17.
(160082521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
102534
L
U X E M B O U R G
Inesia S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 66.931.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 4 avril 2016i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de:
* Paul Lawrence, Administrateur de la Société, et ce avec effet au 8 avril 2016;
- de nommer:
* Monsieur Stephen Osmont, né le 14 mai 1978 à Jersey, ayant son adresse professionnelle au 1
er
étage, Centre Descartes,
287-289 Route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 4 avril 2016 et ce pour
une durée déterminée, à renouveler pendant l'assemblé générale qui se tiendra en l'année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016110247/18.
(160082629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
International Group Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Docteur Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 43.932.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 10 mai 2016i>
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 10 mai 2016:
Le conseil à la majorité des membres prend acte de la démission au poste d'administrateur de:
- Madame Fara CHORFI.
Le conseil à la majorité des membres décide de nommer en son remplacement au poste d'administrateur jusqu'à l'As-
semblée Générale d'approbation des comptes qui se tiendra en 2017 de:
- Monsieur Sébastien THIBAL, né le 21 février 1976 à Perpignan (France), demeurant professionnellement 11, boulevard
Docteur Charles Marx L-2130 Luxembourg.
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016110248/16.
(160083216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
INVESCO European Hotel Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.686.
Die Geschäftsführerin Marion Geniaux hat mit Wirkung zum 13.05.2016 ihr Mandat als Geschäftsführerin der Gesell-
schaft niedergelegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016110249/10.
(160082868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
IPN Unternehmensberatung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5444 Schengen, 16, beim Schlass.
R.C.S. Luxembourg B 105.033.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schengen, den 17.05.2016.
Référence de publication: 2016110253/10.
(160082901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
102535
L
U X E M B O U R G
Interstate Europe, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 141.872.
Les comptes annuels de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016110236/11.
(160082469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Immo Prime S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 14, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 133.518.
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 mars 2016 que:
- Le siège social de la société va être transféré à 14, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg à partir du 1
er
avril 2016.
Fait à Luxembourg, le 18 mars 2016.
<i>Pour Immo Prime S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2016110234/13.
(160083113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Invesco Hanover Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.335.
Die Geschäftsführerin Marion Geniaux hat mit Wirkung zum 13.05.2016 ihr Mandat als Geschäftsführerin der Gesell-
schaft niedergelegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016110237/10.
(160082866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 143.783.
Die Geschäftsführerin Marion Geniaux hat mit Wirkung zum 13.05.2016 ihr Mandat als Geschäftsführerin der Gesell-
schaft niedergelegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016110238/10.
(160082864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.881.
Die Geschäftsführerin Marion Geniaux hat mit Wirkung zum 13.05.2016 ihr Mandat als Geschäftsführerin der Gesell-
schaft niedergelegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016110239/10.
(160082865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
102536
L
U X E M B O U R G
Imerys Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 32.615.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Ce
dépôt rectifie le dépôt L150073922 effectué le 29/04/2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016110241/11.
(160082484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Immobilière Ecole Européenne Bertrange/Mamer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 21.307.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016110244/10.
(160083146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Jacaranda Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 108.876.
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 avril 2016i>
L’assemblée accepte la démission de Madame Martina GATTO.
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2019:
- Madame Giovanna CIPRIANI, demeurant au 48 via Sistina, 00187 Rome, Italie;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxem-
bourg;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg;
- Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, demeurant au 1, rue Jean Piret, L-2350, Luxembourg;
- Monsieur Arrigo CIPRIANI, demeurant au 269, Dorsoduro I-30123 venise, Italie.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2019:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 1, rue Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016110262/22.
(160083040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Jalor Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 69.601.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JALOR FINANCE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016110263/11.
(160082396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
102537
L
U X E M B O U R G
Les Résidences sa, Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 35.243.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale tenue au siège social de la société le 4 avril 2016i>
Il a été décidé, à l’unanimité:
- De révoquer le Commissaire aux comptes TP Management (Luxembourg) SA, société établie 23, Grand-rue à L-8372
Hobscheid et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B62998,
- De nommer Fiduciaire Internationale SA, Route d’Esch, 7 à L-1470 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B34813, en tant que Commissaire aux comptes pour une période venant à échéance lors de
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui se
tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 25 avril 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016110296/19.
(160082540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Lhold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 44.990.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 5, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 203.656.
EXTRAIT
En date du 29 février 2016, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Bart de Sonnaville, en tant que gérant de classe A de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Yvonne Theuns, ayant son adresse professionnelle au WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 231, B-Tower, 5
th
floor, 1118 BH Schiphol, the Netherlands, est nommé gérant de classe A de la société avec effet immédiat, pour une
durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016110298/16.
(160082883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 156.671.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Audrey Coque.
Référence de publication: 2016110301/10.
(160083000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
K-Erlen, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 135.368.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016110273/9.
(160082813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
102538
L
U X E M B O U R G
M-Square Finance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 82.901.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que Madame Rika Mamdy, née le 04 novembre 1946 à Diksmuide (Belgique), avec adresse professionnelle 12D,
Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite
au numéro RCS B 99746 et ayant son siège social au 12 Impasse Drosbach, bâtiment D, L-1882 Luxembourg, à partir du
1
er
décembre 2015 et ce en remplacement de Monsieur Patrick Goldschmidt.
- que Madame Rika Mamdy, née le 04 novembre 1946 à Diksmuide (Belgique), avec adresse professionnelle 12D,
Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au
numéro RCS B 99747 et ayant son siège social au 12 Impasse Drosbach, bâtiment D, L-1882 Luxembourg, à partir du 1
er
décembre 2015 et ce en remplacement de Monsieur Jean-Bernard Zeimet.
- que Madame Rika Mamdy, née le 04 novembre 1946 à Diksmuide (Belgique), avec adresse professionnelle 12D,
Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite
au numéro RCS B 99739 et ayant son siège social au 12 Impasse Drosbach, bâtiment D, L-1882 Luxembourg, à partir du
1
er
décembre 2015 et ce en remplacement de Monsieur Patrick Goldschmidt.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
<i>Pour M-Square Finance S.A. SPFi>
Référence de publication: 2016110335/24.
(160082766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Makena Capital Luxco B, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 140.814.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 17 mai 2016i>
1) Madame Anne Bridget STORM a démissionnée de son mandat de gérant A.
2) Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant B.
3) Monsieur Paul ROSTKOWSKI, gérant de société, né à Rabat (Malte), le 10 octobre 1987, demeurant profession-
nellement au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg a été nommé comme gérant B pour une durée illimitée.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Makena Capital Luxco B
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016110337/16.
(160083192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
PTC Essen Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 117.290.
- Mons. David Moscato, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est
nommé administrateur de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mme. Laurie Domecq, avec effet
au 29 avril 2016.
- Le nouveau mandat de Mons. David Moscato prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.
Luxembourg, le 28 avril 2016.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016111209/14.
(160084041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
102539
L
U X E M B O U R G
St Martin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxemburg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 206.045.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the sixth day of May.
Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Independent Star Venture, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 186763, having its
registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Maître Michael Jonas, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 29 April and 3 May 2016.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which he/she wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name “St
Martin S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 An additional purpose of the Company is the direct and indirect acquisition and sale of real estate properties either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or
foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease
of real estate properties.
2.5 The Company may carry out any commercial, financial, real estate or intellectual property activities which it con-
siders useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
102540
L
U X E M B O U R G
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may repurchase its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
102541
L
U X E M B O U R G
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class
A managers (the “Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”). Any reference made hereinafter
to the “managers” shall be construed as a reference to the Class A Managers and/or the Class B Managers, depending on
the context and as applicable.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, without cause, by a decision of the
shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager or by one (1) Class A Manager and one (1) Class B
Manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
102542
L
U X E M B O U R G
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers, the board of managers may deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one
(1) Class B Manager is present or represented at the meeting.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event
the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, decisions shall be taken by a majority of
the managers present or represented including at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by (i) the chairman, if any or in his absence
by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or (ii) any two (2) managers or, by one (1) Class A Manager and
one (1) Class B Manager if applicable. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by two (2) managers or, by one (1) Class A Manager and one (1)
Class B Manager if applicable.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties.
19.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager,
or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers or, by the joint signatures of one
(1) Class A Manager and one (1) Class B Manager if applicable, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The statutory auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company may also be allocated to the legal reserve.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
102543
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last financial year of which the annual accounts have been approved, increased
by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders pro rata to their shareholding.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed as follows:
- twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Independent Star Venture, aforementioned,
represented as stated above, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR
1,400).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Ian Chappell, born in Croydon, United Kingdom, on 29 January 1969, professionally residing at 155 Bishopsgate,
London, EC2M 3XJ, United Kingdom is appointed as manager;
(ii) Michel Martin, born in Metz, France, on 3 May 1981, professionally residing at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as manager; and
(iii) Renaud Ransy, born in Liège, Belgium, on 28 April 1982, professionally residing at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as manager.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
102544
L
U X E M B O U R G
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendsechzehn, am sechsten Tag des Monats Mai.
Vor uns, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Independent Star Venture, eine société à responsabilité limitée bestehend nach dem Recht vom Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 186763, mit Sitz in 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,
hier vertreten durch Maître Michael Jonas, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privaschriftlichen Vollmacht welche am 29. April und am 3. Mai 2016 ausgestellt wurde.
Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu
werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen will:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen “St Martin S.à r.l.“ (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Ein weiterer Gesellschaftszweck ist der Erwerb und Verkauf von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,
deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung
von Immobilien ist.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art
und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
102545
L
U X E M B O U R G
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus
zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Aussetzung der Bürgerrechte, die Auflösung, den Konkurs, die
Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der
überlebenden Gesellschafter mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden.
Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile den Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden
Ehepartner/in übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und diese Satzung aus-
drücklich vorbehalten sind.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, können gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein Stimmrecht
schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-
lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufung zu dieser
Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher
in der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend
oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung
auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
102546
L
U X E M B O U R G
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Gesellschafter ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den „Einzelgeschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt. Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A (die „Geschäftsführer der Kategorie A“) und Geschäftsführer der
Kategorie B (die „Geschäftsführer der Kategorie B“). Jeder Bezug auf die „Geschäftsführer“ in der vorliegenden Satzung
ist als Bezug auf die Geschäftsführer der Kategorie A und/oder die Geschäftsführer der Kategorie B, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche
Amtszeit des zu ersetzenden Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversamm-
lung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen über die endgültige
Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines (1) beliebigen Geschäftsführers oder eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum
zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dring-
lichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer
schriftlich, per Fax, EMail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben,
wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen
des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäfts-
führungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
102547
L
U X E M B O U R G
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien
von Geschäftsführern ernannt hat, kann der Geschäftsführungsrat nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest
ein (1) Geschäftsführer der Kategorie A und ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B in der Sitzung anwesend oder vertreten
sind.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat, werden Beschlüsse mit der Mehrheit der an der Sitzung teilnehmenden oder
vertretenen Geschäftsführer, welche mindestens einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer
der Kategorie B enthält, gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden, hat im Falle von Stimm-
gleichheit nicht die entscheidende Stimme.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats; Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird (i) vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, falls
vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhan-
den), oder (ii) von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B, falls vorhanden, unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungs-
rates, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie
A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B, falls vorhanden, unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige
Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten.
19.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des Einzelgeschäftsfüh-
rers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2)
beliebigen Geschäftsführern, oder durch die gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines
(1) Geschäftsführers der Kategorie B, falls vorhanden, oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige
Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden
ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsund Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen,
in seiner geänderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréés) ernennen,
entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
102548
L
U X E M B O U R G
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 In andere Rücklagen erbrachte Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz
von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für welches
der Jahresabschluss genehmigt wurde, angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die nach dem Gesetz
von 1915 oder dieser Satzung einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter pro rata zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember
2016.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
- Zeichnung von zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen durch Independent Star Venture, vorbenannt, verteten wie
vorgenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500).
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ab sofort ein Betrag
in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nach-
gewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftska-
pital zugeführt.
102549
L
U X E M B O U R G
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
oder Auslagen werden auf eintausendvierhundert Euro (EUR 1,400) geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Die Gründer, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und welche auf eine formelle Einberufungsbe-
kanntmachung verzichten, haben folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
(i) Ian Chappell, geboren am 29. Januar 1969 in Croydon, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig in 155 Bishopsgate,
London, EC2M 3XJ, Vereinigtes Königreich, wird zum Geschäftsführer ernannt;
(ii) Michel Martin, geboren am 3. Mai 1981 in Metz, Frankreich, geschäftsansässig in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wird zum Geschäftsführer ernannt; und
(iii) Renaud Ransy, geboren am 28. April 1982 in Lüttich, Belgien, geschäftsansässig in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg wird zum Geschäftsführer ernannt.
Worüber Urkunde Aufgenommen in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf
Ersuchen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll
die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welcher dem Notar mit
Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte diese Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.
Signé: M. Jonas, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 11 mai 2016. GAC/2016/3694. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016108899/570.
(160081202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Strategic Value Credit General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 206.131.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh of April.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
MaplesFS Limited, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with Cayman
Islands Monetary Authority under number 96041, having its registered office at PO Box 1093, Queensgate House, Grand
Cayman, KY1-1102, Cayman Islands;
here represented by Mrs Arlette Siebenaler, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given April 25, 2016.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the
shares hereafter issued a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name Strategic Value Credit
General Partner S.à r.l. (the “Company”), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular by the law dated 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Company Law”), as well
as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).
102550
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company shall in particular be ap-
pointed and act as managing general partner (associé gérant commandité) of Strategic Value Credit Fund SLP, a special
limited partnership (société en commandite spéciale), subject to the Company Law.
2.2 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
2.3 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders of
the Company adopted in the manner required for an amendment of the Articles.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg City by a resolution of the board of managers of the
Company.
4.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that
extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or
events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad (which country shall
not be the United Kingdom), until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company has a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) consisting of one hundred
and twenty-five (125) shares in registered form fully paid up with par value of one hundred euros (EUR 100) each.
5.2 The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a
resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the
Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than twelve thousand five hundred
euros (EUR 12,500).
Art. 6. Shares.
6.1 The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives).
6.2 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the fraction of the share capital of the Company represented by such share, increased by the amount of the share premium,
if any, paid with respect to such share.
6.3 A shareholders' register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be
available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or
elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and
the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.
6.4 The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that
purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1 Shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the issued share capital of the
Company. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance
by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg civil code.
7.2 For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Company Law.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.
8.1 Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the
Company.
102551
L
U X E M B O U R G
8.2 The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held at the registered office of the Company
within six months of the close of the financial year.
8.3 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
8.4 If there are not more than 25 (twenty-five) shareholders in the Company, the decisions of the shareholders may be
taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by
telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures
of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced
by letter or facsimile.
8.5 If there is only one single shareholder in the Company, the single shareholder assumes all powers conferred by the
Company Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the single shareholder are set out in a written
resolution executed by or on behalf of the single shareholder. Any reference to the “shareholders”, to the “meeting of
shareholders” and to the “general meeting of shareholders” in these Articles shall be understood as, respectively, the “sole
shareholder” and the “resolutions of the sole shareholder” when the context so requires.
Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
9.1 The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of share-
holders of the Company, unless otherwise provided herein.
9.2 Each share is entitled to one vote.
9.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company
duly convened will be passed by the shareholders representing more than one half of the total issued share capital of the
Company.
9.4 The shareholders may not resolve upon the following transactions without the consent of a majority of the share-
holders representing at least three-quarters of the total issued share capital of the Company:
(i) to amend, alter or repeal (including any amendment, alteration or repeal effected by merger, consolidation or similar
business combination) any provision of the Articles; and
(ii) to dissolve and/or liquidate the Company.
9.5 The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only
with the unanimous consent of the shareholders.
9.6 A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy
in writing whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex.
9.7 If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,
and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.
D. Management
Art. 10. Management.
10.1 The Company shall be managed by a board of managers composed of a minimum of three (3) managers. For the
purposes of these Articles, any manager of the Company who also serves as partner, director, manager, officer or employee
of an investment manager or investment advisor which the Company has or may appoint in its capacity as managing general
partner (associé gérant commandité) of Strategic Value Credit Fund SLP shall be designated as a “Representative Manager”.
Managers of the Company who are not “Representative Managers” shall be designated as the “Independent Managers”.
The Independent Managers and Representative Managers each represent a separate category of managers.
10.2 The managers shall be appointed by the shareholders of the Company at the general meeting which shall also
determine the term of their office. The general meeting of shareholders shall also determine to which category each manager
belongs for the purposes of these Articles, in accordance with the requirements of Article 10.1 above.
10.3 A manager may be removed with or without cause and/or replaced at any time, by resolution adopted by the general
meeting of shareholders of the Company.
10.4 Managers shall be re-eligible. In the event of a vacancy in the office of a manager, the general meeting of the
shareholders of the Company shall be convened as soon as practicable in order to appoint a new manager, provided that
(i) the number of Representative Managers shall at no time constitute a majority, and (ii) notwithstanding a vacancy arising
in the office of manager, there shall be no obligation for the shareholders of the Company to appoint a replacement to such
vacancy (subject to those minimum requirements of Article 10.1).
Art. 11. Meetings of the board of managers of the Company.
11.1 The board of managers of the Company shall appoint a chairman among the Independent Managers and it may
choose a secretary (who need not be a manager) who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.
11.2 The board of managers of the Company shall meet upon call by any manager, at the place indicated in the notice
of meeting which, in principle, shall be in Luxembourg and shall never be in the United Kingdom.
102552
L
U X E M B O U R G
11.3 Written notice of any meeting of the board of managers of the Company shall be given to all managers at least
twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting (which will be a business day).
11.4 No such written notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the commencement of the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full
knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original,
by fax, e-mail, telegram or telex, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall
not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of
the board of managers of the Company.
11.5 Any member of the board of managers of the Company may act at any meeting of the board of managers of the
Company by appointing a proxy, who must also be member of the board of managers belonging to the same category.
11.6 Any manager may participate in a meeting of the board of managers of the Company by conference call or similar
means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
11.7 The board of managers of the Company can deliberate and/or act validly only if (i) a majority of the Company's
managers present or represented at the meeting of the board of managers of the Company are Independent Managers, or
(ii) at least two (2) of the Company's managers present or represented at the meeting of the board of managers of the
Company are Independent Managers. Decisions shall be validly taken by a majority of the managers present or represented
at the meeting. Each manager shall have one (1) vote, provided that in the event of a tie vote, the chairman of the board of
managers of the Company shall have a casting vote.
11.8 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers of the Company may also be passed in writing,
provided such resolution is preceded by a deliberation between the managers by such means as is, for example, described
in Article 11.6. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and
every manager (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.
Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers of the Company.
12.1 The minutes of any meeting of the board of managers of the Company shall be signed by the chairman of the board
of managers of the Company or by any two managers of the Company.
12.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the secretary (if any) or by any manager of the Company.
Art. 13. Powers of the board of managers of the Company. All powers not expressly reserved by Company Law or by
the Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
Art. 14. Delegation of powers. The board of managers of the Company is authorized to appoint any person, either
manager or not, or any entity, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders of the Company,
for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.
Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of
any manager of the Company or by the signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the
board of managers, but only within the limits of such power.
Art. 16. Conflict of interests.
16.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a manager, associate,
officer or employee of such other company or firm.
16.2 Any manager or officer of the Company who serves as manager, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.
16.3 In the event that any manager of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of
the Company, such manager shall make known to the board of managers of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager's interest therein,
shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify such trans-
action.
E. Audit and supervision
Art. 17. Auditor.
17.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.
102553
L
U X E M B O U R G
17.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
17.3 The statutory auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
17.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies' Register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
17.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Accounting year - Allocation of profits
Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company starts on the first day of January and finishes on the last
day of December each year.
Art. 19. Allocation of profits.
19.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profits. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
19.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
19.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the shareholders of the Company; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
19.4 The dividends may be paid in euro (EUR) or any other currency selected by the board of managers of the Company
and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers of the Company.
19.5 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the sharehol-
ders, subject to the provisions of the Company Law and these Articles.
G. Liquidation
Art. 20. Liquidation.
20.1 The liquidation of the Company shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general
meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s). The
dissolution and liquidation of the Company shall be carried out in accordance with the Company Law.
20.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
H. Financial information
Art. 21. Financial information.
21.1 The Company shall provide each shareholder with a copy of the annual accounts in respect of each financial year
within the period fixed by the Company Law.
21.2 The Company shall provide each shareholder with all information in relation to itself available to the Company
which may be reasonably required by a shareholder to meet tax and legal reporting obligations of the group of companies
of which the shareholder is part. Such information shall include but shall not be limited to all available tax filings, returns
and receipts, bank statements, books and other records of the Company.
21.3 The Company shall prepare its annual accounts in conformity with Luxembourg generally accepted accounting
principles.
Art. 22. Access to books and files of the Company. Each shareholder and its respective auditors and/or any person
appointed by the shareholder to whom the Company has no reasonable objection may, during normal business hours, have
access to the offices, buildings and sites of the Company and shall have the right to inspect and audit at its own expense
all books and records and to check all possessions owned by the Company.
I. Final clause - Governing law
Art. 23. Applicable laws. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Company Law.
102554
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the [thirty-
first December 2016].
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been entirely subscribed by MaplesFS Limited, prenamed.
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of 12,500 euros (EUR
12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder has passed the following resolutions:
1) The Company will be administered by the following managers:
- Henry Kelly, born on 05 October 1955 in Douglas Isle of Man, UK, residing professionally at 4, rue Jean-Pierre Lanter,
L-5943 Itzig, Grand Duchy of Luxembourg, as Independent Manager;
- William Jones, born on 11 February 1963 in New York, USA, residing professionally at 24, rue Beaumont L-1219
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Independent Manager;
- Nick Williams, born on 21 March 1956 in Lymington, UK, residing professionally at 77, Grosvenor Street, London,
W1K 3JR, UK, as Representative Manager; and
- Siu-Wai Ng, born on 18 January 1976 in Hong Kong residing professionally at 77, Grosvenor Street, London, W1K
3JR, UK, as Representative Manager.
The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the sole signature of any one manager.
2) The registered office of the Company is set at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder[s] of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder[s] of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-sept avril.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
MaplesFS Limited, une société constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, immatriculée auprès de la Monetary
Authority des Îles Caïmans sous le numéro 96041, ayant son siège social à PO Box 1093, Queensgate House, Grand
Cayman, KY1-1102, Îles Caïmans;
dûment représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée le 25 avril 2016.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il est établi par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires d'actions émises par
la suite une société à responsabilité limitée sous la dénomination Strategic Value Credit General Partner S.à r.l (ci-après
la «Société») qui sera régie par les lois du Grand- Duché de Luxembourg, notamment la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés»), ainsi que par les présents statuts (ci-après les
«Statuts»).
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l'acquisition de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes entreprises ou
sociétés de toute forme, et la gestion de telles participations. La Société doit en particulier être nommée et agir comme
102555
L
U X E M B O U R G
associé-gérant-commandité de Strategic Value Credit Fund SLP, une société en commandite spéciale, soumise à la Loi sur
les Sociétés.
2.2 La Société peut utiliser des techniques et instruments pour gérer efficacement ses investissements et se protéger
contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les risques de taux d'intérêt et d'autres risques.
2.3 La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions concer-
nant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés de la
Société, adoptée selon les conditions requises pour une modification des Statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance de la Société.
4.2 Des succursales, des filiales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand- Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
par décision du conseil de gérance de la Société. Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements
exceptionnels d'ordre politique ou militaire se sont produits ou seraient imminents, et que ces évènements sont de nature
à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social ou avec la communication entre ce siège et les personnes
à l'étranger, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger (à l'exception du Royaume Uni) jusqu'à la
cessation complète de ces circonstances exceptionnelles. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent vingt-cinq
(125) parts sociales nominatives entièrement libérées avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
5.2 Le capital social de la Société souscrit peut être augmenté par l'émission de parts sociales, ou réduit, par une décision
de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
En aucun cas, le capital social souscrit ne peut être réduit à un montant inférieur à douze mille cinq cents euros (EUR
12.500.).
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales de la Société sont et resteront nominatives.
6.2 Chaque part sociale donne droit au détenteur à une portion des actifs et bénéfices de la Société en proportion de la
portion du capital social de la Société représentée par cette part sociale, majorée du montant de la prime d'émission, le cas
échéant, payée eu égard à cette part sociale.
6.3 Un registre des associés de la Société est tenu au siège social de la Société, où il est mis à disposition de chaque
associé pour consultation. Ce registre indique le nom de chaque associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de
parts sociales détenues par lui, les montants versés pour chacune de ces parts sociales, et le transfert des parts sociales et
les dates de ces transferts. La propriété des parts sociales sera établie par l'inscription sur ce registre.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales sous réserve que la Société dispose de réserves distribuables
suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
Art. 7. Transfert des parts sociales.
7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Le transfert de parts sociales à de nouveaux associés est
subordonné à l'approbation de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social
émis de la Société. Toute cession de parts sociales sera uniquement opposable à la Société et aux tiers sur notification de
la cession à, ou après l'acceptation de la cession par, la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code
civil.
7.2 Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés.
C. Décisions des associés
Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'ensemble des associés de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes relatifs à toutes les opérations
de la Société.
8.2 L'assemblée générale annuelle des associés de la Société se tiendra au siège social de la Société dans les six mois
suivant la clôture de l'exercice fiscal.
8.3 D'autres assemblées des associés de la Société peuvent être tenues au lieu et heure spécifiés dans les avis de con-
vocation des assemblées en question.
102556
L
U X E M B O U R G
8.4 Dans l'hypothèse où la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions des associés pourront être
adoptées par résolution circulaire, dont le texte doit être envoyé à tous les associés par écrit, soit en original soit par
télégramme, télex, télécopie ou e-mail. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés peuvent apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être
prouvées par lettre ou par télécopie.
8.5 En cas d'associé unique de la Société, cet associé unique exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des
associés en vertu des dispositions de la Loi sur les Sociétés. Les décisions de l'associé unique sont énoncées dans une
résolution écrite signée par ou au nom de l'associé unique. Toute référence faite aux «associés», à «l'assemblée des associés»
et à «l'assemblée générale des associés» dans ces Statuts devra être entendue comme une référence à «l'associé unique» et
aux «résolutions de l'associé unique» selon le contexte.
Art. 9. Ordre du jour, quorum, procurations et avis de convocation.
9.1 Les délais de convocation et quorum requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées
des associés de la Société, sauf disposition contraire.
9.2 Chaque part sociale donne droit à une voix.
9.3 Sauf disposition contraire prévue par la loi ou par les présents Statuts, les résolutions d'une assemblée des associés
de la Société dûment convoquée seront prises par les associés représentant plus de la moitié de la totalité du capital émis
de la Société.
9.4 Les associés ne peuvent pas résoudre sur les opérations suivantes sans le consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts de la totalité du capital émis de la Société:
(i) modifier, changer ou abroger (y compris toute modification, changement ou abrogation effectuée par fusion, conso-
lidation ou regroupement d'entreprises similaires) toutes dispositions des Statuts; et
(ii) dissoudre et / ou liquider la Société.
9.5 La nationalité de la Société peut être changée et les engagements des associés ne peuvent être augmentés seulement
avec le consentement unanime des associés.
9.6 Un associé peut agir à toute assemblée des associés de la Société en désignant une autre personne comme son
mandataire par écrit, soit en original, par télécopie, courrier électronique, télégramme ou télex.
9.7 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à une assemblée des associés de la Société, et se
considèrent comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans
convocation.
D. Gérance
Art. 10. Gérance.
10.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un minimum de trois (3) gérants. Aux fins des présents
Statuts, tout gérant de la Société qui sert également en tant qu'associé, administrateur, gérant, agent ou employé d'un
gestionnaire ou d'un conseiller en investissement que la Société détient ou peut nommer en sa qualité d'associé-gérant-
commandité de Strategic Value Credit Fund SLP est désigné comme un «Gérant Représentatif». Les gérants de la Société
qui ne sont pas «Gérants Représentatifs» devront être désignés comme les «Gérants Indépendants». Les Gérants Indépen-
dants et les Gérants Représentatifs représentent chacun une catégorie distincte de gérants.
10.2 Les gérants sont nommés par les associés de la Société à l'assemblée générale qui détermine également la durée de
leur mandat. L'assemblée générale des associés doit également déterminer à quelle catégorie appartient chaque gérant pour
l'application des présents Statuts, conformément aux exigences de l'Article 10.1 ci-dessus.
10.3 Un gérant peut être révoqué avec ou sans motif et / ou remplacé à tout moment, par une résolution adoptée par
l'assemblée générale des associés de la Société.
10.4 Les gérants sont rééligibles. En cas de vacance du poste d'un gérant, l'assemblée générale des associés de la Société
sera convoquée le plus tôt possible, afin de nommer un nouveau gérant, à condition (i) que le nombre de Gérants Repré-
sentatifs ne constitue en aucun cas une majorité, et (ii) qu'en dépit d'une vacance survenant dans le bureau du gérant, il n'y
aura pas d'obligation pour les associés de la Société de nommer un remplaçant à ce poste (sous réserve des exigences
minimales de l'Article 10.1).
Art. 11. Convocation aux réunions du conseil de gérance de la Société.
11.1 Le conseil de gérance de la Société peut élire un président parmi les Gérants Indépendants et peut également désigner
un secrétaire (qui peut ne pas être un gérant) qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des assemblées des associés de la
Société et les procès-verbaux des assemblées générales des associés de la Société.
11.2 Le conseil de gérance de la Société se réunit sur convocation de tout gérant, au lieu indiqué dans la convocation,
qui en principe, doit être au Luxembourg et ne doit jamais être au Royaume Uni.
11.3 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance de la Société doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre
(24) heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation (qui sera un jour ouvrable).
11.4 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les membres du conseil de gérance seront
présents ou représentés à l'ouverture de la réunion et qu'ils déclarent avoir été dûment informés, et avoir eu connaissance
102557
L
U X E M B O U R G
de l'ordre du jour de la réunion. La convocation peut être peut être enlevée par le consentement par écrit, soit en original,
fax, e-mail, télégramme et télex, de chaque membre du conseil de gérance de la Société. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour les réunions qui ont lieu aux heures et lieux prescrits dans un calendrier préalablement adopté par résolution
du conseil de gérance de la Société.
11.5 Tout membre du conseil de gérance de la Société peut agir à toute réunion du conseil de gérance de la Société en
désignant un mandataire, qui doit également être membre du conseil de gérance appartenant à la même catégorie.
11.6 Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance de la Société par conférence téléphonique ou des
moyens similaires de communication permettant à tous les participants de la réunion d'entendre et de parler les uns aux
autres et de délibérer valablement, et participer à une réunion par de tels moyens constitue une présence en personne à une
telle réunion.
11.7 Le conseil de gérance de la Société ne peut délibérer et / ou agir valablement que si (i) la majorité des gérants de
la Société présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance de la Société sont des Gérants Indépendants, ou (ii)
au moins deux (2) des gérants de la Société présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance de la Société sont
des Gérants Indépendants. Les décisions seront valablement prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la
réunion. Chaque gérant aura un (1) vote, à condition que dans le cas d'une égalité des voix, le président du conseil de
gérance de la Société aura une voix prépondérante.
11.8 Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil de gérance de la Société peut également être transmise par
écrit, à condition qu'elle soit précédée par une délibération entre les gérants par des moyens tels que, par exemple, décrits
dans l'Article 11.6. Une telle résolution doit consister en un ou plusieurs documents contenant les décisions et signées par
chaque et par tous gérant(s) (résolution circulaire). La date de cette résolution sera la date de la dernière signature.
Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
12.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président du conseil de gérance
de la Société ou par deux gérants de la Société.
12.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront signés par le
secrétaire (le cas échéant), ou par tout gérant de la Société.
Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou par
les Statuts à l'assemblée générale des associés de la Société tombent dans la compétence du conseil de gérance, qui aura
tous les pouvoirs pour réaliser et approuver tous les actes et opérations conformément à l'objet social de la Société.
Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance de la Société est autorisé à nommer une personne, que ce soit un
gérant ou non, ou une entité, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés de la Société, aux fins
d'exécuter des fonctions spécifiques à tous les niveaux au sein de la Société.
Art. 15. Signatures engageant la Société vis-à-vis des tiers. La Société sera engagée envers les tiers en toutes circons-
tances par la seule signature de tout gérant de la Société ou par la signature de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de
signature a été accordé par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites d'un tel pouvoir.
Art. 16. Conflit d'intérêts.
16.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé
par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou agents de la Société est intéressé, ou est un gérant, associé, agent ou employé
d'une telle autre société ou entreprise.
16.2 Tout gérant ou agent de la Société, qui est gérant, agent ou employé de toute société ou entreprise avec laquelle la
Société contractera ou s'engagera autrement dans des affaires ne sera pas, uniquement en raison de cette affiliation avec
cette autre société ou entreprise, empêché d'examiner et de voter ou d'agir en ce qui concerne les questions en relation à
un tel contrat ou autre affaire.
16.3 Dans le cas où un gérant de la Société peut avoir un intérêt personnel et opposé dans une transaction de la Société,
ce gérant doit faire connaître au conseil de gérance de la Société son intérêt personnel et opposé et ne doit pas examiner
ou voter sur cette transaction, et une telle transaction, et un tel intérêt opposé d'un gérant, seront reportés à la prochaine
assemblée générale des associés de la Société qui devra ratifier une telle transaction.
E. Audit et surveillance
Art. 17. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
17.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires statutaires et
détermine la durée de leurs mandats.
17.2 Un commissaire statutaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale
des associés.
17.3 Le commissaire statutaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanent sur toutes les opérations de
la Société.
102558
L
U X E M B O U R G
17.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire statutaire sera supprimée.
17.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Affectation des bénéfices
Art. 18. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 19. Distribution des bénéfices.
19.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges représentent les bénéfices nets. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est alloué
à la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.
19.2 L'assemblée générale des associés a un pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus. Elle peut en particulier
allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende ou le transférer à la réserve ou le reporter.
19.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est établi par le conseil de gérance;
(ii) cet état comptable, inventaire ou rapport montre que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution; étant
entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve
légale;
(iii) la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par l'assemblée générale des associés de la Société; et
(iv) l'assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
19.4 Les dividendes peuvent être payés en euro (EUR) ou toute autre devise choisie par le conseil de gérance de la
Société et ils peuvent être payés aux lieux et dates tels que déterminés par le conseil de gérance de la Société.
19.5 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés,
sous réserve des dispositions de la Loi sur les Sociétés et de ces Statuts.
G. Liquidation
Art. 20. Liquidation.
20.1 La liquidation de la Société sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques
ou morales) nommé(s) par l'assemblée générale des associés de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée
générale des associés de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du/des liquidateur(s). La disso-
lution et la liquidation de la Société doivent être effectuées conformément à la Loi sur les Sociétés.
20.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif de la Société sera payé aux associés proportionnellement
aux parts sociales détenues par chaque associé dans la Société.
H. Information financière
Art. 21. Informations financières.
21.1 La Société doit fournir à chaque associé une copie des comptes annuels en ce qui concerne chaque exercice dans
le délai fixé par la Loi sur les Sociétés.
21.2 La Société doit fournir à chaque associé toutes les informations en relation avec elle-même qui est disponible à la
Société qui peut être raisonnablement requise par un associé pour répondre aux obligations fiscales et légales de rapport
du groupe de sociétés dont l'associé fait partie. Ces informations comprennent, mais ne doivent pas être limitées à toutes
les déclarations fiscales, les rendements et recettes, les relevés bancaires, registres et autres documents de la Société.
21.3 La Société préparera ses comptes annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus au
Luxembourg.
Art. 22. Accès aux registres et dossiers de la Société. Chaque associé et ses auditeurs respectifs et/ou toute personne
nommée par l'associé à l'encontre de laquelle la Société n'a pas d'objection raisonnable peut, pendant les heures normales
de bureau, avoir accès aux bureaux, bâtiments et lieux de la Société et auront le droit d'inspecter et de vérifier à ses frais
tous les livres et registres et de vérifier tous les biens appartenant à la Société.
I. Disposition finale - Loi applicable
Art. 23. Loi applicable . Tout ce qui n'est pas régi par les présents Statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi sur
les Sociétés.
102559
L
U X E M B O U R G
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente et-un décembre
2016.
<i>Souscription et paiementi>
Les douze mille cinq cent (12.500) parts sociales émises ont été entièrement souscrites par MaplesFS Limited, prén-
ommée.
Ces parts sociales telles que souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire de sorte que le
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.800.-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé fondateur a adopté les résolutions suivantes:
1. La Société sera administrée par les gérants suivants:
- Henry Kelly, né le 05 Octobre 1955 à Douglas Isle of Man, Royaume Uni, résidant professionnellement au 4, rue Jean-
Pierre Lanter, L-5943 Itzig, Grand- Duché du Luxembourg, en tant que Gérant Indépendant;
- William Jones, né le 11 Février 1963 à New York, États-Unis d'Amérique, résidant professionnellement au 24, rue
Beaumont L-1219 Luxembourg, Grand- Duché du Luxembourg, en tant que Gérant Indépendant;
- Nick Williams, né le 21 Mars 1956 à Lymington, Royaume Uni, résidant professionnellement au 77, Grosvenor Street,
Londres, W1K 3JR, Royaume Uni, en tant que Gérant Représentatif; et
- Siu-Wai Ng, né le 18 Janvier 1976 à Hong Kong, résidant professionnellement au 77 Grosvenor Street, Londres, W1K
3JR, Royaume Uni, en tant que Gérant Représentatif.
La durée de leur mandat est illimitée. La Société sera engagée par la signature unique d'un des gérants.
2. Le siège social de la Société est fixé au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du/des comparant((e)s) que le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du/des même(s) comparant((e)s) et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire du/des comparant((e)s) connu(s) du notaire instrumentant par nom, prénom, et rési-
dence, ledit mandataire du/des comparant((e)s) a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14093. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111260/551.
(160083958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
LB Immo Invest LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 107.783.
In the year two thousand and sixteen,
on the third day of May.
Before Us the undersigned notary Henri BECK, residing in Echternach, (Grand- Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED
The private limited liability Company of German Law PATRIZIA GewerbeInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
having its registered office at D-20095 Hambourg, Burchardstrasse 14, registered with the companies' register of the
Hamburg District court under number HRB 79685.
The appearing party is hereby represented by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach,
9, Rabatt, by virtue of a proxy given under private seal on April 20, 2016,
102560
L
U X E M B O U R G
which proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as said before, declared and requested the officiating notary to act:
1.- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability Company LB Immo Invest LUX S.à r.l.,
having its registered office at L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 107.783,
incorporated by deed of the notary Henri HELLINCKX, then residing at Mersch on April 22, 2005, published in the
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 946 of September 27, 2005, and which articles of association
have been amended as follows:
- by deed of the notary Joseph ELVINGER, then residing in Luxembourg, in replacement of the notary Henri HEL-
LINCKX, prenamed, on May 23, 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1059
of October 19, 2005;
- by deed of the notary Karine REUTER, then residing in Pétange, on December 13, 2013, published in the Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations number 3265 of December 23, 2013.
2.- That the share capital is set at nine million sic hundred ninety thousand Euro (EUR 9.690.000.-), represented by
ninety-six thousand nine hundred (96.900) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The said appearing party, represented as said before, requested the officiating notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides the premature dissolution of the Company and its liquidation.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint the Company KPMG Luxembourg, société coopérative, having its registered
office at L-1855 Luxembourg, 39, avenue John F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 149133, represented by Mr. Zia HOSSEN, as liquidator of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by
article 144 and following of the law of August 10
th
, 1915, concerning commercial companies, without having to ask for
authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolves to appoint PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, having its registered office at
L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 0065477, as auditor to the liquidation.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder grants discharge of the Board of Directors of the Company for the activities performed from 1
st
January 2015 until the date of the liquidation of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party
the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in case
of discrepancies between the English and the German texts, the German version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary, by her surname,
Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorherstehenden Textes
Im Jahre zwei tausend sechzehn,
am dritten Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grosshergotum Luxemburg),
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts PATRIZIA GewerbeInvest Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH, mit Sitz in D-20095 Hamburg, Burchardstrasse 14, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg
unter der Nummer HRB 79685.
Welche Komparentin hier vertreten ist durch Peggy Simon, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-6475 Echternach,
9, Rabatt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 20. April 2016,
102561
L
U X E M B O U R G
welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, dem handelnden Notar Folgendes auseinandersetzte:
1.- Dass die Komparentin die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LB Immo Invest
LUX S.à r.l. ist, mit Sitz in L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 107.783,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitze in
Mersch, am 22. April 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 946 vom 27.
September 2005, und deren Statuten abgeändert worden sind wie folgt:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph ELVINGER, mit dem damaligen Amtssitze in Luxembourg,
in Vertretung des Notars Henri HELLINCKX, vorgenannt, am 23. Mai 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 1059 vom 19. Oktober 2005;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Karine REUTER, mit dem damaligen Amtssitze in Petingen, am 13.
Dezember 2013, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3265 vom 23. Dezember
2013.
2.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf neun Millionen sechs hundert neunzig tausend Euro (EUR 9.690.000.-) beläuft,
eingeteilt in sechsundneunzig tausend neun hundert (96.9000) zu je ein hundert Euro (EUR 100.-).
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den handelnden Notar ersuchten nachfolgende Beschlüsse zu beur-
kunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, die Gesellschaft KPMG Luxembourg, Société coopérative, mit Sitz in L-1855
Luxembourg, 39, avenue John F. Kennedy, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg unter der
Nummer B 149133, vertreten durch Herrn Zia HOSSEN, zum Liquidator der Gesellschaft zu ernennen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Liquidator ist mit den weitgehensten durch das Gesetz und namentlich durch die Artikel 144 bis 148 über das
Handelsgesellschaftsgesetz vorgesehenen Vollmachten ausgestattet, sogar ohne vorherige Ermächtigung durch die Gene-
ralversammlung im Falle wo diese Ermächtigung normalerweise erfordert wäre.
<i>Vierter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, mit Sitz in L-2182 Luxem-
bourg, 2, rue Gerhard Mercator, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg unter der Nummer B
0065477 zum Abschlussprüfer für die Dauer der Liquidationsperiode zu bestellen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, die Mitglieder des ehemaligen Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten vom 1.
Januar 2015 bis zum Ende der Liquidationsperiode zu entlasten.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Bevollmächtigte der Komparentin, dem Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 mai 2016. Relation: GAC/2016/3592. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 12. Mai 2016.
Référence de publication: 2016108713/114.
(160080815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
102562
L
U X E M B O U R G
Stëftung Hëllef Doheem, Fondation.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 50, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg G 51.
<i>Comptes annuels révisés au 31 décembre 2015i>
Contenu
Page(s)
Rapport de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 - 5
Rapport d'audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 - 7
Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 - 9
Compte de profits et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Notes aux comptes annuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 20
<i>Rapport de Gestion SHD pour l'exercice 2015i>
Les critères plus restrictifs appliqués par la Cellule d'Évaluation et d'Orientation de l'Etat dans l'octroi des prestations
de l'assurance dépendance ont eu un impact financier significatif au niveau des prestataires du secteur d'aides et de soins.
C'est ainsi qu'après une année 2014 déjà difficile, la fondation «Stëftung Hëllef Doheem» affiche à la date du 31.12.2015
un chiffre d'affaires de EURO 94 716 707, en recul de -1,81% par rapport à l'année précédente.
Les frais de personnel - représentant les coûts les plus élevés de la fondation - se chiffrent à EURO 85 858 998, en baisse
de -1.81% par rapport à l'exercice précèdent.
Au vu de la baisse d'activités, la fondation a dû en effet procéder, à travers un plan de maintien dans l'Emploi (PME),
à la réduction de son effectif à raison de 88 personnes, finissant l'année avec un total de 1909 collaborateurs. L'externalisation
du service de nettoyage des bureaux explique une partie de cette baisse, le personnel concerné ayant trouvé une autre
affectation en interne ou auprès du prestataire externe.
La mise en place d'un ensemble de mesures de réduction de coûts ont, par ailleurs, permis de réduire dé 1,87 % les frais
de fonctionnement qui s'élèvent en date du 31 décembre 2015 à un montant de EURO 15 184 714. Ces mesures produiront
leur plein effet en 2016 et englobent notamment une baisse du nombre et de segment des véhicules.
Le résultat d'exploitation affiche une perte de EURO -4 835 883, auquel s'ajoutent un résultat financier positif de EURO
12 360 et un résultat exceptionnel positif de EURO 146 080.
La Fondation clôture dès lors l'exercice 2015 avec une perte financière d'un montant total de EURO -4 677 442.
En cours d'année 2015, l'activité assurance dépendance, en termes d'heures prestées au lit du client, a connu une baisse
à raison de -2.36%. Cette diminution est majoritairement le résultat d'un octroi plus restrictif des prestations de l'assurance
dépendance par la Cellule d'Evaluation et d'Orientation (CEO) tant au niveau des nouveaux clients que pour les clients
existants (dont les dossiers sont réévalués à la baisse).
Le nombre de clients distincts, ayant bénéficié durant l'année 2015 de prestations d'aides et de soins au niveau de
l'assurance dépendance, a baissé d'un total de -0.8% par rapport à l'année 2014.
L'activité au niveau des prestations de l'assurance maladie affiche pour l'année 2015 une baisse plus importante de -2.7%
par rapport à l'année précédente. Cette diminution s'explique à la fois par un effet technique et par une baisse du nombre
de clients. Le nombre de clients distincts ayant bénéficié durant l'année 2015 de prestations de soins infirmiers au niveau
de l'assurance maladie a connu ainsi une baisse importante d'un total de -3.8%.
Le nombre total de clients distincts pris en charge par la fondation «Stëftung Hëllef Doheem» a diminué de -3.3% par
rapport à l'année 2014. Au 31.12.2015, le nombre de clients distincts se chiffre à 15 101 clients, soit une baisse de -512
clients sur l'année.
Le service Sécher Doheem (Téléalarme), a, quant à lui, vu son nombre de clients distincts augmenter légèrement, passant
de 3 409 en 2014 à 3 452 clients en 2015.
Le nombre total de présences dans les foyers de jour (CPG) a diminué de 4.7% par rapport à l'année 2014. Cette baissé
s'explique d'une part par le fait de la réduction du nombre total de jours d'ouverture, suite à la décision de fermer les foyers
de jour les dimanches, ainsi que par la fermeture définitive du foyer d'Echternach (Op der Foar) fin août 2015, dont la
majorité des clients a pu être transférée au foyer de Larochette. Le taux d'occupation moyen des foyers de jour pour l'année
2015 est de 74,4% et donc légèrement en baisse par rapport à l'année précédente (76,2%). Ceci résulte aussi de la politique
plus restrictive de la CEO au niveau des jours moyens accordés.
Le service «Propper Doheem» a connu un léger recul de sa clientèle (-1,02% par rapport à 2014).
Le service des gardes de nuit à domicile a reçu l'accord de la part du Ministère de la Famille et de l'Intégration quant au
financement de ce type de prestations pour les années 2015 et 2016. Les clients pris en charge par le service des gardes de
nuit à domicile en 2015 est de 281, ce qui correspond à une baisse de -13.5% par rapport à l'année précédente.
Le nombre de clients pris en charge par le service «Betreit Wunnen Doheem» pour l'année 2015 a connu une augmen-
tation de +14,8% par rapport à l'année 2014. Plus de 73% des demandes sont réalisées dans le cadre du «Mëttesdesch»,
qui permet aux personnes âgées de garder un contact social et relationnel régulier, dans le cadre d'un déjeuner au restaurant.
102563
L
U X E M B O U R G
Le service du «Berodungsdengscht» a connu une diminution d'activité de -4.6% au niveau des clients qui ont été pris
en charge durant l'année 2015, Le nombre de bénéficiaires du service des soins palliatifs à domicile est resté quasi inchangé
par rapport à l'année dernière, avec un total de 299 personnes prises en charge durant l'année 2015.
L'année 2015 a permis à la fondation «Stëftung Hêllef Doheem» de sensibiliser les autorités publiques aux conséquences
d'une politique d'austérité trop sévère.
Les réponses aux revendications de SHD - auxquelles les autres prestataires regroupés au sein de la COPAS se sont
joints - sous la forme d'une compensation financière du recul des activités ainsi que d'une hausse forfaitaire de 2,2% de la
valeur monétaire, donnent davantage de sécurité de planification aux prestataires du secteur.
Cependant, ces mesures ne suffiront pas à résorber le sous-financement structurel de certaines activités de l'assurance-
dépendance comme de l'assurance maladie, pourtant dans l'intérêt de nos clients. La fondation continuera à militer pour un
financement correct de ces activités dans le cadre des réformes en cours, tout en défendant une qualité élevée d'aide et de
soins au profit des personnes dépendantes.
Luxembourg, le 25 avril 2016.
Benoît Holzem / Paul-Henri Meyers
<i>Directeur Général / Présidenti>
<i>Rapport sur les comptes annuelsi>
Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de Stëftung Hëllef Doheem, comprenant le bilan au 31 dé-
cembre 2015, le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date et l'annexe contenant un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres notes explicatives.
Responsabilité du Conseil d'Administration pour les comptes annuels
Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Responsabilité du Réviseur d'entreprises agréé
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sut la base de notre audit. Nous avons effectué
notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier
et réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du Réviseur d'entreprises
agréé, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le Réviseur d'entreprises agréé prend en
compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels
afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur le
fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Admi-
nistration de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de Stëftung Hëllef
Doheem au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations
légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.
<i>Rapport sur d'autres obligations légales et réglementairesi>
Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du Conseil d'Administration, est en concordance avec les comptes
annuels.
Luxembourg, le 25 avril 2016.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Représentée par Patrick Ries
<i>Bilan au 31 décembre 2015i>
<i>(exprime en euro)i>
ACTIF
NOTES
31.12.15
31.12.14
C.
ACTIF IMMOBILISE
6 088 473,08
6 883 380,52
1.
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
1 714 030,95
2 108 665,01
102564
L
U X E M B O U R G
2.
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs
Similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 714 030,95
2 108 665,01
II.
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
4 374 442,13
4 774 715,51
1.
Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 991 785,13
3 068 984,24
2.
Installations techniques et machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 361,81
76 201,35
3.
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 334 295,19
1 629 529,92
D.
ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 896 634,32 48 950 801,52
II.
Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
26 189 499,94 39 484 123,68
1.
Créances résultant de ventes et prestations de services . . . . . . . . . .
5
23 781 697,16 35 606 639,48
4.
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 407 802,78
3 877 484,20
IV.
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques
et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 707 134,38
9 466 677,84
E.
COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
294 571,37
364 651,13
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 279 678,77 56 198 833,17
PASSIF
A.
Fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7
16 526 876,19 20 563 455,46
I.
Fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 155 091,39 10 452 509,88
a.
Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 578,70
49 578,70
e.
Libéralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.6
11 105 512,69 10 402 931,18
IV.
Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 771 881,50 11 771 881,50
4.
Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
11 771 881,50 11 771 881,50
V.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
(3 188 571,49)
0,00
VI.
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4 677 441,97) (3 188 571,49)
VIII. Subventions d'investissement en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.9
1 465 916,76
1 527 635,57
C.
PROVISIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.10
1 857 515,26
1 641 136,12
3.
Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 857 515,26
1 641 136,12
D.
DETTES NON SUBORDONNEES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
22 895 287,32 33 994 241,59
2.
Dettes envers des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
899 357,49
1 009 683,28
4.
Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
16 738 128,46 26 084 403,78
9.
Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5 257 801,37
6 900 154,53
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 279 678,77 56 198 833,17
<i>Compte de profits et pertes pour l'exercice clôture au 31 décembre 2015i>
<i>(exprimé en euro)i>
NOTES
31.12.15
31.12.14
A.
PRODUITS D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 804 067,19 101 092 644,11
Ventes de prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 716 706,69
96 460 557,36
Subventions d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6
1 042 465,72
996 609,48
Reprises sur amortissements et provisions . . . . . . . . . . . . . . .
3 300,00
1 396 275,67
Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 041 594,78
2 239 201,60
A'.
CHARGES D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(102 639
949,82)
(104 316
095,97)
Autres achats et charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(15 184 713,56) (15 473 583,50)
Impôts, taxes et versements assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1 568,98)
(4 857,37)
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.
(85 858 997,51) (87 444 555,86)
Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(74 728 001,31) (76 263 204,50)
Charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(11 127 772,03) (11 053 103,67)
Autres frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3 224,17)
(128 247,69)
Dotations aux amortissements et aux provisions . . . . . . . . . .
(1 594 669,77)
(1 393 099,24)
Sur immobilisations dotations aux amortissements . . . . . . . .
(1 353 990,63)
(1 261 818,71)
Sur actif circulant: dotations aux provisions . . . . . . . . . . . . .
(21 000,00)
(0,00)
Sur risques et charges: dotations aux provisions . . . . . . . . . .
10
(219 679,14)
(131 280,53)
A.-A'.
RESULTAT D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4 835 882,63)
(3 223 451,86)
C.
PRODUITS FINANCIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 692,35
25 880,92
102565
L
U X E M B O U R G
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 692,35
25 880,92
C'.
CHARGES FINANCIERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3 332,18)
(5 422,59)
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3 332,18)
(5 422,59)
C.-C'.
RESULTAT FINANCIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 360,17
20 458,33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS . . . . . . . . . . . . .
(4 823 522,46)
(3 202 993,53)
RESULTAT COURANT APRES IMPOTS . . . . . . . . . . . . .
(4 823 522,46)
(3 202 993,53)
E.
PRODUITS EXCEPTIONNELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
562 595,06
178 256,24
E'.
CHARGES EXCEPTIONNELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
(416 514,57)
(163 834,20)
E.-E'.
RESULTAT EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146 080,49
14 422,04
TOTAL DES PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 382 354,60 101 296 781,27
TOTAL DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(103 059
796,57)
(104 485
352,76)
EXCEDENT / (DEFICIT) DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . .
(4 677 441,97)
(3 188 571,49)
Les notes en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels.
Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2015
Note 1. Généralités. La Fondation Stëftung Hëllef Doheem (ci-après «La Fondation») a été créée le 29 septembre 1999
par:
- la Congrégation des Frères de Charité;
- la Congrégation des Sœurs du Tiers-Ordre Régulier de Notre Dame du Mont Carmel;
- les Chanoinesses régulières de Saint Augustin de la Congrégation de Notre Dame;
- la Congrégation des Soeurs de la Doctrine Chrétienne;
- la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde;
- la Congrégation des Sœurs du Pauvre Enfant Jésus;
- la Congrégation des Sœurs Hospitalières de Sainte Elisabeth;
- l'association Aide Familiale-Aide Senior;
- l'association Foyers Seniors.
La Fondation a comme objet la promotion du bien-être psychique, physique et social ainsi que l'autonomie des personnes
âgées, dépendantes, malades et / ou handicapées. A cette fin elle promeut, coordonne, assure, gère et organise des services
ambulatoires en faveur du maintien à domicile, des établissements stationnaires et semi-stationnaires et des institutions
spécialisées apportant des aides, des soins et des activités de conseil et de soutien. Les statuts de la Fondation «Stëftung
Hëllef Doheem» ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1999.
La Fondation a repris avec effet au 1
er
janvier 2000 les activités des associations suivantes:
- le patrimoine net de Hëllef Doheem Krankefieg A.s.b.l., créé en 1980 par les congrégations religieuses qui dispensaient
depuis le 19
ème
siècle des aides et des soins à travers le pays principalement dans le cadre de l'assurance maladie, a été
transférée entièrement à la Fondation dans le cadre de sa liquidation;
- les associations «Foyers Seniors A.s.b.l.» et «Aide Familiale - Aide Senior A.s.b.l.» actives dans le domaine des
prestations de soins à domicile dans le cadre de l'assurance dépendance, ont cédé une partie de leurs activités à la Fondation.
La Fondation «Stëftung Hëllef Doheem» a conclu des contrats de sous-traitants avec d'autres prestataires intervenant
dans le cadre de l'assurance maladie et/ou dans le cadre de l'assurance dépendance. C'est la Fondation qui facture à la Caisse
Nationale de Santé. Conformément aux termes du contrat elle leur reverse leur dû.
Note 2. Résumé des principales politiques comptables. Suite au contrat signé entre la Fondation et l'organisme gestion-
naire de l'assurance dépendance, la Fondation est tenue de respecter les principales politiques comptables suivantes:
2.1 Actifs immobilisés
Les actifs immobilisés sont évalués au prix d'acquisition historique. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais
accessoires au prix d'achat. Le prix d'acquisition des actifs immobilisés dont l'utilisation est limitée dans le temps est diminué
des amortissements calculés de manière à amortir la valeur de ces éléments sur leur durée d'utilisation estimée.
En cas de dépréciation durable, les éléments immobilisés dont l'utilisation est ou non limitée dans le temps font l'objet
de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces
corrections de valeur sont ex-tournées lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.
2.1.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles figurent au prix d'acquisition et sont amorties sur une base linéaire selon leur durée
d'utilisation estimée. Les durées d'amortissement sont entre 2 à 10 ans.
Les immobilisations incorporelles en cours ne sont pas amorties.
2.1.2 Immobilisations corporelles
102566
L
U X E M B O U R G
Les immobilisations corporelles figurent au coût d'acquisition. A l'exception du terrain qui n'est pas amorti, les immo-
bilisations corporelles sont amorties sur une base linéaire selon leur durée de vie estimée.
Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement entre 3 et 10 ans à l'exception des constructions dont la durée
d'amortissement est de 50 ans.
Les immobilisations corporelles de faible valeur sont intégralement prises en chargé lors de l'acquisition.
2.2 Créances
Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont enregistrées sur décision du
Conseil d'Administration, afin de tenir compte des risques de non-recouvrement. Les corrections de valeur sont déduites
des postes d'actif concernés. Les corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui ont motivé leur constitution
ont cessé d'exister.
Les prestations des sous-traitants relatives à des clients en régime transitoire n'ont pas été comptabilisées. Ces prestations
ne seront enregistrées et facturées à la Caisse Nationale de Santé par la Stëftung Hëllef Doheem que si les clients obtiennent
une décision positive.
2.3 Dettes non subordonnées
Les dettes sont inscrites au passif à leur montant de remboursement.
2.4 Subventions d'investissement en capital
Les subventions destinées au financement d'immobilisations sont amorties au compte de profits et pertes en tenant
compte de la durée de vie économique des immobilisations auxquelles elles se rapportent.
2.5 Dons d'exploitation
Les dons non affectés reçus pendant l'exercice sont comptabilisés systématiquement au passif comme libéralités.
2.6 Subventions d'exploitation
Les subventions d'exploitation sont comptabilisées directement dans le compte de profits et pertes.
2.7 Affectation du résultat de l'exercice
Le résultat de l'exercice, après approbation des comptes annuels, est systématiquement affecté aux fonds propres.
2.8 Conversion des soldes en devises
Les opérations conclues en devises sont converties aux taux de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs,
autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en EURO aux taux en vigueur à la clôture de l'exercice.
Les pertes non-réalisées calculées au moment de la conversion sont comptabilisées dans le compte de profits et pertes.
2.9 Provisions
Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou des dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature
mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à
leur date de survenance.
2.10 Autres
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg
selon la méthode du coût historique.
Les politiques comptables et les principes d'évaluation sont déterminés et mis en place par le Conseil d'Administration.
La préparation des comptes annuels implique le recours à un certain nombre d'estimations comptables déterminantes.
Elle impose aussi au Conseil d'Administration d'exercer son jugement dans l'application des principes comptables. Tout
changement dans les hypothèses peut avoir des répercussions significatives sur les comptes annuels de la période durant
laquelle ces hypothèses ont changé. Le Conseil d'Administration estime que les hypothèses sous-jacentes sont adéquates
et que les comptes annuels donnent ainsi une image fidèle de la situation financière et des résultats de la Fondation.
La Stëftung Hëllef Doheem fait des estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants repris à l'actif et
au passif au cours de la période suivante. Les estimations et les jugements sont évalués de façon continue et se basent sur
l'expérience passée et d'autres facteurs, dont des anticipations d'événements futurs jugés raisonnables dans ces circonstan-
ces.
Note 3. Immobilisations incorporelles. L'évolution du compte «Immobilisations incorporelles» est résumée comme suit:
Concessions,
brevets
licences,
marques ainsi
que droits et
valeurs
similaires
EURO
Valeur brute au 01.01.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 140 924,94
Acquisitions et transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264 815,26
Cessions et transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(0,00)
102567
L
U X E M B O U R G
Valeur brute au 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 405 740,20
Amortissements au 01.01.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 032 259,93)
Amortissements de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(659 449,32)
Reprises de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Amortissements cumulés au 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 691 709,25)
Valeur nette au 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 714 030,95
Valeur nette au 31.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 108 665,01
Le compte «Immobilisations incorporelles» est constitué de logiciels informatiques.
Note 4. Immobilisations corporelles. L'évolution du poste «Immobilisations corporelles» est résumée comme suit:
Terrains et
construc-
tions
Installations
techniques
et machines
Autres
installations,
outillage et
mobilier
Total
EURO
EURO
EURO
EURO
Valeur brute au 01.01.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 815 934,68
584 552,32
6 714 851,94 11 115 338,94
Acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 081,31
898,13
292 791,22
295 770,66
Transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
0,00
Cessions/Désinvestissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(0,00)
(5 821,85)
(55 832,58)
(61 654,43)
Valeur brute au 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 818 015,99
579 628,60
6 951 810,58 11 349 455,17
Amortissements cumulés au 01.01.2015 . . . . . . . . . . . (746 950,44) (508 350,97) (5 085 322,02) (6 340 623,43)
Amortissements de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(79 280,42)
(28 737,67)
(586 523,22)
(694 541,31)
Reprises de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
5 821,85
54 329,85
60 151,70
Amortissements cumulés au 31.12.2015 . . . . . . . . . . . (826 230,86) (531 266,79) (5 617 515,39) (6 975 013,04)
Valeur nette au 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 991 785,13
48 361,81
1 334 295,19
4 374 442,13
Valeur nette au 31.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 068 984,24
76 201,35
1 629 529,92
4 774 715,51
Note 5. Créances résultant de l'exploitation. Le poste «Créances résultant de l'exploitation» a évolué comme suit:
2015
EURO
2014
EURO
Créances Caisse Nationale de Santé 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 073 478,38
0,00
Créances Ministère de la Famille 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 325 078,35
0,00
Créances Caisse Nationale de Santé 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 408,27 32 244 180,99
Créances Ministère de la Famille 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
382 883,61
881 736,17
Créances clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 026 870,26
874 694,91
Autres créances clients (Secher Doheem,..) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
647 758,73
830 545,19
Créances Ministère de la Famille 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296 419,56
368 962,59
Créances Ministère de la Famille 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 800,00
250 966,25
Créances Ministère de la Famille 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
155 553,38
Solde net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 781 697,16 35 606 639,48
Note 6. Libéralités. Le compte «Libéralités» a évolué comme suit:
Libéralités
2015
EURO
Libéralités
2014
EURO
Dons d'exploitation à la création de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
556 430,29
556 430,29
Affectation des dons années antérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 523 489,54 7 931 921,55
Affectation des dons de l'année précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 323 011,35
591 567,99
Affectation des dons de l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
702 581,51 1 323 011,35
Solde net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 105 512,69 10 402 931,18
Note 7. Résultats reportés. Le compte «Résultats reportés» a évolué comme suit:
Résultats
reportés
EURO
Résultats reportés au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Résultat de l'exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 188 571,49)
Résultats reportés à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 188 571,49)
102568
L
U X E M B O U R G
Note 8. Autres réserves. L'évolution du poste «Autres réserves» est résumée comme suit:
Autres
réserves
2015
EURO
Autres
réserves
2014
EURO
Apport des actifs nets à la création de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 371 939,94 1 371 939,94
Excédents/(déficits) cumulés années antérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 399 941,56 9 344 250,21
Affectation du résultat de l'année précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 1 044 611,95
Résultat reportés exercices précédents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
11 079,40
Autres réserves à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 771 881,50 11 771 881,50
Note 9. Subventions d'investissement en capital. L'évolution du poste «Subventions d'investissement» est résumée
comme suit:
Subventions
d'investissement
EURO
Montant à l'ouverture de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 527 635,57
Dotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Amortissements de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(61 718,81)
Valeur nette an 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 465 916,76
Valeur nette au 31.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 527 635,57
Note 10. Autres provisions. Le poste «Autres provisions» est principalement composé d'une provision pour heures
supplémentaires, jours fériés, dimanche et congé pour un montant de EURO 1 515 515,23 (2014: EURO 1 295 836,12) et
de provisions pour litiges pour un montant de EURO 300 000,00 (2014: EURO 302 500,00).
Note 11. Autres dettes. Le poste «Autres dettes» a évolué comme suit:
Autres
dettes
2015
EURO
Autres
dettes
2014
EURO
Dette envers la Sécurité Sociale et dettes envers l'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 097 401,20 6 816 271,03
Dettes envers le personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 610,68
31 509,11
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 789,49
52 374,39
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 257 801,37 6 900 154,53
Note 12. Dettes sur achats et prestations de services. Le poste «Dettes sur achats et prestations de services» est princi-
palement composé des avances reçues pour les prestations non encore décomptées auprès de la Caisse Nationale de Santé.
Note 13. Comptes de régularisation actif. Dans les comptes de régularisation actifs sont enregistrées des charges payées
d'avance et des charges à répartir sur plusieurs exercices.
Note 14. Personnel. La Fondation employait à la fin de l'exercice 1 909 personnes (2014: 1 997).
Note 15. Produits exceptionnels. Dans le compte «Produits exceptionnels», (a Fondation a principalement enregistré
des recettes liées à des exercices antérieurs mais régularisées durant l'exercice 2015 pour un montant de EURO 458 887,52
(2014: EURO 69 168,15) ainsi que la quote-part des subventions d'investissement transférée au résultat de l'exercice pour
un montant de EURO 83 413,63 (2014: EURO 68 595,62).
Note 16. Charges exceptionnelles. Dans le compte «Charges exceptionnelles», la Fondation a principalement enregistré
des charges liées à des exercices antérieurs mais régularisées durant l'exercice 2014 pour un montant de EURO 368 756,31
(2014: EURO 43 661,43) ainsi que des pertes sur créances irrécouvrables pour un montant de EURO 15 856,98 (2014:
EURO 18 036,80).
Note 17. Jetons de présence. Pendant l'exercice 2015, la Fondation n'a pas alloué aux membres du Conseil d'Adminis-
tration des jetons de présence.
Note 18. Engagements financiers hors bilan. Les engagements non encore échus se chiffrent à EURO 8 222 738,52
(2014: EURO 10 767 752,18). Ils sont relatifs à des contrats leasing de 793 voitures (2014: 847) pour un montant de EURO
8 154 979,95 (2014: EURO 10 618 269,21), à des contrats leasing de 292 laptops pour un montant de EURO 57 294,57
(2014: EURO 139 018,97) et des garanties bancaires pour un montant total de EURO 10 464,00 (2014: EURO 10 464,00).
<i>Budget 2016i>
DEPENSES
01.01.2016 RECETTES
01.01.2016
102569
L
U X E M B O U R G
-31.12.2016
-31.12.2016
A Frais du personnel . . . . . . . . . . . . . . . 85'539'575.63 A Prestations en relation avec la Sécurité
Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'026'850.62
B Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . 13'988'816.43 B Autres prestations . . . . . . . . . . . . . . . .
6'750'351.62
C Provisions pour créances
irrécupérables et autres . . . . . . . . . . . . . .
0.00
D Autres dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
Total des Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . 99'528'392.06 Total des Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96'777'202.24
Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2'751'189.82
Référence de publication: 2016111256/397.
(160083756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Tamweelview European Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 93.081.
In the year two thousand and sixteen, on the third day of May,
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., a société
anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 13, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Alphonse Lentz, notary then
residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, of 17 April 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 525 of 15 May 2003 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 93081 ("Tamweelview European Holdings"). The articles of incorporation of Tamweelview European
Holdings have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary of 27 January 2016, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was declared open at 2.30 p.m. by Me Simone SCHMITT, lawyer, with professional address in Luxem-
bourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Pascaline MOISAN, employee, with professional address in
Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Camille LE DANTEC, employee, with professional address in Lxuembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the
following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To consider and, if thought fit, increase the share capital of Tamweelview European Holdings by an amount of nineteen
million eight hundred fifty thousand euro (EUR 19,850,000.-) so as to raise it from its present amount of one billion fifty-
seven million four hundred twenty-five thousand eight hundred euro (EUR 1,057,425,800.-) to one billion seventy-seven
million two hundred seventy-five thousand eight hundred euro (EUR 1,077,275,800.-).
2 To consider and, if thought fit, issue one hundred ninety-eight thousand five hundred (198,500) new class Z common
shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as the existing
shares.
3 To consider and, if thought fit, acknowledge the waiver by all the existing shareholders of Tamweelview European
Holdings of their preferential subscription rights and to accept subscription for these new class Z common shares with
payment of a share premium in a total amount of one hundred seventy-nine million ten thousand euro (EUR 179,010,000.-)
and to accept full payment in cash for these new class Z common shares by Silver Holdings S.A..
4 To consider and, if thought fit, amend the first paragraph of article 3.1 of the articles of association of Tamweelview
European Holdings, in order to reflect the capital increase.
5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present,
the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the
board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
102570
L
U X E M B O U R G
(iv) That the whole share capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared
that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally
convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the extraordinary general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to increase the share capital of Tamweelview European
Holdings by an amount of nineteen million eight hundred fifty thousand euro (EUR 19,850,000.-) so as to raise it from its
present amount of one billion fifty-seven million four hundred twenty-five thousand eight hundred euro (EUR
1,057,425,800.-) to one billion seventy-seven million two hundred seventy-five thousand eight hundred euro (EUR
1,077,275,800.-).
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to issue one hundred ninety-eight thousand five hundred
(198,500) new class Z common shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights
and privileges as the existing shares.
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders acknowledged that all existing shareholders of Tamweelview Eu-
ropean Holdings had decided to waive their preferential subscription rights with respect to these new shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Silver Holdings S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 198784 (the “Subscriber”), represented by
Maître Simone SCHMITT by virtue of a proxy given on 2 May 2016 in Luxembourg. .
The Subscriber declared to subscribe to one hundred ninety-eight thousand five hundred (198,500) new class Z common
shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, with payment of a share premium in a total amount
of one hundred seventy-nine million ten thousand euro (EUR 179,010,000.-) and to fully pay up these new shares in cash.
The amount of one hundred ninety-eight million eight hundred sixty thousand euro (EUR 198,860,000.-) was thus as
from that moment at the disposal of Tamweelview European Holdings, evidence thereof having been submitted to the
undersigned notary.
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the
new shares to the above mentioned Subscriber.
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 3.1 of the articles of
incorporation of Tamweelview European Holdings in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now
on read as follows:
“Tamweelview’s share capital is set at one billion seventy-seven million two hundred seventy-five thousand eight
hundred euro (EUR 1,077,275,800.-), divided into ten million seven hundred seventy-two thousand seven hundred fifty-
eight (10,772,758) class Z common shares (the “Class Z Common Shares” or the “Common Shares”), with a nominal value
of one hundred euro (EUR 100.-) each, entirely paid in.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by Tamweelview European Holdings as a result
of the present deed are estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 3.00 p.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le deuxième jour du mois de mai,
par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
102571
L
U X E M B O U R G
s'est réunie
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., une
société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Alphonse Lentz, notaire résidant
alors à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 525 du 15 mai 2003, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 93081 («Tamweelview European Holdings»). Les statuts de Tamweelview European Holdings ont été
modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 27 janvier 2016, pas encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Me Simone SCHMITT, avocat, domicilié
professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Mme Pascaline MOISAN, employée, domicilié pro-
fessionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Mme Camille LE DANTEC, employée, domicilié professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Examen de et, si jugé approprié, décision d’augmenter le capital social de Tamweelview European Holdings à con-
currence d’un montant de dix-neuf millions huit cent cinquante mille euros (EUR 19.850.000,-) pour le porter de son
montant actuel d’un milliard cinquante-sept millions quatre cent vingt-cinq mille huit cents euros (EUR 1.057.425.800,-)
à un montant d’un milliard soixante-dix- sept millions deux cent soixante-quinze mille huit cent euros (EUR
1.077.275.800,-).
2 Examen de et, si jugé approprié, décision d’émettre cent quatre-vingt- dix-huit mille cinq cents (198.500) nouvelles
actions ordinaires de classe Z d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes.
3 Examen de et, si jugé approprié, décision d’accepter la renonciation par tous les actionnaires existants de Tamweelview
European Holdings de leur droit préférentiel de souscription et acceptation de la souscription de ces nouvelles actions
ordinaires de classe Z avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de cent soixante-dix-neuf millions dix
mille euros (EUR 179.010.000,-) et acceptation du paiement intégral en numéraire pour ces nouvelles actions ordinaires
de classe Z par Silver Holdings S.A..
4 Examen de et, si jugé approprié, décision de modifier l’alinéa premier de l’article 3.1 des statuts de Tamweelview
European Holdings, afin de refléter l’augmentation de capital.
5 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau
et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l’assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont
déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont
renoncé à leur droit d’être formellement convoqués.
(v) Que l’assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points
inscrits à l'ordre du jour.
(vi) Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a adopté, à chaque fois à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’augmenter le capital social de Tamweelview European
Holdings à concurrence d’un montant de dix-neuf millions huit cent cinquante mille euros (EUR 19.850.000,-) pour le
porter de son montant actuel d’un milliard cinquante-sept millions quatre cent vingt-cinq mille huit cents euros (EUR
1.057.425.800,-) à un montant d’un milliard soixante-dix-sept millions deux cent soixante-quinze mille huit cent euros
(EUR 1.077.275.800,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’émettre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents
(198.500) nouvelles actions ordinaires de classe Z, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les
mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
102572
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existants de Tamweelview
European Holdings ont décidé de renoncer à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l’émission de ces
nouvelles actions.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Silver Holdings S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198784 (le «Souscripteur»), représenté par Maître
Simone SCHMITT, en vertu d’une procuration donnée le 2 mai 2016 à Luxembourg.
Le Souscripteur a déclaré souscrire cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents (198.500) nouvelles actions ordinaires
de classe Z, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant
total de cent soixante-dix-neuf millions dix mille euros (EUR 179.010.000,-) et libérer intégralement en espèces ces actions
nouvelles.
Le montant de cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent soixante mille euros (EUR 198.860.000,-) a dès lors été à
la disposition de Tamweelview European Holdings à partir de ce moment, la preuve en ayant été rapportée au notaire
soussigné.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’allouer
les actions nouvelles au Souscripteur susmentionné.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de modifier l’alinéa premier de l’article 3.1 des statuts
des statuts de Tamweelview European Holdings pour refléter les résolutions ci-dessus.
Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social de Tamweelview est fixé à un montant d’un milliard soixante-dix-sept millions deux cent soixante-
quinze mille huit cent euros (EUR 1.077.275.800,-), représenté par dix millions sept cent soixante-douze mille sept cent
cinquante-huit (10.772.758) actions ordinaires de classe Z (les «Actions Ordinaires de Classe Z» ou les «Actions Ordinai-
res»), d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par Tamweelview European Holdings en raison du
présent acte sont évalués à six mille sept cents euros (EUR 6.700,- .
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: S. SCHMITT, P. MOISAN, C. LE DANTEC, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/14987. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016108932/197.
(160081351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
THB JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 74.605.906,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 165.909.
In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of May,
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared
102573
L
U X E M B O U R G
TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with registered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 93081 (“Tamweelview European
Holdings”),
hereby represented by Maître Catherine KREMER, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given on 2 May 2016.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
Tamweelview European Holdings has requested the undersigned notary to record that Tamweelview European Holdings
is the sole shareholder of THB JV S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having a share capital of fifty-two million one hundred sixty-five thousand nine hundred six United States
dollars (USD 52,165,906.-), with registered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 16 December 2011, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 499 of 24 February 2012 and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 165909 ("THB JV"). The articles of incorporation of THB JV have for the last
time been amended following a deed of the undersigned notary of 27 January 2016, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Tamweelview European Holdings, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed
of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To consider and, if thought fit, increase the share capital of THB JV by an amount of twenty-two million four hundred
forty thousand United States dollars (USD 22,440,000.-) so as to raise it from its present amount of fifty-two million one
hundred sixty-five thousand nine hundred six United States dollars (USD 52,165,906.-) to seventy-four million six hundred
five thousand nine hundred six United States dollars (USD 74,605,906.-).
2 To consider and, if thought fit, issue twenty-two million four hundred forty thousand (22,440,000) new shares, with
a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares.
3 To consider and, if thought fit, accept the subscription for these new shares with payment of a share premium in a
total amount of two hundred one million nine hundred sixty thousand United States dollars (USD 201,960,000.-) and to
accept full payment in cash for these new shares by TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A..
4 To consider and, if thought fit, amend the first paragraph of article 8 of the articles of incorporation of THB JV, in
order to reflect the capital increase.
5 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Tamweelview European Holdings resolved to increase the share capital of THB JV by an amount of twenty-two million
four hundred forty thousand United States dollars (USD 22,440,000.-) so as to raise it from its present amount of fifty-two
million one hundred sixty-five thousand nine hundred six United States dollars (USD 52,165,906.-) to seventy-four million
six hundred five thousand nine hundred six United States dollars (USD 74,605,906.-).
<i>Second resolutioni>
Tamweelview European Holdings resolved to issue twenty-two million four hundred forty thousand (22,440,000) new
shares with a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing
shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Tamweelview European Holdings, as above mentioned.
Tamweelview European Holdings declared to subscribe to twenty-two million four hundred forty thousand (22,440,000)
new shares, with a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) per share, with payment of a share premium in a
total amount of two hundred one million nine hundred sixty thousand United States dollars (USD 201,960,000.-) and to
fully pay up these new shares in cash.
The amount of two hundred twenty-four million four hundred thousand United States dollars (USD 224,400,000.-) was
thus as from that moment at the disposal of THB JV, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
Tamweelview European Holdings resolved to accept said subscription and payment and to allot the new shares according
to the above mentioned subscription.
102574
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
Tamweelview European Holdings resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of incorporation of
THB JV in order to reflect the above resolutions.
Said paragraph will from now on read as follows:
“The share capital is set at seventy-four million six hundred five thousand nine hundred six United States dollars (USD
74,605,906.-), represented by seventy-four million six hundred five thousand nine hundred six (74,605,906) shares, with
a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by THB JV as a result of the present deed are
estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois de mai,
par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand Duché de Lu-
xembourg,
a comparu:
TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93081 («Tamweelview European
Holdings»),
représenté aux fins des présentes par Maître Catherine KREMER, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 2 mai 2016.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Tamweelview European Holdings a requis le notaire instrumentant d'acter que Tamweelview European Holdings est le
seul et unique associé de THB JV S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un
capital social de cinquante-deux millions cent soixante-cinq mille neuf cent six dollars des Etats-Unis (USD 52.165.906,-),
dont le siège social est au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant
acte du notaire soussigné en date du 16 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous
le numéro 499 du 24 février 2012 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 165909 («THB JV»). Les statuts de THB JV ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date
du 27 janvier 2016, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Tamweelview European Holdings, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement
informé des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Examen de et, si jugé approprié, décision d’augmenter le capital social de THB JV à concurrence d’un montant de
vingt-deux millions quatre cent quarante mille dollars des Etats-Unis (USD 22.440.000,-) pour le porter de son montant
actuel de cinquante-deux millions cent soixante-cinq mille neuf cent six dollars des Etats-Unis (USD 52.165.906,-) à un
montant de soixante-quatorze millions six cent cinq mille neuf cent six dollars des Etats-Unis (USD 74.605.906,-).
2 Examen de et, si jugé approprié, décision d’émettre vingt-deux millions quatre cent quarante mille (22.440.000)
nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et
privilèges que les parts sociales existantes.
3 Examen de et, si jugé approprié, décision d’accepter la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement
d’une prime d’émission d’un montant total de deux cent un millions neuf cent soixante mille dollars des Etats-Unis (USD
201.960.000,-) et acceptation du paiement intégral en numéraire par TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A..
4 Examen de et, si jugé approprié, décision de modifier l'alinéa premier de l'article 8 des statuts de THB JV, afin de
refléter l'augmentation de capital.
5 Divers.
a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
102575
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Tamweelview European Holdings a décidé d’augmenter le capital social de THB JV à concurrence d’un montant de
vingt-deux millions quatre cent quarante mille dollars des Etats-Unis (USD 22.440.000,-) pour le porter de son montant
actuel de cinquante-deux millions cent soixante-cinq mille neuf cent six dollars des Etats-Unis (USD 52.165.906,-) à un
montant de soixante-quatorze millions six cent cinq mille neuf cent six dollars des Etats-Unis (USD 74.605.906,-).
<i>Deuxième résolutioni>
Tamweelview European Holdings a décidé d’émettre vingt-deux millions quatre cent quarante mille (22.440.000) nou-
velles parts sociales, d'une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et
privilèges que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Tamweelview European Holdings, représentée comme indiqué ci-avant.
Tamweelview European Holdings a déclaré souscrire vingt-deux millions quatre cent quarante mille (22.440.000) parts
sociales nouvelles, d'une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis (USD 1,-), chacune, avec paiement d’une prime
d’émission d’un montant total de deux cent un millions neuf cent soixante mille dollars des Etats-Unis (USD 201.960.000,-)
et libérer intégralement en espèces ces parts sociales nouvelles.
Le montant de deux cent vingt-quatre millions quatre cent mille dollars des Etats-Unis (USD 224.400.000,-) a dès lors
été à la disposition de THB JV à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Tamweelview European Holdings a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’allouer les parts sociales
nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.
<i>Quatrième résolutioni>
Tamweelview European Holdings a décidé de modifier l’alinéa premier de l’article 8 des statuts de THB JV pour refléter
les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social est fixé à soixante-quatorze millions six cent cinq mille neuf cent six dollars des Etats-Unis (USD
74.605.906,-), représenté par soixante-quatorze millions six cent cinq mille neuf cent six (74.605.906) parts sociales, d'une
valeur d'un dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par THB JV en raison du présent acte sont évalués à
six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: C. KREMER, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/14995. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016108936/158.
(160081366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Scubalux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9380 Merscheid, 8, rue du Puits.
R.C.S. Luxembourg B 166.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016108904/10.
(160081105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
102576
Imerys Re
Imerys Re
Imm. Lux S.A.
Immobilière Ecole Européenne Bertrange/Mamer S.à r.l.
Immo Prime S.A.
Indau S.à r.l.
Inesia S.A.
International Group Company S.A.
Interstate Europe
INVESCO European Hotel Real Estate S.à r.l.
Invesco Hanover Hotel Investment S.à r.l.
Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l.
Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l.
IPN Unternehmensberatung S.A.
Jacaranda Investissements S.A.
Jalor Finance S.A.
Japan Real Estate Invest S.A.
K-Erlen
LB Immo Invest LUX S.à r.l.
Les Résidences sa
Lhold S.à r.l.
Lombard Intermediation Services S.A.
Makena Capital Luxco B
M-Square Finance S.A. SPF
PTC Essen Capital S.A.
Qualtec S.à.r.l.
Reconsultholding S.à r.l.
Reconsult III Mainz S.à r.l.
Robeq S.A.
RTL 9 S.A.
Scubalux Sàrl
SDB Benelux S.A.
SOGEP spf S.A.
SouthBridge Europe Mezzanine S.C.A. SICAR
Stëftung Hëllef Doheem
ST Holdings S.à r.l.
St Martin S.à r.l.
Strategic Value Credit General Partner S.à r.l.
Sword Group SE
Tamweelview European Holdings S.A.
Tang Chu S.à r.l.
Telefónica Insurance S.A.
T&F Luxembourg S.A.
THB JV S.à r.l.
Tovra S.A.
TreeTop Global Sicav
TreeTop Global Sicav
TreeTop Scolea SICAV