logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2120

19 juillet 2016

SOMMAIRE

CMP German Opportunity Fund III  . . . . . . .

101724

Cristalas Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101735

F55 B Chateau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101754

Fondation Cavour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101758

Lamudi Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101743

Optibelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101750

Rambouillet Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

101714

Ramsbury Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101714

Red Fox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101714

Reinart s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101719

Residenz Treuhand S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

101720

Rinispa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101714

Saipem Maritime Asset Management Luxem-

bourg S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101718

Script s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101717

Silux Alternatives S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

101717

Sim Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101718

Société Financière Saka S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

101718

Sommerwasser S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101716

Sparkling Tours S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101720

Staffmatch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101715

ST Berlin Hotel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101716

ST Leipzig S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101716

ST Potsdam S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101723

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101719

Sybil Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101717

Syneco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101758

TA EU Acquisitions III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

101717

TA EU Acquisitions VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

101719

TA EU Acquisitions VI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

101718

TA EU Acquisitions V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

101721

TA EU Acquisitions Zebra S.à r.l.  . . . . . . . . . .

101722

TA EU Luxembourg III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

101723

TA EU Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

101720

Technoport S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101715

Tejo Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101715

Teka Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101721

Telus Applications for Industry  . . . . . . . . . . . .

101721

Tempus Holding 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

101714

TenTwentyFour S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101715

Ternium Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

101715

Theam Quant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101721

Thiolat Developpement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101722

Tiger Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101722

Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l.  . . .

101716

TMB Industry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101720

Topaz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101719

VB (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

101723

Victor Hugo 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101722

101713

L

U X E M B O U R G

Rambouillet Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 113.237.

L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2016.

Référence de publication: 2016108101/11.
(160080590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Ramsbury Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 163.976.

Les comptes annuels clos au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108102/9.
(160080287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Red Fox S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 89.273.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RED FOX S.A.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2016108106/11.
(160079586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Rinispa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 117.628.

<i>Rectificatif déposé le 25.04.2016 sous la référence L160068380

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108120/10.
(160080450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Tempus Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 204.118.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 24 février 2016.

Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2016108215/13.
(160079793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101714

L

U X E M B O U R G

TenTwentyFour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 178.420.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le gérant technique

Référence de publication: 2016108216/11.
(160079679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Ternium Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 154.306.

Le  Conseil  d'Administration  de  Ternium  Investments  S.à.r.l.  a  nommé  la  société  PricewaterhouseCoopers,  Société

coopérative, ayant son siège social au 2, RUE GERHARD MERCATOR, L-2182, Luxembourg, comme réviseur d'entre-
prise agrée, avec effet du 23.02.2016 jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle statutaire qui délibérera sur les
comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 Mai 2016.

Ternium Investments S.à.r.l.

Référence de publication: 2016108217/14.
(160079697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Tejo Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 188.262.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108214/9.
(160079726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Staffmatch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 115.802,72.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 204.496.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2016.

Référence de publication: 2016108199/10.
(160080460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Technoport S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 169.822.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016108210/10.
(160079710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101715

L

U X E M B O U R G

ST Berlin Hotel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 201.595.

La Société informe que l'adresse professionnelle de Messieurs Michel Thill et Jérôme Letscher a été modifiée comme

suit avec effet au 4 avril 2016:

287-289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Michel Thill / Jérôme Letscher
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2016108192/14.
(160079602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

ST Leipzig S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 33.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 128.236.

La Société informe que l'adresse professionnelle de Messieurs Michel Thill et Jerôme Letscher a été modifiée comme

suit avec effet au 4 avril 2016:

287-289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Michel Thill / Jerôme Letscher
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2016108196/14.
(160080702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.391.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 mai 2016.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2016108221/17.
(160079828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Sommerwasser S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1920 Luxembourg, 1, rue Lavoisier.

R.C.S. Luxembourg B 137.985.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108187/9.
(160080069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101716

L

U X E M B O U R G

TA EU Acquisitions III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.212.480,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.383.

<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 29 Avril 2016

- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France résidant professionnellement

au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;

- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2016.

Référence de publication: 2016108228/25.
(160079841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Silux Alternatives S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 193.778.

Der Jahresabschluss zum 31. März 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108176/9.
(160080514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Script s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 159.305.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 12/05/2016.

Référence de publication: 2016108163/10.
(160080414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Sybil Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 115.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 183.968.

Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2016.

Référence de publication: 2016108157/10.
(160079942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101717

L

U X E M B O U R G

TA EU Acquisitions VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 182.062.

<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 29 Avril 2016

- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement

au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;

- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2016.

Référence de publication: 2016108233/25.
(160079891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Saipem Maritime Asset Management Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 141.486.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108158/9.
(160079693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Sim Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 104.433.

EXTRAIT

En date du 1 

er

 Avril 2016, l’associé unique a pris la résolution suivante:

1. Transfert du siège social de la Société au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108177/11.
(160079970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Société Financière Saka S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 11.670.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108183/9.
(160079620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101718

L

U X E M B O U R G

TA EU Acquisitions VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 18.417.133,40.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 187.043.

<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 29 Avril 2016

- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement

au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;

- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2016.

Référence de publication: 2016108234/25.
(160079890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Topaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 162.793.

Les comptes annuels au 30 Septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016108222/10.
(160079561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 22.765.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108204/9.
(160079853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Reinart s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Luxembourg, 52, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 189.357.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 12/05/2016.

Référence de publication: 2016108108/10.
(160080403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101719

L

U X E M B O U R G

Residenz Treuhand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 185.353.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108090/9.
(160079682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

TA EU Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.212.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.380.

<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique en date du 29 Avril 2016

- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement

au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;

- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2016.

Référence de publication: 2016108238/25.
(160079958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Sparkling Tours S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4447 Soleuvre, 16, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 125.141.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108188/9.
(160080266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

TMB Industry, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 83.492.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016108258/11.
(160080251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101720

L

U X E M B O U R G

TA EU Acquisitions V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.212.499,90.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 175.263.

<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 29 Avril 2016

- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement

au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;

- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2016.

Référence de publication: 2016108232/25.
(160079892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Telus Applications for Industry, Société Anonyme.

Siège social: L-9559 Wiltz, Zoning Industriel Salzbaach, Bâtiment Berens.

R.C.S. Luxembourg B 177.345.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DUCAgest S.à r.l.

Référence de publication: 2016108251/10.
(160080327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Teka Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 131, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 198.441.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108250/9.
(160080238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Theam Quant, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 183.490.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 Mai 2015.

Référence de publication: 2016108253/10.
(160079676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101721

L

U X E M B O U R G

TA EU Acquisitions Zebra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.212.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 168.321.

<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 29 Avril 2016

- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement

au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;

- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2016.

Référence de publication: 2016108235/25.
(160079889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Thiolat Developpement, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 166.075.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108254/9.
(160079672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Tiger Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 135.753.

Les comptes annuels au 30.11.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108255/9.
(160079690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Victor Hugo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 16, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 133.196.

<i>Extrait complémentaire de la publication L160079443 déposée le 11 mai 2016

Le bilan du 1 

er

 août 2014 au 31 juillet 2015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 Mai 2016.

Référence de publication: 2016108278/11.
(160080248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101722

L

U X E M B O U R G

TA EU Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.500.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.382.

<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique en date du 29 Avril 2016

- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement

au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;

- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2016.

Référence de publication: 2016108237/25.
(160079959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

VB (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 169.694.

EXTRAIT

En date du 10 Mai 2016, l'associé a pris les résolutions suivantes:
- La révocation de Monsieur Peter Lundin, en tant que gérant A, est acceptée avec effet immédiat.
- Madame Diana Dumitru, née le 20 Mai 1981 à Tirgoviste, Roumanie, et avec adresse professionnelle au 15 Rue Edward

Steichen, L-2540, Luxembourg, est élue nouveau gérant A de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéter-
minée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 Mai 2016.

Référence de publication: 2016108287/15.
(160079734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

ST Potsdam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 201.571.

La Société informe que l'adresse professionnelle de Messieurs Michel Thill et Jérôme Letscher a été modifiée comme

suit avec effet au 4 avril 2016:

287-289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Michel Thill / Jérôme Letscher
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2016108198/14.
(160079603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101723

L

U X E M B O U R G

CMP German Opportunity Fund III, Société en commandite par actions qualifiée de Société d'Investissement à

Capital Variable - 

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 206.071.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of April.
Before us, Maître Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

CMP German Opportunity, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)

having its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen (formerly 7A, rue Robert Stümper), L-1282 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 157.944 and
having a share capital of 12,500 Euro, and

CMP German Opportunity Investors Fund III, SCSp, a Luxembourg special limited partnership (société en commandite

spéciale), having its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen (formerly 7A, rue Robert Stümper), L-1282 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, and whose registration with the Luxembourg Trade and Companies’ Register is
pending, and

CMP GOF III Vermögensverwaltung GmbH &amp; Co. KG, a German limited partnership (Kommanditgesellschaft) existing

under the laws of Germany, registered with commercial register of the Lower Court Berlin under number HRA 51909 and
having its registered office at Leipziger Platz 15, 10117 Berlin, Germany

here represented by Jennyfer Nündel, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Luxembourg, on 15 April 2016,

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a Luxembourg société

en commandite par actions (S.C.A.) which they wish to incorporate with the following articles of association (the “Arti-
cles”):

<i>Definitions

The following definitions constitute an integral part of these Articles.
“Additional Shareholder” shall mean a Limited Shareholder admitted to the Company, or increasing its Capital Com-

mitment, after the First Closing.

“Affiliate” shall mean the Managing General Partner, the Team Pool, the Investment Advisor, the Key Persons and any

of their Associates.

“AIFM Law” shall mean the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers, as maybe

amended from time to time.

“Articles” shall mean the articles of association of the Company, as maybe amended from time to time.
“Associate” shall mean an entity or person directly or indirectly controlling, or controlled by, or under common control

with, the relevant party; the term “control” (and any cognate expression) means, in respect of an entity, the rights to (a)
exercise the majority of the voting rights in that entity, or (b) appoint the majority of the members of the management of
the entity, or (c) determine the policy and strategy of the entity.

“Business Day” shall mean any day when banks are open to the public in Luxembourg other than a Saturday, Sunday

or a public holiday.

“Capital Call” shall mean the written notification from the Managing General Partner to the Limited Shareholders to

pay installments in Euro of their Capital Commitments upon not less than 10 Business Days advance notice.

“Capital Commitment” shall mean the amount of capital in Euro committed by a Limited Shareholder to the Company.
“Capital Contribution” shall mean the amount drawn down by the Managing General Partner from the Limited Share-

holders in respect of their Capital Commitments pursuant to a Capital Call. Capital Contributions shall be called from the
Limited Shareholders by the Managing General Partner always at the same time and pro-rata in the proportion of their
Capital Commitments except in case a Limited Shareholder is partly excused pursuant to § 7 subsection (5) and subject to
specific characteristics of the Classes of Ordinary Shares as described in the Offering Memorandum.

“Cause” shall mean (i) the material breach of these Articles or any side letter by an Affiliate to the detriment of the

Company through gross negligence (negligence grave, faute grave) or willful misconduct (faute intentionelle), including
fraud (fraude), (ii) conviction of criminal felony (crime(s)) (e.g. fraud) with respect to the Company, (iii) the insolvency,
administration, involuntary reorganization and bankruptcy of the Managing General Partner, the Team Pool (including in
its capacity as the founding general partner of the Feeder Partnership), or the Investment Advisor, and (iv) the occurrence
of cause with respect to the Feeder Partnership.

101724

L

U X E M B O U R G

“Commercial  Companies  Law”  shall  mean  the  Luxembourg  law  of  10  August  1915  on  commercial  companies,  as

amended and supplemented.

“Company” shall mean CMP German Opportunity Fund III, SCA SICAV-SIF having its registered office at 1, rue

Hildegard von Bingen (formerly 7A, rue Robert Stümper), L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and whose
registration with the Luxembourg Trade and Companies’ Register is pending.

“CSSF” shall mean the Luxembourg Commission for the Supervision of the Financial Sector (Commission de Surveil-

lance du Secteur Financier).

“Defaulting Shareholder” shall mean a Limited Shareholder who fails to make a Capital Contribution when due.
“Depositary” shall mean the depositary of the Company or any successor thereto.
“Feeder Pool” shall mean the Feeder Partnership and each parallel feeder pools, if any, as defined in the Offering

Memorandum.

“Feeder Partnership” shall mean CMP German Opportunity Investors Fund III, SCSp, a special limited partnership

(société en commandite spéciale).

“F+F Pool” shall be a Feeder Pool which will subscribe a Capital Commitment of no more than 2% of the total Capital

Commitments, as described in the Offering Memorandum.

“Final Closing” shall mean the end of the subscription period as described in the Offering Memorandum.
“First Closing” shall mean the date of the first closing which will be held as soon as practicable.
“Investment Advisor” shall mean the investment advisors of the Company as further described in the Offering Memo-

randum.

“Investment Period” shall mean the period commencing on the later of (i) First Closing and (ii) expiration of the in-

vestment period of the Previous Fund (as defined in the Offering Memorandum), and shall terminate on the earlier of (i)
the fifth anniversary of the commencement of the Investment Period, provided that the Managing General Partner may
with the consent of the investor advisory board of the Feeder Pools (other than the F+F Pool) extend such period for one
additional year, or (ii) the date on which the Managing General Partner decides to terminate the Investment Period early
because (x) 70 % of the total Capital Commitments have been invested in Portfolio Companies, or (y) changes in applicable
law or regulations or business conditions make an early termination necessary or advisable in the reasonable discretion of
the Managing General Partner, or (iii) the date on which the investment period of the Feeder Pools terminates.

“Key Person” shall mean the Managing Directors and the Investment Directors as defined in the Offering Memorandum.
“Limited Shareholder(s)” shall mean any holder of one or more Ordinary Shares.
“Losses” shall mean the Company’s balance sheet losses within the meaning of Commercial Companies Law.
“Management Fee” shall mean the managing fee payable to the Managing General Partner for managing the affairs of

the Company as described in the Offering Memorandum.

“Managing General Partner” shall mean CMP German Opportunity, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company (having its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen (formerly 7A, rue Robert Stümper), L-1282 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B
157.944)  a  sub-threshold  alternative  investment  fund  manager  (AIFM)  registered  with  the  CSSF,  acting  as  managing
general partner (associé gérant commandité) of the Company or a successor appointed in accordance with § 16 subsection
(1) and (2).

“Net Asset Value” shall have the meaning ascribed to in § 22 subsection (2).
“Offering Memorandum” shall mean the issuing document of the Company, as may be amended from time to time.
“Ordinary Shares” shall mean the fully paid-up shares of no par value (including, for the avoidance of doubt, fractions

of shares) issued to Limited Shareholders.

“Portfolio Companies” shall mean the companies in which the Company holds an investment of any type.
“Professional Investor” shall mean any professional investor according to § 1 (19) no. 32 of the German Capital In-

vestments Act (Kapitalanlagegesetzbuch), as amended.

“Profits” shall mean the Company’s balance sheet profits within the meaning of the Commercial Companies Law.
“Qualifying Investor” shall mean any person or entity qualifying as (i) a Well-Informed Investor as well as (ii) a Pro-

fessional Investor or as a Semiprofessional Investor.

“Register” shall mean the register to be kept by the Managing General Partner at the Company’s registered office in

accordance with the Commercial Companies Law.

“Securities in Portfolio Companies” shall mean all instruments (regardless of whether evidenced in paper form) issued

directly or indirectly by Portfolio Companies to the Company.

“Semiprofessional Investor” shall mean any semiprofessional investor according to § 1 (19) no. 33 of the German Capital

Investments Act (Kapitalanlagegesetzbuch), as amended.

“Share(s)” means the shares issued by the Company to its Shareholders, i.e. the Managing General Partner Share pursuant

to § 6 subsection (2) lit. b) and all Ordinary Shares.

“Share Capital” shall mean the share capital of the Company.

101725

L

U X E M B O U R G

“Shareholders” shall mean the Managing General Partner and the Limited Shareholders.
“SIF Law” shall mean the law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended.
“Subscription Booklet” shall mean the separate document as provided by the Managing General Partner setting out the

Capital Commitment and certain administrative information and additional legal and regulatory confirmations to be given
by the Limited Shareholders.

“Subsequent Closing Date” shall mean the date when the initial Capital Contribution of an Additional Shareholder shall

be due.

“Team Pool” shall mean CMP GOF III Vermögensverwaltung GmbH &amp; Co. KG, registered with the local court of

Berlin (Charlottenburg) under the number HRA 51909.

“Well-Informed Investor” shall mean any well-informed investor within the meaning of article 2 of the SIF Law, which

is (a) an institutional investor; (b) a professional investor; or (c) any other investor that meets the following conditions:

(i) he/she/it has confirmed in writing that he/she/it adheres to the status of Well-Informed Investor; and
(ii) either (x) invests a minimum of Euro 125,000.00 in the Company; or (y) he/she/it has been subject of an assessment

made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, an investment firm within the meaning of Directive
2004/39/EC, or a management company within the meaning of Directive 2009/65/EC, certifying his/her/its expertise, his/
her/its experience and his/her/its knowledge in adequately appraising an investment in the Company.

Art. 1. Formation of the Company.
§ 1 Formation, Commencement
(1) Formation
There exists among the Managing General Partner, the Limited Shareholders and all those who may become owners of

Shares hereafter issued, an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) organised
as a specialised investment fund (fonds d’investissement spécialisé - SIF) in the form of a corporate partnership limited by
shares (société en commandite par actions - SCA) (the “Company”) and which qualifies as an alternative investment fund
under the AIFM Law, which is governed by the Commercial Companies Law, the SIF Law, the AIFM Law, these Articles
and the Offering Memorandum.

(2) Commencement
The Company shall commence on 22 April 2016.
§ 2 Name
The Company shall have the name:
CMP German Opportunity Fund III.
§ 3 Purpose of the Company
The purpose of the Company is to build, hold and manage, either directly or through a wholly-owned holding company,

a portfolio of equity and equity-related investments in small and medium sized companies in Germany, Austria and Swi-
tzerland (including strategic add-on investments which, for the avoidance of doubt, may be located in countries other than
Germany, Austria or Switzerland) undergoing restructuring, business difficulties, underperformance or financial distress.

The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Offering Memorandum.
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and

development of its purpose to the largest extent permitted under the SIF Law and the AIFM Law or any legislative repla-
cements or amendments thereof.

§ 4 Limitation of Purpose, Investment Restrictions
The  purpose  of  the  Company  shall  be  subject  to  the  limitations  and  investment  restrictions  set  out  in  the  Offering

Memorandum.

§ 5 Fiscal Year, Registered Office, Currency
(1) Fiscal Year
The fiscal year of the Company shall be the calendar year. The first fiscal year of the Company shall commence on the

date on which the Company commenced pursuant to § 1 subsection (2) and shall terminate on December 31 of 2016.

(2) Registered Office
The Company shall have its registered office and place of central administration in the City of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the Managing General

Partner. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these Articles.

In the event that the Managing General Partner determines that extraordinary political or military events have occurred

or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the na-
tionality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

101726

L

U X E M B O U R G

The Company may have offices, branches (whether or not a permanent establishment) and subsidiaries either in Lu-

xembourg or abroad.

(3) Currency
The Company shall be denominated in Euro.

Art. 2. Company Capital, Shares, Debt Instruments.
§ 6 Partners, Capital Commitments, Admission
(1) Partners
The Company exists between:
(a) CMP German Opportunity, S.à r.l. which shall be the managing general partner (associé gérant commandité) of the

Company (the “Managing General Partner”), and

(b) the owners of the Ordinary Shares, which shall be the limited partners (actionnaires commanditaires) of the Company

(the “Limited Shareholders”). The Limited Partners Shares are exclusively restricted to CMP German Opportunity Investors
Fund III, SCSp (the “Feeder Partnership”), the Team Pool and other Feeder Pools, which shall be Qualifying Investors.

Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the

Shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

(2) Share Capital
(a) The Company has adopted a variable share capital structure meaning that the capital of the Company shall at any

time be equal to the net assets of the Company determined pursuant to § 22. The net assets of the Company shall, within
twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund (fonds
d’investissement  spécialisé),  achieve  and  remain  no  less  than  one  million  two  hundred  and  fifty  thousand  Euro  (€
1,250,000).

(b) The Company has been incorporated with a subscribed share capital of EUR 31,000 divided into one (1) Managing

General Partner Share and thirty (30) Ordinary Shares of no par value. Upon incorporation, the Shares were fully paid-up.

(3) Capital Commitments; Classes of Ordinary Shares
The Managing General Partner shall not have a capital commitment; the Limited Shareholders shall be committed to

subscribing Ordinary Shares as set out in the Offering Memorandum.

The Feeder Partnership subscribes for Ordinary Shares representing a share capital equaling its total capital commitments

from their investor partners. For the avoidance of doubt, the Capital Commitment of the Feeder Partnership shall automa-
tically increase in accordance with an increase of its total capital commitments.

Further  Limited  Shareholders  (i.e.  Feeder  Pools  other  than  the  Feeder  Partnership,  and  the  Team  Pool)  wishing  to

subscribe for Ordinary Shares shall execute a Subscription Booklet, which upon acceptance will be signed by the Managing
General Partner.

Limited Shareholders commit themselves to subscribing and accepting Ordinary Shares in accordance with the Articles

as well as the terms and conditions set forth in the Offering Memorandum. The subscription of a Limited Shareholder shall
become effective in relation to the Company upon acceptance of the Subscription Booklet by the Managing General Partner
and the admission to the Company shall become effective upon the registration as shareholder in the Register.

The Managing General Partner may decide to issue one or more classes of Ordinary Shares (each a “Class” and together

the “Classes”) or series of shares with different features as described in the Offering Memorandum.

The capital commitments of the Limited Shareholders to the Company are hereinafter collectively referred to as “Capital

Commitments”. Capital Commitments shall be called by the Managing General Partner (a “Capital Call”) in accordance
with the provisions in the Offering Memorandum. Upon payment on the Capital Call the Managing General Partner shall
issue the equivalent Ordinary Shares to the Limited Shareholders.

Capital Commitments can be called only during the Investment Period. After the expiration of the Investment Period,

Capital Commitments can be called only for the following purposes:

(i) to fund investments of the Company which were, as per the expiration of the Investment Period, bindingly committed

or in process according to a letter of intent already submitted prior to the expiration of the Investment Period;

(ii) to fund follow-on investments in Portfolio Companies of the Company in which the Company holds an investment

upon expiration of the Investment Period;

(iii) to fund the Management Fee payable to the Managing General Partner as described in the Offering Memorandum

(the”Management Fee“); provided that Capital Commitments to fund the Management Fee will be called only from Limited
Shareholders holding Class B Ordinary Shares;

(iv) to fund the other fees, expenses, obligations and liabilities to be borne by the Company pursuant to the Offering

Memorandum.

(4) Form of Shares, Register of Shares
All Shares shall be issued in registered form only.
All issued Shares of the Company shall be registered in the register of Shares (the “Register”) which shall be kept by

the Managing General Partner or by an entity designated therefore by the Company and shall contain the name of each

101727

L

U X E M B O U R G

Shareholder, its residence, registered office or elected domicile, the number of Shares (and their Class) held by it, the
amount paid in for each Share, banking references, and, if applicable, their date of transfer.

The registration of the Shareholder’s name in the Register evidences its right of ownership over such registered Shares.

No Share certificates shall be issued.

Each Shareholder may change the data contained in the Register by notice to the Managing General Partner. Any changed

data shall be authoritative for any action at least two (2) weeks thereafter.

The Shares (including, for the avoidance of doubt, fractions of Shares) are indivisible with regard to the Company, which

admits only one owner per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company. In the event that a Share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed or designated
by the joint holders as the sole owner in relation to the Company.

The Company may decide to issue fractional shares up to two (2) decimal places. Such fractional shares shall not be

entitled to vote except to the extent their number held by a Shareholder is such that they represent a whole share in which
case they confer a voting right.

§ 7 Issuance of Shares and Debt Instruments
(1) General Rule
The Managing General Partner is authorized to issue, in accordance with the Offering Memorandum and this § 7, an

unlimited number of Ordinary Shares (including, for the avoidance of doubt, fractions of Ordinary Shares) without reserving
to the existing Shareholders a preferential right to subscribe for the Ordinary Shares to be issued. Subject to the provisions
of the Offering Memorandum, the Managing General Partner may decide on the issuance of Ordinary Shares in its sole
and  absolute  discretion.  The  Ordinary  Shares  may  only  be  subscribed  to  by  Qualifying  Investors.  Each  newly  issued
Ordinary Share entitles its holder to the same rights and obligations as the holders of existing Ordinary Shares of the same
class.

(2) Price, Payment, Additional Shareholder
The price per Ordinary Share is fixed at one thousand Euros (EUR 1,000.-). This issue price per Ordinary Share shall

be payable within a period as determined by the Managing General in its sole reasonable discretion. The Managing General
Partner may delegate to any director, manager, officer, or other duly authorized agent the power to accept subscriptions,
to receive payment of the price of the Ordinary Shares to be issued and to deliver them.

The Managing General Partner may, in its sole discretion, admit additional Limited Shareholders and permit existing

Limited Shareholders to increase their Capital Commitments (additional Shareholders, as well as existing Shareholders in
respect of the increase in their Capital Commitments, referred to as “Additional Shareholder(s)”) at one or more subsequent
closings (“Subsequent Closings”) during the period following the First Closing and ending on the Final Closing.

On or after a Subsequent Closing the Managing General Partner shall first draw down Capital Contributions from the

Additional Shareholders and continue to make such drawdowns from the Additional Shareholders up to and until such time
as the contributed capital of all Shareholders bears the same proportion to their respective Capital Commitments.

(3) No Contribution in Kind
The Company may not agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities.
(4) Debt Instruments
The Managing General Partner is authorized to issue, in accordance with the Offering Memorandum to Limited Sha-

reholders  debt  instruments  with  the  purpose  to  fund  the  Company’s  portfolio  investments.  Amounts  paid  by  Limited
Shareholders in connection with the issuance of such debt instruments shall reduce the respective Limited Shareholders’
unfunded Capital Commitments.

(5) Default
If a Limited Shareholder fails to make a Capital Contribution when due according to a Capital Call (a “Defaulting

Shareholder”), such Defaulting Shareholder shall be deemed to be in default without the requirement of a reminder. In
addition to the statutory remedies upon default of payment, the remedies set forth in the Offering Memorandum shall be
applicable.

If a Feeder Pool becomes a Defaulting Shareholder, as a result of a default by one of its investors of its obligations under

the respective Feeder Pool’s documentation, default provisions shall be applied to the defaulting Feeder Pool to the extent
and in a manner as if the defaulting investor of the Feeder Pool, rather than such Feeder Pool, were the Defaulting Share-
holder.  The  Managing  General  Partner  is  hereby  authorized  to  make  such  allocations  and  distributions,  deliver  such
Drawdown Notices and take all such other actions as it deems appropriate to implement this subsection (5).

For the avoidance of doubt, no default shall exist in the event an investor of a Feeder Pool is excused or excluded from

an investment under such Feeder Pool’s documentation, if and to the extent such Feeder Pool does not satisfy a Capital
Call as a result of such excuse or exclusion. In such event, the unfunded Capital Commitment of such Feeder Pool shall be
reduced by the amount by which the capital commitment to the relevant Feeder Pool are reduced as a result of the excuse
or exclusion.

§ 8 Share in Company’s

101728

L

U X E M B O U R G

Assets Subject to the provisions in § 10 regarding allocations and distributions, the Limited Shareholders shall share in

the Company assets pro rata in proportion to their Capital Commitments.

§ 9 Liability of Shareholders
The Shareholders are only liable up to the amount of their respective unfunded Capital Commitment.
The Managing General Partner bears an unlimited liability for the debts of the Company.

Art. 3. Distribution of Proceeds, Expenses and Fees.
§ 10 Distribution of Proceeds
The Shareholders’ general meeting shall, upon proposal of the Managing General Partner and within the time limits

provided by the Luxembourg laws and regulations, these Articles and the Offering Memorandum, determine how the results
of the Company shall be disposed of and may declare, or may authorize the Managing General Partner to declare, distri-
butions. The Managing General Partner may decide to pay interim dividends in compliance with the applicable law. The
allocations and distributions shall be made in accordance with the provisions set forth in the Offering Memorandum and
the results of the Company shall be distributed to the Limited Shareholders pro-rata to their share in the Share Capital of
the Company, subject, however, to the specific characteristics of the Classes of Ordinary Shares as described in the Offering
Memorandum.

No distribution may be made if after the declaration of such distribution the Net Asset Value of the Company would

fall below one million one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 1,250,000).

Art. 4. Expenses and Costs.
§ 11 Expenses and Fees
The Company will pay all costs and expenses relating to its activities (to the extent not reimbursed by Portfolio Com-

panies) other than Managing General Partner expenses, including but not limited to, (i) direct costs of acquiring, holding,
monitoring or divesting Securities of Portfolio Companies (including legal fees and consulting fees as well as intermediary
fees to third parties) unless such expenses are reimbursed; (ii) broken deal expenses (for the avoidance of doubt, net of any
reimbursements of such expenses (including break-up fees) paid by third parties to the Company); (iii) third party costs
incurred in connection with the book-keeping and accounting of the Company; (iv) taxes and expenses incurred in relation
to the administration and business of the Company (including but not limited to fees and expenses paid to service providers);
(v) third party costs of preparation and audit of annual financial statements of the Company; (vi) fees and costs for litigation,
tax,  legal  and  other  professional  advice  rendered  to  the  Company;  (vii)  costs  of  printing  and  delivering  of  reports  to
Shareholders as well as expenses for organizing Shareholders’ meetings or investor conferences; (viii) fees and costs for
obtaining insurance protection in favor of the Company, its representatives and agents); and (ix) the Management Fee, in
each case as more fully described in the Offering Memorandum.

Art. 5. Management and Representation.
§ 12 Management Authority
(1) Basic Rule
The affairs of the Company shall be managed by the Managing General Partner in accordance with the provisions and

limitations in these Articles and the Offering Memorandum, and as may be otherwise required by mandatory law. The
Limited Shareholders may not participate or interfere in the management of the Company.

The Managing General Partner’s remuneration for the management of the affairs of the Company shall consist in the

Management Fee and no other compensation or remuneration shall be due. The Management Fee shall be calculated and
allowed in accordance with the provisions set forth in the Offering Memorandum. In general, all remunerations of the
Managing General Partner shall be described in the Offering Memorandum.

(2) Management Authority Power
Unless otherwise provided by Commercial Companies Law, the Offering Memorandum or by these Articles, the Ma-

naging General Partner shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition of the Company.

All powers not expressly reserved by the Commercial Companies Law, the Offering Memorandum or these Articles to

the general meeting of Shareholders shall be exercised by the Managing General Partner.

In particular, subject to the restrictions contained in the Offering Memorandum and the Commercial Companies Law,

the Managing General Partner shall have the broadest powers to implement the investment strategy and borrowing res-
trictions, as well as the course of conduct of the management and business affairs of the Company and to manage the
investments for the account of the Company with a view to achieving its investment strategy.

(3) Termination of Management Authority
The management authority of the Managing General Partner shall terminate automatically upon its resignation or re-

moval from the Company.

Any change in the management or replacement of the Managing General Partner will have to be agreed priory by the

CSSF.

(4) Delegation of Powers

101729

L

U X E M B O U R G

The Managing General Partner may, from time to time and always under its responsibility, appoint officers or agents

of the Company considered necessary for the operation and management of the Company, provided however that the
Limited Shareholders may not act on behalf of the Company without risking their limited liability status.

The Managing General Partner may from time to time and under its responsibility subdelegate its power to perform

specific tasks to one or more ad hoc agent(s). In particular, the Managing General Partner may, from time to time, appoint
one or more committees and delegate certain of its functions to such committees.

The Managing General Partner will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s) and/or com-

mittees, the duration of their appointment and any other relevant conditions to his/her/its/their appointment.

§ 13 Restrictions on Management Authority, Compliance
(1) Basic Rule
The management authority of the Managing General Partner shall be limited to the assets of the Company.
(2) Investment Restrictions
The investments of the Company shall be restricted as described in the Offering Memorandum.
(3) Conflict of Interest
No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected or invalidated

by the fact that the Managing General Partner or any one or more of the Shareholders, managers, agents, affiliates, personnel
or officers of the Managing General Partner is interested in, or is a partner, director, officer or employee of such other
company or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business. The Managing General Partner
or such officers shall not by reason of such affiliation with such other company or entity be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

§ 14 Representation
The Company shall be represented by the Managing General Partner. The Managing General Partner shall have complete

discretion and full power, authority and right to represent and bind the Company. The Managing General Partner and its
board of managers may enter into any legal transactions on behalf of the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of any two managers of the Managing General

Partner or by the individual or joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the
Managing General Partner as the Managing General Partner shall determine in its discretion.

Art. 6. Withdrawal of Shareholders.
§ 15 Redemption of Shares
The Company is closed-ended, which means that Shareholders shall not be entitled to require the unilateral redemption

of their Ordinary Shares by the Company.

For distribution purposes only, the Managing General Partner may, at its discretion, resolve to redeem Ordinary Shares

for distribution purposes. Subject to the provisions of the Offering Memorandum, the Managing General Partner shall
decide on the details of any redemption in its sole and absolute discretion. Any redemption request shall be addressed to
all the Shareholders.

§ 16 Removal of Managing General Partner
(1) Removal for Cause
In the event of Cause the Shareholders with a majority of more than 50 % of their votes expressed in a general meeting

of Shareholders may resolve to remove the Managing General Partner from the Company and to appoint a successor.

Notice of a Shareholders’ resolution resolving upon removal shall be given in writing and shall be served upon the

removed Managing General Partner without undue delay by a representative to be appointed in the Shareholders’ resolution.
The removal shall become effective as of the date specified in such notice, at the earliest on the date of service of the notice.

The management authority of the Managing General Partner shall terminate as per the date specified in the notice. The

Managing General Partner’s entitlement to the Management Fee described in the Offering Memorandum shall terminate
as of the effective date of revocation of the Managing General Partner’s management authority.

(2) Removal without Cause
Upon resolution to be passed by the a general meeting of Partners with a majority of at least 75 % of their votes, the

Managing General Partner may be removed from the Company without Cause and a successor can be appointed. A removal
can only be resolved upon if the Managing General Partner is removed from the Company and the Feeder Partnership. The
provisions in subsection (1) shall correspondingly apply. The management authority of the Managing General Partner shall
terminate upon service of the removal resolution. The Managing General Partner shall still be entitled to such compensation
as determined in the Offering Memorandum.

(3) No Veto Right, Replacement
With respect to the removal of the Managing General Partner, the Managing General Partner and any of its Affiliates

shall not be entitled to vote. The general meeting shall (without the approval of such Managing General Partner but with
the consent of such replacement general partner) appoint a general partner in replacement.

§ 17 Transfer of Shares

101730

L

U X E M B O U R G

(1) Ordinary Shares may be transferred, pledged or assigned only upon approval by the Managing General Partner.

Subject to the provisions of the Offering Memorandum, such approval shall only be given in the case of good cause on the
side of the requesting Limited Shareholder.

(2) Subject to the provisions of the Offering Memorandum, transfers of Shares shall be effected by inscription of the

transfer in the Register. Any transfer or assignment of Shares is subject to the purchaser or assignee thereof fully and
completely assuming in writing prior to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the transferor under the
subscription agreement entered into by the transferor.

Art. 7. Partners’ Meetings.
§ 18 Shareholders’ Meetings
(1) General
The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of Shareholders. Any regularly constituted

general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders. The general meeting of Shareholders is
vested with the powers expressly reserved to it by the Commercial Companies Law and by these Articles.

(2) Proceedings
The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice for,

and conduct of, the general meetings of Shareholders, unless otherwise provided herein.

General meetings of the Shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of the general meetings.

If all Shareholders are present or represented at a general meeting of the Shareholders, and consider themselves as being

duly convened and informed of the agenda of the general meeting, the general meeting may be held without prior notice.

A Limited Shareholder may act at any general meeting of the Shareholders by appointing another person (who needs

not be a Limited Shareholder) as its proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

Each Limited Shareholder may also participate in any general meeting of Shareholders by telephone or video conference

call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the general meeting to identify,
hear and speak to each other. The participation in a general meeting by these means is deemed equivalent to a participation
in person at such general meeting.

Each Limited Shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain

the date and place of the general meeting, the agenda of the general meeting, the text of the proposed resolutions as well
as for each proposed resolution, three boxes allowing the Shareholders to vote in favor, against or abstain from voting on
the proposed resolution. The voting forms must be sent by the Limited Shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or
e-mail to the registered office of the Company. The Company will only accept voting forms which are received prior to
the time of the general meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favor or
against the proposed resolutions) nor an abstention shall be void.

Except as otherwise required by Commercial Companies Law or by these Articles, resolutions at a general meeting of

the Shareholders duly convened will be adopted by a simple majority of those present or represented and voting, regardless
of the proportion of the Share Capital represented at such general meeting. Abstentions and nil votes shall not be taken into
account.

An extraordinary general meeting of Shareholders convened to amend any provisions of the Articles shall not validly

deliberate unless at least one-half of the Share Capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments
to the Articles. If this quorum is not reached, a second general meeting shall be convened, in the manner prescribed by the
Articles. The second general meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Share Capital represented
at such general meeting, if so stated in the notice for such subsequent general meeting. At both general meetings, resolutions,
in order to be adopted, must be carried by the majority as provided for in subsection (4) below.

One Shareholders’ general meeting shall be held annually at the registered office of the Company or elsewhere as may

be specified in the convening notice of such annual meeting on the first day of June of each year at 3 o’clock CET. If such
day is not a Business Day, or is a legal or banking holiday, the annual general meeting shall be held on the next Business
Day.

Further Shareholders’ general meetings will be called by the Managing General Partner (i) whenever deemed necessary

or advisable, or (ii) upon request of Limited Shareholders representing at least 10 % of their aggregate Shares, by giving
at least 15 Business Days’ advance notice in writing, which notice shall include the time and place of such general meeting
and state the agenda for such general meeting. The determination of the 15 Business Days period is to be made on the
beginning of the third Business Day after such notice is given. If the agenda is subsequently amended, such amended agenda
must be received by the Limited Shareholders by the third day before the scheduled date of a Partners’ general meeting,
and each Limited Shareholders shall have the right to request that the agenda shall be amended.

(3) Subject Matters
The Shareholders’ general meeting will inter alia resolve upon the following subject-matters:
(a) approval of the annual financial statements of the Company submitted by the Managing General Partner;
(b) discharge of the Managing General Partner for its activities during the past fiscal year;

101731

L

U X E M B O U R G

(c) appointment of a successor auditor for the fiscal year’s financial statements of the Company;
(d) changes of, and amendments to, these Articles, the Offering Memorandum and dissolution of the Company (in each

case subject to the prior approval of the CSSF as necessary under the SIF Law, see below);

(e) abandonment of the SIF status of the Company (subject to the prior approval of the CSSF, see below); and
(f) other subject-matters as provided for under the Offering Memorandum or any mandatory law;
each time in accordance with the subject matter relevant mandatory quorum and voting requirements.
(4) Majorities; Right to Split Votes
Subject to the provisions of these Articles and mandatory law, majority requirements shall be as follows: Shareholders’

resolutions shall be passed upon the simple majority of votes cast. The simple majority of votes cast shall mean more than
50 % of votes cast.

Resolutions according to the subsection (3) lit. d) above shall require a majority of at least 75 % of the Share Capital

and require in addition the consent of the Managing General Partner and the prior approval of the CSSF. Resolutions
according to the subsection (3) lit. e) above shall require the unanimous consent of all Partners and the prior approval of
the CSSF.

Any amendment of this subsection (4) shall require the unanimous consent of the Partners.
With respect to any request to the Shareholders for consent or approval under these Articles, a Feeder Pool may cast a

divided vote as if it were two Shareholders, with one vote reflecting the vote of its investors that consent or approve the
matter requested to be consented to or approved and with the other vote reflecting the vote of its investors that disapprove
such matter, in each case, as determined pursuant to the terms of such Feeder Pool’s documentation. Each investor of a
Feeder Pool who does not indicate any approval or disapproval of such matter under the terms of its documentation (in-
cluding, for the avoidance of doubt, investors excluded from voting in such matter) shall not be reflected in the Feeder
Pool’s votes in respect of such matter and the portion of the Feeder Pool’s voting rights attributable to such investor shall
be treated as having abstained from voting.

The general meeting of Shareholders may only adopt or ratify acts affecting the interests of the Company vis-à-vis third

parties with the consent of the Managing General Partner.

Art. 8 Term, Termination, Dissolution.
§ 19 Term of the Company
The term of the Company shall be limited and shall commence as of the date specified in § 1 subsection (2) and shall

continue for a period ending on the earlier of:

(a) the tenth anniversary of the commencement of the Investment Period; provided that the Managing General Partner

may, with the consent of the investor advisory board of the Feeder Pools (other than the F+F Pool), in its sole discretion
extend the term for two (2) additional consecutive one-year periods; or

(b) the date of occurrence of any of the events set forth in § 20, subject to the provision thereof.

§ 20 Early Termination
(1) The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders deliberating as

prescribed for amendment of these Articles, with the consent of the Managing General Partner.

(2) Notwithstanding the provisions of § 19 of these Articles, the Company shall dissolve upon the occurrence of any of

the following events: (a) dissolution of the Managing General Partner, the Feeder Partnership or the Investment Advisor;
(b) commencement of insolvency proceedings over the assets of the Managing General Partner, of the Feeder Partnership
or of the Investment Advisor or rejection of a petition to commence such proceedings for lack of assets; or (c) removal of
the Managing General Partner from the Company; provided that the Company shall not terminate if, within 90 days after
such an event, Shareholders holding at least 75 % of the total Capital Commitments elect to continue the business of the
Company and to appoint a successor; each time subject to the prior approval of the CSSF.

§ 21 Dissolution
1) Liquidator
Upon dissolution of the Company, the Managing General Partner may be appointed as liquidator of the Company by

the Shareholders (subject to CSSF approval) and shall liquidate all or any part of the assets of the Company; provided that
upon dissolution according to § 20 because of an event relating to the Managing General Partner, the Company shall be
wound up by a liquidator appointed by the Shareholders with a majority of more than 50 % of the total Share Capital in
the Company.

Such appointed liquidator(s) must be approved by the CSSF and must provide all requisite guarantees of honorability

and professional skills.

(2) Allocation of Liquidation Proceeds
Upon liquidation of the Company, the Managing General Partner shall be repaid its Managing General Partner Share,

increased  or  decreased  by  its  share  in  the  Company’s  aggregate  Profits  or  Losses  calculated  by  reference  to  the  total
performance of the Company (realized until the Company is dissolved). Profits and Losses arising from the liquidation of

101732

L

U X E M B O U R G

the assets of the Company upon liquidation shall be allocated among the Limited Shareholders pursuant to the formula as
set forth in the applicable subsection of § 10 of these Articles.

Art. 9. Valuation, Accounting, Reporting.
§ 22 Valuation of Company Assets, Net Asset Value
(1) Valuation
The assets of the Company shall be valued by the Managing General Partner on the basis of the fair value. Such value

shall be the value of the assets less the value of the liabilities and shall be determined as follows:

(i) the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after
making such discount as the Managing General Partner may consider on a consistent basis appropriate in such case to
reflect the true value thereof;

(ii) securities dealt in on a regulated market will be valued on the basis of their quoted mid-market price on the last day

of trading prior to the valuation date, subject to any discounts which in accordance with Invest Europe (formerly EVCA)
valuation guidelines and on a consistent basis may be applicable due to the nature of such security, on the market which is
normally the principal market for such securities;

(iii) all other assets of any kind or nature will be valued at fair value, as determined in good faith and on a consistent

basis by or under the responsibility of the Managing General Partner in accordance with with the international private
equity and venture capital valuation guidelines as published by the IPEV Board from time to time, unless otherwise provided
for under mandatory law (droit applicable). For the purpose of determining the fair value of the assets under this provision,
the Managing General Partner may have regard to all factors that it reasonably considers relevant on a consistent basis in
relation to such assets which factors may include (when applicable) inter alia: (a) the characteristics of and fundamental
analytical data relating to the assets including the costs, size, current interest rate, period until next interest rate reset,
maturity and lending rate of the assets, the terms and conditions of the assets’ debt structure; (b) the nature and adequacy
of the Company’s rights, remedies and interests; (c) the creditworthiness of the assets business, cash flows, capital structure
and future prospects; (d) information relating to recent relevant market transactions; (e) the reputation and financial con-
dition of the Portfolio Companies and recent reports relating to the assets; (f) general economic market conditions affecting
the fair value of the assets;

(iv) the value of assets denominated in a currency other than Euro shall be determined by taking into account the rate

of exchange prevailing at the time of the determination of the Net Asset Value.

Subject to the provisions of the Offering Memorandum, the Managing General Partner is authorized to apply other fair

valuation principles for the assets of the Company, when circumstances or market conditions so justify, but on a consistent
basis. When evaluating any assets which are held subject to any restriction on transfer or sales, such assets will be valued
at a reasonable discount. All valuation regulations and determinations shall be interpreted and applied in accordance with
Lux GAAP and the SIF Law.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken

by the Managing General Partner or by any custodian, company or other organization which the Managing General Partner
may appoint for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and on its
present, past or future Shareholders, subject to the year-end audit by the auditor of the Company being a réviseur d’entre-
prises agréé.

(2) Net Asset Value
The net asset value of the Company (the “Net Asset Value”) shall be calculated by taking into account the valuations

as prepared by the Managing General Partner in accordance with the principles set out here above and shall be determined
and expressed in Euro as may be further detailed in the Offering Memorandum.

The Net Asset Value shall be calculated as of the end of each calendar quarter by the Managing General Partner (or any

agent duly appointed by the Managing General Partner) and may be rounded up or down to two (2) decimal places as
described further in the Offering Memorandum.

(3) Suspension of Calculation of the Net Asset Value
The Managing General Partner may suspend the calculation of the Net Asset Value when:
(a) any period when, in the reasonable opinion of the Managing General Partner, a fair valuation of the assets of the

Company is not practicable for reasons beyond the control of the Company; or

(b) any period when any of the principal stock exchanges on which Investments of the Company are quoted are closed

(otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted or suspended; or

(c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned

by the Company would be impractical; or

(d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the

price or value of any of the Investments or the currency price or values on any such stock exchange.

§ 23 Accounting

101733

L

U X E M B O U R G

The Company or an entity designated therefore by the Company shall maintain complete and accurate books of account

of the Company’s affairs at the Company’s office, which books (i) will be open to inspection by any Shareholder, any
investor of a Shareholder if such Shareholder is a Feeder Pool, or such limited partner’s or a Shareholder’s authorized
representative - which can be an external adviser, bound by a legal confidentiality obligation - at any time during ordinary
business hours and (ii) will be preserved during the longer of (x) the periods required by law and (y) the term of the Company
and for a period of five years thereafter. Legal inspection rights of Shareholders under mandatory law shall remain unaf-
fected. The accounts of the Company shall be maintained in Euro. Within the time periods required by law, the financial
statements of the Company shall be prepared and audited in accordance with the provisions of Lux GAAP and the SIF
Law.

§ 24 Reporting
(1) Annual Reports
Subject to the provisions of the Offering Memorandum, the Managing General Partner shall provide to the Shareholders

annual reports of the Company as required by the SIF Law.

(2) Other Information
The Company shall provide to the Shareholders the other information as set out in the Offering Memorandum.
(3) Feeder Pools
The Managing General Partner agrees to use its commercially reasonable efforts to provide the Feeder Pools or any of

their representatives with all information, data and documents in its possession or which can be obtained at a reasonable
cost and which are required to fulfil each Feeder Pool’s own reporting obligations.

Art. 10. General Provisions.
§ 25 Depositary, Statutory Auditor
(1) Depositary
The Company has entered into a depositary agreement with an entity, which shall satisfy the requirements of the SIF

Law (the “Depositary”), who shall assume towards the Company and its Shareholders the duties and responsibilities pro-
vided by the SIF Law.

In the event of the Depositary desiring to retire, the Managing General Partner shall use its best endeavors to find a

successor to act as depositary within two (2) months of the effective date of such retirement and upon doing so the Managing
General Partner shall appoint such corporation to be depositary in place of the retiring Depositary. The Managing General
Partner may terminate the appointment of the Depositary, but shall not remove the Depositary unless and until a successor
depositary shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.

The duties of the Depositary shall cease:
(i) in the case of the voluntary withdrawal of the Depositary or its removal by the Company; until it is replaced, the

Depositary shall take all necessary steps for the successful maintaining of the interests of the Partners; or

(ii) in the event that the Depositary or the Company have (a) been declared bankrupt, (b) obtained a suspension of

payments, (c) entered into a composition with creditors, (d) been placed under controlled management or any similar
proceedings, or (e) been put into liquidation; or

(iii) where the CSSF withdraws its authorization of the Depositary or the Company.
(2) Independent Auditor
The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised by one

authorized auditor (“réviseur d‘entreprises”), who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness
and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the SIF Law.

§ 26 Indemnification
The Company shall provide indemnification to Affiliates, their respective partners, shareholders, managers, employees,

advisers and agents as well as to the members of the investor advisory board of the Feeder Pools (other than the F+F Pool)
and the investor of the Feeder Pools represented by such member, as set out in the Offering Memorandum.

§ 27 Amendments to the Articles; Governing Law
(1) Subject to the prior approval of the CSSF, these Articles may be amended from time to time by a general meeting

of Partners’, subject to the quorum and majority requirements of § 18.

(2) These Articles shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on thirty-first (31 

st

 )

December 2016.

2. The first annual general meeting of Partners shall be held in 2017.
3. The first annual report of the Company will be the annual report as of 2016.

101734

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The thirty-one thousand (31,000) Shares issued have been subscribed as follows:
- one (1) Managing General Partner Share has been subscribed by CMP German Opportunity, S.à r.l., aforementioned,

for the price of one thousand euro (EUR 1,000); and

-  twenty-nine  (29)  Ordinary  Shares  have  been  subscribed  by  CMP  German  Opportunity  Investors  Fund  III,  SCSp,

aforementioned, for the price of one thousand euro (EUR 1,000), each;

- one (1) Ordinary Share has been subscribed by CMP GOF III Vermögensverwaltung GmbH &amp; Co. KG, aforementioned,

for the price of one thousand euro (EUR 1,000).

The Shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand

euros (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. The total
contribution in the amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000) is entirely allocated to the share capital.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for or referred to in

article 26 of the Commercial Companies Law and expressly states that they have been complied with.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR
1,200.-).

<i>Resolutions of the Partners

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entire subscribed capital

and considering themselves as duly convened, have immediately held an extraordinary general meeting. Having first ve-
rified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 1, rue Hildegard von Bingen, L-2557 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg;

2. The following person is appointed as approved statutory auditor until the general meeting of shareholders convened

to approve the Company’s annual accounts for the first financial year:

Ernst &amp; Young, a „société anonyme“, with registered office at 35 E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47.771.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Signé: J. NÜNDEL, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/13424. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 13 mai 2016.

Référence de publication: 2016109169/666.
(160081913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.

Cristalas Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 206.083.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh of the month of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Headstart S.à r.l., having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149993,

101735

L

U X E M B O U R G

here represented by Mrs. Annick Braquet, having her professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy given

on April 26, 2016.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a joint-stock company:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There exists a public limited liability company under the name of “Cristalas Holding S.A.", which shall be

governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10,
1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of incorporation
(hereinafter, the Articles).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such partici-
pating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any
enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way what-
soever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities
and patents developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or other-
wise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies
to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions,

take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purpose or which are liable to promote their development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees
and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies
or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over
some of its assets.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole

Director (as defined below) or the Board of Directors (as defined below), respectively by a resolution taken by the ex-
traordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Title II. - Capital, shares

Art. 5. The subscribed share capital of the Company is set at EUR 31,000,- (thirty-one thousand Euro) represented by

31,000 (thirty-one thousand) shares, with a nominal value of EUR 1,- (one Euro) each.

The shares may be registered or bearer shares at the option of the shareholders.
Bearer shares shall be signed by the Sole Director or, in case of plurality of directors, by two directors. The signature

may be manual, in facsimile or affixed by means of a stamp. The signature may also be affixed by a person delegated for
that purpose by the Board of Directors, but in such case, it must be manual.

The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the certificate.
The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

The owner of shares in bearer form may, at any time, request that they be converted, at their expense, into shares or

securities in registered form.

The shares are freely transferable.
Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to

appoint a sole person as their representative towards the Company.

Title III. - Management

Art. 6. The Company is managed by a Board of Directors (hereinafter, the Board of Directors) composed of at least

three (3) members either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general
meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

101736

L

U X E M B O U R G

In case of a single shareholder, the Company may be managed by a sole director (the Sole Director) who assumes all

the rights, duties and liabilities of the Board of Directors.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman (hereinafter, the Chairman).
The Board of Directors is convened upon call by the Chairman, as often as the interest of the Company so requires. It

must be convened each time two (2) directors so request.

Written notice of any meeting of the Board of Directors will be given to all directors, in writing or by telefax or electronic

mail (e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency. This notice may be waived if all the directors are present and/or represented, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board of Directors.

A director may be represented by another member of the Board of Directors, and a member of the Board of Directors

may represent several directors.

The Board of Directors can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present and/or repre-

sented by proxies. Any decisions taken by the Board of Directors shall require a simple majority of the directors.

A written decision, approved and signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a

meeting of the Board of Directors, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Directors.

One or more directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-

nication  enabling  thus  several  persons  participating  therein  to  simultaneously  communicate  with  each  other.  Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Decisions taken during such a meeting may be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate objects of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant
legal requirements.

Art. 9. The Company will be bound in any circumstances by the signature of the Sole Director or, in case of plurality

of directors, by the joint signatures of any two (2) directors.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or

more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more directors,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either
shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

Company by the Board of Directors, represented by the Chairman or by a director delegated for this purpose.

Title IV. - General meeting of shareholders

Art. 12. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sha-

reholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.

Art. 13. The annual general meeting of the shareholders shall be held on the second Wednesday of the month of May

at 16.00 p.m. CET at the registered office of the Company or at any other location specified in the notice of meeting.

If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

business day.

Art. 14. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate by telephone or video conference call or by other similar means of communication

allowing (i) the identification of the shareholders, (ii) all the shareholders taking part in the meeting to hear one another,
(iii) the meeting to be held live. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting.

Art. 15. The shareholders' meeting shall meet upon notice by the Board of Directors or by the auditor.
They shall convene such a meeting within a month if a shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten

percent (10%) of the shares of the Company so requests, provided they make a written request with a determined agenda.

A shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company may add

discussion points to the agenda, provided that they make a written request no later than five (5) days prior to the meeting.

101737

L

U X E M B O U R G

Notification letters for each shareholders meeting mention the agenda of the meeting.
Provided that all shares are nominative, notifications may be addressed individually to each shareholder by means of a

registered letter.

Art. 16. Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by the Articles, resolutions at a duly convened meeting of the shareholders of

the Company will be passed by a simple majority of the votes expressed by the shareholders present and/or represented.

Art. 17. Any resolutions aiming to amend the Articles shall require the holding of an extraordinary general meeting that

only validly deliberates if one half of the capital is represented and provided that the agenda indicated the proposed amend-
ments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the

Articles and the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of shares present or represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes expressed by the
shareholders present and/or represented.

Art. 18. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

Art. 19.  A  shareholder  may  act  at  any  meeting  of  the  shareholders  of  the  Company  by  appointing  another  person,

shareholder or not, as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or e-mail (provided that the
electronic signature is in conformity with the Luxembourg relevant legislation).

If all shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and

declare themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without
prior notice.

Prior to any debates, the shareholders elect amongst them a chairman for the meeting of the shareholders, who will then

proceed to the nomination of a secretary. The shareholders will appoint the scrutineer.

The minutes of the meetings of the shareholders are signed by the chairman, the secretary and the scrutineer, and by

any shareholder willing to.

Title V. - Audit

Art. 20. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders

which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six (6) years.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 21. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 22. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital

but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten
percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their

shareholding in the Company.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. The Company may be dissolved by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders. The

liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of
shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provision

Art. 24. All matters not governed by the Articles are to be construed in accordance with the Law.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2016.

<i>Subscription - Payment

The articles of incorporation having thus been established, the 31.000 (thirty one thousand) shares have been subscribed

and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:

101738

L

U X E M B O U R G

Subscriber

Shares

Payment

- Headstart S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 EUR 31,000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 EUR 31,000,-

The amount of EUR 31.000,- (thirty one thousand Euro) has been fully paid up in cash and is now available to the

Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at EUR 1,200.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions
1. The following person is appointed as director of the Company until the annual general meeting of the shareholders

to be held on 2017:

- Mr. Rémy Cornet, born on 8 June 1984 in Marche-en-Famenne, Belgium, with professional address at 7, rue Robert

Stümper, L-2557 Luxembourg.

2.  The  following  person  is  appointed  as  statutory  auditor  of  the  Company  until  the  annual  general  meeting  of  the

shareholders to be held on 2017:

- PME Xpertise, société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under

number B100087, having its registered office at 2b, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler.

3. The address of the Company is fixed at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois d'avril.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Headstart S.à r.l., ayant son siège social à 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

et enregistré auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149993,

ici représentée par Mme Annick Braquet, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée le 26 avril 2016.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Cristalas Holding S.A.» (ci-après la Société), soumise

aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée (ci-après, la Loi) ainsi qu'aux
dispositions des présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et
brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou
entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société
(y compris ses actionnaires ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-

mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement
ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

101739

L

U X E M B O U R G

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement

par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles
ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre
nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement

par décision de l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) ou le Conseil d'Administration (tel que défini ci-après),
ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tel que requis par les dispositions applicables
de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) représenté par 31.000 (trente et un mille)

actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, toutes intégralement libérées.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
L'action au porteur est signée par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par deux (2) admi-

nistrateurs. Sauf disposition contraire des Statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au
moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Conseil
d'Administration, qui dans ce cas, devra être manuscrite.

La cession de l'action au porteur s'opère par la seule tradition du titre.
Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les  propriétaires  d'actions  au  porteur  peuvent,  à  toute  époque,  en  demander  la  conversion,  à  leur  frais,  en  actions

nominatives.

Les actions sont librement transmissibles.
Chaque action est indivisible à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. En cas de

pluralité de propriétaires d'une action, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul
propriétaire soit désigné.

Titre III. - Administration

Art. 6. La Société est administrée par un conseil d'administration (ci-après, le Conseil d'Administration) composé d'au

moins trois membres, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans, par l'assemblée générale
des actionnaires qui peut à tout moment les révoquer.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la

Société.

Si toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un

administrateur unique (l'Administrateur Unique) qui assume alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil d'Ad-
ministration.

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président (ci-après, le Président).
Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux (2) administrateurs le demandent.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs par écrit ou télécopie

ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Il pourra
être passé outre cette convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés
de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion individuelle se tenant à une heure et à
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Un administrateur peut être représenté par un autre membre du Conseil d'Administration, et un membre du Conseil

d'Administration peut représenter plusieurs administrateurs.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente et/ou représentée par procurations. Toute décision du Conseil d'Administration doit être prise à la majorité
simple.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produit effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil
d'Administration.

101740

L

U X E M B O U R G

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication permettant à tous les Administrateurs participant à la réunion de se comprendre
mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être
documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les
participants.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition conformément à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale sont de la

compétence du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant
les dispositions légales.

Art. 9. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de l'Administrateur Unique ou les signatures

conjointes de deux (2) administrateurs.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis
dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'Administration, poursuites et diligences du Président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Assemblée des actionnaires

Art. 12. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires

de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la Société.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de mai à 16 heures CET, au siège social

ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 14. Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues aux lieu et date spécifiés dans les convocations

respectives de chaque assemblée.

Tout actionnaire de la Société peut participer par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de

communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toute per-
sonne participant à l'assemblée peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) l'assemblée est retransmise en direct.
La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'as-
semblée.

Art. 15. Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou

par le commissaire aux comptes.

Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires repré-

sentant au moins dix pourcent (10%) du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social peuvent demander l'inscription

d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour, à la condition de faire une telle demande par écrit cinq (5) jours au moins avant
la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.
Si toutes les actions sont nominatives, les notifications peuvent être adressées individuellement à chaque actionnaire

par lettre recommandée.

Art. 16. Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale

des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes exprimés par les actionnaires
présents et/ou représentés.

Art. 17. Les décisions pour modifier les Statuts requièrent la tenue d'une assemblée générale des actionnaires de la

Société qui ne délibérera valablement que si au moins la moitié du capital social est représenté et pour laquelle l'ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues

par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de la précédente assemblée
générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital présent et/ou représenté. Dans
les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés par
les actionnaires présents et/ou représentés.

101741

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Cependant, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu'à l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

Art. 19. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblés générales des actionnaires de la Société en désignant une

autre personne, actionnaire ou non, en qualité de mandataire, par écrit, soit en original, soit par téléfax, ou par courriel (si
la signature électronique est conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise).

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le

président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment
le bureau de l'assemblée générale.

Les procès verbaux des assemblées générales des actionnaires de la Société seront signés par les membres du bureau de

l'assemblée générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Titre V. - Surveillance

Art. 20. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais

doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'actionnaire unique ou aux actionnaires au prorata de leur participation

dans la Société.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire. Lors de la dissolution de la

Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés
par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Disposition générale

Art. 24. Pour tous les points non spécifiés dans les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la

Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2016.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les 31.000 (trente et un mille) actions ont été souscrites et intégralement

libérées en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteur

Actions

Libération

- Headstart S.à r.l., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 EUR 31.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 EUR 31.000,-

Le montant de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent

à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200.-

<i>Décisions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2017:

- M. Rémy Cornet, né le 8 juin 1984 à Marche-en-Famenne, Belgique, avec une adresse professionnelle au 7, rue Robert

Stümper, L-2557 Luxembourg.

101742

L

U X E M B O U R G

2. La personne suivante est nommée commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui

se tiendra en 2017:

- PME Xpertise, société à responsabilité limitée, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Société du Lu-

xembourg sous le numéro B100087, ayant son siège social au 2b, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler.

3. L'adresse du siège social est fixée au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14082. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 mai 2016.

Référence de publication: 2016109142/405.
(160082476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.

Lamudi Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.486.

In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of May.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.038, having
its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “AIH”),

being the holder of six thousand two hundred fifty (6,250) common shares, six thousand two hundred fifty (6,250) series

A1 shares and four thousand two (4,002) series B shares, and becoming the holder of three hundred seventy five (375) new
series C shares,

here represented by Mrs. Camille Braconnier, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Karachi, on 28 April 2016,

2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg),
Germany, under no. HRB 139778 B, having its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of three thousand one hundred twenty-five (3,125) common shares and three thousand one hundred

twenty-five (3,125) series A2 shares,

here represented by Mrs. Camille Braconnier, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Berlin, on 29 April 2016,

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 176.544, having
its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of one thousand five hundred sixty-two (1,562) common shares and one thousand five hundred sixty-

three (1,563) series A3 shares,

here represented by Mrs. Camille Braconnier, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in London, on 2 May 2016,

4. TEC Global Invest VII GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Duisburg (Amtsgericht Duisburg), Germany,
under no. HRB 26063, having its registered office at Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany (hereinafter
“TEC”),

being the holder of one thousand five hundred sixty-three (1,563) common shares, one thousand five hundred sixty-two

(1,562) series A4 shares and one thousand five hundred (1,500) series B shares, and becoming the holder of one hundred
sixty eight (168) new series C shares,

101743

L

U X E M B O U R G

here represented by Mrs. Camille Braconnier, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Mülheim an der Ruhr, on 29 April 2016, and

5. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 191.426 (hereinafter “Holtzbrinck”),

being the holder of two thousand five hundred (2,500) series B shares, and becoming the holder of six hundred fifty six

(656) new series C shares,

here represented by Mrs. Camille Braconnier, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Luxembourg, on 28 April 2016.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders, representing the entire share capital of Lamudi Global S.à r.l. (hereinafter

the “Company”), formerly Digital Services XXV S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 188486, incorporated pursuant to a deed of notary Carlo Wersandt on 18 June 2014, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2492 on 16 September 2014. The articles of association have
been amended for the last time pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux dated 15 April 2015, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1653 on 3 July 2015.

The appearing parties representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general meeting

of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares in the share capital of the Company, referred to as the series C

shares (the “Series C Shares”), so that the Company will hence have seven (7) classes of shares, the common shares, the
series A1 shares, the series A2 shares, the series A3 shares, the series A4 shares, the series B shares and the series C shares.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one thousand one hundred ninety nine euros (EUR

1,199.-) from its current amount of thirty three thousand two euros (EUR 33,002.-) up to thirty four thousand two hundred
one euros (EUR 34,201.-) through the issuance of one thousand one hundred ninety nine (1,199) series C shares, with a
nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

3. Subsequent amendment of article five point 1 (5.1) of the articles of association of the Company, so that it shall

henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company’s share capital is set at thirty four thousand two hundred one euros (EUR 34,201.-), represented

by:

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (hereinafter

“Common Shares”),

5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each

(hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each

(hereinafter “Series A3 Shares”),

5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each

(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”),

5.1.6 eight thousand and two (8,002) series B shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (hereinafter “Series

B Shares”) and

5.1.7 one thousand one hundred ninety nine (1,199) series C shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each

(hereinafter “Series C Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.”

4. Amendment of article eight (8) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an

economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii) of
the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the events

101744

L

U X E M B O U R G

described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -subject to
Articles 8.2 to 8.4 below - will be distributed in accordance with Article 8.5 to the Shareholders pro rata to their participation
in the Liquidity Event.

8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series C Shares shall receive per Series C Share an amount of two

thousand three hundred ninety nine euros and eighty five cents (EUR 2,399.85) being subject to the Liquidity Event.

8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series B Shares shall receive per Series B Share an amount of

two thousand euros (EUR 2,000) being subject to the Liquidity Event.

8.4 On a third level (“Third Level”) the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4

Shares shall receive per Share of the respective share class (“Share Class”) an amount stipulated next to the relevant Share
Class being subject to the Liquidity Event in the following table:

Share Class

Amount

per Share

in Euro

Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.00

Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,695.18

Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,599.49

Series A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,600.51

8.5 After the payments on the First Level, the Second Level and the Third Level have been made, the remaining Exit

Proceeds shall be allocated on a fourth level (“Fourth Level”) to all Shareholders pro rata corresponding to their participation
in the Liquidity Event. Any amounts received by any Investor on the First Level, the Second Level and/or the Third Level
shall reduce the amount to be allocated to such Investor on the Fourth Level provided that no Investor shall be obliged to
repay any amount received on the First Level, the Second Level and/or the Third Level. Irrespective of whether or not the
sale of Shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions no
shareholder shall receive for the sale of all of its Shares (and shall repay any exceeding amount to the other shareholders)
an amount exceeding the higher of (i) its Share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the Shares sold on a
common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level, the Second Level and/or the
Third Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised
once.

8.6. The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level, Second Level and Third Level applies for the benefit

of the respective Investor so long as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to
such Investor according to the First Level, the Second Level and/or the Third Level.”

5. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mrs.

Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the share-
holders register of the Company.

6. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires

the undersigned notary to enact, the following resolutions:

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares in the share capital of the

Company, referred to as the series C shares (the “Series C Shares”), so that the Company will hence have seven (7) classes
of shares, the common shares, the series A1 shares, the series A2 shares, the series A3 shares, the series A4 shares, the
series B shares and the series C shares.

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders decides to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand

one hundred ninety nine euros (EUR 1,199.-) from its current amount of thirty three thousand two euros (EUR 33,002.-)
up to thirty four thousand two hundred one euros (EUR 34,201.-) through the issuance of one thousand one hundred ninety
nine (1,199) Series C Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Subscription

The new one thousand one hundred ninety nine (1,199) Series C Shares have been duly subscribed as follows:
- AIH, here represented as aforementioned, subscribed for three hundred seventy five (375) Series C Shares for an

aggregate amount of three hundred seventy five euros (EUR 375.-);

- Holtzbrinck, here represented as aforementioned, subscribed for six hundred fifty six (656) Series C Shares for an

aggregate amount of six hundred fifty six euros (EUR 656.-); and

- TEC, here represented as aforementioned, subscribed for one hundred sixty eight (168) Series C Shares for an aggregate

amount of one hundred sixty eight euros (EUR 168.-)

101745

L

U X E M B O U R G

<i>Payment

The new one thousand one hundred ninety nine (1,199) Series C Shares subscribed as stated above have been entirely

paid up through a contribution in cash in an aggregate amount of one thousand one hundred ninety nine euros (EUR 1,199.-).

The proof of the existence of the above contribution in cash has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand one hundred ninety nine euros (EUR 1,199.-) is entirely allocated to

the share capital of the Company.

<i>Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article five point

one (5.1) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as set out in the agenda of the present
deed.

<i>Fourth Resolution

The general meeting of shareholders decides to amend article eight (8) of the articles of association of the Company so

that it shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Fifth Resolution

The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,

as well as Mrs. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely,
the shareholders register of the Company.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechzehn, am vierten Mai.
Vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

SIND ERSCHIENEN:

1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Lu-
xemburg unter der Nummer B 177.038, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg (im
Folgenden „AIH“),

Inhaberin von sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Stammanteilen, sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) An-

teilen der Serie A1 und viertausendzwei (4.002) Anteilen der Serie B, und zukünftige Inhaberin von dreihundertfünfund-
siebzig (375) neuen Anteilen der Serie C,

hier vertreten durch Frau Camille Braconnier, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 28. April 2016, ausgestellt in Karachi,

2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778 B,
mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaberin von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Stammanteilen und dreitausendeinhundertfünfundzwan-

zig (3.125) Anteilen der Serie A2,

hier vertreten durch Frau Camille Braconnier, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 29. April 2016, ausgestellt in Berlin,

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Lu-
xemburg  unter  der  Nummer  B  176.544,  mit  Sitz  in  6C,  rue  Gabriel  Lippmann,  L-5365  Munsbach,  Großherzogtum
Luxemburg,

Inhaberin von eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Stammanteilen und eintausendfünfhundertdreiundsechzig

(1.563) Anteilen der Serie A3,

101746

L

U X E M B O U R G

hier vertreten durch Frau Camille Braconnier, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 2. Mai 2016, ausgestellt in London,

4. TEC Global Invest VII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 26063, mit Sitz
in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland (im Folgenden „TEC“),

Inhaberin  von  eintausendfünfhundertdreiundsechzig  (1.563)  Stammanteilen,  eintausendfünfhundertzweiundsechzig

(1.562) Anteilen der Serie A4 und eintausendfünfhundert (1.500) Anteilen der Serie B, und zukünftige Inhaberin von
einhundertachtundsechzig (168) neuen Anteilen der Serie C,

hier vertreten durch Frau Camille Braconnier, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 29. April 2016, ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, und

5. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend

nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer B 191.426 (im Folgenden „Holtzbrinck“),

Inhaberin von zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie B und zukünftige Inhaberin von sechshundertsech-

sundfünfzig (656) neuen Anteilen der Serie C,

hier vertreten durch Frau Camille Braconnier, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 28. April 2016, ausgestellt in Luxemburg.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital der Lamudi Global

S.à r.l. (im Folgenden die „Gesellschaft”), vormals Digital Services XXV S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 188486, gegründet am 18. Juni 2014
gemäß einer Urkunde des Notars Carlo Wersandt, welche am 16. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 2492 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 15. April 2015 gemäß
einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux geändert, welche am 3. Juli 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 1653 veröffentlicht wurde.

Da die erschienenen Parteien das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet

haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft,

welche als Anteile der Serie C bezeichnet werden (die „Anteile der Serie C“), sodass die Gesellschaft nunmehr sieben (7)
Anteilsklassen hat, die Stammanteile, die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2, die Anteile der Serie A3, die
Anteile der Serie A4, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von dreiunddreißigtausendzwei

Euro (EUR 33.002) um einen Betrag von eintausendeinhundertneunundneunzig Euro (EUR 1.199) auf einen Betrag von
vierunddreißigtausendzweihunderteins Euro (EUR 34.201) durch die Ausgabe von eintausendeinhundertneunundneunzig
(1.199) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

3. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie

folgt lautet:

„ 5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierunddreißigtausendzweihunderteins Euro (EUR 34.201),

bestehend aus:

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (im Fol-

genden die „Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR

1) (im Folgenden die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1) (im Folgenden die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1) (im Folgenden die „Anteile der Serie A3“),

5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1) (im Folgenden die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie
A3 und Anteile der Serie A4 im Folgenden gemeinschaftlich als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden),

5.1.6 achttausendzwei (8.002) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (im Folgenden

die „Anteile der Serie B“), und

101747

L

U X E M B O U R G

5.1.7 eintausendeinhundertneunundneunzig (1.199) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1) (im Folgenden die „Anteile der Serie C“).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“

4. Änderung des Artikels acht (8) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer

Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren verbundenen Transaktionen
oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) eines Verkaufs oder einer Übertra-
gung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass
entweder mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei
bzw. Parteien wären (Kontrollwechsel), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2 bis 8.4 - im Einklang mit Artikel 8.5 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie C pro Anteil der Serie C einen

Betrag von zweitausenddreihundertneunundneunzig Euro und fünfundachtzig Cent (EUR 2.399,85), der dem Liquiditäts-
ereignis unterliegt.

8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B pro Anteil der Serie B

einen Betrag von zweitausend Euro (EUR 2.000), der dem Liquiditätsereignis unterliegt.

8.4 Auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2,

Anteilen der Serie A3 und Anteilen der Serie A4 pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse („Anteilsklasse“) einen in der
folgenden Tabelle neben der entsprechenden Anteilsklasse vereinbarten Betrag, der dem Liquiditätsereignis unterliegt:

Anteilsklasse

Betrag

pro Anteil

in Euro

Serie A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,00

Serie A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.695,18

Serie A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.599,49

Serie A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.600,51

8.5 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene, der Zweiten Ebene und der Dritten Ebene geleistet wurden, werden

die übrigen Exiterlöse auf einer vierten Ebene („Vierte Ebene”) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend
ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Investor auf der Ersten Ebene, der Zweiten Ebene
und/oder der Dritten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Investor zu erhaltenden Betrag auf der Vierten
Ebene, mit der Maßgabe, dass kein Investor zur Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene, der Zweiten Ebene und/oder der
Dritten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liqui-
ditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den
Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzu-
zahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den
Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Ge-
sellschafter auf der Ersten Ebene, der Zweiten Ebene und/oder der Dritten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt
wurde. Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

8.6 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene, Zweiten Ebene und Dritten Ebene gilt zugunsten des

jeweiligen Investors solange, wie dieser den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß der Ersten Ebene, der Zweiten
Ebene und/oder der Dritten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.“

5. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau

Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen im Gesellschaftskapital

der Gesellschaft, welche als Anteile der Serie C bezeichnet werden (die „Anteile der Serie C“), sodass die Gesellschaft
nunmehr sieben (7) Anteilsklassen hat, die Stammanteile, die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2, die Anteile
der Serie A3, die Anteile der Serie A4, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C.

101748

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag

von dreiunddreißigtausendzwei Euro (EUR 33.002) um einen Betrag von eintausendeinhundertneunundneunzig Euro (EUR
1.199) auf einen Betrag von vierunddreißigtausendzweihunderteins Euro (EUR 34.201) durch die Ausgabe von eintau-
sendeinhundertneunundneunzig (1.199) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu
erhöhen.

<i>Zeichnung

Die  neuen  eintausendeinhundertneunundneunzig  (1.199)  Anteile  der  Serie  C  wurden  wie  folgt  ordnungsgemäß  ge-

zeichnet:

- AIH, hier wie vorgenannt vertreten, hat dreihundertfünfundsiebzig (375) Anteile der Serie C für einen Gesamtbetrag

von dreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 375) gezeichnet;

-  Holtzbrinck,  hier  wie  vorgenannt  vertreten,  hat  sechshundertsechsundfünfzig  (656)  Anteile  der  Serie  C  für  einen

Gesamtbetrag von sechshundertsechsundfünfzig Euro (EUR 656) gezeichnet; und

- TEC, hier wie vorgenannt vertreten, hat einhundertachtundsechzig (168) Anteile der Serie C für einen Gesamtbetrag

von einhundertachtundsechzig Euro (EUR 168) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die wie oben beschrieben gezeichneten eintausendeinhundertneunundneunzig (1.199) neuen Anteile der Serie C wurden

vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtbetrag von eintausendeinhundertneunundneunzig Euro (EUR
1.199).

Der Nachweis über die Existenz der oben bezeichneten Bareinlage wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendeinhundertneunundneunzig Euro (EUR 1.199) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Dritter Beschluss

Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel fünf Punkt eins (5.1) der Sat-

zung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel acht (8) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-

tegorie,  sowie  Frau  Magdalena  Staniczek,  das  Anteilsinhaberregister  der  Gesellschaft  in  Einzelunterschrift  und  mit
uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Ur-

kunde zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700,-) geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: C. BRACONNIER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/14831. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Mai 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016107863/365.
(160080006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

101749

L

U X E M B O U R G

Optibelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 206.054.

STATUTS

L'an deux mille seize, le quatrième jour de mai.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Patrick GARDAVOIR, gérant de société, né le 06 mai 1967 à Charleroi (Belgique), demeurant profession-

nellement à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare con-

stituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les présents
statuts («les Statuts»).

Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «OPTIBELUX S.A.».

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Clervaux.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d’administration,

et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière
de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs

de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Objet. La société a pour objet social la location de véhicules aux professionnels et aux particuliers.
Elle pourra acheter, vendre, négocier, entretenir ou louer des matériels de toute nature. Elle assurera la mise en location

de véhicules terrestres et nautiques, avec ou sans chauffeur, et l’organisation de prestations touristiques en découlant en
particulier des séjours «Sport - Aventure» et «Sport - Nature». Elle prestera également des services dans les domaines
informatiques et communication, installation, maintenance, location de systèmes informatiques, professionnels ou parti-
culiers, communication sur les réseaux numériques, implantation et programmation de matériel d’impression profession-
nelle et plus globalement tout outil de communication et marketing.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou

réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra prester tous services dans le domaine de l’intermédiation commerciale et industrielle ainsi que dans

les domaines informatiques, gestion d’entreprises, marketing, sponsoring et exploitation de marques et brevets. Elle est
autorisée à effectuer des prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, in-
dustrielles,  financières  ou  autres,  luxembourgeoises  ou  étrangères,  l’acquisition  de  tous  titres  ou  droits  par  voie  de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de toute autre
manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition de biens
meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes les opérations commerciales, industrielles ou
financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou
le développement

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobi-

lières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou favoriser la réalisation.

Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-), représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de soixante euro (EUR 60,-) chacune.

101750

L

U X E M B O U R G

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Prime d’émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront

transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a

rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour
affecter des fonds à la Réserve Légale.

Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre

forme, au choix des actionnaires, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En présence d’actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre

énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune
des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.

En présence d’actions au porteur, un registre sera tenu auprès d’un des dépositaires énoncé par la loi, ledit registre

énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions au porteur détenues par lui, le transfert d'actions
et les dates de tels transferts, tel qu’énoncé par la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au
porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur portant modification de la loi
du 10 août 1915, modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

Art. 10. Composition du Conseil d’Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé

de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du Conseil d’Administration peut être limitée
à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence
de plus d’un actionnaire.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat

qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment par
une résolution des actionnaire(s).

Art. 11. Pouvoir du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent

de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.

Art. 12. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature indi-

viduelle de l’administrateur unique, soit si le Conseil d’Administration est composé de trois membres ou plus par la signature
conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué pour ce qui concerne la
gestion journalière.

La Société sera également engagée en toutes circonstances vis -à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature

individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seule-
ment dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d’Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base

d’un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi
que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes
à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

Art. 14. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration nommera parmi ses membres un président

et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux
du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date

indiqués dans la convocation.

101751

L

U X E M B O U R G

Si tous les membres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été

dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en

original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués dans

un agenda de réunions adopté à l’avance par le Conseil de d’Administration.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence le Conseil d’Administration

désignera  un  autre  membre  du  Conseil  d’Administration  comme  président  pro  tempore  par  un  vote  à  la  majorité  des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par un écrit, transmis

par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son manda-
taire.

Tout membre du Conseil d’Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d’Administration.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle

avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un

ou plusieurs administrateurs.

Le Conseil d’Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en

fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Art. 15. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir

une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation
avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 16. Conflit d’intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une

transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux
délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le

simple  fait  qu'un  ou  plusieurs  administrateurs  ou  tout  fondé  de  pouvoir  de  la  Société  y  a  un  intérêt  personnel,  ou  est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

Art. 17. Responsabilité des administrateur(s).
Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas leur responsabilité personnelle lorsqu’ils prennent

des engagements au nom et pour le compte de la Société.

Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les  commissaires  aux  comptes  seront  nommés  par  les  actionnaire(s)  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans,

rééligibles et toujours révocables.

Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si  la  Société  ne  compte  qu'un  seul  actionnaire,  celui-ci  exerce  les  pouvoirs  pré-mentionnés  conférés  à  l'assemblée

générale des actionnaires.

Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la

Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1 

er

 jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social

ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration, subsidiairement, des

101752

L

U X E M B O U R G

commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du
capital social conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte

écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou

du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification
des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d’actions
représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption

est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins
la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.

Si ce quorum n’est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les résolu-

tions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des
votes exprimés.

Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration

dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin
de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.

Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

Art. 24. Réserve légale. L’excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-

tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale

(«la Réserve Légale») dans le respect de l’article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).

Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra

dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 25. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du

solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d’une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le
reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux
actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Art. 26. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme

en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés

par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation

sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d’acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions

suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Dispositions transitoires

(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2017.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire intégralement les mille

(1.000) actions comme suit:

101753

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Patrick GARDAVOIR, pré-qualifié,
Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

Les actions ont été partiellement libérées à hauteur de 25% (vingt-cinq pourcents) par les comparants par des versements

en espèces, de sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de
la Société, preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille quatre cents
euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant pré-qualifié, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit

et agissant en tant qu’actionnaire de la Société a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. A été appelés aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Patrick GARDAVOIR, gérant de société, né le 06 mai 1967 à Charleroi (Belgique), demeurant profession-

nellement à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue,

3. La durée du mandat de l’administrateur unique prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en

l'an 2021.

4. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Société à responsabilité limitée Kopalux Trust S.à r.l., avec siège social au L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkër-

rech, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 171.586.

5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra

en l'an 2021.

6. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. GARDAVOIR, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/15003. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 13 mai 2016.

Référence de publication: 2016108807/256.
(160081395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.

F55 B Chateau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 202.258.

In the year two thousand and sixteen on the tenth day of May.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. F55 International Holdings S. à r. l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the trade and
companies register of Luxembourg under number B 202060,

here represented by Mr Vincent Bouffioux, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Miami and Luxembourg on 2 May 2016, AND

101754

L

U X E M B O U R G

2. F55 CI-International Investor S. à r. l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws

of Luxembourg, having its registered office at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the trade and
companies register of Luxembourg under number B 202068,

here represented by Mr Vincent Bouffioux, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Miami and Luxembourg on 2 May 2016,

(F55  International  Holdings  S.  à  r.  l.  and  F55  CI-International  Investor  S.  à  r.  l.  are  referred  to  collectively  as  the

Shareholders hereafter)

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent the

entire share capital of the Company, denominated F55 B Chateau S. à r. l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, having its registered
office at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under
number B 202258 (the Company) and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary public dated 7 December
2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 572 on February 25 

th

 , 2016.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to create two classes of shares: A shares and B shares;
2. Conversion of the shares held by F55 International Holdings S. à r. l. into A shares;
3. Conversion of the shares held by F55 CI-International Investor S. à r. l. into B shares;
4. Amendment of the articles of association of the Company (the Articles).
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to create two classes of shares, A shares (the A Shares) and B shares (the B Shares). Among

the 12,500 shares of the Company 11,250 will be A Shares and 1,250 will be B Shares.

A Shares shall entitle their holders to 95.55852 % of (i) the dividends distributed by the Company and (ii) the surplus

resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company.
Within the A Shares class, each holder of A Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion
to the A Shares held by it.

B Shares shall entitle their holders to 4.44148 % of (i) the dividends distributed by the Company and (ii) the surplus

resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company.
Within the B Shares class, each holder of B Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion
to the B Shares held by it.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to convert the 11,250 shares held by F55 International Holdings S. à r. l. into A Shares.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to convert the 1,250 shares held by F55 CI International Investor S. à r. l. into B Shares.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the first, second and third resolutions, the Shareholders resolve to amend articles 6, 19, 28 and 29

of the Articles, of which the English version shall be henceforth reworded as follows:

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by eleven

thousand two hundred and fifty (11,250) A shares (the A Shares) and one thousand two hundred and fifty (1,250) B shares
(the B Shares) with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

A Shares shall entitle their holders to 95.55852 % of the dividends distributed by the Company and the surplus resulting

from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within the
A Shares class, each holder of A Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to the
A Shares held by it.

B Shares shall entitle their holders to 4.44148 % of the dividends distributed by the Company and the surplus resulting

from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within the
B Shares class, each holder of B Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to the
B Shares held by it.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”

101755

L

U X E M B O U R G

“ Art. 19. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of

interim dividends in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles.”

“ Art. 28. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts

to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole shareholder or, as the case may be, the
general meeting of the shareholders. Dividend distributions may only be realised in accordance with the rights attributed
to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles.”

“ Art. 29. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of the shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation
of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le dix mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. F55 International Holdings S. à r. l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son

siège social à 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, sous le numéro B 202060,

ici représentée par Monsieur Vincent Bouffioux, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Miami et à Luxembourg le 2 mai 2016, ET

2. F55 CI-International Investor S. à r. l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant

son siège social à 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 202068,

ici représentée par Monsieur Vincent Bouffioux, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Miami et à Luxembourg le 2 mai 2016,

(F55 International Holdings S. à r. l. et F55 CI-International Investor S. à r. l. sont désignées ensemble comme les

Associés)

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social de

la société à responsabilité limitée dénommée F55 B Chateau S. à r. l., société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès
du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202258 (la Société), suivant un acte reçu par le
notaire soussigné du 7 décembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 572 en date
du 25 février 2016.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de créer deux classes de parts sociales: les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B;
2. Conversion des parts sociales détenues par F55 International Holdings S. à r. l. en parts sociales de classe A;
3. Conversion des parts sociales détenues par F55 CI-International Investor S. à r. l. en parts sociales de classe B;
4. Modification des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de créer deux classes de parts sociales, les parts sociales de classe A (les Parts A) et les parts

sociales de classe B (les Parts B). Parmi les 12.500 parts sociales de la Société 11.250 seront des Parts A et 1.250 des Parts
B.

101756

L

U X E M B O U R G

Les Parts A donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 95,55852 % (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de la
classe des Parts A chaque titulaire de Parts A aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts A détenues par lui.

Les Parts B donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 4,44148 % (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de la
classe des Parts B chaque titulaire de Parts B aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts B détenues par lui.

<i>Seconde résolution

Les Associés décident de convertir les 11.250 parts sociales détenues par F55 International Holdings S. à r. l. en Parts

A.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de convertir les 1.250 parts sociales détenues par F55 CI-International Investor S. à r. l. en Parts

B.

<i>Quatrième résolution

Suite à la première, la deuxième et la troisième résolution, les Associés décident de modifier les articles 6, 19, 28 et 29

des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par onze mille

deux cent cinquante (11.250) parts sociales de classe A (les Parts A) et mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de
classe B (les Parts B) d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Les Parts A donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 95,55852 % (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de la
classe des Parts A chaque titulaire de Parts A aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts A détenues par lui.

Les Parts B donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 4,44148 % (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de la
classe des Parts B chaque titulaire de Parts B aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts B détenues par lui.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

« Art. 19. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement

d'acomptes sur dividendes conformément aux droits spécifiques attribués aux Parts A et aux Parts B par l'article 6 des
statuts.»

« Art. 28. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'associé unique ou, le cas échéant,
de l'assemblée générale des associés. La distribution de dividendes devra se faire conformément aux droits spécifiques
attribués aux Parts A et aux Parts B par l'article 6 des statuts.»

« Art. 29. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire le
ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la
Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés conformément aux droits spécifiques attribués aux Parts

A et aux Parts B par l'article 6 des statuts.»

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes

l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: V. Bouffioux et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 11 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/9899. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

101757

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 17 mai 2016.

Référence de publication: 2016109342/179.
(160082478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.

Syneco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7343 Steinsel, 14, rue des Templiers.

R.C.S. Luxembourg B 85.034.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016108205/10.
(160079550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Fondation Cavour, Fondation.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg G 218.

<i>Comptes annuels au 31 décembre 2015

<i>et

<i>Rapport du reviseur d’entreprises agrée

INDEX

Pages

- Rapport du Reviseur d’entreprises agrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

- Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

- Compte de profits et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

- Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Au Conseil d'Administration
Fondation Cavour

<i>Rapport du reviseur d’entreprises agrée

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de Fondation Cavour, comprenant le bilan au 31 décembre

2015 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité du Conseil d’Administration pour les comptes annuels
Le Conseil d’Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,

conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu’il juge nécessaire pour permettre l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué

notre audit selon les Normes Internationales d’Audit telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier
et de réaliser l'audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants

et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d’entreprises
agréé, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur d’entreprises agréé prend en
compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels
afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur le
fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d’Adminis-
tration, de même que l'appréciation de la présentation d’ensemble des comptes annuels.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion

101758

L

U X E M B O U R G

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de Fondation Cavour

au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et
réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Le 17 mars 2015.

<i>Pour Deloitte Audit
Cabinet de révision agréé
Marco Crosetto,
<i>Réviseur d’entreprises agréé/ Partner

31/12/2015

EUR

28/02/2015

EUR

ACTIF
Actif Immobilisé
Imm financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.912,24

63.912,24

Actif circulant
Autre créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229,67

458,68

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.825,09

70.255,02

115.967,00

134.625,94

PASSIF
Fonde propre
Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.000,00

62.000,00

Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.599,52

7.272,80

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 19.658,95

65.326,72

Dette
Dette sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.026,42

26,42

115.967,00

134.625,94

<i>Compte de profits et pertes

01/03/2015-

31/12/2015

EUR

01/03/2014-

28/02/2015

EUR

CHARGES
Actions de soutien financier octroyé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.463,85

20.000,00

Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.333,47

3.677,95

télécommunications et internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,35

69,00

frais de bureau et d'imprimerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.418,30

site web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.190,68

frais d'honoraire notaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.269,12

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242,08

261,89

frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242,08

261,89

Résultat de l'exercice
Avance/perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-19.658,95

65.326,72

Total charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.380,45

89.266,56

PRODUITS
Revenus
Revenus de patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

880,45

1.266,56

subsides et subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500,00

88.000,00

Total produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.380,45

89.266,56

Les notes font partie intégrante des comptes annuels.

Notes

Note 1. Généralités. La Fondation Cavour (la Fondation) a été constituée en février 2012 et reconnue d’utilité publique

par arrêté grand-ducal du 2 mars 2012.

La Fondation a comme mission principale celle de promouvoir les relations entre la République Italienne et le Grand-

Duché de Luxembourg dans leurs différentes activités avec une attention toute particulière aux aspects culturels.

A ces fins, elle collabore étroitement avec l'Ambassade d’Italie au Luxembourg et l'Istituto Italiano di Cultura.

101759

L

U X E M B O U R G

La Fondation a pour objectif d’être le centre de récolte des libéralités en faveur de la présence culturelle italienne au

Luxembourg.

Le siège de la Fondation est établi à 12, Avenue de la Liberté, L - 1930 Luxembourg.

Note 2. Evénements survenus pendant l’année. En date du 30 juin 2015, les statuts ont été modifiés.

Les principales modifications concernent l'object social, les règles de composition et de fonctionnement du Conseil

d’Administration, l'exercice social et les dispositions relatives à la liquidation du patrimoine de la Fondation.

Pour ce qui concerne la composition du Conseil d’Administration, Monsieur Bruno Agostini occupe la fonction de

Président, Monsieur Fabio Morvilli occupe la fonction de Vice-Président et l'Ambassadeur en fonction de la République
d’Italie auprès du Grand-Duché de Luxembourg, est nommé Président honoraire du Conseil sans aucune fonction exécutive.

L’année sociale de la Fondation commence le premier janvier et se termine au trente et un décembre. L’exercice social

en cours ayant débuté le 1 

er

 mars 2015 sera clôturé le 31 décembre 2015.

Le présent bilan comptable tient compte des modifications mentionnées.

Note 3. Principes, Règles et méthodes comptables. Les comptes annuels de la Fondation sont établis conformément aux

dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques comptables généralement admises.

La Fondation tient sa comptabilité en Euros (EUR). Le bilan et le compte de revenus et charges sont exprimés dans cette

devise.

Note 4. Investissement du patrimoine. Par décision du Conseil d’Administration, la dotation patrimoniale de la Fondation

a été investie dans l'achat des titres de l'Etat italien, pour une valeur à la clôture d’exercice, selon le principe du coût
historique, de 63.912,24 EUR.

Au 31 décembre 2015, la valeur de marché de ces titres était de 68.045,25 EUR.

Note 5. Charges. La Fondation a financé des initiatives culturelles sous le patronage et avec le support de l'Ambassade

d’Italie pour un montant total de 22.463,85 EUR.

Les autres charges sont composées des éléments suivants:

EUR

Frais de télécommunications et internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,35

frais d'honoraire notaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.269,12
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.333,47

Note 6. Subsides et subventions. En vertu de ses statuts, l'une des sources des fonds nécessaires à la réalisation de l'objet

de la Fondation est constituée de contributions pouvant être octroyées par sujets privés.

Pour l'exercice en question, les subsides et subventions reçus s’élèvent à 3.500,00 EUR. Après le 31/12/2015, à la date

de l'approbation du bilan les donations reçues s'élèvent à 9.600 euros.

Note 7. Personnel. La Fondation n’emploie pas de personnel.

<i>Budget pour l'exercice du 01.01.2016 au 31.12.2016

Budget

2016
EUR

CHARGES
Actions de soutien financier octroyé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

Intérêts et charges assimilées (frais bancaires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

TOTAL CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.500

PRODUITS
Utilisation résultats exercices précédents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.100

Revenus de patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.400

Récolte de contributions et libéralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

TOTAL PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.500

Référence de publication: 2016109332/143.

(160082754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

101760


Document Outline

CMP German Opportunity Fund III

Cristalas Holding S.A.

F55 B Chateau S.à r.l.

Fondation Cavour

Lamudi Global S.à r.l.

Optibelux S.A.

Rambouillet Capital S.A.

Ramsbury Sàrl

Red Fox S.A.

Reinart s.à r.l.

Residenz Treuhand S.à r.l.

Rinispa S.A.

Saipem Maritime Asset Management Luxembourg S.àr.l.

Script s.à r.l.

Silux Alternatives S.à.r.l.

Sim Investments S.A.

Société Financière Saka S.A.

Sommerwasser S.A.

Sparkling Tours S.A.

Staffmatch S.à r.l.

ST Berlin Hotel S.à r.l.

ST Leipzig S.A.

ST Potsdam S.à r.l.

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A.

Sybil Holdings S.à r.l.

Syneco S.à r.l.

TA EU Acquisitions III S.à r.l.

TA EU Acquisitions VII S.à r.l.

TA EU Acquisitions VI S.à r.l.

TA EU Acquisitions V S.à r.l.

TA EU Acquisitions Zebra S.à r.l.

TA EU Luxembourg III S.à r.l.

TA EU Luxembourg S.à r.l.

Technoport S.A.

Tejo Investments S.à r.l.

Teka Systems S.A.

Telus Applications for Industry

Tempus Holding 1 S.à r.l.

TenTwentyFour S.à r.l.

Ternium Investments S.à r.l.

Theam Quant

Thiolat Developpement

Tiger Properties S.A.

Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l.

TMB Industry

Topaz S.à r.l.

VB (Luxembourg) S.à r.l.

Victor Hugo 2 S.à r.l.