This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1998
8 juillet 2016
SOMMAIRE
3M Global Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
95902
Advent Power (Luxembourg) MEP S.à r.l. . . .
95870
Advent Power (Luxembourg) Subco S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95870
Akros Global Opportunities S.A., SICAV-FIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95897
A.R.S. Groupe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95899
Atlantik S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95870
AXA Mezzanine I S.A., SICAR . . . . . . . . . . . .
95887
AXA Private Debt II S.A., SICAR . . . . . . . . . .
95888
AXA Private Debt II S.A., SICAR . . . . . . . . . .
95888
Axis Interim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95888
AXIS (Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95888
Baie de Greco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
95881
Bakery Technology 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95890
Balansys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95902
Baltiman S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95902
Barbat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95882
BBGI SICAV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95882
Beltone MidCap Management S.A. . . . . . . . . .
95887
Benelux Mezzanine 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
95887
BNP Paribas A Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95882
Bobati S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95886
Borea Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95887
B.S. Diffusion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95888
Buwog Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95881
Cablinvest II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95871
Calypso Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95871
Calypso Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
95876
CNA Trading Appliances Limited . . . . . . . . . .
95893
Coca-Cola Enterprises Luxembourg . . . . . . . .
95867
Compagnie Financière de la Sûre S.A. . . . . . .
95893
Cork Quality Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
95893
Cornaline Letzebuerg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
95893
Croix Realty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95894
Daregon Financial Services S.A. . . . . . . . . . . .
95895
Datacenter Development . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95894
DAWID S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95895
Diarough Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95895
Dundeal (International) 33 S.à r.l. . . . . . . . . . .
95894
Eastern Opportunities S.A., SICAV-FIS . . . .
95897
Eco-Business Fund S.A., SICAV-SIF . . . . . . .
95895
Egon Zehnder Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
95896
Euro Gaming Investment S.A. . . . . . . . . . . . . .
95896
Eurydome S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95897
Human Capital Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95902
Intelligent Commerce Group S.à r.l. . . . . . . . .
95870
Investment Select Fund Sicav-SIF . . . . . . . . . .
95903
Julie s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95903
Kase World Wide S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
95903
Luxlait Développement S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
95904
LUXLAIT Distribution S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
95903
Multi Stars Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95904
Négoce Company and International Services
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95904
Négoce Company and International Services
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95904
UBS (Lux) Institutional Sicav II . . . . . . . . . . .
95870
Volpi Capital Master Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . .
95858
95857
L
U X E M B O U R G
Volpi Capital Master Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 205.677.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth day of April.
Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Volpi Capital L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at Hadsley
House, Lefebvre Street, St Peter Port, GY1 2JP Guernsey, registered with the Guernsey Registry, under number 2454,
acting by its general partner, Tower Gate Guernsey GP II Limited, a limited company incorporated under the laws of
Guernsey, having its registered office at Hadsley House, Lefebvre Street, St Peter Port, GY1 2JP Guernsey, registered with
the Guernsey Registry under number 61144:
here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, whose professional address is Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal,
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power
of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Volpi Capital Master Lux S.à r.l.” (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions and consent threshold
prescribed by the Law for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
95858
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions and consent threshold prescribed by the Law for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented, provided that
if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a
majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several
class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes
in favour of the resolution.
Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been
appointed, by all the managers present or represented.
95859
L
U X E M B O U R G
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and
any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
and consent threshold prescribed by the Law for the amendment of the Articles..
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
95860
L
U X E M B O U R G
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders’
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions and consent threshold prescribed by the Law for the amendment of the Articles. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company’s assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
95861
L
U X E M B O U R G
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2016.
<i>Subscription and paymenti>
Volpi Capital L.P., represented as stated above, subscribes for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered
form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve
thousand five hundred euros (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at the Company’s disposal and evidence of such
amount has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, adopted the following resolutions:
1. The following person is appointed as class A manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Mark PATTIMORE, born on February 3, 1961 in St Peter Port, Guernsey, residing professionally at Hadsley House,
Lefebvre Street, St Peter Port, GY1 2JP Guernsey.
2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Aldric GROSJEAN, born on September 17, 1979 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing profes-
sionally at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
- Mr Pierre-Yves MAGEROTTE, born on August 30, 1979 in Libramont-Chevigny, Belgium, residing professionally
at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The registered office of the Company is located at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le treizième jour d’avril,
Pardevant le soussigné Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Volpi Capital L.P., limited partnership, régie par les lois de Guernesey, dont le siège social se situe à Hadsley House,
Lefebvre Street, Saint-Pierre-Port, GY1 2JP Guernesey, inscrite au Registre de Guernsey sous le numéro 2454, agissant
par son general partner, Tower Gate Guernsey GP II Limited, une limited company, régie par les lois de Guernesey, ayant
son siège social à Hadsley House, Lefebvre Street, Saint-Pierre-Port, GY1 2JP Guernesey, inscrite au Registre de Guernesey
sous le numéro 61144,
représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
95862
L
U X E M B O U R G
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Volpi Capital Master Lux S.à r.l." (la societe). La Société est une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités et le seuil de consentement requis par
la Loi pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de
ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en
faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée
du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités et le seuil de consentement requis par la Loi pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
95863
L
U X E M B O U R G
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu’elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un
ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe,
sera au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, à
la condition que les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins
un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil sont valablement
adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la condition que les associés ont nommé un ou plusieurs
gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent
en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la
réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un gérant de classe
A et d’un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
95864
L
U X E M B O U R G
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont ad-
optées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés
de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés que par une résolution des associés, adoptée selon les modalités et le seuil de
consentement requis par la Loi pour la modification des Statuts.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice
social en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l’Assemblée Générale annuelle.
Art. 14. Commissaires / réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
95865
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d’émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés, adoptée selon les modalités et le seuil
de consentement requis par la Loi pour la modification des Statuts. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le 31 décembre année.
<i>Souscription et libérationi>
Volpi Capital L.P., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cent (12.500) parts sociales
sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport
en numéraire d’un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500).
Le montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s’élèvent
approximativement à mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommé gérant de classe A de la Société pour une durée indeterminée:
95866
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Mark PATTIMORE, né le 3 février 1961 à Saint-Pierre-Port, Guernesey, demeurant professionnellement à
Hadlsey House, Lefebvre Street, Saint-Pierre-Port, GY1 2JP Guernesey.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Aldric GROSJEAN, né le 17 septembre 1979 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant
professionnellement au 12 rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
- Monsieur Pierre-Yves MAGEROTTE, né le 30 août 1979 à Libramont-Chevigny, Belgique, demeurant profession-
nellement au 12 rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 20 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/12812. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 avril 2016.
Référence de publication: 2016099287/504.
(160070055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2016.
Coca-Cola Enterprises Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 237.465.946,00.
Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 62.499.
In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of April,
before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Bottling Holdings (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorpo-
rated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue des Joncs, L-1818 Howald,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
78351 and with a share capital of EUR 1,908,103,948.37 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Peggy Simon, notary's clerk residing professionally in L- 6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue
of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the issued and outstanding shares in the share capital of Coca-Cola Enterprises
Luxembourg, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue des Joncs, L-1818 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 62499 and having a share capital
of EUR 483.990.447,49 (the Company).
II. That the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary then residing in Luxem-
bourg-Eich, on 23 December 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 241 on 15
April 1998. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on 17 July 2015
pursuant to a deed of Paul Decker, prenamed, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2523.
III. That as Coca-Cola Enterprises, Inc. has announced a merger of Coca- Cola Enterprises, Inc., Coca-Cola Iberian
Partners and the German subsidiaries of The Coca-Cola Company, resulting in the incorporation of a listed top company
in the UK, the current legal structure has been reviewed and several improvements have been identified that are aimed at
facilitating the future cash flows within the new Coca- Cola European Partners, which will enter into an additional USD
3.3 billion debt to fund the cash payment the merger provides for the benefit of the CCE current shareholders. In this respect,
the distribution of the dividends from the Belgian entity to its Luxembourg parent company should be remediated based
95867
L
U X E M B O U R G
on reasonable expectations that cash could flow (i.e. dividend/repatriation) within a European group without any tax impact,
in accordance with the EU freedom of establishment principle
IV. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to reduce the Company's share capital by an amount of two hundred forty six million
five hundred twenty four thousand five hundred one euro (EUR 246,524,501) by repayment to the Sole Shareholder of the
same amount, so as to reduce it from its present amount of four hundred eighty-three million nine hundred ninety thousand
four hundred forty-seven point four nine euro (EUR 483,990,447.49) divided into four hundred and seventy-two (472)
shares with a par value of one million twenty-five thousand four hundred and three point four nine zero four four euro
(EUR 1,025,403.49044) each to an amount of two hundred thirty seven million four hundred sixty five thousand nine
hundred forty six euro (EUR 237,465,946), by reducing the par value of each share from its present amount of one million
twenty-five thousand four hundred and three point four nine zero four four euro (EUR 1,025,403.49044) to five hundred
three thousand one hundred five point eighty two euro (503,105.82 EUR) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to reduce, as a result of the above capital reduction, the Company's legal reserve by an
amount of twenty four million six hundred fifty two thousand four hundred fifty euro (24,652,450 EUR) by allocation of
the same amount to the Company's other reserves (available for distribution purposes), so as to reduce it from its present
amount of forty-eight million three hundred ninety-nine thousand forty-five euro (EUR 48,399,045) to twenty three million
seven hundred forty six thousand five hundred ninety five euro (EUR 23,746,595).
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles, so that it shall henceforth
read as follows:
“ Art. 5. The issued share capital of the Company is set at two hundred thirty seven million four hundred sixty five
thousand nine hundred forty six euro (EUR 237,465,946) divided into four hundred and seventy-two (472) shares with a
par value of five hundred three thousand one hundred five point eighty two euro (503,105.82 EUR) each.»
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to authorize and empower the board of managers of the Company, to implement the
previous resolutions.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingtième jour d'avril, devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Bottling Holdings (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, dont le siège social est établi au 2, rue des Joncs, L-1818 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78351 et disposant d'un capital social
de EUR 1.908.103.948,37 (l'Associé Unique),
dûment représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour le besoin de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales émises et en circulation dans le capital social de Coca-Cola
Enterprises Luxembourg, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
dont le siège social est établi au 2, rue des Joncs, L-1818 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 62499 et disposant d'un capital social de EUR
483,990,447.49 (la Société).
II. Que la Société a été constituée suivant un acte de Maître Paul Decker, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich,
le 23 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 241 le 15 avril 1998. Les statuts
95868
L
U X E M B O U R G
de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 17 juillet 2015 suivant un acte de Paul Decker, précité
et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2523.
III. Dans la mesure où Coca-Cola Enterprises, Inc. a annoncé une fusion en août 2015 afin de parvenir à une association
d'entreprises de Coca-Cola Enterprises, Inc., Coca-Cola Iberian Partners et des filiales allemandes de The Coca-Cola
Company, résultant dans la constitution d'une société de tête cotée (listed top company) au Royaume-Uni, la structure
juridique actuelle a été examinée et plusieurs améliorations ont été identifiées qui visent à faciliter les flux de trésorerie
futurs au sein de la nouvelle société Coca-Cola European Partners, qui s'endettera à nouveau pour un montant s'élevant à
USD 3.3 milliards afin de financer le paiement en numéraire que la fusion prévoit au bénéfice des actionnaires actuels de
CCE. A cet égard, la distribution des dividendes par l'entité belge à sa société mère luxembourgeoise devraient être assainie
sur base des attentes raisonnables que l'argent puisse circuler (c'est-à-dire les dividendes / rapatriements) au sein d'un groupe
européen sans aucune incidence fiscale, conformément au principe de liberté d'établissement.
IV. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de diminuer le capital social de la Société par un montant de deux cent quarante-six millions
cinq cent vingt-quatre mille cinq cent un euros (EUR 246.524.501) par voie de remboursement à l'Associé Unique du même
montant, de sorte de le réduire de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix
mille quatre cent quarante-sept euros et quarante-neuf centimes (EUR 483.990.447,49) divisé en quatre cent soixante-douze
(472) parts sociales ayant une valeur nominale d'un million vingt-cinq mille quatre cent trois virgule quatre neuf zéro quatre
quatre euros (EUR 1.025.403,49044) chacune à un montant de deux cent trente-sept millions quatre cent soixante-cinq
mille neuf cent quarante-six euros (EUR 237.465.946), en diminuant la valeur nominale de chaque part sociale de son
montant actuel d'un million vingt-cinq mille quatre cent trois virgule quatre neuf zéro quatre quatre euros (EUR
1.025.403,49044) à cinq cent trois mille cent cinq virgule quatre-vingt-deux euros (EUR 503.105,82) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de diminuer, en conséquence de la diminution de capital mentionnée ci-dessus, la réserve
légale de la Société par un montant de vingt-quatre millions six cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante euros
(EUR 24.652.450) par affectation du même montant aux autres réserves de la Société (disponible à des fins de distribution),
de sorte de le diminuer de son montant actuel de quarante-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante-
cinq euros (EUR 48.399.045) à vingt-trois millions sept cent quarante-six mille cinq cent quatre-vingt- quinze euros (EUR
23.746.595).
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts, de sorte qu'il ait désormais
la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à deux cent trente-sept millions quatre cent soixante-cinq mille neuf
cent quarante-six euros (EUR 237.465.946) divisé en quatre cent soixante-douze (472) parts sociales d'une valeur nominale
de cinq cent trois mille cent cinq virgule quatre-vingt-deux euros (EUR 503.105,82) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'autoriser et de donner pouvoir au conseil de gérance de la Société pour mettre en oeuvre les
résolutions précédentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare expressément qu'à la demande de la partie comparante ci-
dessus, le présent acte est libellé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.
En foi de quoi le présent acte est passé à Echternach, à la date mentionnée qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte
original.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 avril 2016. Relation: GAC/2016/3217. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 29 avril 2016.
Référence de publication: 2016100894/140.
(160072432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
95869
L
U X E M B O U R G
Intelligent Commerce Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6755 Grevenmacher, 1, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 191.169.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG & MALDENER S.A.R.L.
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
i>31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature
Référence de publication: 2016101141/13.
(160072425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
UBS (Lux) Institutional Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 115.356.
Les comptes annuels au 31 janvier 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016103757/9.
(160075027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.
Advent Power (Luxembourg) MEP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 169.019.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 mai 2016.
Référence de publication: 2016103861/10.
(160075840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Advent Power (Luxembourg) Subco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 169.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 mai 2016.
Référence de publication: 2016103862/10.
(160075842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
Atlantik S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 170.670.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 Mai 2016.
Atlantik S.A.
Robin Naudin ten Cate
<i>Director Ci>
Référence de publication: 2016103875/14.
(160076014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.
95870
L
U X E M B O U R G
Cablinvest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 164.068.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016104718/10.
(160076578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Calypso Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 201.600.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of April,
before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1) DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its regis-
tered office at First Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the
Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1695, acting through its general partner DBG
Fund VI GP (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered office at First
Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of Limited
Partnerships of the Island of Guernsey under number 1680, acting through its general partner DBG Management GP
(Guernsey) Limited, a limited company having its registered office at First Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St
Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of Companies of the Island of Guernsey under number
55086 (hereafter «DBG Fund Konzern»),
hereby represented by Maître Stephan Weling, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on 8 April 2016;
2) DBAG Fund VI (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered office
at First Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of
Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1692, acting through its general partner DBG Fund VI GP
(Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered office at First Floor, La
Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of Limited Part-
nerships of the Island of Guernsey under number 1680, acting through its general partner DBG Management GP (Guernsey)
Limited, a limited company governed by the laws of Guernsey, having its registered office at First Floor, La Plaiderie
Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of Companies of the Island
of Guernsey under number 55086 (hereafter «DBG Fund»),
hereby represented by Maître Simone Schmitt, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on 8 April 2016;
3) DBG Advisors VI GmbH & Co. KG, a company governed by the laws of Germany, having its registered office at
Börsenstraße 1,60313 Frankfurt am Main, Germany, and registered with the Frankfurt trade register under number HRA
46856, acting through its general partner DBG Service Provider Verwaltungs GmbH, a company governed by the laws of
Germany, having its registered office at Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main, Germany, and registered with the
commercial register of the local court of Frankfurt am Main under number HRB 90813,
hereby represented by Maître Stephan Weling, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on 8 April 2016
(hereafter collectively referred to as the «Shareholders»);
The abovementioned proxies shall be annexed to the present deed for registration purposes.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole shareholders of
Calypso Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary on 17 No-
vember 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 237 of 29 January 2016 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 201600 (the "Company"). The
articles of incorporation of the Company have not yet been amended.
95871
L
U X E M B O U R G
The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the issued capital of the Company by an amount of sixty-five million one hundred thousand euro (EUR
65,100,000.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount
of sixty-five million one hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 65,112,500.-).
2 To issue seven hundred twenty-three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four
(723,333,334) new Class A Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-three thousand three hundred
thirty-four (723,333,334) new Class B Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-three thousand
three hundred thirty-four (723,333,334) Class C Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-three
thousand three hundred thirty-four (723,333,334) Class D Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-
three thousand three hundred thirty-four (723,333,334) Class E Shares, seven hundred twenty-three million three hundred
thirty-three thousand three hundred thirty-four (723,333,334) Class F Shares, seven hundred twenty-three million three
hundred thirty-three thousand three hundred thirty-two (723,333,332) Class G Shares, seven hundred twenty-three million
three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-two (723,333,332) Class H Shares, seven hundred twenty-three
million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-two (723,333,332) Class I Shares, each with a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01) per share.
3 To accept subscription for these new shares, and to accept payment in full of each such new share by a contribution
in cash.
4 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the foregoing agenda.
5 Miscellaneous.
Have unanimously requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the issued capital of the Company by an amount of sixty-five million one hundred
thousand euro (EUR 65,100,000.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) to an amount of sixty-five million one hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 65,112,500.-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to issue seven hundred twenty-three million three hundred thirty-three thousand three hundred
thirty-four (723,333,334) new Class A Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-three thousand
three hundred thirty-four (723,333,334) new Class B Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-three
thousand three hundred thirty-four (723,333,334) Class C Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-
three thousand three hundred thirty-four (723,333,334) Class D Shares, seven hundred twenty-three million three hundred
thirty-three thousand three hundred thirty-four (723,333,334) Class E Shares, seven hundred twenty-three million three
hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four (723,333,334) Class F Shares, seven hundred twenty-three million
three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-two (723,333,332) Class G Shares, seven hundred twenty-three
million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-two (723,333,332) Class H Shares, seven hundred twenty-
three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-two (723,333,332) Class I Shares, each with a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01) per share.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared the Shareholders represented by the above mentioned proxy.
The Shareholders declared to subscribe for new shares as set out below:
- DBG Fund declared to subscribe for five hundred seventy-eight million five hundred seventy-six thousand two hundred
fifty (578,576,250) new Class A Shares, five hundred seventy-eight million five hundred seventy-six thousand two hundred
fifty (578,576,250) new Class B Shares, five hundred seventy-eight million five hundred seventy-six thousand two hundred
fifty (578,576,250) new Class C Shares, five hundred seventy-eight million five hundred seventy-six thousand two hundred
fifty (578,576,250) new Class D Shares, five hundred seventy-eight million five hundred seventy-six thousand two hundred
fifty (578,576,250) new Class E Shares, five hundred seventy-eight million five hundred seventy-six thousand two hundred
fifty (578,576,250) new Class F Shares, five hundred seventy-eight million five hundred seventy-six thousand two hundred
fifty (578,576,250) new Class G Shares, five hundred seventy-eight million five hundred seventy-six thousand two hundred
fifty (578,576,250) new Class H Shares, five hundred seventy-eight million five hundred seventy-six thousand two hundred
fifty (578,576,250) new Class I Shares each with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01.-) per share;
- DBG Fund Konzern declared to subscribe for one hundred thirty-five million seven hundred fifteen thousand four
hundred seventeen (135,715,417) new class A Shares, one hundred thirty-five million seven hundred fifteen thousand four
hundred seventeen (135,715,417) new class B Shares, one hundred thirty-five million seven hundred fifteen thousand four
hundred seventeen (135,715,417) new class C Shares, one hundred thirty-five million seven hundred fifteen thousand four
hundred seventeen (135,715,417) new class D Shares, one hundred thirty-five million seven hundred fifteen thousand four
hundred seventeen (135,715,417) new class E Shares, one hundred thirty-five million seven hundred fifteen thousand four
95872
L
U X E M B O U R G
hundred seventeen (135,715,417) new class F Shares, one hundred thirty-five million seven hundred fifteen thousand four
hundred sixteen (135,715,416) new class G Shares, one hundred thirty-five million seven hundred fifteen thousand four
hundred sixteen (135,715,416) new class H shares, one hundred thirty-five million seven hundred fifteen thousand four
hundred sixteen (135,715,416) new class I shares;
- DBG Advisors declared to subscribe for nine million forty-one thousand six hundred sixty-seven (9,041,667) new
class A Shares, nine million forty-one thousand six hundred sixty-seven (9,041,667) new class B Shares, nine million forty-
one thousand six hundred sixty-seven (9,041,667) new class C Shares, nine million forty-one thousand six hundred sixty-
seven (9,041,667) new class D Shares, nine million forty-one thousand six hundred sixty-seven (9,041,667) new class E
Shares, nine million forty-one thousand six hundred sixty-seven (9,041,667) new class F Shares, nine million forty-one
thousand six hundred sixty-six (9,041,666) new class G Shares, nine million forty-one thousand six hundred sixty-six
(9,041,666) new class H Shares, nine million forty-one thousand six hundred sixty-six (9,041,666) new class I Shares,
with a nominal value of one euro cent (0,01) per share.
All the issued new shares have been fully paid up by way of a contribution in cash.
The amount of sixty-five million one hundred thousand euro (EUR 65,100,000.-) was thus as from that moment at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
In view of the above, the Shareholders resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company so as
to reflect the foregoing resolutions.
As a result, article 5 shall from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at sixty-five million one hundred twelve thousand five
hundred euro (EUR 65,112,500.-) divided into one million two hundred and forty-one thousand (1,241,000) ordinary shares,
seven hundred twenty-three million three hundred thirty-four thousand three hundred thirty-four (723,334,334) new Class
A Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-four thousand three hundred thirty-four (723,334,334)
Class B Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-four thousand three hundred thirty-four
(723,334,334) Class C Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-four thousand three hundred thirty-
four (723,334,334) Class D Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-four thousand three hundred
thirty-four (723,334,334) Class E Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-four thousand three
hundred thirty-four (723,334,334) Class F Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-four thousand
three hundred thirty-two (723,334,332) Class G Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-four
thousand three hundred thirty-two (723,334,332) Class H Shares, seven hundred twenty-three million three hundred thirty-
four thousand three hundred thirty-two (723,334,332) Class I Shares, all with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01.-)
each, all of which are fully paid up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at about seven thousand euro (EUR 7,000,-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same parties and in case of
divergences between the English and the German texts, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, known to the undersigned notary by
surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechzehn, am achten Tag des Monats April,
vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, (Großherzogtum Luxemburg),
sind erschienen:
1) DBG Advisors VI GmbH & Co. KG, eine nach dem deutschen Recht gegründete Gesellschaft, mit Sitz in der Bör-
senstraße 1, D-60313 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der
Nummer HRA 46856, handelnd durch ihren Komplementär DBG Service Provider Verwaltungs GmbH, eine nach dem
deutschen Recht gegründete Gesellschaft, mit Sitz in der Börsenstraße 1, D-60313 Frankfurt am Main, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 90813 („DBG Advisors“);
hier vertreten durch RA Stephan Weling, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer am 8. April 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht;
2) DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem
Recht von Guernsey, mit Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey,
95873
L
U X E M B O U R G
und im Register der Limited Partnerships of the Island of Guernsey eingetragen, handelnd durch ihren Komplementär
DBAG Fund VI GP (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht von
Guernsey, mit Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im
Register der Limited Partnerships of the Island of Guernsey eingetragen, handelnd durch ihren Komplementär DBG Ma-
nagement GP (Guernsey) Limited, eine durch die Guernsey Financial Services Commission regulierte Aktiengesellschaft
(„DBG Fund Konzern“);
hier vertreten durch RA Simone Schmit, vorgenannt,
kraft einer am 8. April 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht;
3) DBAG Fund VI (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht von
Guernsey, mit Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im
Register der Limited Partnerships of the Island of Guernsey registriert, handelnd durch ihren Komplementär DBAG Fund
VI GP (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht von Guernsey, mit
Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im Register der
Limited Partnerships of the Island of Guernsey registriert, handelnd durch ihren Komplementär DBG Management GP
(Guernsey) Limited, eine durch die Guernsey Financial Services Commission regulierte Aktiengesellschaft („DBG Fund“);
hier vertreten durch RA Stephan Weling, vorgennant, kraft einer am 8. April 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht
(hiernach gemeinsam mit DBG Advisors und DGB Fund Konzern, die „Gesellschafter“ genannt);
Die vorgenannten Vollmachten bleiben dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Die Gesellschafter haben den unterzeichnenden Notar gebeten anzugeben, dass sie die alleinigen Gesellschafter von
Calypso Holding S.à r.l. sind, einer nach dem luxemburgischen Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und Sitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 17.
November 2015, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 237 vom 29. Januar 2016 veröf-
fentlicht wurde, und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 201600 (die
„Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.
Die Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärte über die Beschlüsse ausführlich informiert zu sein, welche
auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals um einen Betrag von fünfundsechzig Millionen einhunderttausend
Euro (EUR 65.100.000.-), um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf fünfund-
sechzig Millionen einhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 65.112.500,-) zu erhöhen.
2. Ausgabe von siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig
(723.333.334) Anteilen der Klasse A, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihun-
dertvierunddreißig (723.333.334) Anteilen der Klasse B, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiundd-
reißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.333.334) Anteilen der Klasse C, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen
dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.333.334) Anteilen der Klasse D, siebenhundertdreiund-
zwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.333.334) Anteilen der Klasse E,
siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.333.334) An-
teilen der Klasse F, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertzweiunddreißig
(723.333.332) Anteilen der Klasse G, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihun-
dertzweiunddreißig (723.333.332) Anteilen der Klasse H und siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdrei-
unddreißigtausenddreihundertzweiunddreißig (723.333.332) Anteilen der Klasse I, jeweils mit einem Nennwert von einem
Euro Cent (EUR 0,01) pro Anteil.
3. Zustimmung zur Zeichnung dieser neuen Anteile und Zustimmung zur vollständigen Zahlung dieser neuen Anteile
in bar.
4. Neufassung des ersten Absatzes von Artikel 5, um die oben genannten Beschlüsse abzubilden.
5. Verschiedenes.
und forderte einstimmig daraufhin den unterzeichnenden Notar auf, die folgenden Beschlüsse festzuhalten:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschlossen, das ausgegebene Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünfundsechzig Millionen
einhunderttausend Euro (EUR 65.100.000.-) zu erhöhen, um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500,-) auf fünfundsechzig Millionen einhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 65.112.500,-) zu erhöhen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschlossen die Ausgabe von siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißig-
tausenddreihundertvierunddreißig (723.333.334) Anteilen der Klasse A, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen drei-
hundertdreiunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.333.334) Anteilen der Klasse B, siebenhundertdreiund-
zwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.333.334) Anteilen der Klasse C,
95874
L
U X E M B O U R G
siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.333.334) An-
teilen der Klasse D, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig
(723.333.334) Anteilen der Klasse E, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihun-
dertvierunddreißig (723.333.334) Anteilen der Klasse F, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertdreiundd-
reißigtausenddreihundertzweiunddreißig (723.333.332) Anteilen der Klasse G, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen
dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertzweiunddreißig (723.333.332) Anteilen der Klasse H und siebenhundertd-
reiundzwanzig Millionen dreihundertdreiunddreißigtausenddreihundertzweiunddreißig (723.333.332) Anteilen der Klasse
I.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Daraufhin erschienen die Gesellschafter gemäß der oben genannten Vertretungsmacht.
Die Gesellschafter erklärten die Zeichnung der neuen Anteile wie folgt:
- DBG Fund erklärte die Zeichnung von fünfhundertachtundsiebzig Millionen fünfhundertsechsundsiebzigtausend-
zweihundertfünfzig (578.576.250) Anteilen der Klasse A, fünfhundertachtundsiebzig Millionen fünfhundertsechsundsieb-
zigtausendzweihundertfünfzig (578.576.250) Anteilen der Klasse B, fünfhundertachtundsiebzig Millionen fünfhundert-
sechsundsiebzigtausendzweihundertfünfzig (578.576.250) Anteilen der Klasse C, fünfhundertachtundsiebzig Millionen
fünfhundertsechsundsiebzigtausendzweihundertfünfzig (578.576.250) Anteilen der Klasse D, fünfhundertachtundsiebzig
Millionen fünfhundertsechsundsiebzigtausendzweihundertfünfzig (578.576.250) Anteilen der Klasse E, fünfhundertach-
tundsiebzig Millionen fünfhundertsechsundsiebzigtausendzweihundertfünfzig (578.576.250) Anteilen der Klasse F, fünf-
hundertachtundsiebzig Millionen fünfhundertsechsundsiebzigtausendzweihundertfünfzig (578.576.250) Anteilen der
Klasse G, fünfhundertachtundsiebzig Millionen fünfhundertsechsundsiebzigtausendzweihundertfünfzig (578.576.250)
Anteilen der Klasse H, fünfhundertachtundsiebzig Millionen fünfhundertsechsundsiebzigtausendzweihundertfünfzig
(578.576.250) Anteilen der Klasse I;
- DBG Fund Konzern erklärte die Zeichnung von einhundertfünfunddreißig Millionen siebenhundertfünfzehntausend-
vierhundertsiebzehn (135.715.417) Anteilen der Klasse A, einhundertfünfunddreißig Millionen siebenhundertfünfzehn-
tausendvierhundertsiebzehn (135.715.417) Anteilen der Klasse B, einhundertfünfunddreißig Millionen siebenhundert-
fünfzehntausendvierhundertsiebzehn (135.715.417) Anteilen der Klasse C, einhundertfünfunddreißig Millionen
siebenhundertfünfzehntausendvierhundertsiebzehn (135.715.417) Anteilen der Klasse D, einhundertfünfunddreißig Mil-
lionen siebenhundertfünfzehntausendvierhundertsiebzehn (135.715.417) Anteilen der Klasse E, einhundertfünfunddreißig
Millionen siebenhundertfünfzehntausendvierhundertsiebzehn (135.715.417) Anteilen der Klasse F, einhundertfünfundd-
reißig Millionen siebenhundertfünfzehntausendvierhundertsechzehn (135.715.416) Anteilen der Klasse G, einhundertfün-
funddreißig Millionen siebenhundertfünfzehntausendvierhundertsechzehn (135.715.416) Anteilen der Klasse H, einhun-
dertfünfunddreißig Millionen siebenhundertfünfzehntausendvierhundertsechzehn (135.715.416) Anteilen der Klasse I;
- DBG Advisors erklärte die Zeichnung von neun Millionen einundvierzigtausendsechshundertsiebenundsechzig
(9.041.667) Anteilen der Klasse A, neun Millionen einundvierzigtausendsechshundertsiebenundsechzig (9.041.667) An-
teilen der Klasse B, neun Millionen einundvierzigtausendsechshundertsiebenundsechzig (9.041.667) Anteilen der Klasse
C, neun Millionen einundvierzigtausendsechshundertsiebenundsechzig (9.041.667) Anteilen der Klasse D, neun Millionen
einundvierzigtausendsechshundertsiebenundsechzig (9.041.667) Anteilen der Klasse E, neun Millionen einundvierzigtau-
sendsechshundertsiebenundsechzig (9.041.667) Anteilen der Klasse F, neun Millionen einundvierzigtausendsechshun-
dertsechsundsechzig (9.041.666) Anteilen der Klasse G, neun Millionen einundvierzigtausendsechshundertsechsundsech-
zig (9.041.666) Anteilen der Klasse H, neun Millionen einundvierzigtausendsechshundertsechsundsechzig (9.041.666)
Anteilen der Klasse I,
mit einem Nennwert von jeweils einem Eurocent (0,01) pro Anteil.
Alle neue ausgegebene Anteile sind in bar voll eingezahlt worden.
Der Betrag von fünfundsechzig Millionen einhunderttausend Euro (EUR 65.100.000.-) stand ab diesem Zeitpunkt der
Gesellschaft zur Verfügung, und der unterzeichnende Notar hat die notwendigen Dokumente dies belegend erhalten.
<i>Fünfter Beschlussi>
In Anbetracht der obigen Beschlüsse beschließt der Gesellschafter den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung der
Gesellschaft abzuändern und neu zu verfassen, um diese Beschlüsse widerzuspiegeln.
Artikel 5 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:
„ Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundsechzig Milli-
onen einhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 65.112.500.-), und ist in eine Million zweihunderteinundvierzigtau-
send (1.241.000) Stammanteile, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertvierunddreißigtausenddreihundert-
vierunddreißig (723.334.334) Anteile der Klasse A, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertvierunddreißig-
tausenddreihundertvierunddreißig (723.334,334) Anteile der Klasse B, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen
dreihundertvierunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.334.334) Anteile der Klasse C, siebenhundertdreiund-
zwanzig Millionen dreihundertvierunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.334.334) Anteile der Klasse D, sie-
benhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertvierunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig (723.334.334) Anteile
der Klasse E, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertvierunddreißigtausenddreihundertvierunddreißig
95875
L
U X E M B O U R G
(723.334.334) Anteile der Klasse F, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertvierunddreißigtausenddreihun-
dertzweiunddreißig (732.334.332) Anteile der Klasse G, siebenhundertdreiundzwanzig Millionen dreihundertvierundd-
reißigtausenddreihundertzweiunddreißig (732.334.332) Anteile der Klasse H und siebenhundertdreiundzwanzig Millionen
dreihundertvierunddreißigtausenddreihundertzweiunddreißig (732.334.332) Anteile der Klasse I mit einem Nennwert von
je einem Eurocent (EUR 0,01) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.“
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf ungefähr siebentausend Euro (EUR 7.000,-) geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen
genannten Partei das vorliegende Dokument in englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage derselben
Partei und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll der englische Text
Vorrang haben.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten
Bevollmächtigter der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat derselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichn-
enden Notar unterzeichnet.
Signé: S. Weling, S. Schmitt, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 avril 2016. GAC/2016/3250. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016104719/298.
(160076965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Calypso Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.917.875,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 201.612.
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of April,
before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Calypso Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having a current share capital of sixty-five million one hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 65,112,500.-),
with registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 201600,
hereafter referred to as the “Shareholder”,
hereby represented by Maître Simone Schmitt, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on 8 April 2016;
The said proxy shall be annexed to the present deed for registration purposes.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Calypso
Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a
share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned on 17 November
2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 257 of 1 February 2016 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 201612 (the “Company”). The articles of
incorporation of the Company have not yet been amended.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To create two new classes of shares, namely the “Class A Ordinary Shares” and the “Class B Preferred Shares”.
2 To convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares into twelve thousand five hundred
(12,500) Class A Ordinary Shares.
95876
L
U X E M B O U R G
3 To increase the issued capital of the Company by an amount of sixteen million nine hundred five thousand three
hundred seventy-five euro (EUR 16,905,375.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-) to an amount of sixteen million nine hundred seventeen thousand eight hundred seventy-five euro
(EUR 16,917,875.-).
4 To issue sixteen million four hundred twelve thousand five hundred (16,412,500) new Class A Ordinary Shares with
a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, and four hundred ninety-two thousand eight hundred seventy-five
(492,875) Class B Preferred Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share.
5 To accept subscription for these new Class A Ordinary Shares and Class B Preferred Shares, with payment of a share
premium in a total amount of forty-eight million seven hundred ninety-four thousand six hundred twenty-five euro (EUR
48,794,625.-) on the Class B Preferred Shares, by Calypso Holding S.à r.l., and to accept payment in full of each such new
Class A Ordinary Share and Class B Preferred Share by a contribution in cash.
6 To amend paragraph 1 of article 5 as well as article 28 and article 29 of the articles of incorporation of the Company,
in order to reflect the foregoing agenda, and to define the respective financial rights of the Class A Ordinary Shares and
the Class B Preferred Shares.
7 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to create two new classes of shares, namely the “Class A Ordinary Shares” and the “Class B
Preferred Shares”.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares into twelve thousand
five hundred (12,500) Class A Ordinary Shares.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the issued capital of the Company by an amount of sixteen million nine hundred
five thousand three hundred seventy-five euro (EUR 16,905,375.-) so as to raise it from its present amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount of sixteen million nine hundred seventeen thousand eight hundred
seventy-five euro (EUR 16,917,875.-).
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to issue sixteen million four hundred twelve thousand five hundred (16,412,500) new Class
A Ordinary Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, and four hundred ninety-two thousand eight
hundred seventy-five (492,875) Class B Preferred Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share.
<i>Subscription - Paymenti>
The Shareholder declared to subscribe for sixteen million four hundred twelve thousand five hundred (16,412,500) new
Class A Ordinary Shares and four hundred ninety-two thousand eight hundred seventy-five (492,875) new Class B Preferred
Shares with payment of a share premium in a total amount of forty-eight million seven hundred ninety-four thousand six
hundred twenty-five euro (EUR 48,794,625.-) on the Class B Preferred Shares, and to accept full payment in cash for these
new shares.
The amount of sixty-five million seven hundred thousand euro (EUR 65,700,000.-) was thus as from that moment at
the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
In view of the above, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5, and to restate article 28 and
article 29 of the articles of association of the Company so as to reflect the foregoing resolutions, and to define the respective
rights of the Class A Ordinary Shares and the Class B Preferred Shares.
As a result, paragraph 1 of article 5 shall from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set sixteen million nine hundred seventeen thousand eight
hundred seventy-five euro (EUR 16,917,875.-) divided into sixteen million four hundred twenty-five thousand (16,425,000)
Class A Ordinary Shares and four hundred ninety-two thousand eight hundred seventy-five (492,875) Class B Preferred
Shares, all with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.”
As a result, article 28 shall from now on read as follows:
“ Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
95877
L
U X E M B O U R G
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s).
In respect of each distribution of dividends, the amount allocated to this effect shall be distributed as follows. First, the
Class B Preferred Shares shall entitle on a pro rata basis to a preferred cumulative dividend in an amount of twelve percent
(12%) per annum of the aggregate nominal value of the Class B Preferred Shares together with the share premium paid
thereon (the “Yearly Preferred Dividend”) and any accumulated but unpaid previous Yearly Preferred Dividend, and
second, the Class A Ordinary Shares shall entitle to any remaining dividend which shall be allocated pro rata among the
Class A Ordinary Shares.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.”
As a result, article 29 shall from now read as follows:
“ Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by
half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may
be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.
In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the
Company’s debts and liabilities;
(ii) second, to the holders of Class B Preferred Shares for the repayment of the nominal value of their Class B Preferred
Shares and for an amount corresponding (and in no case exceeding) to the entitlement of these Class B Preferred Shares
to preferred dividends in accordance with Article 28, third paragraph, above, on a pro rata basis;
(iii) third, to the holders of Class A Ordinary Shares for the repayment of the nominal value of their Class A Ordinary
Shares and for an amount corresponding to the remaining assets and cash to be distributed, on a pro rata basis.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at about seven thousand euro (EUR 7.000,-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same party and in case of
divergences between the English and the German texts, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary by surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechzehn, am elften Tag des Monats April,
vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:
Calypso Holding S.à r.l, eine nach dem luxemburgischen Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit
einem derzeitigen Gesellschaftskapital von fünfundsechzig Millionen einhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR
65,112,500.-) und Sitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg-Findel, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen
beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 201600,
hiernach der „Gesellschafter“ genannt,
hier vertreten durch RA Me. Simone Schmitt, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer am 8. April 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht.
Die vorgenannte Vollmacht bleibt dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Der Gesellschafter hat den unterzeichnenden Notar gebeten anzugeben, dass er der alleinige Gesellschafter von Calypso
Investment S.à r.l. ist, einer nach dem luxemburgischen Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit
einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und Sitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 17.
November 2015, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 257 vom 1. Februar 2016 veröffentlicht
95878
L
U X E M B O U R G
wurde, und eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 201612 (die „Gesellschaft“).
Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.
Der Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärte über die Beschlüsse ausführlich informiert zu sein, welche
auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Schaffung von zwei neuen Anteilsklassen, namentlich die „Stammanteile der Klasse A“ und die „Vorzugsanteile der
Klasse B“.
2. Umwandlung der existierenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile in zwölftausendfünfhundert
(12.500) Stammanteile der Klasse A.
3. Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals um einen Betrag von sechzehn Millionen neunhundertfünftau-
senddreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 16.905.375.-), um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500,-) auf sechzehn Millionen neunhundertsiebzehntausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 16.917.875,-)
zu erhöhen.
4. Schaffung von sechzehn Millionen vierhundertzwölftausendfünfhundert (16.412.500) Stammanteilen der Klasse A
mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil, und von vierhundertzweiundneunzigtausendachthun-
dertfünfundsiebzig (492.875) Vorzugsanteilen der Klasse B, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) pro
Anteil.
5. Zustimmung zur Zeichnung dieser neuen Stammanteile der Klasse A und dieser neuen Vorzugsanteile der Klasse B,
mit Zahlung eines Aufgeldes auf die Vorzugsanteile der Klasse B in Höhe von achtundvierzig Millionen siebenhundert-
vierundneunzigtausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 48.794.625,-) durch Calypso Holding S.à r.l., und Zu-
stimmung zur vollständigen Zahlung dieser neuen Anteile in bar.
6. Neufassung von Artikel 5 der Satzung, um die oben genannten Beschlüsse abzubilden.
7. Verschiedenes.
und forderte daraufhin den unterzeichnenden Notar auf, die folgenden Beschlüsse festzuhalten:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschloss zwei neue Anteilsklassen, namentlich die „Stammanteile der Klasse A“ und die „Vor-
zugsanteile der Klasse B“ zu schaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschloss, die existierenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile in zwölftausendfünfhundert
(12.500) Stammanteile der Klasse A, umzuwandeln.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschloss, das ausgegebene Gesellschaftskapital um einen Betrag von sechzehn Millionen neun-
hundertfünftausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 16.905.375.-) zu erhöhen, um das bestehende Kapital von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf sechzehn Millionen neunhundertsiebzehntausendachthundertfünfund-
siebzig Euro (EUR 16.917.875,-) zu erhöhen.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschloss, sechzehn Millionen vierhundertzwölftausendfünfhundert (16.412.500) Stammanteile der
Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil, und vierhundertzweiundneunzigtausendach-
thundertfünfundsiebzig (492.875) Vorzugsanteilen der Klasse B, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
pro Anteil, auszugeben.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Daraufhin erschien der Gesellschafter gemäß der oben genannten Vertretungsmacht.
Der Gesellschafter erklärte die Zeichnung von sechzehn Millionen vierhundertzwölftausendfünfhundert (16.412.500)
Stammanteilen der Klasse A, und von vierhundertzweiundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig (492,875) Vorzugs-
anteilen der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil, mit Zahlung eines Aufgeldes auf
die Vorzugsanteile der Klasse B in Höhe von achtundvierzig Millionen siebenhundertvierundneunzigtausendsechshun-
dertfünfundzwanzig (EUR 48.794.625,-), und die vollständige Zahlung dieser neuen Anteile in bar.
Der Betrag von fünfundsechzig Millionen siebenhunderttausend Euro (EUR 65,700,000.-) stand ab diesem Zeitpunkt
der Gesellschaft zur Verfügung, und der unterzeichnende Notar hat die notwendigen Dokumente dies belegend erhalten.
<i>Fünfter Beschlussi>
In Anbetracht der obigen Beschlüsse beschließt der Gesellschafter den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung der
Gesellschaft, sowie den Artikel 28 und den Artikel 29 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und neu zu verfassen, um
95879
L
U X E M B O U R G
diese Beschlüsse widerzuspiegeln und die jeweiligen finanziellen Rechte der Stammanteile der Klasse A und der Vor-
zugsanteile der Klasse B festzulegen.
Artikel 5 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:
„ Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt sechzehn Millionen
neunhundertsiebzehntausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 16.917.875,-), und ist in sechzehn Millionen vierhun-
dertfünfundzwanzigtausend (16,425,000) Stammanteile der Klasse A und vierhundertzweiundneunzigtausendachthun-
dertfünfundsiebzig (492,875) Vorzugsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) aufgeteilt.
Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.“
Artikel 28 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:
„ Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%)
der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt, sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter, wie der verbleibende jährliche Reinge-
winn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-
jahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die
Gesellschafter ausschütten.
Die für die Ausschüttung der Dividenden vorgesehene Summe wird wie folgt aufgeteilt. Zuerst vermitteln die Vor-
zugsanteile der Klasse B, auf einer pro-rata Basis, Anrecht auf eine kumulative Dividende in Höhe der Summe von (i)
zwölf Prozent (12%) pro Jahr bezogen auf den Nominalwert der Vorzugsanteile der Klasse B zuzüglich des darauf einge-
zahlten Aufgeldes (die „Jährliche Vorzugsdividende“) und aller aufgelaufenen jedoch nicht gezahlten Jährlichen Vor-
zugsdividenden, und danach vermitteln die Stammanteile der Klasse A Anrecht auf jegliche restlichen Dividenden, welche
im pro-rata Verhältnis zwischen den Stammanteilen der Klasse A verteilt werden.
Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-
henden Bestimmungen können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Gesellschafter auszahlen. Die Ge-
schäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.“
Artikel 29 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:
„ Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst
werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche
oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt wer-
den.
Im Falle einer Liquidation werden alle Aktiva sowie die Barbestände der Gesellschaft in folgender Rangordnung aus-
geschüttet:
(i) zuerst, an die Gläubiger (durch Rückzahlung beziehungsweise durch angemessene Rückstellung zwecks Rückzah-
lung) für alle Schulden und Passiva der Gesellschaft;
(ii) dann, an die Gesellschafter, welche Vorzugsanteile der Klasse B halten, als Rückzahlung in Höhe des Nennwertes
dieser Vorzugsanteile der Klasse B, erhöht durch einen Betrag, der dem Wert des Anspruchs dieser Anteile auf die in den
in Artikel 28, Paragraph 3, erwähnten Vorzugsdividenden entspricht, und auf keinen Fall höher als dieser ist, pro rata;
(iii) dann, an die Gesellschafter, welche Stammanteile der Klasse A halten, als Rückzahlung in Höhe des Nennwertes
dieser Stammanteile der Klasse A, erhöht durch einen Betrag, der den verbleibenden auszuschüttenden Aktiva und Bar-
geldbeständen entspricht.“
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf ungefähr siebentausend Euro (EUR 7.000,-) geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen
genannten Partei das vorliegende Dokument in englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage derselben
Partei und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll der englische Text
Vorrang haben.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten
Bevollmächtigter der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichn-
enden Notar unterzeichnet.
Signé: S. Schmitt, M. Loesch.
95880
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 13 avril 2016. GAC/2016/2966. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016104720/249.
(160076995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Baie de Greco Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 48.332.
<i>Extrait des décisions de l'actionnaire unique en date du 9 avril 2016i>
L'Actionnaire Unique décide de fixer le siège social de la Société au 30, Dernier Sol, L-2543 Luxembourg;
L'Actionnaire Unique décide d'accepter la démission des administrateurs, des administrateurs-délégués et du Commis-
saire aux Comptes de la Société;
L'Actionnaire Unique décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la Société jusqu'à l'assem-
blée annuelle qui se tiendra en l'année 2020:
- Monsieur David VENDEIRINHO, né à Châlons-en-Champagne (France) le 26 mars 1982, demeurant à 1445, rue
Principale, F-38850 Charavines (France)
- Monsieur Didier DE LANDAS, né 11 février 1955 à Lobbes (Belgique), demeurant 23, Haffstrooss, L-5752 Frisange;
- Monsieur Frédéric DEFLORENNE, né le 4 octobre 1973 à Charleroi (Belgique), demeurant 30, Dernier Sol, L-2543
Luxembourg
L'Actionnaire Unique décide de nommer la société FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES S.à r.l., société établie
et ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 111495 comme Commissaire aux Comptes de la Société jusqu'à l'assemblée annuelle
qui se tiendra en l'année 2020:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016104690/25.
(160076763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Buwog Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 125.553.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution écrite des associés de la Société en date du 25 avril 2016 que la Société a accepté la démission
de M. Herwig Teufelsdorfer en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- M. Jean (John) Wantz, gérant de classe A;
- M. Charles Meyer, gérant de classe A;
- M. Martin Puckl, gérant de classe B;
- Dr. Paul Kozubek, gérant de classe B;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016104689/19.
(160076812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
95881
L
U X E M B O U R G
Barbat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4974 Dippach, 1, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 78.170.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle du 6 mai 2016i>
Le mandat d'administrateur de Monsieur LEPORE Marcello, demeurant à L-4974 Dippach, 1, Rue des Romains, est
renouvelé pour un terme de six ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2022.
Le mandat d'administrateur de Madame KAISER Rosa, demeurant à L-4974 Dippach, 1, Rue des Romains, est renouvelé
pour un terme de six ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2022.
Le mandat d'administrateur de Madame LEPORE Sandy, demeurant à L-4974 Dippach, 1, Rue des Romains, est re-
nouvelé pour un terme de six ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2022.
Le mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière de Madame KAISER Rosa, demeurant à L-4974 Dippach,
1, Rue des Romains, est renouvelé pour un terme de six ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra
en 2022.
Le mandat de commissaire aux comptes de FIDUCIAIRE DENIS SOUMANN E.U.R.L., immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B85288 avec siège social à L-5886 Alzingen, 484, route de
Thionville, est renouvelé pour un terme de six ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2022.
Pour extrait conforme
<i>Le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2016104691/22.
(160076764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
BBGI SICAV S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 163.879.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de surveillance de la Société en date du 23 mars 2016i>
En date du 23 mars 2016, le conseil de surveillance a décidé de renouveler le mandat de M. Michael Denny dans sa
fonction de membre du directoire de la Société pour une durée d'un an (renouvelable), avec effet au 30 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016104697/12.
(160077141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
BNPP T0, BNP Paribas A Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 10, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 145.536.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth day of April.
Before the undersigned Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
was held
an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of BNP PARIBAS A FUND, en abrégé BNPP T0
(hereafter referred to as the "Company"), a société d'investissement à capital variable having its registered office at L-5826
Hesperange, 33, Rue de Gasperich, registered with the Luxembourg Trade Register of Commerce and Companies (“Registre
de Commerce et des Sociétés”) under number B 145.536, incorporated pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, on 31
st
March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
802 of 15
th
April 2009. The Articles of Incorporation were amended for the last time under a deed of Me Edouard Delosch,
then notary residing in Diekirch, on the 25
th
September 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial") number 2864 of 14
th
November 2013.
The Meeting is opened at 10.30 a.m. and presided by Mr. Arnaud PERAIRE, private employee, residing professionally
in Hesperange, who appoints Mrs. Fabienne VERONESE, private employee, residing professionally in Hesperange, as
Secretary.
The Meeting elects Mr. Guillaume DEBAUVE, private employee, residing professionally in Hesperange, as Scrutineer.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
95882
L
U X E M B O U R G
I. The Shareholders were convened to the Meeting by letter containing the Agenda, sent to them by letter on 23
rd
March
2016, and published in the Mémorial C and in the Luxemburger Wort and in the Letzebuerger Journal on 23
rd
March 2016
and 08
th
April 2016.
II. The shareholders represented, and the number of shares is shown on an attendance list, signed by the Chairman, the
Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary.
This list as well as the proxy signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration
authorities.
III. A first meeting of shareholders duly convened, was held on 22
nd
March 2016 in order to decide on the same agenda.
This meeting could not take any decision because the legal quorum of presence was not met.
IV. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the
Agenda.
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 25 April 2016:
1) Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2) Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6 April
2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August 1915
as amended.
3) Article 14(c):
Replacement of “the last known price on the valuation day” by “the last known closing price on the valuation day” and
replacement of “the most recent price on the principal market on which they are traded” by “the last known closing price
on the principal market on which they are traded” for the listed assets valuation price;
4) Article 16:
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director by using the same
terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
5) Article 19:
Cancellation of the possibility to manage jointly the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
6) Article 20:
Cancellation of the following condition, relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Company,
to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law of 12 July
2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions at
the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
7) Article 22:
Replacement of the title of the article “invalidation clause” by “conflict of interest” After deliberation, the Meeting took
the following resolutions which were carried by at least two-thirds of the votes cast:
<i>First resolutioni>
The general Meeting decides to update the Articles of Association of the Company as following:
Art. 4. Registered office. “The Company’s registered office is located in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
In the case where the Board of Directors considers that extraordinary political, economic or social events might com-
promise the Company’s normal operations at the registered office or ease of communication with said registered office or
by said office with other countries have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad
until said abnormal situation no longer exists. However, any such temporary measure shall have no effect on the Company’s
nationality, which, notwithstanding the above mentioned temporary transfer of the registered office, shall continue to be a
Luxembourg company.
The Company may, by simple decision of the Board of Directors, open branches or offices in the Grand Duchy of
Luxembourg or elsewhere.
95883
L
U X E M B O U R G
The registered office may be moved by simple decision of the Board of Directors, either within the commune or, within
the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxembourg.”
Art. 8. Share form. “All shares, regardless of the sub-fund, category or class to which it belongs, may be in registered,
bearer, or dematerialised form as decided by the Board of Directors.
Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended
(the “Companies Act”).
Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act Dematerialised shares
shall be issued as described by the Act of 6 April 2013 on dematerialised securities.
Within the limits and conditions set by the Board of Directors, shares issued in one of these three forms may be converted
into another form. The shareholder requesting the conversion may have to pay the costs of such operation.
The Company acknowledges only one shareholder per share. If a share is jointly owned, if title is split or if the share is
disputed, individuals or legal entities claiming a right to the share shall appoint a sole representative to represent the share
with regard to the Company. The Company shall be entitled to suspend the exercise of all rights attached to the share until
said representative has been appointed.”
Art. 14. Net asset value. “The Company shall calculate the net asset value of each sub-fund, the net asset value per share
for each category and class and the issue, conversion and redemption prices at least twice per month, at to a frequency to
be set by the Board of Directors.
The net asset value of each sub-fund shall be equal to the total value of the assets of said sub-fund less the sub-fund's
liabilities.
The net asset value per share is obtained by dividing the net assets of the sub-fund in question by the number of shares
issued for said sub-fund, considering, where applicable, the breakdown of the net assets of said sub-fund between the
various share categories and classes of such subfund.
Said net value shall be expressed in the currency of the sub-fund in question or in any other currency that the Board of
Directors may choose.
The day on which the net asset value is dated shall be referred to in these Articles of Association as the “Calculation
Date”.
The valuation methods shall be as follows:
The Company's assets include:
(1) cash in hand and cash deposits, including interest accrued but not yet received and interest accrued on these deposits
until the payment date;
(2) all notes and bills payable on demand and amounts receivable (including the results of sales of securities before the
proceeds have been received);
(3) all securities, units, shares, bonds, option or subscription rights and other investments and securities which are the
property of the Company;
(4) all dividends and distributions to be received by the Company in cash or securities that the Company is aware of;
(5) all interest accrued but not yet received and all interest generated up to the payment date by securities which are the
property of the Company, unless such interest is included in the principal of these securities;
(6) the Company's formation expenses, insofar as these have not been written down;
(7) all other assets, whatever their nature, including prepaid expenses.
Without prejudice to the specific provisions applicable to any sub-fund, category and /or class, the value of these assets
shall be determined as follows:
(a) the value of cash in hand and cash deposits, bills and drafts payable at sight and amounts receivable, prepaid expenses,
and dividends and interest due but not yet received, shall comprise the nominal value of these assets, unless it is unlikely
that this value could be received; in that event, the value will be determined by deducting an amount which the Company
deems adequate to reflect the actual value of these assets;
(b) the value of shares or units in undertakings for collective investment shall be determined on the basis of the last net
asset value available on the valuation day;
(c) the valuation of all securities listed on a stock exchange or any other regulated market which functions regularly, is
recognised and accessible to the public, is based on the last known closing price on the valuation day, and, if the securities
concerned are traded on several markets, on the basis of the last known closing price on the principal market on which they
are traded; if the last known closing price is not a true reflection, the valuation shall be based on the probable sale price
estimated by the Board of Directors in a prudent and bona fide manner;
(d) unlisted securities or securities not traded on a stock exchange or another regulated market which functions in a
regular manner, is recognised and accessible to the public, shall be valued on the basis of the probable sale price estimated
in a prudent and bona fide manner by a qualified professional appointed for this purpose by the Board of Directors.
(e) securities denominated in a currency other than the currency in which the sub-fund concerned is denominated shall
be converted at the exchange rate prevailing on the valuation day;
95884
L
U X E M B O U R G
(f) the Board of Directors is authorised to draw up or amend the rules in respect of the relevant valuation rates. Decisions
taken in this respect shall be included in the prospectus;
(g) derivative financial instruments shall be valued according to the rules decided by the Board of Directors and described
in the prospectus. These rules shall have been approved in advance by the Company’s auditor and the supervisory autho-
rities.
The Company's liabilities include:
(1) all loans, matured bills and accounts payable;
(2) all known liabilities, whether or not due, including all contractual obligations due and relating to payment in cash
or kind, including the amount of dividends announced by the Company but yet to be paid;
(3) all reserves, authorised or approved by the Board of Directors, including reserves set up in order to cover a potential
capital loss on certain of the Company's investments;
(4) any other undertakings given by the Company, except for those represented by the Company's equity. For the
valuation of the amount of these other liabilities, the Company shall take account of all the charges for which it is liable,
including, without restriction, the costs of amendments to the Articles of Association, the prospectus and any other docu-
ments relating to the Company, management, performance and other fees and extraordinary expenses, any taxes and duties
payable to government departments and stock exchanges, the costs of financial charges, bank charges or brokerage incurred
upon the purchase and sale of assets or otherwise. When assessing the amount of these liabilities, the Company shall take
account of regular and periodic administrative and other expenses on a pro rata temporis basis.
The assets, liabilities, expenses and fees not allocated to a sub-fund, category or class shall be apportioned to the various
sub-funds, categories or classes in equal parts or, subject to the amounts involved justifying this, proportionally to their
respective net assets. Each of the Company's shares which is in the process of being redeemed shall be considered as a
share issued and existing until closure on the valuation day relating to the redemption of such share and its price shall be
considered as a liability of the Company as from closing on the date in question until such time as the price has been duly
paid. Each share to be issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be considered
as issued as from closing on the calculation date of its issue price and its price shall be considered as being an amount due
to the Company until such time as it has been duly received by the Company. As far as possible, account shall be taken of
any investment or disinvestment decided by the Company until the valuation day.
The total amount of annual fees payable by a sub-fund, category or class of share shall never exceed 5% (five per cent)
of its average net assets.
If it considers that the net asset value calculated is not representative of the real value of the Company’s shares, or if
since the calculation there have been significant developments on the markets concerned, the Board of Directors may decide
to have it updated on that same day, and shall determine a new net asset value in a prudent and bona fide manner.”
Art. 16. Directors. “A Board of Directors comprised of at least three members shall manage the Company. Board
members do not need to be Company shareholders. The General Meeting of shareholders shall appoint them for a term of
office of six years at most, which shall be renewable.
The General Meeting may remove a director from office at will.
In case of vacancy of the office of a director appointed by the General Meeting of shareholders, the remaining directors
so appointed may fill the vacancy on a provisional basis. In such circumstances, the next General Meeting of shareholders
shall make the final appointment.”
Art. 19. Daily management. “The Company’s Board of Directors may delegate its powers relating to the daily mana-
gement of the Company’s business (including the right to act as the Company’s authorised signatory) and to represent it
for said management either to one or more directors or to one or more agents who need not necessarily be Company
shareholders. Said individuals shall have the powers conferred on them by the Board of Directors. They may sub-delegate
their powers, if authorised by the Board of Directors. The Board of Directors may also grant all special mandates by notarised
power of attorney or by private power of attorney.”
Art. 20. Investment policy. “The Board of Directors, applying the principle of the spreading of risks, shall be fully
empowered to determine the investment policy and restrictions of the Company and each of its sub-funds, and the guidelines
to be followed for the management of the Company, in compliance with the law and subject to the following conditions:
a) The Company may invest in any transferable securities and money market instruments officially listed on a stock
exchange or traded on a regulated market, operating regularly, that is recognised and open to the public, in any country;
b) Overall, the Company may not invest more than 10% of the assets of each sub-fund in UCITS and other undertakings
for collective investment, apart for certain sub-funds if mentioned in their investments policy;
c) The Board of Directors may specify that a sub-fund’s investment policy should be the replication of the composition
of an equity or bond index within the limits authorised by law and the supervisory authorities;
d) The Company may invest, in accordance with the principle of risk-spreading, at least 35% and up to 100% of its
assets in different issues of transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State
of the European Union, by its local authorities, or by a state that is not part of the European Union or by international public
organisations to which one or more Member States of the European Union belong. These securities must come from at
95885
L
U X E M B O U R G
least six different issues, and the securities belonging to a single issue must not account for more than 30% of the net asset
value of the sub-fund.
e) A sub-fund of the Company may subscribe, acquire and / or hold shares of one or more other sub-funds (referred to
as “target sub-funds”) of the Company provided that:
- the target sub-funds do not in turn invest in this sub-fund;
- the proportion of assets that each target sub-fund invests in other target sub-funds of the Company does not exceed
10%;
- any voting rights attached to the shares of the target sub-funds are suspended for as long as they are held by the sub-
fund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any events, for as long as these target sub-fund’s shares are held by the Company, their value shall not be taken into
consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of
net assets required by the law;
f) The Board of Directors may create “feeder sub-funds” under the conditions provided for by law.”
Art. 22. Conflict of interest. “No contract and transaction that the Company may enter into with other companies or
firms may be affected or invalidated by the fact that one or more directors or executive directors of the Company has/have
any interest whatsoever in such other company or firm or by the fact that he is a director, shareholder or partner, executive
director or employee thereof.
The director or executive director of the Company who is a director, executive director or employee of a company or
firm with which the Company signs contracts or otherwise does business shall not thereby be deprived of the right to
deliberate, vote and act in connection with matters related to such contracts or such business. In the event a director or an
executive director has a personal interest in a Company transaction, said director or executive director shall inform the
Board of Directors of his personal interest and shall not deliberate or take part in the vote on said transaction. A report on
said transaction and on the personal interest of such director or non-executive director shall be submitted at the next meeting
of shareholders.”
<i>Second resolutioni>
These changes will be effective as from 25 April 2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).
There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned at 10.45 a.m.
Whereof, this deed is drawn up in Hesperange on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the bureau of the Meeting, who are known to the undersigned notary
by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the notary this deed.
Signé: A. PERAIRE, F. VERONESE, G. DEBAUVE, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14145. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 09 mai 2016.
Référence de publication: 2016104703/230.
(160076818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Bobati S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 173.350.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echtemach, le 6 mai 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016104705/10.
(160076450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
95886
L
U X E M B O U R G
Borea Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 112.825.
Avec effet au 1
er
Avril 2016, le Conseil de Gérance de la Société BOREA HOLDING S.à r.l. a décidé de transférer le
siège social de la Société au 13, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016104710/13.
(160076445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Benelux Mezzanine 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 247.200,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 111.941.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2016.
Référence de publication: 2016104682/10.
(160076943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Beltone MidCap Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 143.335.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires en date du 19 avril 2016i>
En date du 19 avril 2016, l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Abdel-Monem Omran, Monsieur Paul Tholly, Monsieur Hazem Barakat,
Monsieur Arnold Spruit et de Monsieur Dominique Nouvellet en qualité d'Administrateurs, jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Annuelle en 2017,
- de renouveler le mandat de Ernst & Young, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Réviseur
d'Entreprises, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2017.
Luxembourg, le 3 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Beltone MidCap Management SA
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2016104681/18.
(160076921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
AXA Mezzanine I S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 108.403.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016104672/10.
(160077132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
95887
L
U X E M B O U R G
AXA Private Debt II S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à
Risque.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 138.458.
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 25 avril 2016, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Ratification de la cooptation de Joan-Sophie Kiener-Wegmann, avec adresse professionnelle au 24, avenue Emile
Reuter, L-2420 Luxembourg, au mandat d’administrateur, avec effet immédiat au 15 juillet 2015;
2. Ratification de la cooptation de Guillaume Chinardet, avec adresse professionnelle au 20, place Vendôme, 75001
Paris, France, au mandat d’administrateur, avec effet au 10 septembre 2015;
3. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Joan-Sophie Kiener-Wegmann, avec adresse professionnelle au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
- Guillaume Chinardet, avec adresse professionnelle au 20, place Vendôme, 75001 Paris, France
pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice
social se clôturant au 31 décembre 2018 et qui se tiendra en 2019;
4. Renouvellement du mandat de réviseur d’entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 2, rue
Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2016 et qui se tiendra en 2017;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2016.
Référence de publication: 2016104673/22.
(160076483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
AXA Private Debt II S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à
Risque.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 138.458.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2016.
Référence de publication: 2016104674/11.
(160076957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
B.S. Diffusion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 72.297.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016104676/10.
(160076944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
AXIS (Luxembourg), Société à responsabilité limitée,
(anc. Axis Interim).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 117.338.
L'an deux mille seize, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
La société de droit belge Finparco N.V., établie et ayant son siège social à 65, Frankrijklei, B-2000 Anvers, inscrite au
Registre de Commerce RPR d’Antwerpen sous le numéro 0878.353.410;
95888
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Monsieur Christophe VELGE, demeurant professionnellement à Anvers, en sa qualité d’adminis-
trateur-délégué de la société.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'il est l’associé unique actuel de la société à responsabilité
limitée «AXIS INTERIM» établie et ayant son siège social au 49, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 117338, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, alors notaire de résidence à Remich, en date du 30 mai 2006, publié au mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1608 du 24 août 2006, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis,
et qu’ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de la raison sociale d’«AXIS INTERIM» en «AXIS (Luxembourg)» et modification subséquente de
l’article 4 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La Société prend la dénomination AXIS (Luxembourg).»
2. Modification de l’objet social afin de lui ajouter un deuxième et troisième paragraphes suivants à l’article 2 des statuts:
« Art. 2. Deuxième et troisième paragraphes. La société a également pour objet la prestation à toutes personnes physiques
ou morales, organismes publics ou privés, aux entreprises au sens le plus large, de tous services en vue de la création et/
ou la gestion ainsi que le conseil pour toutes activités de sélection, recrutement, évaluation et formation du personnel
concernant tout emploi à titre définitif, ainsi que toutes opérations d’assistance ou de sous-traitance, tant techniques qu’ad-
ministratives, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.
La société peut faire toutes opérations se rapportant à son objet ou de nature à le développer ou é faciliter sa réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement,
dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, au Luxembourg ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou
connexe au sien. Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acception la plus large.»
3. Divers.
Et ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier la raison sociale d’«AXIS INTERIM» en «AXIS (Luxembourg)» et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La Société prend la dénomination AXIS (Luxembourg).»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’objet social afin de lui ajouter un deuxième et troisième paragraphes suivants à
l’article 2 des statuts:
« Art. 2. Deuxième et troisième paragraphes. La société a également pour objet la prestation à toutes personnes physiques
ou morales, organismes publics ou privés, aux entreprises au sens le plus large, de tous services en vue de la création et/
ou la gestion ainsi que le conseil pour toutes activités de sélection, recrutement, évaluation et formation du personnel
concernant tout emploi à titre définitif, ainsi que toutes opérations d’assistance ou de sous-traitance, tant techniques qu’ad-
ministratives, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.
La société peut faire toutes opérations se rapportant à son objet ou de nature à le développer ou à faciliter sa réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement,
dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, au Luxembourg ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou
connexe au sien. Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acception la plus large.»
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentaire a rendu attentive le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la Société pré-
sentement modifié, celui-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille trois cents euros (EUR
1.300,-) et l’associé s'y engage personnellement.
DONT ACTE, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: C. Velge et M. Schaeffer.
95889
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 2 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/9309. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016104675/71.
(160077093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Bakery Technology 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 180.571.
In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth of April.
Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the single partner of Bakery Technology 1., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée unipersonelle) organised under the laws of Luxembourg with its registered office
at L-7610 Larochette, 18, Place Bleech, registered with the Trade and Companies Register under number B 180571. The
Company was incorporated on the 18
th
of September 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed was
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2875 of November 15, 2013.
There appeared:
Sarabel Bakery Investments S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 50, rue Charles Martel, 1
st
floor, 2134 Luxembourg, RCS Luxembourg 180570, (the Single Partner),
hereby represented by Mr Rob Kemmerling, residing professionally at 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed and will be filed along with such deed with the registration
authorities.
The Single Partner, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Single Partner owns all the 12,500 shares having a nominal value of EUR 1.- each in the share capital of the
Company;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1) To accept the resignation of Andreas Management Services S.à r.l. as “Gérant A” of the Company and give full
discharge for its duties and functions.
2) To accept the resignation of Mr. B.L.M. Schreuders as “Gérant A” of the Company and give full discharge for his
duties and functions.
3) To accept the resignation of Mr. W.A. Blijdorp as “Gérant B” of the Company and give full discharge for his duties
and functions.
4) To appoint Mr Rob Kemmerling as ‘Gérant A’
5) To appoint Claude Zimmer as ‘Gérant A’.
6) To appoint the company LuxGlobal Management S.à r.l., having its registered office at L-2134 Luxembourg, 50, rue
Charles Martel, registered with the Trade and Companies’ Register under the number B 159.893 as “Gérant B”.
7) To change the corporate seat and registered address to 50, rue Charles Martel, 1
st
floor, 2134 Luxembourg
III. that the Single Partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Single Partner accepts the resignation of Andreas Management Services S.à r.l. as “Gérant A” of the Company and
grants full discharge for its duties and functions.
<i>Second resolutioni>
The Single Partner accepts the resignation of Mr. Bastiaan Lodewijk Melchior Schreuders as “Gérant A” of the Company
and grants full discharge for his duties and functions.
95890
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Single Partner accepts the resignation of Mr. Willem Adriaan Blijdorp as “Gérant B” of the Company and grants
full discharge for his duties and functions.
<i>Fourth resolutioni>
The Single Partner resolves to appoint as “Gérant A” for an unlimited duration:
Mr Rob Kemmerling, born at Heerlen (The Netherlands) on 22 March 1965 residing professionally at 50, rue Charles
Martel L-2134 Luxembourg
<i>Fifth resolutioni>
The Single Partner resolves to appoint as “Gérant A” for an unlimited duration:
Mr Claude Zimmer, born at Luxembourg on 18 July 1956 residing professionally at 50, rue Charles Martel L-2134
Luxembourg.
<i>Sixth resolutioni>
The Single Partner resolves to appoint as “Gérant B” for an unlimited duration:
The company LuxGlobal Management S.à r.l.”, having its registered office at L-213 Luxembourg, 50, rue Charles
Martel, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 159893.
<i>Seventh resolutioni>
The Single Partner resolves to change the corporate seat and registered address to 50, rue Charles Martel, 1
st
floor, 2134
Luxembourg.
Article 2.1. of the Articles of Incorporation is therefore amended as follows:
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us,
the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Bakery Technology 1, une société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-7610 Larochette, 18, Place Bleech,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180571. La Société a été
constituée le 18 septembre 2013, en vertu d’un acte du notaire soussigné, publié au numéro 2875 du Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C en date du 15 novembre 2013.
A comparu:
Sarabel Bakery Investments S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 50, rue Charles Martel, 1
st
floor, 2134 Luxembourg, RCS Luxembourg 180570, (l'Associé Unique),
ici représentée par Monsieur Rob Kemmerling, avec adresse professionnelle à 50, rue Charles Martel L-2134 Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient la totalité des 12.500 parts sociales du capital social de la Société, chaque part ayant une
valeur nominale de EUR 1.-II. que l'ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1) Acceptation de la démission de Andreas Management Services S.à r.l. comme «Gérant A» de la Société et décharge
pour l’exécution de ses devoirs et fonctions.
2) Acceptation de la démission de M. B.L.M. Schreuders comme «Gérant A» de la Société et décharge pour l’exécution
de ses devoirs et fonctions.
3) Acceptation de la démission de M. W.A. Blijdorp comme «Gérant B» de la Société et décharge pour l’exécution de
ses devoirs et fonctions.
95891
L
U X E M B O U R G
4) Nomination de Monsieur Rob Kemmerling comme «Gérant A».
5) Nomination de Claude Zimmer comme «Gérant A».
6) Nomination de la société LuxGlobal Management S.à r.l., ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue
Charles Martel, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 159.893 comme «Gérant B».
7) Transfert du siège social au 50, rue Chartel Martel, 1
er
étage, 2134 Luxembourg.
III. que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique accepte la démission de Andreas Management Services S.à r.l. comme «Gérant A» de la Société et
lui donne décharge pour l’exécution de ses devoirs et fonctions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé unique accepte la démission de M. Bastiaan Lodewijk Melchior Schreuders comme «Gérant A» de la Société
et lui donne décharge pour l’exécution de ses devoirs et fonctions.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé unique accepte la démission de M. Willem Adriaan Blijdorp comme «Gérant B» de la Société et lui décharge
pour l’exécution de ses devoirs et fonctions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé unique décide de nommer Monsieur Rob Kemmerling, né à Heerlen (Pays-Bas) le 22 Mars 1965 avec adresse
professionnelle à 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg comme «Gérant A» pour une durée indéterminée.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé unique décide de nommer Monsieur Claude Zimmer, né à Luxembourg le 18 Juillet 1956 avec adresse
professionnelle à 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg comme «Gérant A» pour une durée indéterminée.
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé unique décide de nommer LuxGlobal Management S.à r.l., ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 50,
rue Charles Martel, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 159.893 comme «Gérant B» pour
une durée indéterminée.
<i>Septième résolutioni>
L’Associé unique décide de transférer le siège social au 50, rue Charles Martel, 1
er
étage, à L-2134 Luxembourg et de
modifier en conséquence l’article 2.1. des statuts comme suit:
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Le notaire soussigné, lequel comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: R. KEMMERLING et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/13670. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Référence de publication: 2016104677/140.
(160076207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
95892
L
U X E M B O U R G
CNA Trading Appliances Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 158.915.
RECTIFICATIF
La présente mention remplace la première version déposée le 13 octobre 2015 L150185388 auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés Luxembourg.
Les bilans au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016104775/15.
(160077196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Compagnie Financière de la Sûre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 59.512.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016104776/10.
(160077176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Cork Quality Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 105.027.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2016104780/14.
(160076204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Cornaline Letzebuerg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6670 Mertert, 52A, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 76.032.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsräte abgehalten am 14. Januar 2016 um 14.50 Uhri>
Der Verwaltungsrat beschlieBt, das Mandat des Depositars FIDUCIAIRE MOSELLAN Sarl., eingetragen im Handels-
register Luxemburg unter der Nummer B120014 mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, mit heutigem Datum aufzuheben.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016104781/12.
(160076366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
95893
L
U X E M B O U R G
Dundeal (International) 33 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 201.563.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son
adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec
effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal (International) 33 S.à r.l.
Référence de publication: 2016104794/14.
(160076423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Croix Realty S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2267 Luxembourg, 4, rue d'Orange.
R.C.S. Luxembourg B 164.236.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique datées du 2 mai 2016i>
En date du 2 mai 2016, l'actionnaire unique de la Société a décidé de renouveler te mandat du commissaire aux comptes
Audiex S.A., ayant son siège social à 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B65.469,
jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires chargée d'approuver les comptes annuels de la Société
au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016104784/18.
(160077062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Datacenter Development, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 138.526.
Aus den Beschlüssen des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 3. Mai 2016 geht hervor, dass:
1. das Mandat von Frau Jacqueline Wacker als Verwaltungsratsmitglied (administrateur) der Gesellschaft mit Wirkung
zum 3. Mai 2016 per Rücktritt beendet wurde; und dass
1. Herr Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren am 21. Dezember 1967 in München, Deutschland, geschäftlich ansässig in
25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, mit Wirkung zum 3. Mai 2016 auf unbestimmte Zeit als Verwaltungsrats-
mitglied ernannt wird; und dass
2. der Verwaltungsrat mit Wirkung zum 3. Mai 2016 folgendermaßen zusammengesetzt ist:
- Herr Adam Tamburini
- Herr Horst Baumann, und
- Herr Dr Bernhard Engelbrecht.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 9. Mai 2016.
<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2016104803/21.
(160077092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
95894
L
U X E M B O U R G
Diarough Management, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 170.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 119.881.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 23 octobre 2015i>
Le mandat de la société RSM Audit Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.621, en tant que réviseur
d'entreprises agréé a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié conforme
Référence de publication: 2016104790/14.
(160077033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Daregon Financial Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 110.359.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 Avril 2016i>
L’Assemblée Générale accepte, avec effet au 31 Août 2015, la démission d’un administrateur, à savoir:
- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-
nellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
L’Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer un administrateur, à savoir:
- Madame Emilie GALLAIS, administrateur, né le 3 Mai 1978 à Coutances (France), domicilié professionnellement au
50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016104802/17.
(160076215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
DAWID S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 2, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 146.301.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérancei>
Référence de publication: 2016104804/10.
(160076772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Eco-Business Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 193.523.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 25 avril 2016 à 14 heures dans les locaux dei>
<i>Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourgi>
L'Assemblée a approuvé l'élection de Monsieur Vitalis Ritter, résident professionnellement, 5-9. Palmengartenstrasse
D-60325 Frankfurt am Main en tant qu'Administrateur de la Société jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se tiendra
en 2020.
L'Assemblée a approuvé la ré-élection des Auditeurs Ernst & Young, 35E avenue John F. Kennedy, Luxembourg, L-1855
Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprise pour l'année débutant le 1
er
janvier 2016 jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur les comptes annuels se terminant le 31 décembre 2016.
95895
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 2 mai 2016.
<i>Pour le compte de Eco-Business Fund S.A., SICAV-SIF
i>Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, Luxembourg Branch
Référence de publication: 2016104834/20.
(160076429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Egon Zehnder Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 32.207.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2016i>
- Suite à la démission de Madame Aline Huvelle en tant que commissaire aux comptes de la Société en date du 1
er
mai
2016, les actionnaires ont décidé de nommer FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg comme commissaire aux comptes de la Société. Ce mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 octobre 2016.
- Suite à la démission de Damien O'Brien et Egon Zehnder Finanz AG en tant qu'Administrateurs de la Société avec
effet rétroactif au 1
er
novembre 2015, les actionnaires ont décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'Adminis-
trateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuvant les comptes au 31 octobre 2016:
* Monsieur Karsten De Clerck, né le 27 août 1964 à Anvers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 14, Avenue
Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles (Belgique);
* Monsieur Joost MAES, né le 17 septembre 1960 à Zwevegem (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 14,
Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles (Belgique).
- Les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de Egon Zehnder Associates International NV en tant que qu'Ad-
ministrateur avec effet rétroactif au 1
er
novembre 2015 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuvant les
comptes au 31 octobre 2016.
- Les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Karsten De Clerck en tant que Président du Conseil d'Administration
jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuvant les comptes au 31 octobre 2016.
- Les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Karsten De Clerckdélégué à la gestion journalière de la Société
jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuvant les comptes au 31 octobre 2016.
- Les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Karsten De Clerck en tant que représentant permanent de Egon
Zehnder Associates International NV jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuvant les comptes au 31 oc-
tobre 2016.
Référence de publication: 2016104838/29.
(160076721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Euro Gaming Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 138.216.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 27 avril 2016 que:
- Les administrateurs suivants ont démissionnés de leur mandat, avec effet au 27 avril 2016:
* Madame Candice De Boni, administrateur de catégorie A et Président du conseil;
* Madame Carla Maria Alves Silva, administrateur de catégorie A;
* Monsieur Flavio Marzona, administrateur de catégorie A.
- Monsieur Guillaume Fonquernie, né le 1
er
février 1973 à Enghien Les Bains (France), ayant pour adresse le 90, avenue
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine (France), agissant en tant qu'administrateur de catégorie C, a été nommé
administrateur de catégorie A, avec effet au 27 avril 2016.
Le conseil d'administration est désormais composé de:
- Monsieur Guillaume Fonquernie, administrateur de catégorie A;
- Monsieur Pierre Charles Alain Blum, administrateur de catégorie C.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
95896
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 9 mai 2016.
<i>Pour Euro Gaming Investment S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016104845/23.
(160076981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Eurydome S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 205.836.
<i>I. Transfert de partsi>
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 29 avril 2016, que l'associé unique de la Société,
AIM Services S.à r.l., a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:
- ICG Europe Fund VI Lux SCS, une société en commandite simple, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 6D, route de Trêves, L-2633 Senningerberg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B205117.
En conséquence, la totalité des 12.500 parts sociales de la Société sont désormais détenues par le nouvel associé unique
de la Société, ICG Europe Fund VI Lux SCS.
<i>II. Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 avril 2016i>
En date du 29 avril 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Monsieur Olivier HAMOU en tant que gérant de la Société avec effet au
29 avril 2016;
- de nommer Monsieur Ronan CARROLL, né le 11 novembre 1971 à Dublin, Irlande, ayant l'adresse professionnelle
suivante: 6D, route de Trêves, L-2633 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 29 avril 2016
et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Paul BROGAN, né le 21 juin 1981 à Dublin, Irlande, ayant l'adresse professionnelle suivante:
6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 29 avril 2016 et ce pour
une durée indéterminée;
- de nommer Madame Constanze SCHMIDT, née le 8 novembre 1976 à Gardelegen, Allemagne, ayant l'adresse pro-
fessionnelle suivante: 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au
29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
* Monsieur Ronan CARROLL
* Monsieur Paul BROGAN
* Madame Constanze SCHMIDT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2016.
Eurydome S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016104848/37.
(160076375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Akros Global Opportunities S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé,
(anc. Eastern Opportunities S.A., SICAV-FIS).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 141.101.
In the year two thousand sixteen, on the twenty-ninth day of April.
Before Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “EASTERN OPPORTUNITIES S.A., SICAV-FIS”, a company
in the form of a Luxembourg public limited company (société anonyme) with variable capital, qualifying as a société
d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SICAV-FIS), registered with the Registrar of Com-
95897
L
U X E M B O U R G
panies of Luxembourg (“RCS”) under the number B 141.101, constituted by a deed of Maître Paul DECKER, then notary
residing in Luxembourg, on 28 July 2008, published in the Mémorial, Recueil C, number 2233 of 12 September 2008,
published in the Mémorial C on the 12 September 2008 under number 2233 (the “Fund”), having its registered office in 2,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The articles of association have not been
amended since the incorporation of the company.
The meeting was opened with Mrs. Caroline RAMIER, private employee, professionally residing in Luxembourg, in
the chair.
The chairman/woman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs. Claudia ROUCKERT, private
employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman/woman requested the notary to act:
- that the shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list
attached to these minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and the
members of the board of the general meeting of shareholders.
- that the meeting has been convened at this date and time by convening notice sent to each shareholder by registered
letter on 16
th
March 2016 A copy of such convening notices has been given to the board of the meeting;
- that the agenda of the present meeting is the following:
* Acknowledgement and acceptance of change of name of the Company from:
(i) “EASTERN OPPORTUNITIES S.A., SICAV-FIS”; to
(ii) “AKROS GLOBAL OPPORTUNITIES S.A., SICAV-FIS”; and
* subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation.
I. That as per the provisions of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") and applicable laws, the
quorum required for this meeting is at least one half of the capital and resolutions on the items on the agenda have to be
adopted by an affirmative vote of two third of the votes cast.
II. That it appears from the attendance list, that all (100%) of the 12,716.34 issued shares, representing the entirety of
the share capital of the Company are present or duly represented at the Meeting. The meeting is therefore regularly con-
stituted and can validly deliberate and decide on the afore cited agenda of the meeting of which the shareholders have been
informed before the meeting. The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties
will also remain annexed to the present deed, representing 100% of the issued shares, at the present extraordinary general
meeting and that, seen the agenda and the prescriptions of article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies.
III. After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The meeting of shareholders acknowledges and accepts the change of name of the Company from:
(i) EASTERN OPPORTUNITIES S.A., SICAV-FIS; to
(ii) Akros Global Opportunities S.A., SICAV-FIS.
<i>Second resolutioni>
The Meeting of Shareholders resolves to amend article 1 of the Articles of Incorporation of the Company, which will
henceforth read as follows:
“ Art. 1. Name and form. There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares in
the future, a company in the form of a public limited company (société anonyme) qualifying as a société d'investissement
à capital variable - fonds d'investissement spécialisé under the name of “Akros Global Opportunities S.A., SICAV-
FIS" (hereinafter the "Company").“
There being no further business on the agenda, the chairman/woman thereupon closed the Meeting.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known by the notary by their names, surnames,
civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.
Signé: C. Ramier, C. Rouckert, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 mai 2016. Relation: EAC/2016/10481. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
95898
L
U X E M B O U R G
Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016104849/67.
(160076274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
A.R.S. Groupe S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 94.473.
L’an deux mille seize, le vingt-et-un avril.
Par devant nous Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch,
S’est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois «A.R.S. GROUPE
S.A.», une société anonyme (ci-après, la «Société») ayant son siège social à L-9647 Doncols, 25, Bohey, constituée suivant
acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 6
octobre 1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 283 du 24 novembre 1983.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN,
notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 7 novembre 1994, publié au Mémorial C. Recueil des Sociétés et des Asso-
ciations n°54 de 1995,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.473.
L’assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur René SCHMIT domicilié à L-9647 DON-
COLS, Bohey 23,
,qui se désigne également comme scrutateur.
L’assemblée choisit comme secrétaire Monsieur Arthur SCHMIT domicilié à L-9647 DONCOLS, Bohey 19
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. La Société a un capital social actuel de trente-et-un mille euros (31.000,-EUR) représenté par mille deux cent cinquante
actions (1.250) sans désignation de valeur nominale.
II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont portés sur une liste de présence;
laquelle liste de présence, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire des actionnaires représentés, les membres
du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable ainsi que:
- du projet commun de fusion déposé au registre de commerce et des sociétés en date du 29 janvier 2016 et publié en
date du 4 février 2016;
- des comptes annuels de chacune des trois sociétés ainsi que des rapports de gestion des trois derniers exercices;
- du rapport du réviseur d’entreprises en application des articles 32-1 et 26-1§2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée;
Et ce dans les délais impartis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915
IV. L’ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.Examen et approbation du projet commun de fusion des sociétés «A.R.S. IMMOBILIERE S.A.», société anonyme,
ayant son siège social à L-9647 Doncols, 25, Bohey, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 93.926 (la «Société Absorbante»), et «MAZOUT BERENS S.A.», société anonyme, ayant son siège social à
L-9647 Doncols, 36, Bohey, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.208
et «ARS GROUPE S.A.», société anonyme, ayant son siège social à L9647 Doncols, 25, Bohey», inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.473 (les «Sociétés Absorbées») et des autres documents
prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915;
2. Décision de fusionner les sociétés «A.R.S. IMMOBILIERE S.A.», société anonyme, prénommée, et «MAZOUT
BERENS S.A.», société anonyme, prénommée, et A.R.S. GROUPE S.A., société anonyme, prénommée, par voie d’ab-
sorption de ces deux dernières sociétés par «A.R.S. IMMOBILIERE S.A.», société anonyme, prénommée, étant entendu
que cette fusion s’opérera sur la base de la situation comptable des sociétés au 31 octobre 2015, mais qu’elle ne deviendra
effective qu’à la date de la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires, sans préjudice de l'application de
l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les effets de la fusion par rapport aux tiers;
95899
L
U X E M B O U R G
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu’au jour de la
présente assemblée;
4. Formalité de la radiation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et détermination du lieu de conser-
vation des documents de notre Société pendant le délai légal;
5. Constatation de la réalisation de la fusion à la date de l'assemblée générale des actionnaires de la société approuvant
la fusion;
6. Divers
V. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer vala-
blement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
VI. Les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée relatives aux fusions ont
été respectées, à savoir:
- Publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, n° 294, le 4 février 2016, du projet commun de fusion
établis par les trois conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, soit un (1) mois au moins avant la réunion des
assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion;
- Mise à disposition des actionnaires un mois au moins avant la date de la présente assemblée générale du projet commun
de fusion et des comptes annuels ainsi que des rapports de gestion des années 2012, 2013 et 2014 conformément à l'article
267§1 de la loi du 10 août 1915;
- Renonciation par tous les actionnaires aux rapports des organes d’administration conformément à l'article 265§3 et à
l'examen du projet commun de fusion et au rapport d’expert conformément à l'article 266 §5 de la loi du 10 août 1915;
- Etablissement d’un rapport par un réviseur d’entreprise agréé relatif à l'apport en nature de tous les actifs et passifs
des sociétés absorbées à la société absorbante conformément à l'article 26-1§2 de la loi du 10 août 1915
L’assemblée générale, après délibération, a pris, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’Assemblée Générale, après avoir examiné le projet de fusion des sociétés «A.R.S. IMMOBILIERE S.A.», ayant son
siège social à L-9647 Doncols, 25, Bohey, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 93.926 (la «Société Absorbante»), «MAZOUT BERENS S.A.», ayant son siège social à L-9647 Doncols, 36, Bohey,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.208 et «A.R.S. GROUPE S.A.»,
ayant son siège social à L-9647 Doncols, 25, Bohey, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 94.473 (les «Sociétés Absorbées»), et les autres documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915,
approuve le projet de fusion en toute sa forme et teneur.
Conformément à l'article 26-1§2 de la loi du 10 août 1915, l'apport en nature dans le chef de la Société Absorbante a
fait l'objet d’un examen de FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. avec siège social à L-1470 Luxembourg, 7, route
d’Esch, avec le numéro du Registre du Commerce et des Sociétés B 34.813 représentée plus particulièrement par Monsieur
Alain KOHNEN.
Le rapport du réviseur d’entreprises conclut comme suit:
«L’apport en nature sur l'acceptation duquel vous êtes amenés à vous prononcer en augmentation de capital de la Société
consiste en l'universalité des actifs et passifs des sociétés MAZOUT BERENS S.A. et A.R.S. GROUPE S.A. tels que décrits
dans le paragraphe 3.1 ci-avant.
Cette opération a fait l'objet des vérifications en conformité avec les recommandations de l'Institut des Réviseurs d’en-
treprises ainsi que de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), tant en ce qui concerne la situation de
propriété et des charges éventuelles, que de l'existence, la description et l'évaluation des apports.
Les universalités d’actifs et de passifs des sociétés MAZOUT BERENS S.A. et A.R.S. GROUPE S.A. ont été valorisés
à leur valeur comptable nette telle qu’elle ressort des livres comptables des sociétés au 31 octobre 2015 pour s’établir
respectivement à 1.226.891,61 EUR et 5.830.556,16 EUR tel que décrit dans le paragraphe 3.2.
Ces apports seront rémunérés par la création de 31.279 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les
mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
En conclusion de nos travaux et sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à
penser que la valeur globale des apports, valorisés à 7.057.447,77 EUR, ne correspond pas au moins au nombre et à la
valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
Le présent rapport est rédigé en application des articles 266-5, 26-1 et 32-1 § 5 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur
les Sociétés Commerciales, dans le cadre des présents apports en nature en augmentation de capital de la Société. Il ne
pourra servir, en tout ou en partie, à d’autres fins.»
Le rapport restera annexé au présent acte, après avoir été signé «ne varietur» par les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné.
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée décide de la fusion des sociétés «A.R.S. IMMOBILIERE S.A.», prénommée, et «MAZOUT BERENS
S.A.», prénommée, et «A.R.S. GROUPE S.A.», prénommée, par voie d’absorption de ces deux dernières par «A.R.S.
95900
L
U X E M B O U R G
IMMOBILIERE S.A.», prénommée, étant entendu que cette fusion est faite de manière à ce que toute la situation active
et passive des Sociétés Absorbées, sur base de la situation comptable de la société au 31 octobre 2015 soit transférée à la
Société Absorbante par voie d’apport à la date de la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires.
Les opérations des Sociétés Absorbées sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte
de la Société Absorbante à partir du 1
er
janvier 2016.
L'assemblée constate qu'à la suite de la décision de fusion ci-dessus actée ainsi que des décisions concordantes prises
par les assemblées générales extraordinaire des Sociétés Absorbées antérieurement aux présentes, la fusion telle que décrite
ci- avant se trouve ainsi réalisée et entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:
- la transmission universelle, tant entre les Sociétés Absorbées et la Société Absorbante qu’à l'égard des tiers, de l'en-
semble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées;
- les actionnaires des Sociétés Absorbées deviennent actionnaires de la Société Absorbante;
- les Sociétés Absorbées cessent d’exister.
<i>Troisième résolution:i>
L’Assemblée décide d’octroyer pleine et entière décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exer-
cice de leur mandat jusqu’au jour de la présente assemblée.
<i>Quatrième résolution:i>
L’Assemblée constate que la fusion ne sera réalisée que lorsqu'une décision concordante aura été prise par les action-
naires de «A.R.S. IMMOBILIERE S.A.», prénommée, et «MAZOUT BERENS S.A.», prénommée.
<i>Cinquième résolution:i>
L’Assemblée décide que tous les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés pendant le délai légal au
siège social de la Société Absorbante sis à L-9647 Doncols, 25, Bohey et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une
exécution des présentes pour requérir la radiation de l'inscription des Sociétés Absorbées, la dissolution sans liquidation
étant achevée.
<i>Sixième résolution:i>
L’Assemblée ayant pris connaissance des documents suivants et constatant que toutes les formalités légales ont été
accomplies, décide d’accepter le projet et de constater expressément la réalisation de la fusion à la date de tenue de l'as-
semblée générale des actionnaires de la Société Absorbante approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article
273 de la loi du 10 août 1915 sur les effets de la fusion par rapport aux tiers et sous la seule réserve de l'approbation de la
fusion par la Société Absorbante et par l'autre société absorbée «MAZOUT BERENS S.A.».
<i>Constatationi>
La société «ARS GROUPE S.A.», possède différents immeubles qui sont plus amplement désignés dans l'acte de la
société «A.R.S. IMMOBILIERE S.A.», reçu par le notaire instrumentaire ce jour.
<i>Constatation:i>
Le notaire instrumentant, conformément à l'article 271 (2) de la loi du 10 août 1915, atteste par les présentes l'existence
et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et du projet de fusion.
Plus rien n’étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée à dix heures.
<i>Fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente fusion à environ huit cents euros
(800,-.EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Doncols, date qu’en tête Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux com-
parants et aux membres du bureau connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Schmit R., Schmit A., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Diekirch, le 27 avril 2016. Relation: DAC/2016/6074. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.
Diekirch, le 9 avril 2016.
Référence de publication: 2016104609/158.
(160077348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
95901
L
U X E M B O U R G
Balansys, Société Anonyme.
Siège social: L-1248 Luxembourg, 59-61, rue de Bouillon.
R.C.S. Luxembourg B 196.896.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016100854/9.
(160072454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
Baltiman S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 108.946.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016100856/9.
(160071951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
Human Capital Focus, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5314 Contern, 40, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 89.770.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016101127/9.
(160071661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
3M Global Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 110.189.
<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> mai 2016i>
En date du 1
er
mai 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
Prend acte de la démission de:
- Madame Sarah Grauze, en tant que gérant de classe B, avec effet au 30 avril 2016;
- Monsieur Olivier Hermann, en tant que gérant de classe B, avec effet au 30 avril 2016.
De nommer la personne suivante:
- Monsieur Jed Davidson Larkin, né le 6 août 1970 à Iowa, États-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 3M
Center, Building 224-5N-40, 55144-1000 St. Paul, Minnesota, États-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de classe
B de la Société avec effet au 1
er
mai 2016 et pour une durée indéterminée,
Depuis le 1
er
mai 2016, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
<i>Gérants de classe A:i>
Monsieur Philippe van den Avenne
Mme Scarlett Meadows
Gérants de c <i>li> asse B:
Monsieur Matthew James Ginter
Monsieur Jed Davidson Larkin
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016106488/27.
(160078181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
95902
L
U X E M B O U R G
Investment Select Fund Sicav-SIF, Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 114.322.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016101165/9.
(160072347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
Julie s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3440 Dudelange, 76, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.968.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016101170/9.
(160072111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
Kase World Wide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 173.394.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2677 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016101176/9.
(160072419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
LUXLAIT Distribution S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7759 Roost,
R.C.S. Luxembourg B 106.768.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mars 2016i>
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2016:
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats de Monsieur John RENNEL (Administrateur) de Monsieur Camille THIRIFAY (Administrateur) et de
Monsieur Claude STEINMETZ (Président du conseil d'administration, Administrateur, Administrateur-délégué,) demeu-
rent inchangés.
Chacun de ces mandats prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2018. Le mandat d'administrateur
de Monsieur Marion DIDIER prend fin à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Marc REINERS (né le 30.04.1969 à Clervaux demeurant Maison 10, L-9770 Rumlange) est nommé en qualité
d'Administrateur. A l'instar des mandats de Monsieur John RENNEL, de Monsieur Camille THIRIFAY et de Monsieur
Claude STEINMETZ, le mandat d'administrateur de Monsieur Marc REINERS prendra fin à l'issue de l'Assemblée Gé-
nérale Ordinaire de l'an 2018.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée désigne la société Audit and Trust Services S.à.r.l., immatriculée au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro B 169138, sise 6 Jos Seylerstrooss, L-8522 Beckerich, représentée par Madame Zoé MAKA, comme
réviseur d'entreprises associée pour l'exercice de l'année 2016.
Son mandat prendra ainsi fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2017.
<i>Pour LUXLAIT DISTRIBUTION
i>Claude STEINMETZ
<i>Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2016106942/27.
(160078722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
95903
L
U X E M B O U R G
Multi Stars Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.371.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016101308/9.
(160071615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
Négoce Company and International Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 170.013.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016101310/9.
(160071934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
Négoce Company and International Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 170.013.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016101311/9.
(160071984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.
Luxlait Développement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7759 Roost,
R.C.S. Luxembourg B 62.101.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mars 2016i>
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2016:
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats de Monsieur John RENNEL (Administrateur, Président du conseil d'administration) de Monsieur Camille
THIRIFAY (Administrateur) et de Monsieur Claude STEINMETZ (Administrateur, Administrateur-délégué) demeurent
inchangés.
Chacun de ces mandats prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2018. Le mandat d'administrateur
de Monsieur Marion DIDIER prend fin à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Marc REINERS (né le 30 avril 1969 à Clervaux, demeurant Maison 10 L-9770 Rumlange) est nommé en
qualité d'Administrateur. A l'instar des mandats de Monsieur John RENNEL, de Monsieur Camille THIRIFAY et de
Monsieur Claude STEINMETZ, le mandat d'administrateur de Monsieur Marc REINERS prendra fin à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire de l'an 2018.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée désigne la société Audit and Trust Services S.à.r.l., immatriculée au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro B 169138, sise 6 Jos Seylerstrooss, L-8522 Beckerich, représentée par Madame Zoé MAKA, comme
réviseur d'entreprises associée pour l'exercice de l'année 2016.
Son mandat prendra ainsi fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2017.
<i>Pour LUXLAIT DEVELOPPEMENT
i>Claude STEINMETZ
<i>Administrateur / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2016106943/27.
(160078721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
95904
3M Global Capital S.à r.l.
Advent Power (Luxembourg) MEP S.à r.l.
Advent Power (Luxembourg) Subco S.à r.l.
Akros Global Opportunities S.A., SICAV-FIS
A.R.S. Groupe S.A.
Atlantik S.A.
AXA Mezzanine I S.A., SICAR
AXA Private Debt II S.A., SICAR
AXA Private Debt II S.A., SICAR
Axis Interim
AXIS (Luxembourg)
Baie de Greco Holding S.A.
Bakery Technology 1
Balansys
Baltiman S.A.
Barbat S.A.
BBGI SICAV S.A.
Beltone MidCap Management S.A.
Benelux Mezzanine 5 S.à r.l.
BNP Paribas A Fund
Bobati S.à r.l.
Borea Holding S.à r.l.
B.S. Diffusion S.à r.l.
Buwog Lux I S.à r.l.
Cablinvest II S.à r.l.
Calypso Holding S.à r.l.
Calypso Investment S.à r.l.
CNA Trading Appliances Limited
Coca-Cola Enterprises Luxembourg
Compagnie Financière de la Sûre S.A.
Cork Quality Services S.A.
Cornaline Letzebuerg S.A.
Croix Realty S.A.
Daregon Financial Services S.A.
Datacenter Development
DAWID S.à r.l.
Diarough Management
Dundeal (International) 33 S.à r.l.
Eastern Opportunities S.A., SICAV-FIS
Eco-Business Fund S.A., SICAV-SIF
Egon Zehnder Luxembourg S.A.
Euro Gaming Investment S.A.
Eurydome S.à r.l.
Human Capital Focus
Intelligent Commerce Group S.à r.l.
Investment Select Fund Sicav-SIF
Julie s.àr.l.
Kase World Wide S.à r.l.
Luxlait Développement S.A.
LUXLAIT Distribution S.A.
Multi Stars Sicav
Négoce Company and International Services S.A.
Négoce Company and International Services S.A.
UBS (Lux) Institutional Sicav II
Volpi Capital Master Lux S.à r.l.