logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 841

23 mars 2016

SOMMAIRE

AK Conseil & Stratégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40332

Allianz Finance VIII Luxembourg S.A.  . . . . .

40367

Alternative Leaders Investissements S.A.  . . . .

40332

Amphitrite International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

40332

Anaconda S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40332

Antimo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40331

Antoinette LENTZ-SCHLEICH SCI  . . . . . . .

40365

AXL International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40331

AXL Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40331

AZ Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40332

B2 Construction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40330

Capital Dynamics CEI GP S.à r.l.  . . . . . . . . . .

40325

Carpathian Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

40360

Challenger Luxembourg Holding No. 2 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40323

Chephren S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40323

CHIRIAC Engineering S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

40323

Colors Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40323

Conchita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40323

C.R.G. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40330

DB STG Lux 10 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40343

Dehus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40324

DiezTres13ink S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40324

Duckfin International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

40324

East Western S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40325

Elba Group Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

40357

Euromoney Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

40325

European Healthcare Investments S.à r.l.  . . .

40325

EURX Epsilon Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . .

40325

E.V.A.F. Luxembourg (Olympic) S.à r.l.  . . . .

40326

Fame Group Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40322

Fill Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40342

Floow2 International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40363

Followcorp S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40322

F&S Investholding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40322

F&S Investholding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40322

F&S Investholding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40322

Gamma Holdco (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . .

40329

GARAGE BERNARD MUZZOLINI, société

anonyme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40326

Geert Dirkx S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40331

Glentel International Corp.  . . . . . . . . . . . . . . .

40329

Golden Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40326

Greenland S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40326

Guizet Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40326

Henley Trust (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

40331

Holky Investors S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40326

Image Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40327

Kury Kamak Artisanat S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

40327

Lazarus Investments Limited . . . . . . . . . . . . . .

40354

LF Hotels Acquico II (GP) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

40329

Link Logistics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40329

Luxlease S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40327

Makalu S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40327

Marne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40327

MBM LX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40328

Medrom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40328

Medrom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40328

Medrom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40328

Medrom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40328

Medrom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40328

Moore Emerging Markets, (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40327

Nettoyage de Vitres Eko S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

40330

Networking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40331

Networking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40330

PATRIZIA Real Estate 37 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

40329

Secure Capital Financing S. à r. l.  . . . . . . . . . .

40324

Sheet Anchor LuxHoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . .

40324

Sheet Anchor LuxHoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . .

40324

Soverino International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

40330

stesca S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40367

Wow LuxCo 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40333

40321

L

U X E M B O U R G

F&S Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 53.128.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 février 2016.

Référence de publication: 2016063679/10.
(160025199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

F&S Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 53.128.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 février 2016.

Référence de publication: 2016063680/10.
(160025200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

F&S Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 53.128.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 février 2016.

Référence de publication: 2016063681/10.
(160025201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Fame Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 184.559.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016063682/11.
(160025500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Followcorp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 169.888.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/02/2016.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016063686/11.
(160025495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

40322

L

U X E M B O U R G

Challenger Luxembourg Holding No. 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.889.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 Juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2016.

Michaël Watrin
<i>Gérant

Référence de publication: 2016064361/13.
(160026687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Chephren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 92.299.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2016064363/13.
(160025893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

CHIRIAC Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6970 Hostert, 90, rue Andethana.

R.C.S. Luxembourg B 163.171.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016064364/10.
(160026383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Colors Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 181.535.

Le bilan au 30 septembre 2015, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Colors Investment

Référence de publication: 2016064365/11.
(160026735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Conchita S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 38.026.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

40323

L

U X E M B O U R G

CONCHITA S.A.

Référence de publication: 2016064372/10.
(160026342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

DiezTres13ink S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 28, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 162.395.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016064387/10.
(160026007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Secure Capital Financing S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 131.237.

Le Bilan du 1 

er

 Janvier 2014 au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064017/9.
(160025423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Sheet Anchor LuxHoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 177.791.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064018/9.
(160025316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Sheet Anchor LuxHoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 177.791.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064019/9.
(160025317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Dehus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 176.632.

Les comptes annuels au 31 mai 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064399/9.
(160026494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Duckfin International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 99.674.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064406/9.
(160026753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

40324

L

U X E M B O U R G

Capital Dynamics CEI GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 196.083.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064317/9.
(160026135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Euromoney Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 24.520.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 190.757.

Le bilan au 30 septembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Référence de publication: 2016064418/10.
(160026414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

European Healthcare Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.744.700,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 159.484.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Référence de publication: 2016064421/10.
(160026287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

East Western S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 71.282.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AKELYS EUROPEAN SCORE
20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2016064423/12.
(160026371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

EURX Epsilon Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.732.

Les comptes annuels de la société EURX Epsilon Investment S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064443/10.
(160025972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

40325

L

U X E M B O U R G

E.V.A.F. Luxembourg (Olympic) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 128.252.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Nahima BARED / Kailash RAMASSUR.

Référence de publication: 2016064408/10.
(160026655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

GARAGE BERNARD MUZZOLINI, société anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 17.443.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064481/9.
(160026425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Golden Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 61.382.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2016064486/10.
(160026181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Greenland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 123.507.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064492/9.
(160025986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Guizet Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.153.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064495/9.
(160026088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Holky Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.773.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064516/9.
(160026671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

40326

L

U X E M B O U R G

Image Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.237.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Image Management S.A.

Référence de publication: 2016064522/10.
(160026297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Kury Kamak Artisanat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3841 Schifflange, 70, rue de Hédange.

R.C.S. Luxembourg B 98.923.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064575/9.
(160026525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Luxlease S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 74.898.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064611/9.
(160026459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Makalu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue de Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 121.942.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064637/9.
(160026094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Marne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 31.166.

Le Bilan du 1 

er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064639/9.
(160026240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Moore Emerging Markets, (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 175.574.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064633/9.
(160026673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

40327

L

U X E M B O U R G

MBM LX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 190.608.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064643/9.
(160026674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Medrom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.567.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064648/9.
(160026539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Medrom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.567.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064649/9.
(160026540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Medrom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.567.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064650/9.
(160026541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Medrom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.567.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064651/9.
(160026542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Medrom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.567.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064652/9.
(160026543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

40328

L

U X E M B O U R G

Glentel International Corp., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 918.182,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.719.

Les comptes consolidés de Glentel Inc, au 31 décembre 2014 en conformité avec l’article 316 de la loi du 10 août 1915

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2016.

Référence de publication: 2016063710/11.
(160025479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Gamma Holdco (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 160.352.

Les comptes annuels en date du 1 

er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063743/10.
(160025588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

LF Hotels Acquico II (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 175.057.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2016.

M. Robert Kimmels
<i>Gérant

Référence de publication: 2016063847/13.
(160024965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Link Logistics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 45.964.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016063849/10.
(160025010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

PATRIZIA Real Estate 37 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 180.618.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063959/9.
(160025305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

40329

L

U X E M B O U R G

Soverino International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.287.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
SOVERINO INTERNATIONAL S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016063365/12.
(160024756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

B2 Construction, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.910.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-1470 Luxembourg, le 18 décembre 2015.

<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2016063566/11.
(160025264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

C.R.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8313 Capellen, 1A, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 58.493.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063569/9.
(160025587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Nettoyage de Vitres Eko S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3712 Rumelange, 60, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 180.180.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016064688/10.
(160026170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Networking, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.689.

Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Networking

Référence de publication: 2016064689/10.
(160025882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

40330

L

U X E M B O U R G

Networking, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.689.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Networking

Référence de publication: 2016064690/10.
(160025883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Antimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 99.956.

Les comptes annuels au 31 juillet 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 9 février 2016.

Référence de publication: 2016065753/10.
(160027670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Henley Trust (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Geert Dirkx S.à r.l.).

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.533.

Le bilan au 30 septembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2016.

Geert DIRKX
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2016065759/12.
(160028376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

AXL International, Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 59, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 152.256.

Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016065765/10.
(160028595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

AXL Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 154.418.

Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016065766/10.
(160028598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

40331

L

U X E M B O U R G

AZ Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 157.197.

Les comptes annuels au 3 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065767/9.
(160028382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Alternative Leaders Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 90.418.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016065741/10.
(160027831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Amphitrite International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 152.990.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2016.

Référence de publication: 2016065747/10.
(160028676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Anaconda S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 28, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 62.808.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2016.

<i>Pour compte de Anaconda S.A. SPF
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2016065750/12.
(160027773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

AK Conseil &amp; Stratégie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15-17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 179.363.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2016.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2016065735/12.
(160027632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

40332

L

U X E M B O U R G

Wow LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 202.843.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of December.
Before the undersigned, Me Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

KKR WOW Aggregator L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Québec, with its registered office

located at 4000-1155 Boulevard René-Lévesque O, Montréal H3B3V2, Canada, registered with the Registrar of Enterprises
of Québec under number 3371493209,

here represented by Peggy Simon, employee, with professional address in L- 6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of

a power of attorney given under private seal;

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power

of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Wow LuxCo 1 S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

40333

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five

hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance

with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
8.2. All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

8.3. The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

Art. 9. Procedure.
9.1. The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which

in principle shall be in Luxembourg.

9.2. Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

9.3. No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have

full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.

9.4. A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
9.5. The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A manager and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes
signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

40334

L

U X E M B O U R G

9.7. Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

Art. 10. Representation.
10.1. Where the Company has a sole manager, the Company shall be bound towards third parties by the signature of the

latter.

10.2. Where the Company is managed by a board of managers, the Company shall be bound towards third parties in all

matters by the joint signatures of any two (2) managers or, where different classes of managers have been appointed, by
the joint signatures of any class A manager and any class B manager.

10.3. The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 11. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 12. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 13. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
13.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at

a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may

be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions). Written Shareholders Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
13.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from any manager or from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.

The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda

of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to

be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall

bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 14. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is

to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

40335

L

U X E M B O U R G

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 15. Financial year and approval of annual accounts.
15.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
15.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.

15.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
15.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Written Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 16. Auditors.
16.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d’entreprises agréés).

16.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 17. Allocation of profits.
17.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal

Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

17.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

17.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;

and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the

distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund

the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

18.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and  remuneration.  Unless  otherwise  decided  by  the  shareholders,  the  liquidators  shall  have  full  power  to  realise  the
Company’s assets and pay its liabilities.

18.2 The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

19.1 Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

19.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

19.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
original  or  several  counterparts  of  the  same  document,  all  of  which  taken  together  shall  constitute  one  and  the  same
document.

19.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

40336

L

U X E M B O U R G

<i>Transitional provision

The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December

2016.

<i>Subscription and payment

KKR WOW Aggregator L.P., represented as stated above, subscribes for twelve thousand five hundred (12,500) shares

in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in
cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the Company’s disposal and evidence of such

amount has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The  expenses,  costs,  fees  and  charges  of  any  kind  whatsoever  to  be  borne  by  the  Company  in  connection  with  its

incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1.100.-).

<i>Resolutions of the shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to appoint the following persons as managers of the Company for an undetermined

period:

- Stanislas de Joussineau de Tourdonnet, born on June 22, 1981 in Paris, France, with professional address at Stirling

Square, 7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD London, United Kingdom;

-  Richard  Norton,  born  on  December  21,  1986  in  Villeneuve-sur-Lot,  France,  with  professional  address  at  Stirling

Square, 7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD London, United Kingdom;

- Dr. Wolfgang Zettel, born on November 15, 1962 at Konstanz, Germany, with professional address at 61, rue de

Rollingergrund, L-2440 Luxembourg; and

- Stefan Lambert, born on 8 

th

 January 1964 in Trier, Germany, with professional address at 61, rue de Rollingergrund,

L-2440 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed

is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour de décembre,
Par devant le soussigné Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Agrégateur KKR WOW S.E.C., une société en commandite constituée selon le droit du Québec, dont le siège social est

situé au 4000-1155 Boulevard René- Lévesque O, Montréal H3B3V2, Canada et immatriculée au Registraire des entreprises
du Québec sous le numéro 371493209,

représenté par Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration

restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Wow LuxCo 1 S.à r.l." (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

40337

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par

décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de
toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées, ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation
requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments et moyens légaux nécessaires à une gestion efficace

de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) qu’elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

40338

L

U X E M B O U R G

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils composeront le conseil de gérance (le Conseil). Les

associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A
et un ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,

qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe,

sera au Luxembourg.

9.2. Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.

9.3. Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

9.4. Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
9.5. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition
que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou
représentés.

9.6. Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.

9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

Art. 10. Représentation.
(i) Si la Société n’a qu’un gérant unique, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de celui-ci.
(ii) Si la Société est gérée par un conseil de gérance, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances

par les signatures conjointes de deux (2) gérants et, si des gérants de différentes classes ont été nommés, par les signatures
conjointes d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

(iii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 11. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 12. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 13. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
13.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont ad-

optées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si la Société ne compte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être adoptées par

écrit (des Résolutions Écrites des Associés). Les Résolutions Écrites des Associés signées par tous les associés sont valables

40339

L

U X E M B O U R G

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées en Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
13.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus d’un dixième (1/10) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la

date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés.

Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés

de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute

Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au

moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Écrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l’expiration du délai fixé par le Conseil.

Art. 14. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Écrites des Associés est

considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 15. Exercice social et approbation des comptes annuels.
15.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
15.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
gérants et des associés envers la Société.

15.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
15.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés lors de l’Assemblée Générale annuelle ou par voie de

Résolutions Écrites des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice social.

Art. 16. Réviseurs d’entreprises.
16.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas prévus

par la loi.

16.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat qui ne peut dépasser six (6) ans mais peut-être renouvelé.

Art. 17. Affectation des bénéfices.
17.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve

Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

17.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

17.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d’émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant

40340

L

U X E M B O U R G

des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;

(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes

intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les

associés doivent immédiatement reverser l’excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

18.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

18.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

19.1 Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Écrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.

19.2 Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions

du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

19.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visio-conférence et des Résolutions Écrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

19.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le trente-et-un (31) décembre

2016.

<i>Souscription et libération

Agrégateur KKR WOW S.E.C., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, et accepte de les libérer inté-
gralement par un apport en numéraire d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s’élèvent

approximativement à mille cent Euros (EUR 1.100.-).

<i>Résolutions de l’associé

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Stanislas de Joussineau de Tourdonnet, né le 22 juin 1981 à Paris, France, avec adresse professionnelle à Stirling

Square, 7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD Londres, Royaume-Uni;

- Richard Norton, né le 21 décembre 1986 à Villeneuve-sur-Lot, France, avec adresse professionnelle à Stirling Square,

7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD Londres, Royaume-Uni;

- Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Konstanz, Allemagne, avec adresse professionnelle à 61, rue de

Rollingergrund, L-2440 Luxembourg; et

- Stefan Lambert, né le 8 janvier 1964 à Trèves, Allemagne, avec adresse professionnelle à 61, rue de Rollingergrund,

L-2440 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 61, rue de Rollingergrund, L- 2440 Luxembourg.

40341

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante que le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Echternach, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11945. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 06 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004281/494.
(160002820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Fill Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 217, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 145.949.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Francisco Javier FUENTES VALENZUELA, licencié en informatique, né le 27 décembre 1963 à Santiago

au Chili et domicilié au 217, rue de Hamm, L-1713 Luxembourg (ci-après dénommé "l'Actionnaire Unique"),

ici représentée par Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg.

En vertu d'une procuration donnée sous seing privée à Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- la société anonyme "FILL CONSULTING S.à r.l.", ayant son siège social au 217, rue de Hamm, L-1713 Luxembourg,

inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 145.949 (ci-après dénommée "la Société"), fut constituée en date du 28
avril 2009 suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1006 du 14 mai 2009;

- le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune, toutes entièrement libérées;

- l'Actionnaire Unique est le seul propriétaire de la totalité des actions de la Société et déclare expressément procéder à

la dissolution de ladite Société avec effet immédiat;

- l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société et déclare que l'activité de la Société a cessé, que le

passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné ainsi que cela résulte d'un rapport du liquidateur joint en annexe
au présent acte;

- l'Actionnaire Unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister

à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société
est à considérer comme faite et clôturée;

- l'Actionnaire Unique reconnaît avoir pris connaissance et approuvé le bilan de clôture en date de ce jour;
- les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par

la société CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au R.C.S.
Luxembourg sous le numéro B 79327, agissant en tant que commissaire à la dissolution;

- l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au com-

missaire à la dissolution pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour;

- l'Actionnaire Unique donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et

des déclarations fiscales y afférentes;

- le registre des actions de la Société a été annulé;

40342

L

U X E M B O U R G

- les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B
62780.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Koeune et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 6 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/320. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Référence de publication: 2016007491/54.
(160007306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.

DB STG Lux 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 202.837.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen on the twenty-third day of December.
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared

DB Credit Investments S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 2

Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg L1115, Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 114.238;

here represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, residing professionally in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal given on 17 December 2015.
Such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incor-
poration").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "DB STG Lux 10 S.à r.l."

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager

(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the

Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of com-
munications with such office or between such and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect
on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a
company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in

foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favor of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

40343

L

U X E M B O U R G

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well

as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by

the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)

divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, all of which
are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles

of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst

them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but

the shares may be transferred to-

non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several

times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,

suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.

Chapter III. Managers auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The  Managers  will  be  appointed  by  the  shareholder(s),  who  will  determine  their  number  and  the  duration  of  their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or

class B Managers (the "Class B Managers").

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or

useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

40344

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The  Company  will  be  bound  towards  third  parties  by  the  individual  signature  of  the  sole  Manager  or  by  the  joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom

special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present
or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written

notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent
of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding

office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such
quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary

(if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed

by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit
of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager,  associate,  member,  shareholder,  officer  or  employee  of  such  other  company  or  firm.  Any  person  related  as

40345

L

U X E M B O U R G

described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company
is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors
who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the

number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the

Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of
shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 3 

rd

 Tuesday of May in each year at 2.00 p.m..

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the

next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders
are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the
transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the
general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgment
of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a

general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and,
if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of sha-

reholders.

40346

L

U X E M B O U R G

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person

designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending

the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set
for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than
half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders
shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares
represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the

purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall
be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting

of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2)
Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If

the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (1 5) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders.

The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may

be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.

After  payment  of  all  the  debts  of  and  charges  against  the  Company,  including  the  expenses  of  liquidation,  the  net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

40347

L

U X E M B O U R G

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 191 5 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been

subscribed and the nominal value of these shares, has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder

Subscribed

capital

Number

of Shares

Amount

paid-in

DB Credit Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500

12.500

EUR 12.500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500

12.500

EUR 12.500

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal of the

Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for
in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

<i>Transitory Provision

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day

of December of 2016.

<i>Shareholders resolutions

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint

the following for an unlimited duration:

1.  Graeme  James  Jenkins,  employee,  born  on  13  October  1977  in  Glasgow  (U.K.)  with  professional  address  at  2,

boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

2. Nahima Bared, employee, born on 29 December 1977 in Thionville (France), with professional address at 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

3. Laurie Domecq, employee, born on 9 April 1988 in Choisy-Le-Roi (France), with professional address at 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the proxyholder of the appearing party,

the present deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same proxyholder and in
case of divergences between the English and the German texts, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day referred to at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the undersigned notary by surname,

first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

lm Jahre zweitausend und Fünfzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxembourg.

Ist erschienen:

DB Credit Investments S.à r.l., eine nache Luxemburgisch Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in 2 Boulevard Konrad

Adenauer, Luxembourg L1115, Luxembourg, und eingeschrieben beim Handels- und Firmenregister von Luxembourg
unter der Nummer B 114.238,

hiervertreten durch Frau Dr. jur. Khadigea Klingele, senior legal counsel, mit Berufanschrift in Bad-Mondorf,
kraft der unter Privatschrift am 17. Dezember 2015 erteilten Vollmacht.
Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wur-

de, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:

40348

L

U X E M B O U R G

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die "Gesellschaft") gegründet, die den

Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den "Gesetzen") und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die "Sat-
zung") unterliegt.

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren

Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Die Gesellschaft wird unter dem Namen "DB STG Lux 10 S.à r.l." firmieren.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt

Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) entwe-

der  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland  errichtet  werden.  Sollte(n)  die  (der)  Geschäftsführer  oder  die
Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaft-
licher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesell-
schaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle
am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen könnten, so kann die Gesellschaft den Ge-
sellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese
vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welche trotz der vorüber-
gehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den Iuxemburgischen Gesetzen unterliegt. Die genannten vorübergehenden
Maßnahmen sind von der Geschäftsführung zu beschließen und den hiervon betroffenen Dritten mitzuteilen.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von

Beteiligungen in Iuxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Be-
treuung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-

terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche andere bewegliche oder unbewegliche

Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder

ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.

Generell  kann  die  Gesellschaft  jede  kommerzielle,  industrielle  oder  finanzielle  Tätigkeit  ausführen,  welche  für  die

Ausführung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit dem

nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen Mehr-
heiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500), und ist in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR
1) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und

Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf das alle Emissions-

aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten,  zur  Auszahlung  an  den/die  Gesellschafter  in  Form  von  Dividenden  oder  um  Mittel  zur  gesetzlichen  Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.

Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Be-

vollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile

können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.

Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.

Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der

40349

L

U X E M B O U R G

Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser ange-
nommen worden ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-

fenen Beschlüsse mit sich.

Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-

sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Tod, Aussetzung von Bürgerrechten, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die

Handlungsunfähigkeit, der Tod, die Aussetzunq von Bürgerrechten. der Konkurs oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer,
die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer

Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschafter

sein müssen, geführt (die (der) "Geschäftsführer").

Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der "Geschäftsführungsrat") ge-

gründet.

Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats

festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen
Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)

"Geschäftsführer A")) oder als Geschäftsführer B (die (der) "Geschäftsführer B")) zu qualifizieren.

Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,

um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-

prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).

Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle

Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit
bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr

als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, gebunden.

Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben

(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen

gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über die
Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.

Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende

Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der "Vorsitzende"). Er kann auch einen

Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der Ge-
schäftsführung zuständig ist (der "Schriftführer").

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-

rungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit

der Geschäftsführungsrates ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des

Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die
Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungsgemäß
dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort in einem
zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrichtigung er-
forderlich.

40350

L

U X E M B O U R G

Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-

führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-

schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jeder Geschäftsführer kann einen oder
mehrere Geschäftsführer vertreten.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner

amtierenden Mitglieder, wobei im Falle der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäfts-
führer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend oder vertreten sein muss.

Entschlüsse  werden  per  Mehrheitsbescheid  aller  bei  der  Sitzung  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  des  Ge-

schäftsführungsrates gefasst.

Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung

oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen, teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß

einberufenen  und  abgehaltenen  Sitzung  des  Geschäftsführungsrates  gefasst  worden  wäre.  Ein  solcher  Beschluss  kann
festgehalten werden in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.

Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-

weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr
als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.

Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die

(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten.

Darüber hinaus können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur

Verfolgung des Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

Art.  15.  Interessenkonflikte.  Wenn  einer  der  Geschäftsführer  der  Gesellschaft  ein  persönliches  Interesse  an  einem

Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäftsführern
anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.

Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-

schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Marktbe-

dingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder irgend

einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Ge-
schäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder einem solchen Unter-
nehmen  beteiligt  sind  oder  Geschäftsführer,  Gesellschafter,  Bevollmächtigte(r)  oder  Angestellte(r)  einer  solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmen2 sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
einer Gesellschaft oder einem Unternehmen in Beziehung steht, mit der beziehungsweise dem die Gesellschaft vertragliche
Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere
Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung

hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-

lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

40351

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-

schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft der
Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich insbesondere der Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer,
welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

Die  statutarischen  oder  zugelassenen  Wirtschaftsprüfer,  falls  es  solche  gibt,  werden  durch  die  (den)  Gesellschafter

ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und
können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in Fällen,
in denen das Gesetz vorschreibt, dass der zugelassene Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund oder in
gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.

Kapitel IV. Gesellschafter

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz

zustehen.

Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesellschaf-

terversammlung übertragen hat.

Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden

muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am 3. Dienstag im Monat Mai um 14.00
Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-

genden Werktag abgehalten.

Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-

zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden.

Schriftliche Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts

und jeweils von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse
von den Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von
fünfzehn (15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen
und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen.
Die  Bestimmungen  zur  Beschlussfähigkeit  und  den  erforderlichen  Mehrheiten  bei  Beschlüssen  der  Gesellschafterver-
sammlung sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterver-sammlung werden am Gesellschaftssitz ab-

gehalten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können im Ausland abgehalten werden, wenn
Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt, dies erforderlich
machen.

Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die

Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutarischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-

schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über die

Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-

und  Rederecht.  Ein  Gesellschafter  kann  sich  durch  schriftliche  Ermächtigung,  welche  durch  ein  die  Schriftlichkeit
gewährleistendes Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Per-
son, die nicht selbst Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu von

den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafterver-

sammlung anwesend sind, gewählt wird.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-

lung.

40352

L

U X E M B O U R G

Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht einberufen wurde zur Änderung der Satzung oder

zur Fassung von Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unter-
liegen, werden Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsen-
tieren.

Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-

schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der

Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Sat-
zung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse der Mehrheit der Anzahl der
Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-

zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.

Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter

unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls

der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist,
unterzeichnet werden.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von gewinnen

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die

Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr

als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der

gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die "Rücklage"). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-

winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr
vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesell-
schafter ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-

henden  Bestimmungen,  können  die  Geschäftsführer  eine  Abschlagsdividende  an  die  Gesellschafter  auszahlen.  Die
Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst

werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche

oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt wer-
den.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-

quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Gesellschafter so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-

stimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der
zuletzt geltenden Fassung.

40353

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert

Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter

Gezeichnetes

Kapital

Anzahl

der

Anteile

Eingezahlter

Betrag

DB Credit Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500

12.500

EUR 12.500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500

12.500

EUR 12.500

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) stand der Gesellschaft daher von diesem Zeitpunkt an

zur Verfügung. Nachweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Maßgaben von
Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, erfüllt
wurden.

<i>Kosten

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200) geschätzt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2016.

<i>Gesellschafterbeschlüsse

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit

als Geschäftsführer ernannt:

1. Graeme James Jenkins, geboren in Glasgow, Großbritannien, am 13. Oktober 1977, mit Berufsanschrift in 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

2. Nahima Bared, geboren in Thonville, Frankreich, am 29. Dezember 1977, mit Berufsanschrift in 2, boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxembourg;

3. Laurie Domecq, geboren in Choisy-Le-Roi, Frankreich, am 9. April 1988, mit Berufsanschrift in 2, boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag des Vollmachtnehmers

der oben genannten Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag desselben
Vollmachtnehmers und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische
Text.

Worüber Urkunde, Augenommen in Bad-Mondorf, am eingangs erwähnten Datum.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschienenen

Vollmachtnehmerin der oben genannten Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende Urkunde mit dem unter-
zeichnenden Notar, unterzeichnet.

Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 29 décembre 2015. GAC/2015/11814. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2016.

Référence de publication: 2016003636/634.
(160002575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Lazarus Investments Limited, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 182.557.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of November.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

40354

L

U X E M B O U R G

There appeared:

Selected Harvest Limited, a limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with

address at Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and with registration
number being 1770877,

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said power of attorney, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to this deed for registration purposes.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Lazarus Investments S.A., a public limited

liability company (société anonyme) established and existing under Luxembourg law, having its registered office at 6, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 182.557, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, pre-named, dated 29 November
2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 207 of 23 January 2014 and whose articles of
association have not been amended since (the "Company").

III. The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to change the articles of association of the Company, in order to insert the possibility of

distributing interim dividends.

Consequently, Article 16 of the articles of association of the Company is amended to read as follows:

Art. 16. Each year on the 31 

st

 of December, the accounts are closed and the Board of Directors prepares an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation

shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of
the Company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 hereof.

The Company aims to distribute its distributable profits with a time frame of 5 (five) years of the relevant financial year

(a Payment Deadline). Any profits distributable at the end of the relevant financial year, which have not been distributed
as dividend to the shareholders at the end of that financial year, shall accrue to the sole benefit of the holders of the shares
of the Company and shall be paid by the Company to the shareholders as a dividend at by the relevant Payment Deadline.
Profits will be allocated between the Shareholders pro-rata to their participation in the share capital of the Company.

Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board of Directors must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;

and

(iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), as applicable,

must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met."

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of these resolutions are estimated at one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, this deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and in case
of discrepancy between the English and the French versions, the English version will be prevailing.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, the proxy-holder signed this deed, together

with the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-trois novembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

40355

L

U X E M B O U R G

A comparu:

Selected Harvest Limited, a limited liability company constituée et régie par les lois des Iles Vierges britanniques, ayant

son siège social à Offshore Incorporations Centre, P.O Box 957, Road Town, Tortola, Iles Vierges britanniques et imma-
triculée sous le numéro 1770877,

représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter que:
I.  La  partie  comparante  est  l'actionnaire  unique  (l'"Actionnaire  Unique")  de  Lazarus  Investments  S.A.,  une  société

anonyme constituée et régie par le droit du Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B
182.557, constituée par un acte de Maître Henri Hellinckx, susnommé, en date du 29 novembre 2013 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations no 207 le 23 janvier 2014 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la
"Société").

III. L'Actionnaire Unique, représentant la totalité du capital social, prend la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier les statuts de la Société afin d'insérer la possibilité de distribuer des dividendes

intérimaires.

Par conséquent, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour se lire comme suit:

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration dresse un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège
social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci

atteigne dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société, conformément à l'article 6 des présents statuts ou tel
qu'augmenté ou réduit périodiquement, conformément à l'article 6 des présents statuts.

La Société vise à distribuer les bénéfices distribuables dans une période de 5 (cinq) ans à compter de la fin de l'exercice

social concerné (le Délai de Paiement). Tout bénéfice distribuable à la fin de l'exercice social concerné qui n'a pas été
distribué comme dividende aux actionnaires à la fin de cet exercice social, revient de droit aux actionnaires de la Société
et doit être payé par la Société aux actionnaires comme dividende dans le Délai de Paiement. Les bénéfices seront répartis
entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social de la Société.

L'assemblée générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paie-

ment d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil d'Administration;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants

sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale
ou statutaire;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil d'Administration dans les deux (2)

mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer un rapport au Conseil qui doit

vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies."

<i>Coûts

Les dépenses, coûts, frais et charges de toute sorte qui devront être supportés par la Société en conséquence de ces

résolutions sont estimés à mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une version française. Sur demande de la même partie comparante et en cas de divergence
entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire du comparant, le mandataire a signé le présent acte, avec le notaire.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

40356

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37506. Reçu soixante-quinze

euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016003887/122.
(160001965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Elba Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 289.750,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 200.744.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of December,
before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

(1) Roynet 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under

the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  49,  boulevard  du  Prince  Henry,  L-1724
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under registration number B 200520 (Roynet); and

(2) ELBA ACQUISITION S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11, avenue de la Porte
Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under registration number B 200885 (ELBA),

here represented by Mrs Monique Drauth, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of two (2) powers

of attorney given under private seal.

The said powers of attorney, having been signed ne varietur by the proxyholder and by the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed for registration purposes.

The parties listed at (1) and (2) (the Shareholders), represented as stated above, request the undersigned notary to record

the following:

I. The Shareholders hold all of the shares of Elba Group Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under registration number B 200744
(the Company). The Company was incorporated on 23 September 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary,
published in the Luxembourg official gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations) (the Official Gazette) number 3330 dated 12 December 2015. The articles of association of the
Company (the Articles) have not been amended since.

II. The Shareholders wish to pass resolutions on the following items:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred seventy-seven thousand two hundred fifty

euros (EUR 277,250) to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to an
amount of two hundred eighty-nine thousand seven hundred fifty euros (EUR 289,750) through the issuance of (i) two
hundred twenty-two (222) shares for a total subscription price of two hundred seventy-seven thousand three hundred ninety-
six euros (EUR 277,396) to be subscribed by Roynet by way of a contribution in kind, of which twenty-seven thousand
seven hundred fifty euros (EUR 27,750) shall be allocated to the share capital account of the Company and two hundred
forty-nine thousand six hundred forty-six euros (EUR 249,646) shall be allocated to the share premium account of the
Company and (ii) one thousand nine hundred ninety-six (1,996) shares for a total subscription price of two million four
hundred ninety-six thousand five hundred sixty-four euros (EUR 2,496,564) to be subscribed by ELBA by a contribution
in kind, of which two hundred forty-nine thousand five hundred euros (EUR 249,500) shall be allocated to the share capital
account of the Company and two million two hundred forty-seven thousand sixty-four euros (EUR 2,247,064) shall be
allocated to the share premium account of the Company;

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and
3. Miscellaneous.
III. The Shareholders hereby take the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred seventy-seven

thousand two hundred fifty euros (EUR 277,250) to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros

40357

L

U X E M B O U R G

(EUR 12,500) up to an amount of two hundred eighty-nine thousand seven hundred fifty euros (EUR 289,750) through the
issuance of two thousand two hundred eighteen (2,218) new shares of one hundred twenty five Euros (EUR 125) each
vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The Shareholders resolve to accept the following subscriptions:
(a) Roynet declares to subscribe to two hundred twenty-two (222) shares (the Roynet Shares) and to fully pay-up such

Roynet Shares by making a contribution in kind consisting of the partial conversion of a definite, due and payable receivable
incurred by the Company in favour of Roynet valued at an aggregate amount of two hundred seventy-seven thousand three
hundred ninety-six euros (EUR 277,396) (the Roynet Receivable), of which twenty-seven thousand seven hundred fifty
euros (EUR 27,750) shall be allocated to the share capital account of the Company and two hundred forty-nine thousand
six hundred forty-six euros (EUR 249,646) shall be allocated to the share premium account of the Company.

Roynet further declares that (i) it is the sole owner of the Roynet Receivable and has the power to dispose of the Roynet

Receivable, (ii) there exists no impediments whatsoever to the free transferability of the Roynet Receivable to the Company
and (ii) that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Roynet Receivable to the Company.

The ownership and valuation of the Roynet Receivable is supported by a certificate issued by Roynet and the management

of the Company (the Roynet Certificate), which confirms inter alia, that the aggregate value of the Roynet Receivable is
at least equal to two hundred seventy-seven thousand three hundred ninety-six euros (EUR 277,396).

A copy of the Roynet Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of Roynet and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

(b) ELBA declares to subscribe to one thousand nine hundred ninety-six (1,996) shares (the Elba Shares) and to fully

pay-up such Elba Shares by making a contribution in kind consisting of the partial conversion a definite, due and payable
receivable incurred by the Company in favour of ELBA valued at an aggregate amount of two million four hundred ninety-
six  thousand  five  hundred  sixty-four  euros  (EUR  2,496,564)  (the  Elba  Receivable),  of  which  two  hundred  forty-nine
thousand five hundred euros (EUR 249,500) shall be allocated to the share capital account of the Company and two million
two hundred forty-seven thousand sixty-four euros (EUR 2,247,064) shall be allocated to the share premium account of
the Company.

ELBA further declares that (i) it is the sole owner of the Elba Receivable and has the power to dispose of the Elba

Receivable, (ii) there exists no impediments whatsoever to the free transferability of the Elba Receivable to the Company
and (ii) that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Elba Receivable to the Company.

The ownership and valuation of the Elba Receivable is supported by a certificate issued by ELBA and the management

of the Company (the Elba Certificate), which confirms inter alia, that the aggregate value of the Elba Receivable is at least
equal to two million four hundred ninety-six thousand five hundred sixty-four euros (EUR 2,496,564).

A copy of the Elba Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of ELBA and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

<i>Second resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the Shareholders resolve to amend and restate article 6 of the Articles so that it

shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. The capital is set at thirty-six million two hundred eighty-nine thousand seven hundred fifty euros (EUR 289,750)

divided into two thousand three hundred eighteen (2,318) shares of one hundred twenty-five euros (EUR 125) each.”

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately three thousand one hundred euro (EUR 3,100.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of

the Shareholders, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same proxyholder
of the Shareholders and in case of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this notarial deed.

This notarial deed, having been read to the proxyholder of the Shareholders, who is known to the notary by her surname,

name, civil status and residences, the said proxyholder of the Shareholders signs the present deed together with the notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le seizième jour de décembre,
Par devant Nous Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

40358

L

U X E M B O U R G

(3) Roynet 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 49, boulevard du Prince Henry, L-1724 Luxembourg, Grand- Duché de Lu-
xembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatri-
culation B 200520 (Roynet); et

(4) ELBA ACQUISITION S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'im-
matriculation B 200885 (ELBA),

içi représentées par Mme Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux

procurations données sous seing privée.

Lesdites procurations, qui ont été signées ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné, seront joint au présent

acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les parties listées en (1) et (2) (les Associés), représentées tels que repris ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant

d'acter ce qui suit:

I. Les Associés détiennent l'ensemble des parts sociales de Elba Group Holdings S.à r.l., une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200744
(la Société). La Société a été constituée le 23 septembre 2015 suivant un acte du notaire instrumentaire, publié au Journal
Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 3330
en date du 12 décembre 2015. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

II. Les Associés décident de passer les résolutions suivantes:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cent soixante-dix-sept mille deux cent cinquante

euros (EUR 277.250) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un montant
de deux cent quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 289.750) à travers l'émission de (i) deux cent vingt-
deux (222) parts sociales qui seront souscrites par Roynet pour un prix total de souscription de deux cent soixante-dix-sept
mille trois cent quatre-vingt- seize euros (EUR 277.396) par un apport en nature, dont un montant de vingt-sept mille sept
cent cinquante euros (EUR 27.750) sera affecté au compte du capital social de la Société et un montant de deux cent
quarante-neuf mille six cent quarante-six euros (EUR 249.646) sera affecté au compte de la prime d'émission de la Société
et (ii) mille neuf cent quatre-vingt-seize (1.996) parts sociales qui seront souscrites par ELBA pour un prix total de sou-
scription de deux millions quatre cent quatre-vingt- seize mille cinq cent soixante-quatre euros (EUR 2.496.564) par un
apport en nature, dont un montant de deux cent quarante-neuf mille cinq cents euros (EUR 249.500) sera affecté au compte
du capital social de la Société et un montant de deux millions deux cent quarante-sept mille soixante-quatre euros (EUR
2.247.064) sera affecté au compte de la prime d'émission de la Société;

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société; et
3. Divers
III. Les Associés adoptent unanimement par les présentes les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent soixante-dix-sept mille deux

cent cinquante euros (EUR 277.250) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
à un montant de deux cent quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 289.750) à travers l'émission de deux
mille deux cent dix-huit (2.218) nouvelles parts sociales investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

<i>Souscription - Paiement

Les Associés décident d'accepter les souscriptions suivantes:
(c) Roynet déclare souscrire à deux cent vingt-deux (222) parts sociales (les Parts Roynet) et de libérer intégralement

ces Parts Roynet par un apport en nature consistant en la conversion partielle d'une créance certaine liquide et exigible
encourue par la Société au bénéfice de Roynet dont la valeur a été évalué à un montant total de deux cent soixante-dix-sept
mille trois cent quatre-vingt-seize euros (EUR 277.396) (la Créance Roynet), dont un montant de vingt-sept mille sept cent
cinquante euros (EUR 27.750) sera affecté au compte du capital social de la Société et un montant de deux cent quarante-
neuf mille six cent quarante-six euros (EUR 249.646) sera affecté au compte de la prime d'émission de la Société.

Roynet déclare par ailleurs (i) qu'il est le seul propriétaire de la Créance Roynet et possède les pouvoirs d'en disposer,

(ii) qu'il n'existe aucun obstacle à la libre transférabilité de la Créance Roynet à la Société et (iii) que des instructions
légitimes ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités nécessaires afin d'exé-
cuter le transfert de la Créance Roynet à la Société.

La propriété et la valeur de la Créance Roynet est certifié par le certificat émis par Roynet et la gérance de la Société

(le Certificat Roynet), lequel confirme inter alia que la valeur totale de la Créance Roynet est au moins égal à deux cent
soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-seize euros (EUR 277.396).

40359

L

U X E M B O U R G

Une copie du Certificat Roynet, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

(d) ELBA déclare souscrire à mille neuf cent quatre-vingt-seize (1.996) parts sociales (les Parts Elba) et de libérer

intégralement ces Parts Elba par un apport en nature consistant en la conversion partielle d'une créance certaine liquide et
exigible encourue par la Société au bénéfice de Elba dont la valeur a été évalué à un montant total de deux millions quatre
cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-quatre euros (EUR 2.496.564) (la Créance Elba), dont un montant de deux
cent quarante-neuf mille cinq cents euros (EUR 249.500) sera affecté au compte du capital social de la Société et un montant
de deux millions deux cent quarante-sept mille soixante-quatre euros (EUR 2.247.064) sera affecté au compte de la prime
d'émission de la Société.

ELBA déclare par ailleurs (i) qu'il est le seul propriétaire de la Créance Elba et possède les pouvoirs d'en disposer, (ii)

qu'il n'existe aucun obstacle à la libre transférabilité de la Créance Elba à la Société et (iii) que des instructions légitimes
ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités nécessaires afin d'exécuter le
transfert de la Créance Elba à la Société.

La propriété et la valeur de la Créance Elba est certifié par le certificat émis par ELBA et la gérance de la Société (le

Certificat Elba), lequel confirme inter alia que la valeur totale de la Créance Elba est au moins égal à deux millions quatre
cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-quatre euros (EUR 2.496.564).

Une copie du Certificat Elba, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

“ Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 289.750) représenté

par deux mille trois cent dix-huit (2.318) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.”

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à trois mille cent euros (EUR 3.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la mandataire des Associés, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française, et qu'à la demande de la même mandataire, en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des Associés, connue du notaire instrumentaire par son

nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41212. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016003668/202.
(160001911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Carpathian Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 41.025,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.154.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third of December.
Before Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the Sole Shareholder (the “Meeting”) of "Carpathian Holdings S.à r.l." (the “Com-

pany”), a “Société à responsabilité limitée”, established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 109154, incorporated by deed of Maître Paul Bettingen, notary residing
in Niederanven, on July 5, 2005, published in the Luxembourg Memorial C number 1138 on November 3, 2005. The articles
of incorporation have been amended latest pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, then notary residing in Lu-
xembourg, dated April 30 

th

 , 2009, published in the Luxembourg Memorial C number 1130 on June 9 

th

 , 2009.

40360

L

U X E M B O U R G

There appeared:

Simon Killick with residential address at 11, Medway House, May Bate Avenue, Kingston Surrey KT2 5UL, United

Kingdom, (the “Sole Shareholder”),

represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxem-

bourg, by virtue of the proxy given under private seal,

which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. That all the 1,641 (one thousand six hundred forty-one) shares are present or represented at this Meeting, so that the

Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II. That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda

1. To dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation;
2. To appoint the liquidator (the “Liquidator”)
3. To determine the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Miscellaneous.
III. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquida-

tion).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l, a société à responsabilité limitée governed

by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 142389, as liquidator (The “Liquidator”).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg

law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including

those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the Sole Shareholder.
The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or
several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under his sole signature on

behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required
for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments

of the liquidation proceeds to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by her surname, Christian name,

civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique (l'“Assemblée”) de la société à responsabilité limitée "Carpathian

Holdings S.à r.l." (la “Société”), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le N°109154, constituée
suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 5 juillet 2005, publié au

40361

L

U X E M B O U R G

Mémorial C N°1138 du 3 novembre 2005. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de
Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Niederanven, en date du 30 avril 2009, publié au Mémorial C N°1130
9 juin 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de
1.  Simon  Killick,  résidant  au  11,  Medway  House,  May  Bate  Avenue,  Kingston  Surrey  KT2  5UL,  Royaume-Uni,

(“L'Associé Unique”),

ici représenté par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que toutes les 1.641 (mille six cent quarante et une) parts sociales sont présentes ou représentées à la présente assemblée

générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination du liquidateur (le “Liquidateur”);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Divers.
III. Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l, une société à responsabilité limitée régie par

le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 142389, comme liquidateur (le “Liquidateur”).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août

1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce

compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale de l'Associé Unique.
Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement
déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature

au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de
la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur

le solde de liquidation à l'Associé Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en

langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, il a signé avec

Nous notaire la présente minute.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30225. Reçu douze euros Eur 12.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

40362

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004464/122.
(160003854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Floow2 International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 166.272.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty first of December,
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held

the extraordinary general meeting of shareholders of the company “FLOOW2 INTERNATIONAL S.A.”, established

and having its registered office at 31, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, registered with the Register of Commerce
and Companies of Luxembourg under the number B 166272, incorporated on 11 January 2012 by a deed of Maître Martine
SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, deed published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 590 of 06 March 2012, page 28274.

The statutes have not been amended until now.
The general meeting is chaired by Sara Lecomte, private employee, with professional address in Redange-sur-Attert.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Barbara Schmitt, private employee, with pro-

fessional address in Redange-sur-Attert.

The Chairman states:
I. The shareholders represented, the proxy-holders of the shareholders represented and the number of shares they hold

are shown in a list that after being signed by the shareholders or their proxy-holders and by the members of the bureau and
the notary will remain attached to the present deed to be filed. The present powers of attorney, initialized “ne varietur” by
the appearing parties and the notary will also remain attached to the present deed.

II. It results from the attendance list established and certified by the members of the bureau that the one hundred (100)

shares without indication of the nominal value of the Company representing the entire share capital of EUR 31,000 (thirty-
one thousand euro) are present or represented at the Extraordinary General Meeting of shareholders and the holders of the
shares recognise being validly convened to the present meeting so that the Extraordinary General Meeting is duly constituted
and may validly deliberate on all items of the agenda.

III. All shareholders present or represented confirm to have been informed in advance on the agenda.
IV. That the agenda of the present meeting is:

<i>Agenda

1. Decision to liquidate the Company
2. Appointment of Kim TJOA as liquidator of the Company
3. Discharge to the directors of the Company
The meeting, after having approved the statements of the Chairman and recognised to be validly constituted, discussed

the items of the agenda, and, after deliberation took by unanimity the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to appoint as liquidator Kim TJOA, professionally residing at 31 rue de Strasbourg, L-2561

Luxembourg.

The Shareholders resolve that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any

act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to give full discharge to the directors of the Company for the execution of their mandate.
There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand three hundred euros (EUR
1,300.-).

40363

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt et un décembre,
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «FLOOW2 INTERNATIONAL S.A.», éta-

blie et ayant son siège social au 31, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166272, constituée le 11 janvier 2012 suivant un acte reçu par Maître Martine
SCHAEFFER,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  acte  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,
numéro 590 du 06 mars 2012, page 28274.

A ce jour, les statuts n'ont jamais été modifiés.
L'assemblée générale est présidée par Sara Lecomte, employée privée, avec adresse professionnelle à Redange-sur-

Attert.

Le Président désigne comme et l'Assemblée choisit comme scrutateur Barbara Schmitt, employée privée, avec adresse

professionnelle à Redange-sur-Attert.

Le Président expose:
I. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou
leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations
des actionnaires représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Qu'il résulte de la liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent (100) actions de la

Société sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de trente-et-un mille euros (EUR
31.000) sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions se re-
connaissent dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l'Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. Tous les actionnaires représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'odre du jour de la dite assemblée.
IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Mise en liquidation de la Société
2. Nomination de Kim TJOA comme liquidateur
3. Décharge aux administrateurs L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé du Président et après s'être reconnue ré-

gulièrement constituée, a abordé les points portés à l'ordre jour, et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident de prononcer la dissolution de la Société avec effet immédiat et de procéder à la liquidation

de la Société.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de nommer en qualité de liquidateur Kim TJOA, demeurant professionnellement au 31, rue

de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de

disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident d'accorder la décharge complète aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leur

mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

40364

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénoms, état et demeure,

ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, B. SCHMITT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22271. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016003738/118.
(160001917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Antoinette LENTZ-SCHLEICH SCI, Société Civile.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 44, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg E 5.821.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1. - Madame Antoinette LENTZ, veuve SCHLEICH, sans état particulier, née à Luxembourg le 12 décembre 1923,

demeurant à L-1510 Luxembourg, 44, avenue de la Faïencerie,

ici représentée aux fins des présentes par Madame Brigitte BRANDENBURGER, préqualifiée sub 2.-, en vertu de d’une

procuration sous seing privé donnée le 26 novembre 2015,

laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

2. - Madame Brigitte BRANDENBURGER, architecte, née à Luxembourg le 26 janvier 1956, demeurant à L-4972

Dippach-Gare, 53, route des Trois Cantons.

3.  -  Monsieur  Daniel  ANTONY,  expert-comptable,  né  à  Luxembourg  le  4  août  1966,  demeurant  à  D-66706  Perl-

Bueschdorf, zu den Eischen, 3.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte de constitution d'une société civile immo-

bilière qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1 

er

 .  Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: "Antoinette LENTZ-

SCHLEICH SCI".

Art. 2. La société a pour objet l’administration, la gestion et la mise en valeur par location, échange, construction,

transformation ou vente, de tous immeubles ou parts d’immeubles qu'elle pourra acquérir, tant au Grand-Duché de Lu-
xembourg qu’à l’étranger, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social
ou pouvant en faciliter l'extension et le développement.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification des

statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

40365

L

U X E M B O U R G

Titre II. - Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (€ 2.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés
représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à
des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits ap-
partenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir

de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Titre III. - Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les

gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous actes et
opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

Art. 9. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de

bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires,

est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à
une voix.

Art. 11. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou

des gérant(s) et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'as-
semblée.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des gérant

(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide

autrement.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par

la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par
les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Antoinette LENTZ, veuve SCHLEICH, préqualifiée,
quatre-vingt-dix-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

2) Madame Brigitte BRANDENBURGER,
préqualifiée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3) Monsieur Daniel ANTONY,
préqualifié, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents

euros (€ 2.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxima-

tivement à mille euros (€ 1.000.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

40366

L

U X E M B O U R G

1.- Madame Brigitte BRANDENBURGER et Monsieur Daniel ANTONY, préqualifiés, sont nommés gérants de la

société pour une durée indéterminée.

2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
3.- Le siège social est fixé à L-1510 Luxembourg, 44, avenue de la Faïencerie.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: BRANDENBURGER, ANTONY, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41595. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2016004338/98.
(160003184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Allianz Finance VIII Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 165.116.

Les statuts coordonnés au 15 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2016004330/11.
(160002873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

stesca S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 36, rue Léon Kauffmann.

R.C.S. Luxembourg B 160.957.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Ernest HANSEN, docteur en médecine, né à Luxembourg, le 6 août 1948, demeurant à L-1853 Luxembourg,

36, rue Léon Kauffman, propriétaire de vingt-quatre (24) parts sociales,

2) Madame Viviane HANSEN-NEIERTZ, professeur d'enseignement secondaire, née à Luxembourg, le 17 février 1950,

demeurant à L-1853 Luxembourg, 36, rue Léon Kauffman, propriétaire de vingt-quatre (24) parts sociales,

3) Monsieur Stéphane HANSEN, licencié en droit et en économie, né à Luxembourg, le 16 décembre 1971, demeurant

à L-1853 Luxembourg, 36, rue Léon Kauffman, propriétaire de vingt-huit (28) parts sociales,

4) Madame Esther HANSEN, diplômée en psychologie clinique, née à Luxembourg, le 11 août 1977, demeurant à N8

9LA Londres, Inderwick Road 55 (Royaume-Uni), propriétaire de vingt-quatre (24) parts sociales.

Les comparants sub. 3) et 4) étant ici représentés par Monsieur Ernest HANSEN, prénommé, (le “Mandataire”), en vertu

de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le
Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

leurs déclarations et constatations:

a) La société à responsabilité limitée “stesca S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1853 Luxembourg, 36, rue

Léon Kauffman, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 160957,
(la “Société”), a été constituée en date du 16 mai 2011 suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1668 du 25 juillet 2011, et les statuts
(les “Statuts”) ont été modifiés le 10 février 2012 suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, prénommé, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 918 du 7 avril 2012;

40367

L

U X E M B O U R G

b) Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées et détenues comme suit:

- Monsieur Ernest HANSEN: vingt-quatre (24) parts sociales,

- Madame Viviane HANSEN-NEIERTZ: vingt-quatre (24) parts sociales,

- Monsieur Stéphane HANSEN: vingt-huit (28) parts sociales,

- Madame Esther HANSEN: vingt-quatre (24) parts sociales,

ensemble dénommés ci-après les “Associés”;

c) L'activité de la Société ayant cessé, les Associés prononcent la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat

et sa mise en liquidation;

d) Les Associés déclarent avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;

e) Les Associés se désignent comme liquidateurs de la Société (le “Collège des liquidateurs” ou le “Collège”), lequel

Collège aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration
et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

f) Le Collège requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné et

que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels
passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, les Associés assument l'obligation irrévocable de payer,
chacun d'eux en proportion de sa participation dans la Société, ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède
tout le passif de la Société est réglé;

g) Les Associés déclarent également qu'ils reprennent tout l'actif de la Société et qu'ils s'engagent à régler tout le passif

de la Société indiqué au point f), proportionnellement à leur participation dans la Société, sans préjudice du fait qu'ils
répondent personnellement et solidairement de tous les engagements sociaux à l'égard des tiers;

h) Les Associés déclarent formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

i) Les Associés prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la Société a définitivement cessé d'exister et

que tous les registres de la Société seront annulés;

j) Décharge pleine et entière est donnée au gérant technique et au gérant administratif de la Société pour l'exécution de

leur mandat jusqu'en date des présentes;

k) Les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la

Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cent cinquante euros
et les comparants, en tant qu'associés, s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès-qualités qu'ils agissent, connus du notaire par nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. HANSEN, V. HANSEN-NEIERTZ, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 28 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30055. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 06 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004318/72.

(160003852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

40368


Document Outline

AK Conseil &amp; Stratégie

Allianz Finance VIII Luxembourg S.A.

Alternative Leaders Investissements S.A.

Amphitrite International S.A.

Anaconda S.A., SPF

Antimo S.A.

Antoinette LENTZ-SCHLEICH SCI

AXL International

AXL Investments S.A.

AZ Holding S.A.

B2 Construction

Capital Dynamics CEI GP S.à r.l.

Carpathian Holdings S.à r.l.

Challenger Luxembourg Holding No. 2 S.à r.l.

Chephren S.A.

CHIRIAC Engineering S.à r.l.

Colors Investment

Conchita S.A.

C.R.G. S.A.

DB STG Lux 10 S.à r.l.

Dehus S.à r.l.

DiezTres13ink S.à r.l.

Duckfin International S.A.

East Western S.A.

Elba Group Holdings S.à r.l.

Euromoney Luxembourg S.à r.l.

European Healthcare Investments S.à r.l.

EURX Epsilon Investment S.à r.l.

E.V.A.F. Luxembourg (Olympic) S.à r.l.

Fame Group Sàrl

Fill Consulting S.à r.l.

Floow2 International S.A.

Followcorp S.à r.l.

F&amp;S Investholding S.A.

F&amp;S Investholding S.A.

F&amp;S Investholding S.A.

Gamma Holdco (Luxembourg) S.à r.l.

GARAGE BERNARD MUZZOLINI, société anonyme

Geert Dirkx S.à r.l.

Glentel International Corp.

Golden Finance S.A.

Greenland S.A.

Guizet Immobilière S.A.

Henley Trust (Luxembourg) S.à r.l.

Holky Investors S.A.

Image Management S.A.

Kury Kamak Artisanat S.à r.l.

Lazarus Investments Limited

LF Hotels Acquico II (GP) S.à r.l.

Link Logistics S.A.

Luxlease S.A.

Makalu S.A.

Marne S.A.

MBM LX S.à r.l.

Medrom S.A.

Medrom S.A.

Medrom S.A.

Medrom S.A.

Medrom S.A.

Moore Emerging Markets, (Luxembourg) S.à r.l.

Nettoyage de Vitres Eko S.à r.l.

Networking

Networking

PATRIZIA Real Estate 37 S.à r.l.

Secure Capital Financing S. à r. l.

Sheet Anchor LuxHoldCo S.à r.l.

Sheet Anchor LuxHoldCo S.à r.l.

Soverino International S.à r.l.

stesca S.à r.l.

Wow LuxCo 1 S.à r.l.