logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 173

22 janvier 2016

SOMMAIRE

BFF Lux Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8295

Buanderie Centrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8263

Callisto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8265

Camon Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8266

Capita Fiduciary S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8266

Caymus Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8263

CCD Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8263

Cersanit Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

8281

Cheyne Special Situations Investments (N° 2)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8290

CitCor Franconia Berlin VI S.à r.l.  . . . . . . . . .

8276

Cityhold Euro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8264

Cityhold Euro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8264

Clare Acquisitions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8264

Clare Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8265

Corporate Executive Board Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8265

Cotton Connect Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

8290

Elba Acquisition S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8262

Euresa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8266

Even Germany Drei S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

8267

Fane Acquisitions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8267

Far East Hospitality Properties (Europe) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8267

Gerbera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8304

Gestador S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8304

Hakogel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8268

HFB Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8268

High Liquidity Investment Fund  . . . . . . . . . . .

8304

Hiwinglux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8268

Immobilière Vauban S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8269

Innovation cluster 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

8269

Insulation Operations Holdings S.à r.l.  . . . . . .

8269

Jewel HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8270

J.Y.C. Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8270

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8270

KRS Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8271

Langton Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8271

La Sablière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8273

Le Premier Investment III S.C.A.  . . . . . . . . . .

8271

Le Premier Investment S.C.A.  . . . . . . . . . . . . .

8272

Le Premier Sirocco S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

8272

Luxembourg Investment Company 80 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8273

Luxembourg Investment Company 81 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8273

Meyer Neptun GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8302

Michelle Participations Mobilières S.A.  . . . . .

8274

Michelle Participations Mobilières S.A.  . . . . .

8274

Muguet Financière Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

8274

NameDrive IP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8303

Nivelcom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8274

Ogcrew S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8275

PHM Topco 6 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8275

Private Equity International S.A.  . . . . . . . . . .

8275

Ship Global 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8293

Skyline Residences S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8258

Skyline Residences S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8285

Somuchmore Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

8258

Toweb S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8293

traffic.club S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8303

8257

L

U X E M B O U R G

Skyline Residences S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diederich.

R.C.S. Luxembourg B 183.645.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015183375/14.
(150204072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Somuchmore Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.552,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.134.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth of October,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), a Societas Europaea existing under the laws of Germany, registered

with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (“Rocket”),

being the holder of fourteen thousand forty-two (14,042) common shares, nine hundred fifty-eight (958) series A1 shares

and becoming the holder of eight hundred five (805) series A5 shares,

here represented by Mr. David Al Mari, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, Germany, on 26 October 2015;
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 191.426 (“Holtzbrinck”),

being the holder of two thousand eight hundred seventy-four (2,874) series A1 shares and becoming the holder of one

thousand one hundred fortynine (1,149) series A5 shares,

here represented by Mr. David Al Mari, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 28 October 2015;
3. Landerfield Enterprises Limited, a limited liability company under the laws of Cyprus, registered with the Cyprus

Registrar of Companies under no. 210960 having its business address at Naousis 1, Karapatakis Building, 6018, Larnaca,
Cyprus (“Ru-Net”),

being the holder of one thousand one hundred forty-nine (1,149) series A3 shares and becoming the holder of five

hundred seventy-five (575) series A5 shares,

here represented by Mr. David Al Mari, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Larnaca, Cyprus, on 26 October 2015;
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Rocket, Holtzbrinck and Ru-Net are all the current shareholders (the “Shareholders”) of Somuchmore Global S.à r.l.

(the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 194.134 and incorporated under the name of “Digital
Services XXXVIII S.à r.l.” pursuant to a deed of the notary Cosita Delvaux, residing in Luxembourg, on 7 January 2015,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 669 dated 11 March 2015. The articles of
association were amended for the last time pursuant to a deed of the same notary on 12 August 2015, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general meeting

of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

8258

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares in the share capital of the Company, referred to as the series A5

shares (hereinafter the “Series A5 Shares”, so that the Company will hence have four (4) classes of shares, namely the
common shares, the Series A1 Shares, the Series A3 Shares and the Series A5 Shares.

2. Increase of the Company’s share capital by an amount of two thousand five hundred twenty-nine euro (EUR 2,529)

so as to raise it from its current amount of nineteen thousand twenty-three euro (EUR 19,023) up to twenty-one thousand
five hundred fifty-two euro (EUR 21,552) by issuing two thousand five hundred twenty-nine (2,529) Series A5 Shares with
a nominal value of one euro (EUR 1) each.

3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as

follows:

“ 5.1. The Company’s share capital is set at twenty-one thousand five hundred fifty-two euro (EUR 21,552.00), repre-

sented by:

5.1.1 fourteen thousand and forty-two (14,042) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 three thousand eight hundred thirty-two (3,832) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)

each,

5.1.3 one thousand one hundred forty-nine (1,149) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,

and

5.1.4 two thousand five hundred twenty-nine (2,529) series A5 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each

(together with the series A1 shares and the series A3 shares, the “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.”

4. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Ms. Magdalena

Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register
of the Company.

5. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares in the share capital of the

Company, referred to as the series A5 shares (hereinafter the “Series A5 Shares”), so that the Company will hence have
four (4) classes of shares, namely the common shares, the Series A1 Shares, the Series A3 Shares and the Series A5 Shares.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand

five hundred twenty-nine euro (EUR 2,529) so as to raise it from its current amount of nineteen thousand twenty-three euro
(EUR 19,023) up to twenty-one thousand five hundred fifty-two euro (EUR 21,552) by issuing two thousand five hundred
twenty-nine (2,529) Series A5 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The two thousand five hundred twenty-nine (2,529) Series A5 Shares have been subscribed as follows:
1. eight hundred five (805) Series A5 Shares have been duly subscribed by Rocket, aforementioned, for the price of

eight hundred five euro (EUR 805);

2. one thousand one hundred forty-nine (1,149) Series A5 Shares have been duly subscribed by Holtzbrinck, afore-

mentioned, for the price of one thousand one hundred forty-nine euro (EUR 1,149); and

3. five hundred seventy-five (575) Series A5 Shares have been duly subscribed by Ru-Net, aforementioned, for the price

of five hundred seventy-five euro (EUR 575).

<i>Payment

The two thousand five hundred twenty-nine (2,529) Series A5 Shares so subscribed by Rocket, aforementioned, Holtz-

brinck, aforementioned, and Ru-Net, aforementioned, have been entirely paid up through three contributions in cash so
that an aggregate amount of two thousand five hundred twenty-nine euro (EUR 2,529) has been paid and is as of now
available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of two thousand five hundred twenty-nine euro (EUR 2,529) is entirely allocated

to the share capital of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company so that

it shall henceforth read as stated in the agenda.

8259

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well

as Ms. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the
shareholders register of the Company.

<i>Costs and expenses

The  expenses,  costs,  remunerations  or  charges  in  any  form  whatsoever  which  shall  be  borne  by  the  Company  are

estimated at approximately EUR 2,000.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by her name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreissigsten Oktober,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) bestehend

nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 165662 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaberin von vierzehntausendzweiundvierzig (14.042) Stammanteilen, neunhundertachtundfünfzig (958) Anteilen der

Serie A1 und zukünftige Inhaberin von achthundertfünf (805) Anteilen der Serie A5,

hier vertreten durch Herr David Al Mari, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 26. Oktober 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend

unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),

Inhaberin von zweitausendachthundertvierundsiebzig (2.874) Anteilen der Serie A1 und zukünftige Inhaberin von ein-

tausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteilen der Serie A5,

hier vertreten durch Herr David Al Mari, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 28. Oktober 2015, ausgestellt in Luxemburg;
3. Landerfield Enterprises Limited, eine Gesellschaft (limited liability company) nach dem Recht Zyperns, eingetragen

im Cyprus Registrar of Companies unter der Nummer 210960, mit Geschäftsadresse in Naousis 1, Karapatakis Building,
6018, Larnaca, Zypern („Ru-Net“),

Inhaberin von eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteilen der Serie A3 und zukünftige Inhaberin von fünf-

hundertfünfundsiebzig (575) Anteilen der Serie A5,

hier vertreten durch Herr David Al Mari, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 26. Oktober 2015, ausgestellt in Larnaca, Zypern.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Rocket, Holtzbrinck und Ru-Net sind die aktuellen Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Somuchmore Global S.à

r.l.  (die  „Gesellschaft”),  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée),  gegründet  und
bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großher-
zogtum  Luxemburg,  eingetragen  im  Handels-  und  Gesellschaftsregister  Luxemburg  unter  der  Nummer  B  194.134,
gegründet am 7. Januar 2015 unter dem Namen „Digital Services XXXVIII S.à r.l.“ gemäß einer Urkunde der Notarin
Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 11. März 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 669, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 12. August 2015 gemäß einer
Urkunde derselben Notarin geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde.

Da die Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und erklären, auf jegliche Ladungsformalitäten ver-

zichtet zu haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über jeden
Punkt der folgenden Tagesordnung verhandeln:

8260

L

U X E M B O U R G

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft,

welche als Anteile der Serie A5 bezeichnet werden (im Folgenden die „Anteile der Serie A5“), sodass die Gesellschaft
nunmehr vier (4) Anteilsklassen hat, bestehend aus den Stammanteilen, den Anteilen der Serie A1, den Anteilen der Serie
A3 und den Anteilen der Serie A5.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von neunzehntausenddreiund-

zwanzig Euro (EUR 19.023) um einen Betrag von zweitausendfünfhundertneunundzwanzig Euro (EUR

2.529) auf einen Betrag von einundzwanzigtausendfünfhundertzweiundfünfzig Euro (EUR 21.552) durch die Ausgabe

von zweitausendfünfhundertneunundzwanzig (2.529) Anteilen der Serie A5 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1).

3. Dementsprechende Änderung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ 5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einundzwanzigtausendfünfhundertzweiundfünfzig Euro (EUR

21.552,00), bestehend aus:

5.1.1 vierzehntausendzweiundvierzig (14.042) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 dreitausendachthundertzweiunddreißig (3.832) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00),

5.1.3 eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(1,00), und

5.1.4 zweitausendfünfhundertneunundzwanzig (2.529) Anteilen der Serie A5 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (zusammen mit den Anteilen der Serie A1 und den Anteilen der Serie A3 die „Anteile der Serie A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch

das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“

4. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau

Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

5. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Klasse von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesell-

schaft zu schaffen, welche als Anteile der Serie A5 bezeichnet werden (im Folgenden die „Anteile der Serie A5“), sodass
die Gesellschaft nunmehr vier (4) Anteilsklassen hat, bestehend aus den Stammanteilen, den Anteilen der Serie A1, den
Anteilen der Serie A3 und den Anteilen der Serie A5.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag

von neunzehntausenddreiundzwanzig Euro (EUR 19.023) um einen Betrag von zweitausendfünfhundertneunundzwanzig
Euro (EUR 2.529) auf einen Betrag von einundzwanzigtausendfünfhundertzweiundfünfzig Euro (EUR 21.552) durch die
Ausgabe von zweitausendfünfhundertneunundzwanzig (2.529) Anteilen der Serie A5 mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die zweitausendfünfhundertneunundzwanzig (2.529) Anteile der Serie A5 wurden wie folgt gezeichnet:
1. achthundertfünf (805) Anteile der Serie A5 wurden ordnungsgemäß von Rocket, vorbenannt, zum Preis von acht-

hundertfünf Euro (EUR 805) gezeichnet;

2. eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteile der Serie A5 wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck, vorbe-

nannt, zum Preis von eintausendeinhundertneunundvierzig Euro (EUR 1.149) gezeichnet; und

3. fünfhundertfünfundsiebzig (575) Anteile der Serie A5 wurden ordnungsgemäß von Ru-Net, vorbennant, zum Preis

von fünfhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 575) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Rocket, vorbenannt, Holtzbrinck, vorbenannt, und Ru-Net, vorbenannt, gezeichneten zweitausendfünfhun-

dertneunundzwanzig  (2.529)  Anteile  der  Serie  A5  wurden  vollständig  eingezahlt  durch  drei  Bareinlagen,  sodass  ein
Gesamtbetrag von zweitausendfünfhundertneunundzwanzig Euro (EUR 2.529) gezahlt wurde und der Gesellschaft von
nun an zur Verfügung steht, worüber der unterzeichnenden Notarin ein Nachweis erbracht wurde.

Die  Gesamteinlage  in  Höhe  von  zweitausendfünfhundertneunundzwanzig  Euro  (EUR  2.529)  wird  vollständig  dem

Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeführt.

8261

L

U X E M B O U R G

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, so dass dieser nunmehr

wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet

seiner Kategorie, sowie Frau Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und
mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: D. AL MARI, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/34885. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. November 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015183378/231.
(150204066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Elba Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 200.885.

<i>Extrait des décisions de l'Associé Unique datées du 4 novembre 2015

<i>Première résolution

L'Associé Unique nomme Mme Muzna Mustafa ALI ABDUL LATIF, née le 27 Janvier 1988 à Bousher, Sultanat

d'Oman, avec adresse au Building No. 806, Way No.7014, 100 Athaiba North, Sultanat d'Oman en qualité de Gérant de
classe A de la Société pour une durée indéterminée.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique nomme M. Hamood Nasser Khalfan AL-RAWAHI, née le 3 Janvier 1989 à Al Wattaya, Sultanat

d'Oman, avec address au House No. 4191, Way No.3052, 100 Shatti Al Qurum, Sultanat d'Oman en qualité de Gérant de
classe A de la Société une durée indéterminée.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique nomme M. Alexis Kamarowsky, né le 10 avril 1947 à Strang Jetzt Bad Rothenfelde, Allemagne, avec

adresse professionnelle au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg en qualité de Gérant de classe B de la
Société

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique nomme M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, né le 12 Septembre 1964 à La Spezia, Italie, avec

adresse professionnelle au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg en qualité de Gérant de classe B de la
Société

8262

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique nomme Mr. François Manti, né le 7 Octobre 1970 à Algrange, France, avec adresse professionnelle

au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg en qualité de Gérant de classe B de la Société.

Pour Mandat
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015185884/31.

(150207535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

CCD Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5750 Frisange, 5, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 181.180.

En vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 14 octobre 2015, Madame Stéphanie Deltenre, née

à Arlon (Belgique) le 13 mars 1977, demeurant à B-6717 Lottert, 111, La Chavée a cédée 10 (dix) parts sociales à Monsieur
Sébastien Habay, né à Virton (Belgique) le 7 février 1972, demeurant à B-6717 Lottert, 111, La Chavée,.

Cette cession de parts sociales a été approuvée par une assemblée générale extraordinaire conformément aux statuts et

les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article
190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 14 novembre 2015.

CCD Partners S.à r.l.
Signature
<i>La direction

Référence de publication: 2015185852/17.

(150207830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Buanderie Centrale, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-5299 Schrassig,

R.C.S. Luxembourg C 17.

Lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2015, M. Christian GINTER, avec adresse professionnelle à L-1499 Lu-

xembourg, 4, Place de l'Europe (Héichhaus), a été nommé comme membre du conseil de gérance en remplacement de M.
Ricky WOHL dont il terminera le mandat.

<i>Pour le groupement d'intérêt économique Buanderie Centrale

Référence de publication: 2015185834/11.

(150207561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Caymus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: MXN 79.613.163,00.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 180.704.

L'associé unique de la Société a désormais pour adresse le 130, King St. West, Suite 740, M5X A2A, Toronto, Canada.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Caymus Holding S.à r.l.
Un Mandataire

Référence de publication: 2015185835/12.

(150207771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

8263

L

U X E M B O U R G

Cityhold Euro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.486.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 172.171.

EXTRAIT

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales en date du 5 octobre 2015 entre Andra AP-Fonden, en qualité de cédant,

et Cityhold Office Partnership S.à r.l. en qualité de cessionnaire, Andra AP-Fonden, une agence gouvernementale, établie
et régie sous les lois du Royaume de Suède, ayant son siège social au Box 11155, 404 24 Göteborg, Suède et enregistré
sous le numéro fiscal 857209-0606, a cédé 4.173.840 parts sociales ordinaires représentant 44% du capital social de la
Société à Cityhold Office Partnership S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, enregistrée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 196736, ayant un capital social de EUR 12,500 et ayant son siège social à
4A rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015185836/21.
(150207796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Cityhold Euro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.486.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 172.171.

EXTRAIT

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales en date du 5 octobre 2015 entre Första AP-Fonden, en qualité de cédant,

et Cityhold Office Partnership S.à r.l. en qualité de cessionnaire, Första AP-Fonden, une agence gouvernementale, établie
et régie sous les lois du Royaume de Suède, ayant son siège social à P.O. Box 16924, 103 25 Stockholm, Suède et enregistrée
sous le numéro fiscal 802005¬7538, a cédé 4.173.840 parts sociales ordinaires représentant 44% du capital social de la
Société à Cityhold Office Partnership S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, enregistrée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 196736, ayant un capital social de EUR 12,500 et ayant son siège social à
4A rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015185837/21.
(150207796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Clare Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.124,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 197.048.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 16 novembre 2015

Le siège de la Société a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à L-1931 Luxembourg, 13-15,

avenue de la Liberté avec effet au 1 

er

 octobre 2015.

8264

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Clare Acquisitions S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015185838/15.
(150207575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Clare Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 888.479,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 192.491.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 16 novembre 2015

Le siège de la Société a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à L-1931 Luxembourg, 13-15,

avenue de la Liberté avec effet au 1 

er

 octobre 2015.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Clare Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015185839/15.
(150207577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Corporate Executive Board Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 163.531.

Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la Société, la décision suivante a été prise:
- Démission de Madame Martha Sofia CABALLERO ELIZONDO en qualité de Gérant B de la Société, avec effet

immédiat.

- Nomination de Madame Elena TITKOVA, née le 1 

er

 novembre 1980 à Minsk, Bélarus, ayant pour adresse profes-

sionnelle le 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Gérant B de la Société, à compter du 12
novembre 2015 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gwenaëlle Cousin
<i>Gérant B

Référence de publication: 2015185845/17.
(150207452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Callisto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 93.740.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2014

L'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2014 a pris les décisions suivantes:
1. L'assemblée générale renouvelle le mandat des membres actuels du conseil d'administration, à savoir M. Lex THIE-

LEN, M. Joe THIELEN et Mme Magalie HILCHER, dont le mandat courra jusqu'à l'assemblée générale ordinaire se tenant
en 2020.

2. L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes actuel, à savoir SAINT GERANT INVES-

TISSEMENT s.à r.l., dont le mandat courra jusqu'à l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2020.

Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2015185847/15.
(150207763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

8265

L

U X E M B O U R G

Camon Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.419.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire à Luxembourg

<i>en date du 23 juillet 2015 à 11h00

<i>Décisions

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- d'acter le changement d'adresse de Monsieur Clive Godfrey, Administrateur, son adresse actuelle étant: L - 1720

Luxembourg, rue Heinrich Heine, 8.

- d'acter le changement d'adresse de Monsieur Bernard Marchant, Administrateur et Administrateur-Délégué, son adresse

actuellement étant: B - 1640 Rhodes-St-Genèse, avenue de l'Espinette Centrale, 23.

-  d'acter  le  changement  d'adresse  de  Madame  Christine  Marchant,  Administrateur  et  Administrateur-Délégué,  son

adresse actuellement étant: B - 1640 Rhodes-St-Genèse, avenue de l'Espinette Centrale, 23.

- d'acter le changement d'adresse de Data Graphic S.A., Commissaire aux comptes, son adresse actuelle étant: L - 1720

Luxembourg, rue Heinrich Heine, 8.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015185849/22.
(150207766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Capita Fiduciary S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 117.939.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 2 novembre 2015 que le siège social

de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 2 novembre
2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185850/13.
(150207679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Euresa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 5A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 33.730.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 30 octobre 1990

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2014:
1. Le mandat des administrateurs repris ci-après a pris fin suite à la nomination de Mr Bernard Dufourny en tant que

liquidateur:

- Hilde Vemaillen, demeurant à B-1210 Bruxelles, 151, rue Royale.
- Martin Willems, demeurant à B-1210 Bruxelles, 151, rue Royale.
- Jean-Marc Raby, demeurant à L-1445 Strassen, 5A, rue Thomas Edison.
- Carlo Cimbri, demeurant à L-1445 Strassen, 5A, rue Thomas Edison.
- Roger Belot, demeurant à F-79038 Niort, 200, rue Salvator Allende.
- Pierluigi Stefanini, demeurant à L-1445 Strassen, 5A, rue Thomas Edison.
- Thierry Couret, demeurant à F-79000 Niort, 31, rue du Quatre Septembre.
- Alain Montarant, demeurant à F-16100 Cognac, 16, résidence Anatole France

8266

L

U X E M B O U R G

Bernard DUFOURNY
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2015185888/22.
(150207648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Even Germany Drei S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 139.098.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 novembre 2015

Il en résulte dudit procès-verbal que:
- L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Monsieur Sylvain Kirsch en tant que Gérant de la Société.
- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante de la Société Madame Célia Neves, ayant son adresse profession-

nelle au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 16 novembre 2015 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015185889/16.
(150207463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Fane Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 198.001.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 16 novembre 2015

Le siège de la Société a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à L-1931 Luxembourg, 13-15,

avenue de la Liberté avec effet au 1 

er

 octobre 2015.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Fane Acquisitions S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015185891/15.
(150207638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Far East Hospitality Properties (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 189.027.

En date du 12 novembre 2015 l'associé unique de la Société a pris la décision suivante:
- Nomination de Madame Lara Al Raheb, née le 16 janvier 1982 à Amman, en Jordanie, ayant pour adresse profes-

sionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à compter du 1 

er

 novembre 2015, comme gérante B pour

une période illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Far East Hospitality Properties (Europe) S.à r.l.
Lara Al Raheb
<i>Gérante B

Référence de publication: 2015185892/16.
(150207655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

8267

L

U X E M B O U R G

Hiwinglux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 195.593.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 8 octobre 2015

En date du 8 octobre 2015, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Monsieur Shuchun LI de son mandat d'administrateur de catégorie B de la

Société avec effet au 8 octobre 2015;

- de nommer Monsieur Sheng WANG, né le 16 octobre 1966 à Hunan Province, Chine, résidant à l'adresse suivante:

804, Building 14, HepingliBeijie, Dongcheng District, Beijing, Chine, en tant que nouvel administrateur de catégorie B de
la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se
tiendra en l'année 2020.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Guangrong HAN, administrateur de catégorie A
- Monsieur Lijian SONG, administrateur de catégorie B
- Monsieur Sheng WANG, administrateur de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Hiwinglux S.A.
Signature

Référence de publication: 2015185913/23.
(150207546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Hakogel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 39.959.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2015

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Paul Haspeslagh, administrateur de sociétés, de-

meurant au 142, Zwevezeelstraat à B-8851 Aardooie-Koolskamp, de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 40, avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg, et de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social au 40, avenue Monterey à
L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social
40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2015.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015185915/18.
(150207743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

HFB Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 10A, rue Henri M.Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 84.740.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire à Luxembourg le 30 septembre 2015

Acceptation de la démission de Monsieur Vincent Tucci, Madame Filippa Raulet et Monsieur Eriks Martinovskis de

leur fonction d'Administrateurs avec effet au 30 septembre 2015.

Nomination d'un administrateur unique Keystone Mercantil LTD, ayant son siège social au 101, 1 1/2 Miles Northern

Highway, Belize City, immatriculée au RCS de Belize 150.505, pour une durée de trois ans avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8268

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015185917/15.
(150207609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Innovation cluster 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4354 Esch-sur-Alzette, 29, rue Henri Koch.

R.C.S. Luxembourg B 159.335.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s'est tenue le 3/11/2015 à 14.30 au

<i>siège social de la société Innovation cluster 1 S.à r.l.

Les associés décident de transférer le siège social actuel vers le L-4354 Esch-sur-Alzette, 29, Rue Henri KOCH renou-

veler les mandats:

Fait à Esch-sur-Alzette, le 3/11/2015.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Innovation cluster 1 S.à r.l.
Société Anonyme
Robert SCHINTGEN
<i>Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2015185919/17.
(150207582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Insulation Operations Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 71.430.397,20.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 176.500.

Par résolutions signées en date du 10 novembre 2015, l'associé unique a décidé d'accepter la démission d'Isabelle Arker,

avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet
au 30 octobre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185920/13.
(150207593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Immobilière Vauban S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 84.633.

Les décisions suivantes ont été approuvées et ratifiées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

Société qui s'est tenue en date du 9 novembre 2015:

- L'acceptation de résignation de Monsieur Jean-Jacques Josset en tant que administrateur de la Société effectif à partir

du 1 

er

 novembre 2015;

- Nomination de Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, né le 3 avril 1973 à Rennes, France, et

demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que administrateur de la Société
effectif à partir de 1 

er

 novembre 2015 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017;

- Nomination de Monsieur Christiaan Frederik van Arkel, né le 21 mars 1973 à Bangkok, Thaïlande, et demeurant

professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que administrateur de la Société effectif
à partir de 1 

er

 novembre 2015 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017;

- Confirmation que le conseil d'administration de la Société est désormais composé par les administrateurs suivants:
* Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, administrateur et Président du Conseil d'Administration;
* Monsieur Jacob Mudde, administrateur;
* Monsieur Gérald Olivier David Welvaert, administrateur;
* Monsieur Fabrice Michel Gilles Mas, administrateur;
* Monsieur Fabrice Stéphane Rota, administrateur;
* Monsieur Christiaan Frederik van Arkel, administrateur et

8269

L

U X E M B O U R G

* Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Immobilière Vauban S.A.
Jack Mudde
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015185924/31.
(150206927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

J.Y.C. Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 39, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 201.196.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 13/11/2015 a approuvé, avec effet immédiat:
- la révocation de Monsieur Jean GOFFIN, domicilié Rue du Vieux Mayeur, 5, B-400 LIEGES (Belgique) de son mandat

de gérant technique

- la nomination de Monsieur Jerry HOUBEN, né le 19/02/1965 à Liège, domicilié Allée du Hêtre pourpre, 2, B-4121

Neuville-En-Condroz (Belgique) en tant que gérant technique

D'autre part, l'assemblée générale confirme les mandats des deux gérants pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour J.Y.C. LUX S.à r.l.
Vincent VRANCKEN

Référence de publication: 2015185926/17.
(150207651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Jewel HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 646.530,58.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 173.021.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 20 octobre 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 28 août 2015;

2. Nomination de Jessica Camilleri, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185927/15.
(150207500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 185.588.625,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.605.

Veuillez prendre note du changement suivant:
Riccardo Masera, gérant de la Société, a désormais pour adresse professionnelle Plot no 2334, C5V-020 Jumeirah Park,

Dubai, les Émirats arabes unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8270

L

U X E M B O U R G

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings S.à r.l.
Jacob Mudde
<i>Gérant

Référence de publication: 2015185931/14.
(150207742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

KRS Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.403.540,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 105.796.

En date du 10 novembre 2015, la société Fitrus Limited, domiciliée au PO BOX 873, Road Town, Tortolla (Iles Vierges

Britanniques), a cédé 215.000 parts sociales à la société Canela Commercial Corp., domiciliée au Plaza 2000, 16 

th

 Floor,

50 

th

 Street, 0816-01098 Panama City (Panama) enregistrée au registre de Commerce du Panama sous le numéro 367712.

Dès lors, l'actionnariat est réparti de la façon suivante suite à ce transfert:

Associé

Parts sociales

Inversiones Tenor Limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.354 parts sociales
Canela Commercial Corp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.000 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015185935/18.
(150207631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Langton Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 172.912.

<i>Extrait de résolution de l’associé unique de la société

L'associé unique a pris la décision suivante:
La confirmation de la démission de Finsbury Corporate Services Ltd, ayant son domicile à 50 Town Range, Gibraltar,

avec effet du 12 novembre 2015, de ses fonctions de gérant.

Le conseil de gérance se constitue donc avec effet au 12 novembre 2015 du gérant unique, Gentoo Corporate Services

SARL.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Gentoo Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétés

Référence de publication: 2015185943/18.
(150207644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Le Premier Investment III S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 123.285.

EXTRAIT

La Société prend acte que le nom de Madame Marina LEBRUN, membre du conseil de surveillance de la Société est

modifié en Madame Marina KERNEUR.

De plus, il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société en date du 30

octobre 2015 que:

1. Le mandat de Monsieur Patrick MOINET et Madame Corine CHATY, en tant que membre du conseil de surveillance

de la Société, n'a pas été renouvelé.

2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que membre du conseil de surveillance de la Société et ce jusqu'à

l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui se tiendra en 2016:

8271

L

U X E M B O U R G

- Madame Katia CAMBON, née le 24 mai 1972 à Le Raincy (France), demeurant professionnellement au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, en tant que commissaire; et

- Madame Delphine BOSENDORF, née le 28 mars 1980 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 16,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en tant que commissaire.

3. Le mandat de Madame Marina KERNEUR, en tant que membre du conseil de surveillance de la Société, a été renouvelé

jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185946/25.
(150207628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Le Premier Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 98.715.

EXTRAIT

La Société prend acte que le nom de Madame Marina LEBRUN, membre du conseil de surveillance de la Société est

modifié en Madame Marina KERNEUR.

De plus, il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société en date du 30

octobre 2015 que:

1. Le mandat de Monsieur Patrick MOINET et Madame Corine CHATY, en tant que membre du conseil de surveillance

de la Société, n'a pas été renouvelé.

2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que membre du conseil de surveillance de la Société et ce jusqu'à

l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui se tiendra en 2016:

- Madame Katia CAMBON, née le 24 mai 1972 à Le Raincy (France), demeurant professionnellement au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, en tant que commissaire; et

- Madame Delphine BOSENDORF, née le 28 mars 1980 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 16,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en tant que commissaire.

3. Le mandat de Madame Marina KERNEUR, en tant que membre du conseil de surveillance de la Société, a été renouvelé

jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185947/25.
(150207662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Le Premier Sirocco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 129.469.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale annuelle de la Société du 30 octobre 2015 que:
(i)  La  démission  de  Monsieur  Philippe  Salpetier  avec  effet  au  31  octobre  2014  en  tant  que  membre  du  conseil  de

surveillance de la Société a été acceptée.

(ii) Les mandats de Monsieur Patrick Moinet et de Madame Corine Chaty en tant que membres du conseil de surveillance

de la Société n'ont pas été renouvelés.

(iii) Les personnes suivantes ont été nommées, en tant que membres du conseil de surveillance de la Société avec effet

immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:

- Madame Katia Cambon, née le 24 mai 1972 à Le Raincy (France) et résidant professionnellement au 16 avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg;

- Madame Delphine Bosendorf, née le 28 mars 1980 à Messancy (Belgique) et résidant professionnellement au 16 avenue

Pasteur L-2310 Luxembourg;

- Madame Marina Kerneur, née le 19 juin 1978 à Ploemeur (France) et résidant professionnellement au 16 avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg.

8272

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185949/23.
(150207572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Luxembourg Investment Company 80 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 199.052.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 09 novembre 2015:
- Ancienne situation associée:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l: 12.500 parts sociales
- Nouvelle situation associée:

Parts

sociales

Publity Real Estate Opportunity Services, R.C.S. Luxembourg B187131, avec siège social
à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Luxembourg, le 16.11.2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Luxembourg Investment Company 80 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015185952/20.
(150207716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Luxembourg Investment Company 81 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 198.991.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 09 novembre 2015:
- Ancienne situation associée:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l: 12.500 parts sociales
- Nouvelle situation associée:

Parts

sociales

Publity Real Estate Opportunity Services, R.C.S. Luxembourg B187131, avec siège social à L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Luxembourg, le 16.11.2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Luxembourg Investment Company 81 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015185953/20.
(150207729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

La Sablière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 164.434.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle en date du 10 novembre 2015

La dénomination du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie Sàrl, ayant son siège au

63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a changé en ACCOUNTIS S.à r.l. Dès lors, il y a lieu de procéder à la modification
auprès du RCS.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8273

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
LA SABLIÈRE S.A.

Référence de publication: 2015185954/14.
(150207754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Muguet Financière Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.039.

<i>Résolutions prises lors du conseil d'administration du 19 octobre 2015:

- Le siège de la société a été transféré au Building Serenity - Bloc A 2 

ème

 étage, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen

avec effet au 19 octobre 2015.

- L'adresse des administrateurs A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S.L.

sous le numéro B127330, Ingrid Hoolants, née le 28/11/1968 à Vilvorde (Belgique) et TAXIOMA s.à r.l., inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro B128542 a été également modifiée. Leur adresse exacte est fixée au Building Serenity - Bloc A

ème

 étage, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen à partir du 19 octobre 2015.

- L'adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la gérante et représentante permanente de la société A&amp;C

MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, a été fixée
au Building Serenity - Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen à partir du 19 octobre 2015.

- L'adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la gérante et représentante permanente de la société TAXIOMA

s.à r.l., inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, a été fixée au Building Serenity - Bloc A, 19-21 Route d'Arlon,
L-8009 Strassen à partir du 19 octobre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185967/21.
(150207465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Michelle Participations Mobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 87.006.

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.
Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Le 10 novembre 2015.

Marc Koeune.

Référence de publication: 2015185975/10.
(150207432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Michelle Participations Mobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 87.006.

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.
Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Le 10 novembre 2015.

Michael Zianveni.

Référence de publication: 2015185977/10.
(150207432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Nivelcom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 104.663.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue le

12 novembre 2015 que:

Le siège social de la société est transféré du 1, place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945

Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8274

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015185998/16.
(150207519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Ogcrew S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 176.947.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «OGCREW

S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 4 novembre 2015, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25701.

- que la société «OGCREW S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 10B, rue des

Mérovingiens, L-8070 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le
numéro 176 947,

constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 29 avril 2013, lequel acte fut publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 22 juin 2013, sous le numéro 1488,

se trouve à partir de la date du 4 novembre 2015 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 12 octobre 2015 aux termes de laquelle la

Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social

de la Société dissoute, en l'occurrence au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186003/26.
(150207583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Private Equity International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.348.

Il résulte qu'en date du 16 octobre 2015 M. Franco Vivaldi a donné sa démission de sa fonction d'administrateur de

Private Equity International S.A. avec effet à la même date.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Private Equity International S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015186007/14.
(150207653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

PHM Topco 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 198.657.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales, signé en date du 12 novembre 2015, que la société Pamplona Capital

Partners I LP, ayant son siège social à 94, Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 Grand Cayman, Iles Caïmanes a cédé
un million deux cents cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société qu'elle détenait, à Pamplona Capital Partners
III LP, ayant son siège social à 94, Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 Grand Cayman, Iles Caïmanes et immatriculée
au Registrar of Exempted Limited Partnership sous le numéro QH-49170 de sorte que, suite à ce transfert:

- Pamplona Capital Partners I LP, précitée, ne détient désormais aucune part sociale de la Société;

8275

L

U X E M B O U R G

- Pamplona Capital Partners III LP précitée, détient désormais un million deux cents cinquante mille (1.250.000) parts

sociales de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2015.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015186010/19.
(150207792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

CitCor Franconia Berlin VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 130.171.

In the year two thousand fifteen, on the thirtieth day of the month of October,
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

1) Deutsche Annington Holdings Eins GmbH, a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung") under the laws of Germany having its registered address at Philippstraße 3, D-44803 Bochum, Germany, and being
registered with the Commercial Register of the Local Court of Düsseldorf under number HRB 56191, as holder of three
million eight hundred eighty-nine thousand six hundred twenty-seven (3,889,627) shares of the Company (as defined below)
(the "Shareholder 1"), and

2) ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, a private limited liability company ("Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung") under the laws of Germany having its registered address at Tölzer Straße 15, D-82031 Grünwald,
Germany, and being registered with the Commercial Register of the Local Court of Munich under number HRB 216679,
as holder of two hundred nine thousand thirty-two (209,032) shares of the Company (as defined below) (the "Shareholder
2" and, together with Shareholder 1, the "Shareholders").

The Shareholders were represented by Mrs Meryl Herat, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy

of Luxembourg), by virtue of two proxies given under private seal. The said proxies, after having been initialled and signed
"ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be appended to the present deed for the purpose of
registration to be submitted together with it to the registration authorities.

The Shareholders, represented as above stated, declared to be all the shareholders of CitCor Franconia Berlin VI S.à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of four million ninety-eight thousand six hundred fifty nine euro (EUR
4,098,659.-), pursuant to a notarial deed passed on 9 July 2007 before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxem-
bourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1953 on
12 September 2007, having its registered office at 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg) under number B 130171 (the "Company"). The articles of association have last been amended by Maître
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 28 January 2008 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1024 of 25 April 2008. The Shareholders declared and asked the notary to record as follows:

(I) The Shareholders hold all the four million ninety-eight thousand six hundred fifty-nine (4,098,659) shares in issue

of the Company and thus the entire issued share capital of the Company is presented or represented;

(II) The decisions are to be passed based on the following agenda:
1. To acknowledge that the losses of the Company as shown in the interim accounts of the Company as at 30 September

2015 (the "Interim Accounts") are equal to an amount of three million two hundred sixteen thousand nine hundred eighty-
two euro and twenty-six cents (EUR 3,216,982.26) (the "Losses").

2. To decrease the share capital of the Company by an amount of three million two hundred sixteen thousand nine

hundred eighty-three euro (EUR 3,216,983) so as to decrease it from its present amount of four million ninety-eight thousand
six hundred fifty-nine euro (EUR 4,098,659) to eight hundred eighty-one thousand six hundred seventy-six euro (EUR
881,676) by means of the cancellation of three million two hundred sixteen thousand nine hundred eighty-three (3,216,983)
shares, having each a par value of one euro (EUR 1), in order to absorb the Losses.

3. To decrease the share capital of the Company by an amount of eight hundred fifty-six thousand six hundred seventy-

six euro (EUR 856,676) so as to decrease it from eight hundred eighty-one thousand six hundred seventy-six euro (EUR
881,676) to twenty-five thousand euro (EUR 25,000) by means of the cancellation of eight hundred fifty-six thousand six
hundred seventy-six (856,676) shares, having each a par value of one euro (EUR 1), and the allocation of such amount to
a free reserve account;

4. To amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company to reflect the above changes;

8276

L

U X E M B O U R G

5. To change the nationality of the Company and to transfer the registered office, the central administration and the

effective seat of management of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Federal Republic of Germany,
in conformity with article 199 of the law of August 10, 1915 on commercial companies on the basis of the Interim Accounts,
subject to the extraordinary decision of the shareholders of the Company resolving upon such transfer to be passed before
a German notary in accordance with German law and the registration of the Company in the German commercial register
(Handelsregister);

6. In consequence of the preceding item 5 of this agenda, to approve the conversion of the Company into a Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (a private limited liability company) under German law and the change of the name of the
Company to Vonovia Elbe Berlin VI GmbH, without the dissolution of the Company, nor the incorporation of a new
company, neither from a legal point of view nor from a tax point of view, subject to the extraordinary decision of the
shareholders of the Company resolving upon such transfer to be passed before a German notary in accordance with German
law and the registration of the Company in the German commercial register (Handelsregister);

7. To fix the registered seat of the Company at Nuremberg, Germany, and the registered address of the Company at

Philippstraße 3, D-44803 Bochum, Germany;

8. To acknowledge that Mr. Thomas Görgemanns and Mr. Mark Ennis shall remain managers of the Company further

to its conversion into a Gesellschaft mit beschränkter Haftung under German law;

9. To confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Luxembourg nationality, without

limitation, will remain in the ownership in their entirety of the Company maintained without discontinuance, which will
continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (previously of Luxembourg nationality);

10. Miscellaneous.
Thereupon, the Shareholders passed unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders acknowledged that the Losses as shown in the Interim Accounts are equal to an amount of three million

two hundred sixteen thousand nine hundred eighty-two euro and twenty-six cents (EUR 3,216,982.26).

The Interim Accounts, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned

notary, will be appended to the present deed for the purpose of registration to be submitted together with it to the registration
authorities.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of three million two hundred

sixteen thousand nine hundred eighty-three euro (EUR 3,216,983-) so as to decrease it from its present amount of four
million ninety-eight thousand six hundred fifty-nine euro (EUR 4,098,659.-) to eight hundred eighty-one thousand six
hundred seventy-six euro (EUR 881,676.-) by means of the cancellation of three million two hundred sixteen thousand
nine hundred eighty-three (3,216,983) shares held by the Shareholders, having each a par value of one euro (EUR 1.-), in
order to absorb the Losses. Such share capital decrease shall have immediate effect.

<i>Third resolution

The Shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of eight hundred fifty-six thousand

six hundred seventy-six euro (EUR 856,676.-) so as to decrease it from eight hundred eighty-one thousand six hundred
seventy-six euro (EUR 881,676.-) to twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) by means of the cancellation of eight
hundred fifty-six thousand six hundred seventy-six (856,676) shares held by the Shareholders, having each a par value of
one euro (EUR 1.-), and the allocation of such amount to a free reserve account. Such share capital decrease shall have
immediate effect.

The twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one euro (EUR 1) each are held as follows:
1) Deutsche Annington Holdings Eins GmbH, prenamed, twenty-three thousand seven hundred twenty four (23,724)

shares, and

2) ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, prenamed, one thousand two hundred seventy-six (1,276) sha-

res.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholders resolved to amend the first paragraph of article six of the articles

of association of the Company so as to read as follows:

Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) represented by twenty-five

thousand (25,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each."

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolved to change the nationality of the Company and to transfer the registered office, the central

administration and the effective seat of management of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Federal

8277

L

U X E M B O U R G

Republic of Germany, in conformity with article 199 of the law of August 10, 1915 on commercial companies on the basis
of the Interim Accounts subject to the extraordinary decision of the shareholders of the Company resolving upon such
transfer to be passed before a German notary in accordance with German law and the registration of the Company in the
commercial register (Handelsregister) of Nuremberg (Germany).

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolved to convert the Company into a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (a private limited

liability company) under German law and change the name of the Company to Vonovia Elbe Berlin VI GmbH, without
the dissolution of the Company, nor to the incorporation of a new company, neither from a legal point of view nor from a
tax point of view, subject to the extraordinary decision of the shareholders of the Company resolving upon such transfer
to be passed before a German notary in accordance with German law and the registration of the Company in the commercial
register (Handelsregister) of the local court of Nuremberg (Germany).

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolved to fix the registered seat of the Company at Nuremberg (Germany) and the registered address

of the Company at Philippstraße 3, D-44803 Bochum, Germany, subject to the extraordinary decision of the shareholders
of the Company to be held before a German notary as referred to under the sixth resolution and the registration of the
Company in the commercial register (Handelsregister) of the local court of Nuremberg (Germany).

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolved to acknowledge that Mr. Thomas Görgemanns and Mr. Mark Ennis shall remain managers

of the Company further to its conversion into a Gesellschaft mit beschränkter Haftung under German law.

<i>Ninth resolution

The Shareholders resolved to confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Luxembourg

nationality, without limitation, will remain in the ownership in their entirety of the Company maintained without discon-
tinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments
of the Gesellschaft mit beschränkter Haftung (previously of Luxembourg nationality), subject to the extraordinary decision
of the shareholders of the Company to be held before a German notary as referred to under the sixth resolution and the
registration of the Company in the commercial register (Handelsregister) of the local court of Nuremberg (Germany).

<i>Tenth resolution

The Shareholders resolved to authorise and empower any lawyer of NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l., any clerk

of the undersigned notary, any lawyer of Noerr LLP and any clerk of the instrumenting German notary, each acting indi-
vidually on behalf of the Company, and with full power of substitution, to perform and take any actions necessary in
Luxembourg and Germany respectively with respect to the de-registration of the Company from the Luxembourg Trade
and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) and the registration of the transfer with the
commercial register (Handelsregister) of the local court of Nuremberg (Germany).

There being no further items on the agenda, this extraordinary shareholders' decision was thereupon closed.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated

at two thousand four hundred euro (EUR 2,400.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing parties

hereto, this deed is drafted in English, followed by a German translation. At the request of the same appearing parties, in
case of divergences between the English and the German version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day herebefore mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by the surname, name,

civil status and residence, the said person signed together with us, the notary, the present original deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am dreißigsten Tag des Monats Oktober,
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Es sind erschienen:

1) Deutsche Annington Holdings Eins GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen der Bun-

desrepublik Deutschland mit Gesellschaftssitz in der Philippstraße 3, D-44803 Bochum, Bundesrepublik Deutschland,
eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  Düsseldorf  (Bundesrepublik  Deutschland)  unter  der  Nummer  HRB

8278

L

U X E M B O U R G

56191, als Inhaber von drei Millionen achthundert neunundachzigtausend sechshundert siebenundzwanzig (3.889.627)
Anteilen an der Gesellschaft (wie weiter unten bezeichnet) (der “Gesellschafter 1”), und

2) ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen

der  Bundesrepublik  Deutschland  mit  Gesellschaftssitz  in  der  Tölzer  Straße  15,  D-82031  Grünwald,  Bundesrepublik
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht München (Bundesrepublik Deutschland) unter der Nummer
HRB 216679, als Inhaber von zweihundert neuntausend zweiunddreißig (209.032) Anteilen an der Gesellschaft (wie weiter
unten bezeichnet) (der "Gesellschafter 2" und, zusammen mit dem Gesellschafter 1, die "Gesellschafter")

Die Gesellschafter werden hiermit durch Frau Meryl Herat, Juristin, vertreten, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg gemäß zweier privatschriftlichen Vollmachten. Diese Vollmachten werden, nachdem sie pa-
raphiert und ne varietur durch die Bevollmächtigte und die Notarin gegengezeichnet wurden, zum Zwecke der Eintragung
dieser Urkunde beigefügt, sodass sie zusammen mit ihr der Registrierungsbehörde vorgezeigt werden können.

Die Gesellschafter, vertreten wie zuvor erwähnt, sind sämtliche Gesellschafter von der CitCor Franconia Berlin VI S.à

r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), mit einem
Stammkapital in Höhe von vier Millionen achtundneunzigtausend sechshundert neunundfünfzig Euro (EUR 4.098.659,-)
mit Gesellschaftssitz in 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und unter der Nummer B
130171 im Luxemburger Firmen- und Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) eingetragen (die "Gesell-
schaft" ), die infolge eines am 9. Juli 2007 durchgeführten notariellen Urkunde von Maître Henri Hellinckx, einem in
Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) ansässigen Notar, gegründet wurde. Die notarielle Gründungsurkunde der Ge-
sellschaft wurde im Amtsblatt des Großherzogtum Luxemburgs (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) unter
der Nummer 1953 am 12. September 2007 veröffentlicht. Die Gesellschaftssatzung wurde zuletzt am 28. Januar 2008 durch
eine notarielle Ukunde von Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sanem, geändert und im zuvor erwähnten
Amtsblatt des Großherzogtum Luxemburg unter der Nummer 1024 am 25. April 2008 veröffentlicht. Die Gesellschafter
erklären Folgendes und bitten die Notarin dies wie folgt zu beurkunden:

(I) Die Gesellschafter halten zusammen insgesamt alle vier Millionen achtundneunzigtausend sechshundert neunund-

fünfzig (4.098.659) Anteile der Gesellschaft und somit ist das gesamte Stammkapital der Gesellschaft anwesend oder
vertreten;

(II) Die Gesellschafter werden auf Basis der folgenden Tagesordnung die nachstehenden Beschlüsse fassen:
1. Bestätigung, dass sich die Verluste der Gesellschaft, auf drei Millionen zweihundert sechszehntausend neunhundert

zweiundachtzig Euro und sechsundzwanzig Cents (EUR 3.216.982,26) erheben (die "Verluste") wie aus den Zwischen-
konten der Gesellschaft vom 30. September 2015 ("die "Zwischenkonten") ersichtlich ist;

2. Beschluss über die Reduzierung des Gesellschaftskapitals in Höhe von drei Millionen sechszehntausend neunhundert

dreiundachtzig Euro (EUR 3.216.983,-) von vier Millionen achtundneunzigtausend sechshundert neunundfünfzig Euro
(EUR 4.098.659,-) auf achthundert einundachtzigtausend sechshundert sechsundsiebzig Euro (EUR 881.676,-) durch die
Auflösung von drei Millionen sechszehntausend neunhundert dreiundachtzig (3.216.983) Gesellschaftsanteilen, mit einem
Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), um die Verluste der Gesellschaft einzudämmen;

3. Beschluss über die Reduzierung des Gesellschaftskapitals in Höhe von achthundert sechsundfünfzigtausend sechs-

hundert sechsundsiebzig Euro (EUR 856.676,-) von achthundert einundachtzigtausend sechshundert sechsundsiebzig Euro
(EUR 881.676,-) auf fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) durch die Auflösung von achthundert sechsundfünf-
zigtausend sechshundert sechsundsiebzig (856.676) Gesellschaftsanteilen, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR
1,-), um diesen Betrag einem freien Rücklagenkonto zuzuordnen;

4. Änderung des ersten Absatzes von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung um die zuvor genannten Änderungen wider-

zuspiegeln;

5. Änderung der Nationalität der Gesellschaft, der Transfer des Gesellschaftssitzes, der Hauptverwaltung sowie des

tatsächlichen  Sitzes  der  Geschäftsführung  der  Gesellschaft  vom  Großherzogtum  Luxemburg  in  die  Bundesrepublik
Deutschland im Einklang mit Artikel 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, basierend auf
den  Zwischenkonten  und  vorbehaltlich  eines  vor  einem  deutschen  Notar  gefassten  außerordentlichen  Beschlusses  der
Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über diesen Transfer und der Eintragung der Gesellschaft in das
deutsche Handelsregister;

6. Als Schlussfolgerung aus dem vorangegangenen Punkt 5, die Zustimmung zur Umwandlung der Gesellschaft in eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht und der Namensänderung in Vonovia Elbe Berlin VI GmbH
ohne Auflösung der Gesellschaft beziehungsweise ohne Gründung einer neuen Gesellschaft, weder in rechtlicher noch
steuerlicher  Hinsicht  und  vorbehaltlich  eines  vor  einem  deutschen  Notar  gefassten  außerordentlichen  Beschlusses  der
Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über diesen Transfer und der Eintragung der Gesellschaft in das
deutsche Handelsregister;

7. Festlegung des Gesellschaftssitzes auf Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland, und der Geschäftsadresse auf Phi-

lippstraße 3, D-44803 Bochum, Bundesrepublik Deutschland;

8. Bestätigung der Bestellung von Herrn Thomas Görgemanns und Herrn Mark Ennis als Geschäftsführer der Gesell-

schaft nach ihrer Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht;

8279

L

U X E M B O U R G

9. Bestätigung des Verbleibs aller Aktiva und Passiva (ohne Beschränkung und vollumfänglich) der ehemals luxem-

burgischen Gesellschaft bei der ununterbrochen bestehenden Gesellschaft, die weiterhin Inhaberin aller Aktiva sein wird
und durch die bereits eingegangenen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der ehemals luxemburgischen Gesellschaft
ebenso verpflichtet und gebunden ist;

10. Verschiedenes.
Daraufhin erbitten die Gesellschafter die unterzeichnende Notarin die folgenden Beschlüsse zu dokumentieren, die

einstimmig gefasst wurden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen, dass sich die Verluste der Gesellschaft auf drei Millionen zweihundert sechszehntausend

neunhundert zweiundachtzig Euro und sechsundzwanzig Cents (EUR 3.216.982,26) erheben, wie aus den Zwischenkonten
ersichtlich ist.

Diese Zwischenkonten, nachdem sie paraphiert und ne varietur durch die Bevollmächtigte und die Notarin gegenge-

zeichnet wurden, zum Zwecke der Eintragung dieser Urkunde beigefügt, sodass sie zusammen mit ihr der Registrierungs-
behörde vorgezeigt werden können.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Reduzierung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft in Höhe von drei Millionen

sechszehntausend neunhundert dreiundachtzig Euro (EUR 3.216.983,-) von vier Millionen achtundneunzigtausend sechs-
hundert neunundfünfzig Euro (EUR 4.098.659,-) auf achthundert einundachtzigtausend sechshundert sechsundsiebzig Euro
(EUR 881.676,-) durch die Auflösung von drei Millionen sechszehntausend neunhundert dreiundachtzig (3.216.983) von
den Gesellschaftern gehaltenen Gesellschaftsanteilen, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), um die Verluste
der Gesellschaft einzudämmen. Diese Kapitalreduzierung entfaltet unmittelbare Wirkung.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Reduzierung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft in Höhe von achthundert

sechsundfünfzigtausend  sechshundert  sechsundsiebzig  Euro  (EUR  856.676,-)  von  achthundert  einundachtzigtausend
sechshundert sechsundsiebzig Euro (EUR 881.676,-) auf fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) durch die Auflö-
sung von achthundert sechsundfünfzigtausend sechshundert sechsundsiebzig (856.676) von den Gesellschaftern gehaltenen
Gesellschaftsanteilen, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), um diesen Betrag einem freien Rücklagenkonto
zuzuordnen. Diese Kapitalreduzierung entfaltet unmittelbare Wirkung.

Die fünfundzwanzigtausend (25.000) Gesellschaftsanteile, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), werden

wie folgt gehalten:

1)  Deutsche  Annington  Holdings  Eins  GmbH,  vorgenannt,  dreinundzwanzigtausend  siebenhundert  vierundzwanzig

(23.724) Gesellschaftsanteile, und

2) ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, vorgenannt, eintausend zweihundert sechsundsiebzig (1.276)

Gesellschaftsanteile.

<i>Vierter Beschluss

Infolgedessen beschließen die Gesellschafter, den ersten Absatz vom Artikel 6 der Gesellschaftssatzung wie folgt zu

ändern, um die zuvor genannten Änderungen widerzuspiegeln:

„ Art. 6. Das Kapital wird auf fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) festgesetzt, unterteilt in fünfundzwanzig-

tausend (25.000) Geschäftsanteile zu je ein Euro (EUR 1,-).”

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern und den Gesellschaftssitz, die Hauptver-

waltung  sowie  den  tatsächlichen  Sitz  der  Geschäftsführung  der  Gesellschaft  vom  Großherzogtum  Luxemburg  in  die
Bundesrepublik Deutschland zu verlegen im Einklang mit Artikel 199 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften, basierend auf den Zwischenkonten und vorbehaltlich eines vor einem deutschen Notar ge-
fassten außerordentlichen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über diese Umwandlung
und der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg (Deutschland).

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach

deutschem Recht und der Namensänderung in Vonovia Elbe Berlin VI GmbH ohne Auflösung der Gesellschaft bezie-
hungsweise ohne Gründung einer neuen Gesellschaft, weder in rechtlicher noch steuerlicher Hinsicht, zuzustimmen und
vorbehaltlich eines vor einem deutschen Notar gefassten außerordentlichen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft
nach deutschem Recht über diese Umwandlung und der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsge-
richtes Nürnberg (Deutschland).

8280

L

U X E M B O U R G

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftssitz auf Nürnberg (Deutschland) und die Geschäftsadresse auf Phi-

lippstraße 3, D-44803 Bochum, Bundesrepublik Deutschland, festzulegen, vorbehaltlich eines vor einem deutschen Notar
gefassten außerordentlichen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über die Umwandlung
der Gesellschaft entsprechend des Sechsten Beschlusses und der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des
Amtsgerichtes Nürnberg (Deutschland).

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, Herrn Thomas Görgemanns und Herrn Mark Ennis weiterhin als Geschäftsführer der

Gesellschaft, nach ihrer Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht zu bestellen.

<i>Neunter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Verbleib aller Aktiva und Passiva (ohne Beschränkung und vollumfänglich) der

ehemals luxemburgischen Gesellschaft bei der ununterbrochen bestehenden Gesellschaft, die weiterhin Inhaberin aller
Aktiva sein wird und durch die bereits eingegangenen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der ehemals luxemburgi-
schen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ebenso verpflichtet und gebunden ist, vorbehaltlich eines vor einem deutschen
Notar gefassten außerordentlichen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über diese Um-
wandlung  entsprechend  des  Sechsten  Beschlusses  und  der  Eintragung  der  Gesellschaft  in  das  Handelsregister  des
Amtsgerichtes Nürnberg (Deutschland), zu bestätigen.

<i>Zehnter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, einen jeden Rechtsanwalt von NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l., jeden Ange-

stellten der unterzeichnenden Notarin, jeden Rechtsanwalt von Noerr LLP und jeden Angestellten des beurkundenden
deutschen Notars, zu beauftragen und zu bevollmächtigen, jeder einzeln und mit der Vollmacht, im Namen der Gesellschaft
handelnd,  sämtliche  in  Deutschland  bzw.  im  Großherzogtum  Luxemburg  notwendigen  Handlungen  und  Formalitäten
durchzuführen die Löschung aus dem Luxemburger Handelsregister betreffend (Registre de Commerce et des Sociétés)
sowie die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg (Deutschland) zu vollziehen und durchzuführen.

Da über keine weiteren Punkte der Tagesordnung zu entscheiden ist, wird die Gesellschafterversammlung geschlossen.

<i>Ausgaben

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die zu Lasten der Gesellschaft aufgrund dieser

Urkunde entstehen, werden auf ungefähr zweitausendvierhundert Euro (EUR 2.400.-) geschätzt.

<i>Erklärung

Die amtierende Notarin, die Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest, dass auf Anfrage der erschienenen Parteien

diese Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde. Auf Antrag selbiger Parteien soll im
Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version Vorrang haben.

Woraufhin die vorliegende Urkunde am vorherig erwähnten Datum von der unterzeichnenden Notarin in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Nach  Vorlesung  und  Erläuterung  der  Urkunde  gegenüber  der  erschienenen  Bevollmächtigten,  die  der  Notarin  mit

Nachnamen, Vornamen, Personenstand und vom Sitz her bekannt ist, hat zusammen mit der beurkundenden Notarin jene
gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Herat, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/34832. Reçu soixante-quinze

(75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 10. November 2015.

Référence de publication: 2015182909/312.
(150204020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Cersanit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.349.

In the year two thousand and fifteen, on the third day of November,
before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

8281

L

U X E M B O U R G

Rovese Spolka Akcyjna, a company with registered office at Al. Solidarnosci 36, PL-25-323 Kielce, Poland (the “Sole

Shareholder”);

here represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal on October 27, 2015;

which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party

and the undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all of the five hundred (500) ordinary shares having a nominal value of twenty-five Euros

(EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid up, representing the entirety of the share capital of the company Cersanit
Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg  Register  of  Commerce  and  Companies  under  number  B  116.349  (the  “Company”).  The  Company  has  been
incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on May
9, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1373 dated July 17, 2006. The articles
of association of the Company (the “Articles”) have then been amended since its incorporation pursuant to a deed of the
undersigned notary, on April 9, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1461
dated June 10, 2015.

II. The agenda of the Meeting is as follows:
1) Waiver of convening notices;
2) Amendment to and restatement of article 12 of the Articles; and
3) Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the

following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the Sole

Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Meeting resolves to amend and fully restate article 12 of the Articles,

which shall henceforth have the following wording:

“ Art. 12. The Company is administered by one or more managers. The managers need not to be partners. The managers

may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this
article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of board of managers.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of all the managers.
The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several member of the board of managers.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
However, any transactions conducted on behalf of the Company, the value of which exceeds the amount of EUR 60.000,-

(in words: sixty thousand Euros) shall require the prior approval of the single partner or the partners of the Company (as
the case may be) acting in general meeting.

The board of managers of the Company shall only be entitled to undertake only such transactions that fall below the

amount of EUR 60.000,- (sixty thousand Euros).

Regardless of the value of the contemplated transaction as set out in the present article, the following actions shall require

the prior approval of the single partner or the partners of the Company (as the case may be) acting in general meeting:

a) The provision by the Company of any guarantees and charges of any kind and form as well as any other kind of

encumbrances on the immovable property and on any other kind of assets of the Company, as well as the issuance of
promissory notes;

b) The subscription for, acquisition and disposal of the shares and other kind of participatory interests in the Company

or any other entities;

c) The raising or grant of credit of any kind by the Company;
(d) The issuance or grant or creation of a pledge, registered pledge, mortgage or any other encumbrance of any part of

the Company’s assets;

(e) The grant of a general power of attorney for the representation of the Company.

8282

L

U X E M B O U R G

(f) entering into, amending or terminating agreements on opening or terminating bank accounts;
(g) entering into, amending or terminating any loan agreements;
(h) entering into, amending or terminating any factoring agreements;
(i) entering into, amending or terminating any cash pooling agreements;
(j) entering into, amending or terminating agreements concerning currency translation or cash deposits.
The Board of Managers may pass its resolutions in writing or using means of telecommunication, including by corres-

pondence. Members of the Board may adopt resolutions beyond the formal meetings by way of the circulation procedure,
if company`s ordinary course of business so requires. A member or members of the Board of the company may participate
in the meeting of the Board of the company by means of a telephone used for such conferences, or by video or another
system with the aid of which each member can converse with all other members, hear them and be heard by them, and such
manner of participation shall be treated as attendance at the meeting of the Board of Managers of the company. A meeting
of the board may be communicated to members via e-mail or fax.”

There being no further business, the Meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English version and the French version, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his full name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

A Comparu:

Rovese Spolka Akcyjna, une société ayant son siège social au Al. Solidarnosci 36, PL-25-323 Kielce, Pologne (l’«As-

socié Unique»)

ici représentée par Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé lui délivrée le 27 octobre 2015,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L’Associé Unique détient la totalité des 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-

cinq  euro)  chacune,  entièrement  souscrite  et  libérée  représentant  la  totalité  du  capital  social  de  la  Société  Cersanit
Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 2-8, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 116.349 (la «Société»), La Société a été constituée par acte notarié reçu par Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 9 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations sous le numéro 1373 en date du 17 juillet 2006. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont
été modifiés depuis par acte notarié reçu par le notaire instrumentant en date du 9 avril 2015, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations sous le numéro 1461 en date du 10 juin 2015.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Renonciation au droit de convocation
2) Modification et refonte de l'article 12 des statuts de la Société; et
3) Divers.
Ensuite, la partie comparante, agissant via son représentant, a requis le notaire instrumentant d’adopter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

La totalité des parts sociales étant représentée, la partie comparante renonce à son droit de convocation. L'Associé

Unique, ici représenté considère avoir été valablement convoqué et déclare avoir une connaissance parfaite des points à
l'ordre du jour qui lui ont été communiqués en avance.

8283

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, la partie comparante a décidé de modifier et de refondre l’article 12 des

statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants

sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent
article 12 aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront

de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe de tous les gérants.
Le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs membres du conseil

de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Cependant, toutes transactions effectuées au nom de la Société, pour lesquelles la valeur excèdent un montant de EUR

60,000.- (en lettres: soixante mille euros), requerra l’accord préalable de l’Associé Unique ou des Associés de la Société
(le cas échéant) réunis en assemblée générale.

Le conseil de gérance de la Société ne sera autorisé à effectuer des transactions dont les montants seront inférieurs à

EUR 60,000.- (en lettres: soixante mille euros).

Quelle que soit la valeur de la transaction envisagée telle que décrite dans le présent article, les actions suivantes l’accord

préalable de l’Associé Unique ou des Associés de la Société (le cas échéant) réunis en assemblée générale:

a) La fourniture par la Société de toutes formes de garanties et sûretés, quelles que soient leur nature, ainsi que de toutes

formes de sûretés immobilières et émission de billets a ordre;

b) La souscription en vue d’acquérir ou céder des parts sociales et toute autre prises de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans la Société ou dans d’autres personnes morales;

c) L’augmentation ou l’octroi par la Société de crédit de quelque nature que ce soit;
d) L’émission, l’autorisation ou la création de gages, de registres de gage, de prêts hypothécaires ou de toute autre sûreté

sur les biens de la Société;

e) L’attribution d’une procuration générale de représentation de la Société;
f) L’entrée, la modification ou la fin de contrats portants sur l’ouverture ou la clôture de comptes bancaires;
g) L’entrée, la modification ou la fin de tous contrats de prêt;
h) L’entrée, la modification ou la fin de tous contrats d’affacturage;
i) L’entrée, la modification ou la fin de tous contrats de centrales de trésorerie;
j) L’entrée, la modification ou la fin de tous contrats de conversion de devises ou dépôts en espèces.
Le conseil de gérance pourra prendre des résolutions par voie écrite ou au moyen de télécommunication, notamment

par correspondance. Les membres du conseil de gérance pourront prendre des résolutions indépendamment des réunions
formelles du conseil de gérance, par voie écrite circulaire si le cours des affaires le demande. Un membre ou les membres
du conseil de gérance de la société peuvent participer à la réunion du conseil de gérance de la société par conférence
téléphonique ou par visioconférence ou tout autre moyens de communication similaires de telle sorte que les gérants puissent
converser, s'entendre et être entendus les uns avec les autres et, une telle participation équivaut à une présence en personne
à une telle réunion. Le procès-verbal d’une réunion du conseil peut être communiqué aux membres du conseil par e-mail
ou fax.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est alors levée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cent Euros
(EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la comparante et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu de notaire instrumentant par son

nom, son état civil et sa résidence, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Nezar, GRETHEN.

8284

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/34841. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 10 novembre 2015.

Référence de publication: 2015182902/177.
(150204117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Skyline Residences S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diederich.

R.C.S. Luxembourg B 183.645.

In the year two thousand fifteen, on the third day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1) Amstar Poland Property Fund I, LP, a partnership registered under the laws of Cayman Islands, registered under

number 60507 with the Registrar of Limited Partnerships, having its registered office at Codan Trust Company (Cayman)
Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-111, Cayman Islands,

here duly represented by Mr. Fabrice GEIMER, employee, residing professionally in L-1420 Luxembourg, 5, avenue

Gaston Diderich, by virtue of a proxy given under private seal.

2) BBI Development SA, a joint stock company incorporated and governed by the laws of the Republic of Poland with

its seat in Warsaw, 28 Emilii Plater Street, registered in the National Court Register under the KRS number 33065.

here represented by Mr. Roberto CHIAPPALONE, employee, residing professionally in L-1420 Luxembourg, 5, avenue

Gaston Diderich, by virtue of a proxy given under private seal;

Such proxies, after having been signed “ne varietur” by the appearing persons and the officiating notary, will remain

attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties are all the shareholders of the Company (the “Shareholders”), representing the entire share capital

of Skyline Residences S.a r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office
at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under number B 183.645, incorporated pursuant to a deed of the officiating notary, on 17 De-
cember 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 610 on 7 March 2014. The articles
of association were amended for the last time pursuant to a deed of the officiating notary, dated 16 October 2014, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3599 dated 27 November 2014.

The appearing parties representing the entire share capital may validly deliberate on all the items of the following

resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to create a new sub-class of shares by the addition of a new sub-class numbered 3 into the

existing ordinary share classes of the share capital of the Company, which will from now on be comprised of:

- class A ordinary shares, including three sub-classes, class A1 shares (the “Class A1 Shares”) class A2 shares (the

“Class A2 Shares”) and class A3 shares (the “Class A3 Shares”);

- class B ordinary shares, including three sub-classes, class B1 shares (the “Class B1 Shares”) class B2 shares (the “Class

B2 Shares”) and class B3 shares (the “Class B3 Shares”);

- class C ordinary shares, including three sub-classes, class C1 shares (the “Class C1 Shares”) class C2 shares (the “Class

C2 Shares”) and class C3 shares (the “Class C3 Shares”);

- class D ordinary shares, including three sub-classes, class D1 shares (the “Class D1 Shares”) class D2 shares (the

“Class D2 Shares”) and class D3 shares (the “Class D3 Shares”);

- class E ordinary shares, including three sub-classes, class E1 shares (the “Class E1 Shares”) class E2 shares (the “Class

E2 Shares”) and class E3 shares (the “Class E3 Shares”);

- class F ordinary shares, including three sub-classes, class F1 shares (the “Class F1 Shares”) class F2 shares (the “Class

F2 Shares”) and class F3 shares (the “Class F3 Shares”);

- class G ordinary shares, including three sub-classes, class G1 shares (the “Class G1 Shares”) class G2 shares (the

“Class G2 Shares”) and class G3 shares (the “Class G3 Shares”);

- class H ordinary shares, including three sub-classes, class H1 shares (the “Class H1 Shares”) class H2 shares (the

“Class H2 Shares”) and class H3 shares (the “Class H3 Shares”);

- class I ordinary shares, including three sub-classes, class I1 shares (the “Class I1 Shares”) class I2 shares (the “Class

I2 Shares”) and class I3 shares (the “Class I3 Shares”);

8285

L

U X E M B O U R G

- class J ordinary shares, including three sub-classes, class J1 shares (the “Class J1 Shares”) class J2 shares (the “Class

J2 Shares”) and class J3 shares (the “Class J3 Shares”);

which shall have the rights set out in the articles of association of the Company as amended and restated pursuant to the

below resolutions.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to increase the Company’s share capital by an amount of twenty seven thousand two hundred

forty-six euros ninety eurocents (€27,246.90) so as to raise it from one million two hundred sixty-nine thousand seven
hundred five euro and sixty-three cent (€1,269,705.63) to the amount of one million two hundred ninety-six thousand nine
hundred fifty-two euros fifty-three eurocents (€1,296,952.53) through the issue of two millions seven hundred twenty four
thousand six hundred ninety (2,724,690) new shares of the Company with a nominal value of one cent (€0,01) each and
divided as follows:

- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class A3 shares;
- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class B3 shares;
- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class C3 shares;
- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class D3 shares;
- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class E3 shares;
- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class F3 shares;
- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class G3 shares;
- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class H3 shares;
- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class I3 shares;
- two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class J3 shares;
with a nominal value of one cent (€0,01) each (together the New Class 3 Shares)

<i>Subscription and payment

Thereupon appeared the company PROBATUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią spółka komandytowo-akcyjna

a limited joint-stock partnership incorporated and governed by the laws of the Republic of Poland with its seat in Warsaw
at Aleje Jerozolimskie 123A lok. 27, 02-017 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs held by the District Court
for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number
0000479566, with tax number NIP 7010399591,

here duly represented by Mr. Fabrice GEIMER, employee, residing professionally in L-1420 Luxembourg, 5, avenue

Gaston Diderich, by virtue of a proxy given under private seal,

which declares to subscribe to the New Class 3 Shares to have them paid-up by a contribution in cash of twenty-seven

thousand two hundred forty-six euros ninety eurocents (.27,246.90), so that this amount is as of now available to the
Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twenty seven thousand two hundred fortysix euros ninety eurocents (€27,246.90)

is allocated to the share capital of the Company.

<i>Third resolution

Inter alia as a consequence of the preceding resolution, the Shareholders decide to amend the first paragraph of article

5 of the articles of association of the Company which shall be enforced and now read as follows:

“ 5.1. The shares representing the Company’s share capital shall be divided into ten classes of shares, denominated Class

A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares,
Class I Shares and Class J Shares, each share class being subdivided into three sub-classes (a “Sub-Class” or the “Sub-
Classes”) which shall be denominated Class A1 Shares, Class A2 Shares and Class A3 Shares, Class B1 Shares, Class B2
Shares and Class B3 Shares, Class C1 Shares, Class C2 Shares and Class C3 Shares, Class D1 Shares, Class D2 Shares
and Class D3 Shares, Class E1 Shares, Class E2 Shares and Class E3 Shares, Class F1 Shares, Class F2 Shares and Class
F3 Shares, Class G1 Shares, Class G2 Shares and Class G3 Shares, Class H1 Shares, Class H2 Shares and Class H3 Shares,
Class I1 Shares, Class I2 Shares and Class I3 Shares, and Class J1 Shares, Class J2 Shares and Class J3 Shares, the Class
A1 to J1 Shares being hereafter referred to as Sub-Class 1 Shares (the “Sub-Class 1 Shares”), the Class A2 to J2 Shares
being hereafter referred to as Sub-Class 2 Shares (the “Sub-Class 2 Shares”) and the Class A3 to J3 Shares being hereafter
referred to as Sub-Class 3 Shares (the “Sub-Class 3 Shares”).

The Company’s share capital is set at one million two hundred ninety-six thousand nine hundred fifty-two euros fifty-

three eurocents (€1,296,952.53), represented by one hundred and twenty-nine million six hundred and ninety-five thousand
two hundred and fifty-three (129,695,253) shares divided as follows:

- twelve million four hundred and fifty-nine thousand (12,459,000) Class A1 Shares, two hundred and thirty-eight

thousand fifty-seven (238,057) Class A2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469)
class A3 Shares,

8286

L

U X E M B O U R G

-  twelve  million  four  hundred  and  fifty-nine  thousand  (12,459,000)  Class  B1  Shares  and  two  hundred,  thirty-eight

thousand fifty-seven (238,057) Class B2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469)
class B3 Shares,

-  twelve  million  four  hundred  and  fifty-nine  thousand  (12,459,000)  Class  C1  Shares,  two  hundred  and  thirty-eight

thousand fifty-seven (238,057) Class C2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469)
class C3 Shares,

- twelve million four hundred and fifty-nine thousand (12,459,000) Class D1 Shares, two hundred and thirty-eight

thousand fifty-six (238,056) Class D2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469)
class D3 Shares,

-  twelve  million  four  hundred  and  fifty-nine  thousand  (12,459,000)  Class  E1  Shares,  two  hundred  and  thirty-eight

thousand fifty-six (238,056) Class E2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469)
class E3 Shares

-  twelve  million  four  hundred  and  fifty-nine  thousand  (12,459,000)  Class  F1  Shares,  two  hundred  and  thirty-eight

thousand fifty-six (238,056) Class F2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469)
class F3 Shares,

- twelve million four hundred and fifty-nine thousand (12,459,000) Class G1 Shares, two hundred and thirty-eight

thousand fifty-six (238,056) Class G2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469)
class G3 Shares

- twelve million four hundred and fifty-nine thousand (12,459,000) Class H1 Shares, two hundred and thirty-eight

thousand fifty-six (238,056) Class H2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469)
class H3 Shares,

- twelve million four hundred and fifty-nine thousand (12,459,000) Class I1 Shares, two hundred and thirty-eight thou-

sand fifty-six (238,056) Class I2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class
I3 Shares,

- twelve million four hundred and fifty-nine thousand (12,459,000) Class J1 Shares, two hundred and thirty-eight thou-

sand fifty-six (238,056) Class J2 Shares, and two hundred seventy-two thousand four hundred sixty-nine (272,469) class
J3 Shares

with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each. The shares will carry the right to receive all dividends and other

distributions declared, made or paid by the Company in accordance with the terms of these articles and any shareholders
agreement entered into between the shareholders.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, acting as said before, known to the notary by name, first name

and residence, the said appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

ONT COMPARU:

1) Amstar Poland Property Fund I, LP, une société en commandite constituée et existante selon les lois des Iles Caïmans,

ayant son siège social à Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand
Cayman, KY1-111, Iles Caïmans, immatriculée au Registre des Commanditaires des Iles Caïmans sous le numéro 60507,

ici représentée par Monsieur Fabrice GEIMER, employé, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5,

avenue Gaston Diderich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2) BBI Development SA, une société par actions constituée et régie selon les lois de la République de Pologne ayant

son siège à Varsovie, 28 Emili Plater Street, immatriculée au Registre Judiciaire National sous le numéro KRS 33065,

ici représentée par Monsieur Roberto CHIAPPALONE, employé, demeurant professionnellement à L-1420 Luxem-

bourg, 5, avenue Gaston Diderich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

8287

L

U X E M B O U R G

lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Les parties comparantes sont les seules associées de la Société (les «Associes») et représentent l’entièreté du capital

social de Skyline Residences S.a r.l. (la «Societe»), une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois
du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diederich, L-1420 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.645,
constituée en date du 17 décembre 2013 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 610 du 7 mars 2014. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 16 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 3599 du 27 novembre 2014.

Les parties comparantes, représentant l’intégralité du capital social de la Société, peuvent valablement délibérer sur tous

les points des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de créer une nouvelle sous-classe de parts sociales par l’ajout d'une nouvelle sous-classe numé-

rotée 3 dans les classes de parts sociales ordinaires existantes du capital social de la Société, qui sera désormais composé:

- de parts sociales ordinaires de catégorie A, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie A1 (les

«Parts Sociales de Catégorie A1») les parts sociales de catégorie A2 (les «Parts Sociales de Catégorie A2») et les parts
sociales de catégorie A3 (les «Parts Sociales de Catégorie A3»);

- de parts sociales ordinaires de catégorie B, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie B1 (les «Parts

Sociales de Catégorie B1») les parts sociales de catégorie B2 (les «Parts Sociales de Catégorie B2») et les parts sociales
de catégorie B3 (les «Parts Sociales de Catégorie B3»);

- de parts sociales ordinaires de catégorie C, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie C1 (les «Parts

Sociales de Catégorie C1») les parts sociales de catégorie C2 (les «Parts Sociales de Catégorie C2») et les parts sociales
de catégorie C3 (les «Parts Sociales de Catégorie C3»);

- de parts sociales ordinaires de catégorie D, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie D1 (les

«Parts Sociales de Catégorie D1») les parts sociales de catégorie D2 (les «Parts Sociales de Catégorie D2») et les parts
sociales de catégorie D3 (les «Parts Sociales de Catégorie A3»);

- de parts sociales ordinaires de catégorie E, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie E1 (les «Parts

Sociales de Catégorie E1») les parts sociales de catégorie E2 (les «Parts Sociales de Catégorie E2») et les parts sociales de
catégorie E3 (les «Parts Sociales de Catégorie E3»);

- de parts sociales ordinaires de catégorie F, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie F1 (les «Parts

Sociales de Catégorie F1») les parts sociales de catégorie F2 (les «Parts Sociales de Catégorie F2») et les parts sociales de
catégorie F3 (les «Parts Sociales de Catégorie F3»);

- de parts sociales ordinaires de catégorie G, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie G1 (les

«Parts Sociales de Catégorie G1») les parts sociales de catégorie G2 (les «Parts Sociales de Catégorie G2») et les parts
sociales de catégorie G3 (les «Parts Sociales de Catégorie G3»);

- de parts sociales ordinaires de catégorie H, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie H1 (les

«Parts Sociales de Catégorie H1») les parts sociales de classe H2 (les «Parts Sociales de Catégorie H2») et les parts sociales
de catégorie H3 (les «Parts Sociales de Catégorie HI3»);

- de parts sociales ordinaires de catégorie I, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie I1 (les «Parts

Sociales de Catégorie I1») les parts sociales de catégorie I2 (les «Parts Sociales de Catégorie I2») et les parts sociales de
catégorie I3 (les «Parts Sociales de Catégorie I3»);

- de parts sociales ordinaires de catégorie J, y compris trois sous-catégories, les parts sociales de catégorie J1 (les «Parts

Sociales de Catégorie J1») les parts sociales de catégorie J2 (les «Parts Sociales de Catégorie J2») et les parts sociales de
catégorie J3 (les «Parts Sociales de Catégorie J3»),

qui auront toutes les droits énoncés dans les statuts de la société comme modifié et reformulé conformément aux réso-

lutions ci-dessous.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la société d'un montant de vingt-sept mille deux cent quarante-

six euros quatre-vingt-dix centimes (EUR 27.246,90) pour le porter de un million deux cent soixante-neuf mille sept cent
cinq euros et soixante-trois cent (EUR 1.269.705,63) à un million deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent cinquante-
deux euros et cinquante-trois centimes (EUR 1.296.952,53) par l’émission de deux millions sept cent vingt-quatre mille
six cent quatre-vingt-dix (2.724.690) nouvelles parts sociales de la société d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01
EUR) et réparties comme suit:

- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie A3;
- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie B3;
- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie C3;

8288

L

U X E M B O U R G

- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie D3;
- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie E3;
- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie F3;
- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie G3;
- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie H3;
- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie I3;
- deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf (272.469) parts sociales de catégorie J3;
ayant une valeur nominale d’un centime d’euro chacune (EUR 0,01) (ensemble, les «Nouvelles Parts Sociales de Ca-

tegorie 3»)

<i>Souscription et paiement

Intervient alors la société PROBATUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią spółka komandytowo-akcyjna société

en commandite constituée et régie par les lois de la République de Pologne, ayant son siège à Varsovie à lok Aleje Jero-
zolimskie 123 a. 27, Varsovie 02-017, enregistrée dans le registre des entrepreneurs tenu par le Tribunal du District de la
capitale Varsovie sous avec numéro KRS 0000479566, et numéro de TVA 7010399591,

ici représentée par Monsieur Fabrice GEIMER, employé privé, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg,

5, avenue Gaston Diderich, en vertu d'une procuration sous seing privé,

qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales de Catégorie 3, après les avoir libérées par un apport en numéraire

de vingt-sept mille deux cent quarante-six euros quatre-vingt-dix centimes (EUR 27.246,90) de sorte que ce montant est
dès maintenant disponible auprès de la société, tel qu’il a été justifié au notaire instrumentant.

L’apport d'un montant total de vingt-sept mille deux cent quarante-six euros quatre-vingt-dix centimes d'euro (EUR

27.246,90) est attribué au capital social de la société.

<i>Troisième résolution

Entre autres, en conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier entièrement l’alinéa premier

de l’article 5 des statuts de la Société qui doit désormais être lu et appliqué comme suit:

5.1. Le capital social de la Société est divisé en dix catégories de parts sociales dénommées Parts Sociales de Catégorie

A, Parts Sociales de Catégorie B, Parts Sociales de Catégorie C, Parts Sociales de Catégorie D, Parts Sociales de Catégorie
E, Parts Sociales de Catégorie F, Parts Sociales de Catégorie G, Parts Sociales de Catégorie H, Parts Sociales de Catégorie
I, Parts Sociales de Catégorie J, chaque Catégorie de part sociale étant subdivisée en trois sous-catégories (une «Sous-
Catégorie» ou les «Sous-Catégories») qui sont dénommées Parts Sociales de Catégorie A1, Parts Sociales de Catégorie A2
et Parts Sociales de Catégorie A3, Parts Sociales de Catégorie B1, Parts Sociales de Catégorie B2 et Parts Sociales de
Catégorie B3, Parts Sociales de Catégorie C1, Parts Sociales de Catégorie C2 et Parts Sociales de Catégorie C3, Parts
Sociales de Catégorie D1, Parts Sociales de Catégorie D2 et Parts Sociales de Catégorie D3, Parts Sociales de Catégorie
E1, Parts Sociales de Catégorie E2 et Parts Sociales de Catégorie E3, Parts Sociales de Catégorie F1, Parts Sociales de
Catégorie F2 et Parts Sociales de Catégorie F3, Parts Sociales de Catégorie G1, Parts Sociales de Catégorie G2 et Parts
Sociales de Catégorie G3, Parts Sociales de Catégorie H1, Parts Sociales de Catégorie H2 et Parts Sociales de Catégorie
H3, Parts Sociales de Catégorie I1, Parts Sociales de Catégorie I2 et Parts Sociales de Catégorie I3, Parts Sociales de
Catégorie J1, Parts Sociales de Catégorie J2 et Parts Sociales de Catégorie J3. Les Parts Sociales de Catégorie A1 à J1
seront dénommées (les «Parts Sociales de Sous-Catégorie 1»), les Parts Sociales de Catégorie A2 à J2 seront dénommées
(les «Parts Sociales de Sous-Catégorie 2») et les Parts Sociales de Catégorie A3 à J3 seront dénommées (les «Parts Sociales
de Sous-Catégorie 3»).

Le capital social de la Société est fixé à un million deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent cinquante-deux euros

et cinquante-trois centimes (EUR 1.296.952,53), représenté par cent vingt-neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille
deux cent cinquante-trois (129.695.253) parts sociales réparties comme suit:

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie A1, sept cent quatorze mille

cent soixante-dix (714.170) Parts Sociales de Catégorie A2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie A3;

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie B1, sept cent quatorze mille

cent soixante-dix (714.170) Parts Sociales de Catégorie B2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie B3;

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie C1, sept cent quatorze mille

cent soixante-dix (714.170) Parts Sociales de Catégorie C2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie C3;

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie D1, sept cent quatorze mille

cent soixante-neuf (714.169) Parts Sociales de Catégorie D2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie D3;

8289

L

U X E M B O U R G

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie E1, sept cent quatorze mille

cent soixante-neuf (714.169) Parts Sociales de Catégorie E2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie E3;

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie F1, sept cent quatorze mille

cent soixante-neuf (714.169) Parts Sociales de Catégorie F2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie F3;

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie G1, sept cent quatorze mille

cent soixante-huit (714.168) Parts Sociales de Catégorie G2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie G3;

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie H1, sept cent quatorze mille

cent soixante-huit (714.168) Parts Sociales de Catégorie H2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie H3;

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie I1, sept cent quatorze mille

cent soixante-huit (714.168) Parts Sociales de Catégorie I2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie I3; et

- dix-sept millions sept-cent-cinquante-neuf mille (17.759.000) Parts Sociales de Catégorie J1, sept cent quatorze mille

cent soixante-huit (714.168) Parts Sociales de Catégorie J2 et deux cent soixante-douze mille quatre cent soixante-neuf
(272.469) Parts Sociales De Catégorie J3;

ayant une valeur nominale d’un centime d’euro chacune (EUR 0,01). Les parts sociales donnent le droit de recevoir tous

les dividendes et autres distributions déclarées, effectuées ou payées par la Société conformément aux présents statuts et à
tout pacte d’associés conclu entre les associés.

<i>Frais et dépenses

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

à la suite de cet acte sont estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate sur demande des parties comparantes que le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms et résidences, lesdits comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GEIMER, R. CHIAPPALONE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 5 novembre 2015. 2LAC/2015/24944. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183374/309.
(150204006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Cotton Connect Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.383.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015182918/10.
(150203931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Cheyne Special Situations Investments (N° 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 110.809.

In the year two thousand and fifteen, on the twelfh of October.
Before Us Maître Jacques KESSELER, notary, residing in Pétange.

8290

L

U X E M B O U R G

Was held

an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of Cheyne Special Situations Investments (NO. 2) S.à r.l.”,

(R.C.S Luxembourg, section B number 130.809), having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20 rue de la Poste,
incorporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg, on the 16 

th

 of September 2005

and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C number 1098 of the 05 

th

 of October 2005,

The Meeting is presided over by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in

Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange, Grand

Duchy of Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Laetitia ZUANEL, private employee, residing professionally in Pétange, Grand

Duchy of Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The sole represented shareholder, the proxy of the sole represented shareholder and the number of its shares are

shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the proxy of the represented shareholder and the
undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the sole represented shareholder after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons

will also remain annexed to the present deed.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are represented

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been beforehand
informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1.- Deliberation on the dissolution of the company.
2.- Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dissolve

the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator: “Agentis S.A., a public

limited Company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 62, Avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg and registered with the Commercial and Companies Registry of Luxembourg with number R.C.S Luxembourg
B 74.166”

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders in

the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential

rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged
registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period he will fix.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil quinze, le douze octobre
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.

S'est réunie

8291

L

U X E M B O U R G

l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  de  l'actionnaire  unique  de  la  société  à  responsabilité  limitée  "Cheyne  Special

Situations Investments (NO. 2) S.à r.l." (R.C.S. Luxembourg numéro B110.809) ayant son siège social à L-2346 Luxem-
bourg,  20  rue  de  la  Poste,  constituée  suivant  acte  reçu  par  maître  Joseph  ELVINGER,  alors  notaire  de  résidence  à
Luxembourg, le 16 septembre 2005 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1098 du 05
octobre 2005,

L'Assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse profession-

nelle à Pétange.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à

Pétange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia ZUANEL, employée privée, avec adresse professionnelle à

Pétange.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- L’actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient

sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les mandataires des actionnaires représentés
et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement.

La procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, restera

également annexée au présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à

la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont l'actionnaire a été préalablement informé.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée

décide de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur: ”Agentis S.A., Société Ano-

nyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 62, Avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg et enregistrée au register de commerce et des societies de Luxembourg sous le numéro B 74.166”

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas

où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges,

hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Conde, Gomes, Zuanel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24564. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015182904/116.
(150203823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

8292

L

U X E M B O U R G

Toweb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 157.524.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183242/9.
(150204407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Ship Global 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 181.463.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth of October.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

“SHIP Luxco 1 S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
under the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.678,

here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Luxembourg on 30 October 2015.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "Ship Global 1 S.à r.l." (hereinafter the “Company”), a société à res-

ponsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 181.463, incorporated pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 4 November 2013,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”) dated 20 December 2013,
number 3248, page 155873. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a
notarial deed received by the undersigned notary dated 30 June 2015, published in the Mémorial C dated 29 September
2015, number 2660, page 127646.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to appoint, as liquidator of the Company, Florida Liquidator Ltd, a Limited Company

incorporated in the British Virgin Islands with registered office at PO Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter.
The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended (the "1915 Law").

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law, without requesting the autho-

rization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in

rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all
the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part

of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company’s assets to the sole shareholder in cash or in kind to its willingness.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

8293

L

U X E M B O U R G

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

«SHIP Luxco 1 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant

son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.678,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé donnée à Luxembourg en date du 30 octobre 2015.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Ship Global 1 S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à res-

ponsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 181.463, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 4 novembre 2013, dont les statuts ont été publiés au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») en date du 20 décembre 2013, numéro 3248,
page 155873. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en date
du 30 juin 2015, publié au Mémorial C du 29 septembre 2015, numéro 2660, page 127646.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les ré-

solutions suivantes:

<i>Première Résolution

L’associé unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation en date du présent acte.

<i>Deuxième Résolution

L’associé unique décide de nommer en tant que liquidateur, Florida Liquidator Ltd, une société à responsabilité limitée

constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3175, Road Town, Tortola,
Iles Vierges Britanniques, immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques.

<i>Troisième Résolution

L’associé unique décide que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations comme déterminés ci-après.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi de 1915, sans demander l'autorisation de

l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits

réels,  droits  préférentiels,  hypothèques,  actions  en  rescision;  enlever  les  charges,  avec  ou  sans  paiement  de  toutes  les
inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n’a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu’il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.
Plus rien n’étant à l'ordre du jour et personne ne prenant la parole, l'assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu’à la demande du comparant le présent acte est dressé en

langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le comparant a

signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

8294

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25580. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015184965/100.
(150205565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

BFF Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.125.144,90.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 196.716.

In the year two thousand and fifteen, on the second day of November,
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of her colleague Maître Marc

Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.

There appeared:

BFF PEI, L.P., a limited partnership governed by the laws of Canada, with registered office at 65, Grafton Street, c/o

Stewart McKelvey, C12A 8B9 Charlottetown, Canada, and registered with the Commercial Register of Prince Edward
Island under number 147585,

hereafter referred to as the “Shareholder”,
hereby represented by Mrs. Laurence Ouverleaux, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on October 30 

th

 , 2015.

The said proxy shall be annexed to the present deed for registration purpose.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of BFF Lux

Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a
share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), with registered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in
Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg dated 5 May 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of 19 May 2015 number 1286 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 196716 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have never been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To create ten new classes of shares in the share capital of the Company, namely the class A ordinary shares, the class

B ordinary shares, the class C ordinary shares, the class D ordinary shares, the class E ordinary shares, the class F ordinary
shares, the class G ordinary shares, the class H ordinary shares, the class I ordinary shares and the class J ordinary shares,
having the rights and obligations as set out in the articles of association of the Company to be amended pursuant to item 6
of the agenda.

2. To convert the twelve thousand five hundred (12,500) existing shares of the Company with a nominal value of one

euro (EUR 1.-) each into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class A ordinary shares having a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01).

3. To increase the issued share capital of the Company by an amount of four million one hundred twelve thousand six

hundred forty-four euro and ninety euro cent (EUR 4,112,644.90) so as to raise it from its present amount of twelve thousand
five hundred euros (EUR 12,500.-) to an amount of four million one hundred twenty-five thousand one hundred forty-four
euro and ninety euro cent (EUR 4,125,144.90).

4. To issue forty million one thousand four hundred forty-nine (40,001,449) new class A ordinary shares, forty-one

million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class B ordinary shares, forty-one million
two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class C ordinary shares, forty-one million two
hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class D ordinary shares, forty-one million two hun-
dred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class E ordinary shares, forty-one million two hundred
fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class F ordinary shares, forty-one million two hundred fifty-
one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class G ordinary shares, forty-one million two hundred fifty-one
thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class H ordinary shares, forty-one million two hundred fifty-one thou-
sand four hundred forty-nine (41,251,449) new class I ordinary shares and forty-one million two hundred fifty-one thousand
four hundred forty-nine (41,251,449) new class J ordinary shares, each share in each class having a nominal value of one
euro cent (EUR 0.01) per share, all subscribed and fully paid up.

5. To accept the subscription by the sole shareholder of the Company for the newly issued shares of the Company with

payment of a share premium in an amount of four hundred seven million one hundred fifty-one thousand eight hundred
forty-five euro and ten euro cent (EUR 407,151,845.10) and to accept full payment in cash for these new shares.

8295

L

U X E M B O U R G

6. To amend the first paragraph of articles 5, article 29 of the articles of association of the Company and to include an

additional article to the articles of association in order to reflect the above resolutions.

7. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to create ten new classes of shares in the share capital of the Company, namely the class A

ordinary shares, the class B ordinary shares, the class C ordinary shares, the class D ordinary shares, the class E ordinary
shares, the class F ordinary shares, the class G ordinary shares, the class H ordinary shares, the class I ordinary shares and
the class J ordinary shares, having the rights and obligations as set out pursuant to the amended articles of association under
the sixth resolution.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to convert the twelve thousand five hundred (12,500) existing shares of the Company with a

nominal value of one euro (EUR 1.-) each into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class A ordinary shares
having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01).

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of four million one hundred

twelve thousand six hundred forty-four euro and ninety euro cent (EUR 4,112,644.90) so as to raise it from its present
amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to an amount of four million one hundred twenty-five
thousand one hundred forty-four euro and ninety euro cent (EUR 4,125,144.90).

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to issue forty million one thousand four hundred forty-nine (40,001,449) new class A ordinary

shares, forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class B ordinary shares,
forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class C ordinary shares, forty-
one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class D ordinary shares, forty-one
million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class E ordinary shares, forty-one million
two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class F ordinary shares, forty-one million two
hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class G ordinary shares, forty-one million two hun-
dred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class H ordinary shares, forty-one million two hundred
fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class I ordinary shares and forty-one million two hundred
fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class J ordinary shares, having the rights and obligations as
set out pursuant to the amended articles of association under the sixth resolution.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared the Shareholder, represented as above mentioned.
The Shareholder declared to subscribe for forty million one thousand four hundred forty-nine (40,001,449) new class

A ordinary shares, forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class B
ordinary shares, forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class C or-
dinary shares, forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class D ordinary
shares, forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class E ordinary shares,
forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class F ordinary shares, forty-
one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class G ordinary shares, forty-one
million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class H ordinary shares, forty-one million
two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class I ordinary shares and forty-one million
two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) new class J ordinary shares, each share in each class
having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), with payment of a share premium in a total amount of four hundred
seven million one hundred fifty-one thousand eight hundred forty-five euro and ten euro cent (EUR 407,151,845.10) and
to fully pay in cash for these shares.

The subscription amount of four hundred eleven million two hundred sixty-four thousand four hundred ninety euro

(EUR 411,264,490.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted
to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the above newly issued shares according

to the above mentioned subscription.

<i>Sixth resolution

In view of the above, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of

the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

8296

L

U X E M B O U R G

“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at four million one hundred twenty-five thousand one

hundred forty-four euro and ninety euro cent (EUR 4,125,144.90) divided into the following shares:

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class A redeemable ordinary

shares (the “Class A Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid
up;

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class B redeemable ordinary

shares (the “Class B Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid
up;

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class C redeemable ordinary

shares (the “Class C Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid
up;

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class D redeemable ordinary

shares (the “Class D Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid
up;

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class E redeemable ordinary

shares (the “Class E Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid
up;

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class F redeemable ordinary

shares (the “Class F Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid
up;

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class G redeemable ordinary

shares (the “Class G Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid
up;

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class H redeemable ordinary

shares (the “Class H Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid
up;

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class I redeemable ordinary

shares (the “Class I Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
and

- forty-one million two hundred fifty-one thousand four hundred forty-nine (41,251,449) class J redeemable ordinary

shares (the “Class J Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up,

The Shareholder further resolved to add a new article before the article 7 (Increase and Reduction of Capital) which will

read as follows:

“ Art. 7. Repurchase and Redemption of Shares. The Company may repurchase and redeem its own shares with a view

to their immediate cancellation or with a view to their transfer to another person. In such case, the rules of priority and
proportions set out in article 29 (Distribution of profits) below for the appropriation of profits will apply accordingly.

In the case of a repurchase or redemption with cancellation of a whole class of shares, such repurchase or redemption

and cancellation of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting from the Class J Ordinary Shares until
the Class A Ordinary Shares).

The Board of Managers shall have all powers to implement the redemption of the shares in accordance with this article.”
The Shareholder further resolved to amend the number of all articles as from article 7 of the articles of association to

reflect the addition of a new article 7, The Shareholder finally resolved to amend article 29 (formerly article 28), which
will from now on read as follows:

“ Art. 29. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s).

In respect of each distribution of dividend, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order

of priority:

- each Class A Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.10% per annum of the nominal

value of such share (the “Class A Ordinary Shares Fixed Distribution”);

- each Class B Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.15% per annum of the nominal

value of such share (the “Class B Ordinary Shares Fixed Distribution”);

- each Class C Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.20% per annum of the nominal

value of such share (the “Class C Ordinary Shares Fixed Distribution”);

8297

L

U X E M B O U R G

- each Class D Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.25% per annum of the nominal

value of such share (the “Class D Ordinary Shares Fixed Distribution”);

- each Class E Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.30% per annum of the nominal

value of such share (the “Class E Ordinary Shares Fixed Distribution”);

- each Class F Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.35% per annum of the nominal

value of such share (the “Class F Ordinary Shares Fixed Distribution”);

- each Class G Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.40% per annum of the nominal

value of such share (the “Class G Ordinary Shares Fixed Distribution”);

- each Class H Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.45% per annum of the nominal

value of such share (the “Class H Ordinary Shares Fixed Distribution”;

- each Class I Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.50% per annum of the nominal

value of such share (the “Class I Ordinary Shares Fixed Distribution” and together with the Class A Ordinary Shares Fixed
Distribution, the Class B Ordinary Shares Fixed Distribution, the Class C Ordinary Shares Fixed Distribution, the Class D
Ordinary Shares Fixed Distribution, the Class E Ordinary Shares Fixed Distribution, the Class F Ordinary Shares Fixed
Distribution, the Class G Ordinary Shares Fixed Distribution, the Class H Ordinary Shares Fixed Distribution, the “Ordinary
Shares Fixed Distribution”);

- any remaining distribution amount after allocation of the Ordinary Shares Fixed Distribution (the “Ordinary Shares

Distribution”) shall be allocated to the Class J Ordinary Shares on a pro rata and pari passu basis.

Should the whole last outstanding class of shares in reverse alphabetical order (starting from the Class J Ordinary Shares

until the Class A Ordinary Shares) have been cancelled following its redemption or otherwise at the time of the distribution,
the Ordinary Shares in issuance forming the preceding class of Ordinary Shares in reverse alphabetical order (starting from
the Class I Ordinary Shares until the Class A Ordinary Shares) shall be entitled to the Ordinary Shares Distribution.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at around seven thousand euro (EUR 7,000,-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of
divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to representative of the appearing party, known to the undersigned notary by surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de novembre,
Par-devant  Nous,  Maître  Martine  Schaeffer,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  agissant  en  remplacement  de  son

confrère empêché, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, lequel dernier nommé restera dépositaire
de la présente minute,

A comparu:

BFF PEI, L.P., une société en commandite régie par les lois du Canada, ayant son siège social au 65 Grafton Street, c/

o Stewart McKelvey, C12A 8B9 Charlottetown, Canada enregistré au Registre du Commerce de Prince Edward Island
sous le numéro 147585,

ci-après dénommé l’«Associé»,
représentée aux fins des présentes par Madame Laurence Ouverleaux, avocat, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 2015 à elle délivrée.
Ladite procuration restera annexée aux présentes aux fins d’enregistrement.
L’Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l’Associé est l’unique associé de BFF Lux Holdings S.à r.l., une

société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, constituée par un acte de Maître Marc Loesch, notaire résidant à Mondorf-les-Bains, Grand Duché de Lu-
xembourg, en date du 5 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 19 mai 2015 sous le

8298

L

U X E M B O U R G

numéro 1286 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 196716 (la
«Société»). Les statuts de la Société n’ont encore jamais été modifiés.

L’Associé susmentionné reconnaissant être parfaitement informé des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour

1. Création de dix (10) nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir: les parts

sociales ordinaires de catégorie A, les parts sociales ordinaires de catégorie B, les parts sociales ordinaires de catégorie C,
les parts sociales ordinaires de catégorie D, les parts sociales ordinaires de catégorie E, les parts sociales ordinaires de
catégorie F, les parts sociales ordinaires de catégorie G, les parts sociales ordinaires de catégorie H, les parts sociales
ordinaires de catégorie I et les parts sociales ordinaires de catégorie J, ayant les droit et les privilèges qui y sont attachés
conformément aux statuts de la Société suite à leur modification décidée à la sixième résolution de l’ordre du jour.

2. Conversion des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société d’une valeur nominale d’un

euro (EUR 1,-) chacune en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires de catégorie A d’une
valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune.

3. Augmentation du capital social émis de la Société d’un montant total de quatre millions cent douze mille six cent

quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 4.112.644,90) afin de le porter de son montant actuel de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatre millions cent vingt-cinq mille cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-
dix centimes (EUR 4.125.144,90).

4. Émission de quarante millions mille quatre cent quarante-neuf (40.001.449) nouvelles parts sociales ordinaires de

catégorie A, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles
parts sociales ordinaires de catégorie B, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf
(41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille
quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie D, quarante-et-un millions deux
cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie E, qua-
rante-et-un  millions  deux  cent  cinquante-et-un  mille  quatre  cent  quarante-neuf  (41.251.449)  nouvelles  parts  sociales
ordinaires de catégorie F, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449)
nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie G, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent
quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie H, quarante-et-un millions deux cent cinquante-
et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie I, quarante-et-un millions
deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie J
chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant
toutes souscrites et entièrement libérées.

5. Approbation de la souscription par l’associé unique aux nouvelles parts sociales émises par la Société avec paiement

d’une prime d’émission d’un montant total de quatre cent sept millions cent cinquante et un mille huit cent quarante-cinq
euros et dix centimes (EUR 407.151.845,10) et approbation du paiement intégral en espèce pour ces nouvelles parts sociales.

6. Modification du premier paragraphe de l’article 5 et de l’article 29 des statuts de la Société et ajout d’un article

supplémentaire aux statuts afin de refléter les points susmentionnés.

7. Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé a décidé de créer dix (10) nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir:

les parts sociales ordinaires de catégorie A, les parts sociales ordinaires de catégorie B, les parts sociales ordinaires de
catégorie C, les parts sociales ordinaires de catégorie D, les parts sociales ordinaires de catégorie E, les parts sociales
ordinaires de catégorie F, les parts sociales ordinaires de catégorie G, les parts sociales ordinaires de catégorie H, les parts
sociales ordinaires de catégorie I et les parts sociales ordinaires de catégorie J, ayant les droit et les privilèges qui y sont
attachés conformément aux statuts de la Société tels que modifiés suite à la sixième résolution,

<i>Deuxième résolution

L’Associé a décidé de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société d’une valeur

nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires de
catégorie A d’une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Associé a décidé d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de quatre millions cent douze mille

six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 4.112.644,90) afin de le porter de son montant actuel de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatre millions cent vingt-cinq mille cent quarante-quatre euros et quatre-
vingt-dix centimes (EUR 4.125.144,90).

8299

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L’Associé a décidé d’émettre quarante millions mille quatre cent quarante-neuf (40.001.449) nouvelles parts sociales

ordinaires de catégorie A, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449)
nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent
quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, quarante-et-un millions deux cent cinquante-
et-un  mille  quatre  cent  quarante-neuf  (41.251.449)  nouvelles  parts  sociales  ordinaires  de  catégorie  D,  quarante-et-un
millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de
catégorie E, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts
sociales  ordinaires  de  catégorie  F,  quarante-et-un  millions  deux  cent  cinquante-et-un  mille  quatre  cent  quarante-neuf
(41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie G, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille
quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie H, quarante-et-un millions deux
cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie I et
quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales
ordinaires de catégorie J chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR
0,01) chacune, ayant les droit et les privilèges qui y sont attachés conformément aux statuts de la Société suite à leur
modification décidée à la sixième résolution.

<i>Souscription - Paiement

A ainsi comparu l’Associé, tel que susmentionné.
L’Associé a déclaré souscrire à quarante millions mille quatre cent quarante-neuf (40.001.449) nouvelles parts sociales

ordinaires de catégorie A, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449)
nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent
quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, quarante-et-un millions deux cent cinquante-
et-un  mille  quatre  cent  quarante-neuf  (41.251.449)  nouvelles  parts  sociales  ordinaires  de  catégorie  D,  quarante-et-un
millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de
catégorie E, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts
sociales  ordinaires  de  catégorie  F,  quarante-et-un  millions  deux  cent  cinquante-et-un  mille  quatre  cent  quarante-neuf
(41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie G, quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille
quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie H, quarante-et-un millions deux
cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie I et
quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) nouvelles parts sociales
ordinaires de catégorie J chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR
0,01), avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de de quatre cent sept millions cent cinquante et un mille
huit cent quarante-cinq euros et dix centimes (EUR 407.151.845,10) et payer l’intégralité de ces parts sociales en espèces.

Le montant total de quatre cent onze millions deux cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (EUR

411.264.490,-) est à la disposition immédiate de la Société, la preuve ayant été apportée par le notaire soussigné.

<i>Cinquième résolution

L’Associé a décidé d’approuver ladite souscription et paiement et d’attribuer les nouvelles parts sociales selon la sou-

scription susmentionnée.

<i>Sixième résolution

Au vu de ce qui précède et pour refléter les résolutions susmentionnées, l’Associé a décidé de modifier le premier

paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société.

Ledit paragraphe aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Capital émis. Le capital émis de la Société est fixé à quatre millions cent vingt-cinq mille cent quarante-quatre

euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 4.125.144,90), représenté par les parts sociales suivantes (ensemble, les «Parts
Sociales»):

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie A (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A») d’une valeur nominale d’un centime
(EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie B (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B») d’une valeur nominale d’un centime
(EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie C (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C») d’une valeur nominale d’un centime
(EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie D (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D») d’une valeur nominale d’un centime
(EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

8300

L

U X E M B O U R G

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie E (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E») d’une valeur nominale d’un centime
(EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie F (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F») d’une valeur nominale d’un centime
(EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie G (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G») d’une valeur nominale d’un centime
(EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie H (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H») d’une valeur nominale d’un centime
(EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie I (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I») d’une valeur nominale d’un centime (EUR
0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- quarante-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-neuf (41.251.449) parts sociales ordi-

naires rachetables de catégorie J (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J») d’une valeur nominale d’un centime (EUR
0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.» L’Associé a par ailleurs décidé d’ajouter un nouvel article avant
l’article 7 (Augmentation et Réduction de Capital) qui aura la teneur suivante:

« Art. 7. Rachat et Remboursement de Parts Sociales. La Société peut racheter et rembourser ses propres parts sociales

en vue de leur annulation immédiate ou en vue de leur transfert à une autre personne. Dans ce cas, les règles de priorité et
de proportion établies par l’article 29 (Distribution des Bénéfices) ci-dessous relatives à la répartition des bénéfices s’ap-
pliqueront en conséquence.

Dans le cas d’un rachat ou d’un remboursement emportant annulation d’une catégorie entière de parts sociales, un tel

rachat ou remboursement et annulation des parts sociales seront effectués dans l’ordre alphabétique inverse (en commençant
par les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A).

Le Conseil de Gérance doit détenir tous les pouvoirs nécessaires au rachat des parts sociales tel que prévu dans le présent

article.»

L’Associé a par ailleurs décidé de modifier la numérotation de tous les articles à partir de l’article 7 des statuts afin de

refléter l’ajout du nouvel article 7:

L’Associé a finalement décidé de modifier l’article 29 (antérieurement article 28) qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 29. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils

peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau
ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque
part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Dans le cadre de chaque distribution de dividende, le montant attribué à cet effet sera distribué selon l’ordre de priorité

suivant:

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie A (s’il en existe) donnera droit à un dividende d’un montant égal à 0,10%

par année de la valeur nominale d’une telle Part Sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
A»);

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie B (s’il en existe) donnera droit à un dividende d’un montant égal à 0,15%

par année de la valeur nominale d’une telle Part Sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
B»);

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie C (s’il en existe) donnera droit à un dividende d’un montant égal à 0,20%

par année de la valeur nominale d’une telle Part Sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
C»);

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie D (s’il en existe) donnera droit à un dividende d’un montant égal à 0,25%

par année de la valeur nominale d’une telle Part Sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
D»);

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie E (s’il en existe) donnera droit à un dividende d’un montant égal à 0,30%

par année de la valeur nominale d’une telle Part Sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
E»);

8301

L

U X E M B O U R G

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie F (s’il en existe) donnera droit à un dividende d’un montant égal à 0,35%

par année de la valeur nominale d’une telle Part Sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
F»);

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie G (s’il en existe) donnera droit à un dividende d’un montant égal à 0,40%

par année de la valeur nominale d’une telle Part Sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
G»);

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie H (s’il en existe) donnera droit à un dividende d’un montant égal à 0,45%

par année de la valeur nominale d’une telle Part Sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
H»);

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie I (s’il en existe) donnera droit à un dividende d’un montant égal à 0,50%

par année de la valeur nominale d’une telle Part Sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie
I» et ensemble avec la Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, la Distribution Fixe des Parts Sociales
Ordinaires de Catégorie B, la Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, la Distribution Fixe des Parts
Sociales Ordinaires de Catégorie D, la Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, la Distribution Fixe
des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, la Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, la Distri-
bution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires»);

- Tout montant de distribution restant après l’attribution de la Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires (la «Dis-

tribution des Parts Sociales Ordinaires») sera attribué aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J pro rata et pari passu.

Si l’intégralité de la dernière catégorie de Parts Sociales Ordinaires dans l’ordre alphabétique inverse (commençant par

les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A) a été annulée à la suite de
son rachat ou par tout autre moyen lors de sa distribution, les Parts Sociales existantes formant la catégorie précédente de
Parts Sociales Ordinaires en ordre alphabétique inverse (en commençant par les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I
jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A) donneront droit à la Distribution des Parts Sociales Ordinaires.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants

peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que
la date de paiement de tels acomptes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à environ sept mille euros (EUR 7.000).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie

comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire soussigné

par leurs noms, prénoms usuels, états civil et demeures, ledit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. Ouverleaux, M. Schaeffer.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 novembre 2015. GAC/2015/9518. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 11 novembre 2015.

Référence de publication: 2015182874/431.
(150204159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Meyer Neptun GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 360.000.000,00.

Siège social: L-2632 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 193.159.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den fünften November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- NEPTUN INDUSTRIE GmbH &amp; Co. KG, mit Gesellschaftssitz in Werftallee 13, 18119 Rostock, Deutschland,

eingetragen im Handelsregister A des Amtsgerichts Rostock unter der Nummer HRA 3321, und

2.- Herr Bernard Meyer, wohnhaft in Hauptkanal links 1, 26871 Papenburg Deutschland.

8302

L

U X E M B O U R G

Welche Komparenten hier vertreten sind durch Peggy Simon, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-6475 Echternach,

9, Rabatt, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 28. Oktober 2015,

welche Vollmachten nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und dem beurkundenden Notar,

dieser Urkunde als Anlagen beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

I. Die Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MEYER

NEPTUN GmbH, mit Sitz in EBBC Bloc B, 6 D Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 193 159, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar
Henri Beck, mit Amtssitz in Echternach, am 22. Dezember 2014, veröffentlicht im Mémorial C-Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 234, vom 19. Januar 2015 und deren zuletzt Satzung abgeändert wurde zufolge Urkunde aufge-
nommen durch den instrumentierenden Notar am 8. September 2015, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations Nummer 2507 vom 16. September 2015.

II. In ihren Eigenschaften als Gesellschafter haben die Erschienenen dann folgenden Beschluss genommen:

Einziger Beschluss

„ Art. 10. Vertretung.
10.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle durch die alleinige Unterschrift des Einzelgeschäftsführers

bei mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer verpflichtet.

10.2 Falls zwei Kategorien von Geschäftsführern erstellt wurden (Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer

der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  zwingend  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  von  zwei  Geschäftsführern  der
Kategorie B verpflichtet oder die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A.

10.3 Die Gesellschaft wird auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Person(en) verpflichtet,

der/denen eine solche Zeichnungsbefugnis rechtsgültig gemäß Artikel 8.2 der Satzung erteilt wurde“.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung hat die Erschienene, handelnd wie eingangs erwähnt, gemeinsam mit dem Notar die Urkunde unter-

zeichnet.

Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9554. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 12. November 2015.

Référence de publication: 2015184833/45.
(150205677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

traffic.club S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. NameDrive IP S.à r.l.).

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 157.522.

L'an deux mille quinze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

La société anonyme «KeyDrive S.A.», ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite

au R.C.S.L. sous le numéro B 157.525,

ici représentée aux fins des présentes par le membre de catégorie B du Directoire Monsieur Michael RIEDL, Investment

Manager, demeurant à L-1270 Luxembourg, 18, Am Bongert,

détentrice de deux (2) parts sociales.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seule associée de la société à respon-

sabilité limitée "NameDrive IP s.à r.l." (numéro d’identité 2010 24 45 237), avec siège social à L-4740 Pétange, 5, rue
Prince Jean, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 157.522, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 1 

er

 décembre 2010, publié au Mémorial C, numéro 320 du 17 février 2011 et dont les statuts ont été modifiés

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 2013, publié au Mémorial C, numéro 509 du 25
février 2014,

requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:

8303

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’associée unique décide de changer la dénomination de la société de «NameDrive IP s.à r.l.» en «traffic.club S. à r.l.»

et en conséquence de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société prend la dénomination de "traffic.club S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare et en conséquence

de modifier le 1 

er

 alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: RIEDL, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35219. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183243/41.
(150204417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Gerbera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.681.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015183061/10.
(150204380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

High Liquidity Investment Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 148.418.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015183078/10.
(150204376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Gestador S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 18.014.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015183063/10.
(150204383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

8304


Document Outline

BFF Lux Holdings S.à r.l.

Buanderie Centrale

Callisto S.A.

Camon Invest S.A.

Capita Fiduciary S.A.

Caymus Holding S.à r.l.

CCD Partners S.à r.l.

Cersanit Luxembourg S.à r.l.

Cheyne Special Situations Investments (N° 2) S.à r.l.

CitCor Franconia Berlin VI S.à r.l.

Cityhold Euro S.à r.l.

Cityhold Euro S.à r.l.

Clare Acquisitions S.à r.l.

Clare Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l.

Corporate Executive Board Luxembourg S.à r.l.

Cotton Connect Global S.à r.l.

Elba Acquisition S.à r.l.

Euresa Holding S.A.

Even Germany Drei S.à r.l.

Fane Acquisitions S.à r.l.

Far East Hospitality Properties (Europe) S.à r.l.

Gerbera S.A.

Gestador S.A.

Hakogel S.A.

HFB Investissements S.A.

High Liquidity Investment Fund

Hiwinglux S.A.

Immobilière Vauban S.A.

Innovation cluster 1 S.à r.l.

Insulation Operations Holdings S.à r.l.

Jewel HoldCo S.à r.l.

J.Y.C. Lux S.à r.l.

Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl

KRS Investment S.à r.l.

Langton Holdings S.à r.l.

La Sablière S.A.

Le Premier Investment III S.C.A.

Le Premier Investment S.C.A.

Le Premier Sirocco S.C.A.

Luxembourg Investment Company 80 S.à r.l.

Luxembourg Investment Company 81 S.à r.l.

Meyer Neptun GmbH

Michelle Participations Mobilières S.A.

Michelle Participations Mobilières S.A.

Muguet Financière Holding S.A.

NameDrive IP S.à r.l.

Nivelcom S.A.

Ogcrew S.A.

PHM Topco 6 S.à r.l.

Private Equity International S.A.

Ship Global 1 S.à r.l.

Skyline Residences S.à r.l.

Skyline Residences S.à r.l.

Somuchmore Global S.à r.l.

Toweb S.à r.l.

traffic.club S.à r.l.