logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3380

17 décembre 2015

SOMMAIRE

A.E. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162219

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

162236

Avesta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162238

Digital Services XXVI (GP) S.à r.l.  . . . . . . . . .

162240

GT Global S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162220

GT Satellite Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

162221

H2O LuxCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162226

H3O S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162226

HABA Assurances S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

162224

Hailey Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162221

HaPP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162221

Harrods Property Investments Sàrl  . . . . . . . .

162221

Havsund S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162222

Highland VI - CAS (A) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

162222

Highland VI - CAS (B) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

162223

Hiltonian International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

162224

H.K. Studio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162221

Horsmans s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162224

HRGT Shopping Centres Holdco S.à r.l.  . . . .

162225

HRGT Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162225

Hub Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162223

HWB Consulting & Real Estate S.à r.l. . . . . . .

162225

Hypomath S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162226

Ibersports Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162228

Icamm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162228

Icamm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162229

ICG Senior Debt Partners SV 1  . . . . . . . . . . . .

162229

ID Concept S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162229

IF 1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162229

IF 1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162230

I.G. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162228

Igloo JV Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162230

Immo-Service S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162231

Immo T.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162230

Incarta Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

162231

Inimm Due S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162228

Intercity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162231

International Chemical Investors III S.A.  . . .

162232

International Chemical Investors IX S.A. . . . .

162232

International Chemical Investors VIII S.A.  . .

162233

International Chemical Investors VII S.A.  . . .

162233

International Chemical Investors VI S.A. . . . .

162232

International Chemical Investors XI S.A. . . . .

162233

International Chemical Investors X S.A.  . . . .

162233

InterV Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

162226

INVESCO PIT (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . .

162233

IQ Industrial Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

162233

ISAR BS Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162235

ISAR FR Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162235

IS EF Three S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162232

IS EF Three S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162234

IS EF Two S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162234

I.S.H. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162228

Italtriest International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

162235

ITW Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

162235

Jamiva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162236

Japan Universal Investments S.àr.l.  . . . . . . . .

162236

Jean-Charles Manes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

162225

JFA & Interfaces Est.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162223

JIH Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162237

Jost Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162222

Juliette Films S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162236

KAG Europe S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162238

Kag Italy 1 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162238

Kag Italy 2 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162238

KAG Italy S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162238

Karmorneftegaz Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

162237

Karmorneftegaz SARL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162237

Kecha S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162238

Kita S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162239

Kizoku Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

162195

Komatsu Capital Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . .

162195

KS Machines Agricoles et Viticoles S.àr.l.  . . .

162239

Kumming Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162239

162193

L

U X E M B O U R G

Kyra Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

162239

Les Amis de l'Orgue Saint-Martin Dudelange

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162224

Lotus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162219

Luxemburgische Beteiligungs- und Foerde-

rungsgesellschaft S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162219

Lux Fourstar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162234

Lux Germes Compléments Vitalité S.à r.l.  . . .

162219

Lux Technology S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162220

LVS Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162220

Matrix Technologie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162235

MBERP II (Luxembourg) 24 S.à.r.l.  . . . . . . . .

162237

MSREF Danube Lux Holding II S.à r.l.  . . . . .

162229

NovEnergia II - Energy & Environment (SCA),

Sicar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162234

OPTrust Infrastructure Europe I  . . . . . . . . . .

162230

Pavane Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

162239

Peakside Forum S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162232

SALON ANDRE, société à responsabilité limi-

tée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162240

Sincro Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162231

SI Olm (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

162199

SI Vianden (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

162202

SI Vianden (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

162204

Société Luxembourgeoise d'Entreprises et de

Constructions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162240

WCMG (Working Capital Management

Group) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162199

Western Investments Capital S.A.  . . . . . . . . . .

162195

White Gatsby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162195

Wildrosen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162195

Wingust Management S.A., SPF  . . . . . . . . . . .

162199

WM Olm (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

162199

WM Vianden (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

162202

ZAB Prop Co. C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162204

162194

L

U X E M B O U R G

Kizoku Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.392.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172589/10.
(150191478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Komatsu Capital Europe S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.500.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 138.497.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 9 juin 2015 que:
- KPMG Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est renommée en tant que

réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

Munsbach, le 21 octobre 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un Mandataire

Référence de publication: 2015172590/2.
(150190986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Western Investments Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 102.601.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2015172885/11.
(150191100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

White Gatsby, Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 184.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

White Gatsby

Référence de publication: 2015172887/10.
(150191390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Wildrosen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 200.848.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn,
am sechzehnten Tag des Monats Oktober.

162195

L

U X E M B O U R G

Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„PATRIZIA Investment Management HoldCo S.à r.l.“ eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à respon-

sabilité limitée), mit Sitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Alexander Wagner, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in L-1330 Luxemburg, 10, boulevard

Grande-Duchesse Charotte,

aufgrund einer ihm am 14. Oktober 2015 in Luxemburg erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde

beigefügt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung einer den

einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.

Kapitel I. Form, Name, Gesellschaftssitz, Geschäftszweck, Dauer

Art. 1. Form, Gesellschaftsname. Hiermit wird unter dem Namen „Wildrosen S.à r.l.“ eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, die von den jeweiligen Gesetzen bezüglich dieser Gesellschaftsform
geregelt wird (hiernach, die „Gesellschaft“), und insbesondere vom Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften, mehrmals abgeändert, (hiernach, das „Gesetz“), sowie von der vorliegenden Gründungssatzung (hiernach, die
„Satzung“).

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Die Geschäftsführung ist befugt

die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des statutarisch festgelegten Gesellschaftssitzes zu verlegen.

Der Sitz kann an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtum Luxemburg durch Beschluss einer außerordentlichen

Generalversammlung der Anteilshaber, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen
ist, verlegt werden.

Sollten militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse oder unmittelbar bevorstehende Ereignisse den

gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz verhindern, kann der Geschäftssitz der Ge-
sellschaft  vorübergehend  bis  zur  Normalisierung  dieser  Verhältnisse  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorläufigen
Maßnahmen haben jedoch keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der einstweiligen Verlegung
des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Entscheidung, den Gesellschaftssitz ins Ausland zu verlegen, wird von
der Geschäftsführung getroffen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Geschäftsstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.

Art. 3. Geschäftszweck. Der Geschäftszweck der Gesellschaft ist
- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Immobiliengesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierungen an Immobiliengesellschaften, vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt an der

finanzierten Immobiliengesellschaften beteiligt ist; und/oder

- das Kaufen von Immobilien und die Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf (einschließlich Priva-

tisierung) von durch die Gesellschaft gehaltenen Immobilien.

Für Zwecke dieser Klausel umfasst der Begriff "Immobilien" das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus dem Grund

und Boden sowie dem Gebäude) und grundstücksgleiche Rechte, wie z.B. Erbbaurechte. Für die Zwecke dieser Klausel
bezeichnet "Immobiliengesellschaft" jede Kapitaloder Personengesellschaft, deren Ziel (gemäß ihrer Satzung oder ihres
Gesellschaftsvertrags)  der  Kauf  von  Immobilien  und  die  Verwaltung,  der  Betrieb,  die  Vermietung  und  der  Verkauf
(einschließlich der Privatisierung) von durch diese Gesellschaft gehaltenen Immobilien (direkt oder indirekt durch eine
oder mehrere Immobiliengesellschaften mit entsprechender Zielsetzung), der Kauf oder das Halten von Anteilen an einer
oder mehreren solchen Immobiliengesellschaften mit entsprechender satzungs- oder gesellschaftsvertraglicher Zweckse-
tzung und/oder die Gewährung von Darlehen an solche Immobiliengesellschaften ist, vorausgesetzt, dass sie direkt oder
indirekt an der finanzierten Immobiliengesellschaft beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten und Transaktionen durchführen, die sie für notwendig erachtet, um den Ge-

schäftszweck zu erfüllen, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt der Erreichung des Geschäftszwecks dienen,
einschließlich Transaktionen zur Absicherung von Zinssatz- und/oder Wechselkursrisiken.

Die Gesellschaft kann sich durch Eigen- oder Fremdkapital finanzieren.

Art. 4. Geschäftsdauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Kapitel II. Kapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-)

und ist eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro
(EUR 100.-).

162196

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Kapitaländerungen. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Anteilshabers (soweit

es nur einen Anteilshaber gibt) oder durch Beschluss der Anteilshaberversammlung, gemäß Artikel 15 dieser Satzung,
geändert werden.

Art. 7. Ausschüttungsrechte der Anteile. Jeder Anteil gibt seinem jeweiligen Besitzer das Recht auf einen Anteil der

Aktiva und der erzielten Gewinne der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, insofern nur ein

Besitzer pro Anteil zugelassen ist. Die gemeinschaftlichen Miteigentümer sind verpflichtet, eine einzige Person als ihren
Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.

Art. 9. Übertragung der Anteile. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilshaber hat, sind die Gesellschaftsanteile frei

auf Dritte übertragbar.

Hat  die  Gesellschaft  mehrere  Anteilshaber,  können  die  Gesellschaftsanteile  unter  den  im  Artikel  189  des  Gesetzes

vorgeschriebenen Bedingungen übertragen werden.

Jeder Anteilshaber ist einverstanden seine Gesellschaftsanteile nicht zu verpfänden oder als Garantie zu verwenden,

ohne das vorherige Einverständnis der Mehrheit der Anteilshaber, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
besitzen, erhalten zu haben.

Kapitel III. Geschäftsführung

Art. 10. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung, die aus mindestens zwei (2) Mitgliedern besteht, verwaltet die Ge-

sellschaft. Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen nicht Anteilshaber sein. Die Mitglieder der Geschäftsführung
können zu jeder Zeit durch einen Beschluss der Anteilshaber, die eine Mehrheit der Stimmen besitzen, mit oder ohne Grund
abberufen werden.

Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder der Ge-

schäftsführung gefasst.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich bei jeder Sitzung der Geschäftsführung durch ein anderes Mitglied der

Geschäftsführung vertreten lassen, welches von ihm schriftlich oder per Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief bevoll-
mächtigt wurde. Eine Versammlung der Geschäftsführung kann nur dann abgehalten werden, wenn zwei (2) Mitglieder
der Geschäftsführung persönlich, durch Telefonkonferenz oder Videokonferenz anwesend oder vertreten sind.

Das Benutzen von Material zur Abhaltung von Videokonferenzen und Telefonkonferenzen ist erlaubt, insofern ge-

währleistet ist, dass jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung hören kann und von allen anderen teilnehmenden
Mitgliedern der Geschäftsführung gehört werden kann, unabhängig davon, ob diese auch auf solche Technologie zurück-
greifen, und jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung wird als anwesend betrachtet und ist befugt über Video
oder Telefon abzustimmen.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der

Geschäftsführung schriftlich genehmigt und unterschrieben wurden. Diese Genehmigung kann aus einem einzigen oder
mehreren einzelnen Dokumenten hervorgehen, die per Brief, Telefax, E-Mail, Telegramm oder Telex geschickt wurden.
Diese Beschlüsse sind gleichgestellt mit Beschlüssen, die in Versammlungen der Geschäftsführung gefasst wurden.

Abstimmungen können auch wirksam per Telefax, E-Mail, Telegramm, Telex oder Telefon durchgeführt werden, wobei

in letzterem Fall die Abstimmung schriftlich bestätigt werden muss.

Art. 11. Befugnisse der Mitglieder der Geschäftsführung. Gegenüber Dritten haben die Mitglieder der Geschäftsführung

die Befugnis unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte und Handlungen, die dem
Geschäftszweck der Gesellschaft entsprechen, auszuführen und zu genehmigen, vorausgesetzt dass die Bestimmung dieses
Artikels beachtet wurde.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung

der Anteilshaber vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann insbe-
sondere Vermögensberatungsverträge und Verwaltungsverträge, wie z.B. Grundstücksmakler- oder Grundstücksverwal-
tungsverträge abschließen.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift eines Mitglieds der Ge-

schäftsführung rechtsgültig verpflichtet.

Art. 13. Befugnisübertragung und Vertretung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für

bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere ad hoc Vertreter abtreten.

Die Geschäftsführung wird die Verantwortung und Entlohnung (gegebenenfalls), die Dauer der Vertretung und alle

anderen erheblichen Bedingungen dieser Vertretung festlegen.

Art. 14. Haftung der Mitglieder der Geschäftsführung. In Ausübung ihres Mandates sind die Geschäftsführer nicht

persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die
gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

162197

L

U X E M B O U R G

Kapitel IV. Generalversammlung der Anteilshaber

Art. 15. Befugnisse der Generalversammlung der Anteilshaber. Der alleinige Anteilshaber übernimmt alle der Gene-

ralversammlung der Anteilshaber zuerkannten Bedürfnisse.

Falls  es  mehrere  Anteilshaber  geben  sollte,  kann  jeder  Anteilshaber  an  gemeinsamen  Entscheidungen  teilnehmen,

unabhängig der ihm gehörenden Anzahl an Anteilen. Jeder Anteilshaber verfügt über Stimmrecht, entsprechend der ihm
gehörenden Anteilen.

Ein Anteilshaber kann in jeder Generalversammlung der Anteilshaber handeln, indem er eine andere Person, die selbst

nicht Anteilshaber sein muss (oder wenn der Anteilshaber eine juristische Einheit ist, ihre(n) gesetzliche(n) Vertreter),
schriftlich oder per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, E-Mail als seinen Bevollmächtigten ernennt.

Gemeinsame Beschlüsse sind nur gültig gefasst, wenn sie von Anteilshabern, die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-

kapitals besitzen, gefasst wurden. Jedoch können Beschlüsse zur Abänderung der vorliegenden Satzung nur von einer
Mehrheit der Anteilshaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden, im Einklang
mit dem Gesetz.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember

desselben Jahres.

Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erstellt und die Geschäftsführung wird

ein Inventar, einschließlich einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft vorbereiten.

Jeder Anteilshaber hat das Recht die Bücher und Niederschriften der Gesellschaft, das oben genannte Inventar und die

Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zu überprüfen.

Art. 17. Zuweisung und Ausschüttung von Gewinnen. Der Bruttogewinn der Gesellschaft wie in der Jahresbilanz auf-

geführt, nach Abzug der allgemeinen Kosten, Tilgungskosten und Ausgaben jeglicher Art, ergibt den Reingewinn. Vom
Nettogewinn wird die Summe von fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, solange bis diese Rücklage
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Überschuss des Nettogewinns kann an die/den Anteilshaber ausgeschüttet werden, im Verhältnis zu ihren/seinen

Anteilsbeteiligungen in der Gesellschaft.

Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 18. Auflösungsgründe. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nicht im Falle des Todes, der Aufhebung der Zivil-

rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des alleinigen Anteilshabers oder von einem der Anteilshaber.

Art. 19. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren durchgeführt die nicht unbedingt Anteilshaber sein müssen, die aber von den Anteilshabern ernannt werden, welche
ihre Aufgaben und Vergütung festlegen.

Ein einziger Anteilshaber kann die Auflösung der Gesellschaft und die Durchführung der Liquidation beschließen, in

welchem Fall er persönlich die Zahlung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden übernimmt, welche der
Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 20. Ergänzend zu der vorliegenden Satzung gelten die Bestimmungen des Gesetzes.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung und Zahlung

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
Die oben genannte PATRIZIA Investment Management HoldCo S.à r.l. zeichnet einhundert (125) Gesellschaftsanteile

gegen Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-).

Der Nachweis über diese Bareinzahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht, der dies dann auch

ausdrücklich bestätigt.

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf neunhundert

Euro.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Person in Ausübung der der

Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

(i) Die folgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:

162198

L

U X E M B O U R G

- Herr Arwed Fischer, geboren am 2. November 1952 in Kemnath, Deutschland, geschäftlich ansässig in Fuggerstraße

26, D-86150 Augsburg, Deutschland; und

- Herr Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren am 21. Dezember 1967 in München, Deutschland, geschäftlich ansässig in

2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

(ii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den vorgenannten Bevollmächtigten der Erschienenen, hat

letzterer mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. WAGNER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 19. Oktober 2015. Relation: EAC/2015/24109. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75.- EUR).

<i>Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015172888/182.
(150191234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

WCMG (Working Capital Management Group) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 63.826.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 04 novembre 2014

que:

Les démissions de Messieurs Laurent MULLER et Frédéric MULLER de leurs fonctions d'Administrateurs de catégorie

B ont été acceptées avec effet au 12 août 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015172889/16.
(150191815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Wingust Management S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 162.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
WINGUST MANAGEMENT S.A., SPF

Référence de publication: 2015172893/11.
(150191120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

SI Olm (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. WM Olm (Luxembourg) S.à r.l.).

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 105.992.

In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of October;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “WM Olm (Luxembourg) S.à r.l.”, a Luxembourg “société

à responsabilité limitée”, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 105.992 (the “Company”),

162199

L

U X E M B O U R G

incorporated by a deed enacted by Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
on 5 January 2005 and published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 534 dated 3 June 2005.

THERE APPEARED:

The sole shareholder of the Company, WM Merl (Luxembourg) S.à r.l.”, a Luxembourg “société à responsabilité limi-

tée”, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 106.003 (the “Sole Shareholder”), here represented
by Mrs. Alexia UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The above-mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. - That the 20 (twenty) shares of the Company with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars)

each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of the notice right;
2. Change of name of the Company;
3. Approval of the subsequent amendment of the article 2 of the articles of association of the Company in order to reflect

the new name of the Company pursuant to the above resolution; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting
has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully
each document.

<i>Second resolution:

It is resolved that the Company’s name be effectively and immediately changed to SI Olm (Luxembourg) S.à r.l. and

also that the articles of the Company be subsequently amended to reflect this change of name.

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it resolved to amend the first paragraph of article 2 of

the Company’s articles of association to read as follows:

“ Art. 2. The Company’s name is SI Olm (Luxembourg) S.à r.l.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection of the above resolutions, have been estimated at about one thousand Euros (EUR 1,000.-).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn-up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by her name, first name,

civil status and residence, the said proxy-holder of the appearing party has signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le huitième jour d’octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg);

S’est tenue

162200

L

U X E M B O U R G

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «WM Olm (Luxembourg) S.à r.l.», une société à respon-

sabilité  limitée  constituée  selon  le  droit  luxembourgeois,  ayant  son  siège  social  au  7A,  rue  Robert  Stümper,  L-2557
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 105.992 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 Janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 534 du 3 Juin 2005.

A COMPARU:

L’associé unique de la Société, WM Merl (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon

le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.003 (l'«Associé
Unique»),

ici représenté par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration donnée sous seing privé.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire de la partie comparante et par le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

L’Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d’enregistrer comme suit:
I.- Que les 20 (vingt) parts sociales de la Société avec une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américain)

chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été dûment informé par avance.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit et formalités de convocation;
2. Changement du nom de la Société;
3. Approbation de la modification subséquente du de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau nom

de la Société suivant les résolutions ci-dessus;

4. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée;

l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué
et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la
documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps
suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé que le nom de la Société soit effectivement et immédiatement changé par SI Olm (Luxembourg) S.à r.l. et

que les statuts de la Société soient amendés par la suite pour refléter le changement de nom.

<i>Troisième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article

2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 8. Le nom de la Société est SI Olm (Luxembourg) S.à r.l.»
Aucun autre point n’ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec l'augmentation de son capital social, ont été estimés à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été rédigé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme décrit ci-dessus, dont le nom,

prénom, statut civil et lieu de résidence sont connus du notaire, la mandataire de la partie comparante a signé avec Nous,
notaire, le présent acte.

162201

L

U X E M B O U R G

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 octobre 2015. 2LAC/2015/22915. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172894/123.
(150191352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

SI Vianden (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. WM Vianden (Luxembourg) S.à r.l.).

Capital social: USD 22.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 105.994.

In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of October;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

Is held

an  extraordinary  general  meeting  of  the  sole  shareholder  of  “WM  Vianden  (Luxembourg)  S.à  r.l.”,  a  Luxembourg

“société à responsabilité limitée”, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 105.994 (the
“Company”), incorporated by a deed enacted by Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), on 5 January 2005 and published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 533
dated 3 June 2005, and lastly amended by a deed enacted on 17 December 2013 by the undersigned notary and published
in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 1042 dated 24 April 2014.

THERE APPEARED:

The sole shareholder of the Company, WM Merl (Luxembourg) S.à r.l.”, a Luxembourg “société à responsabilité limi-

tée”, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 106.003 (the “Sole Shareholder”), here represented
by Mrs. Alexia UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The above-mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. - That the 22 (twenty-two) shares of the Company with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States

Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide
on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of the notice right;
2. Change of name of the Company;
3. Approval of the subsequent amendment of the article 2 of the articles of association of the Company in order to reflect

the new name of the Company pursuant to the above resolution; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting
has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully
each document.

<i>Second resolution:

It is resolved that the Company's name be effectively and immediately changed to SI Vianden (Luxembourg) S.à r.l.

and also that the articles of the Company be subsequently amended to reflect this change of name.

162202

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it resolved to amend the first paragraph of article 2 of

the Company's articles of association to read as follows:

“ Art. 2. The Company's name is SI Vianden (Luxembourg) S.à r.l.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection of the above resolutions, have been estimated at about one thousand Euros (EUR 1,000.-).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn-up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by her name, first name,

civil status and residence, the said proxy-holder of the appearing party has signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le huitième jour d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg);

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «WM Vianden (Luxembourg) S.à r.l.», une société à

responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 105.994 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 Janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 533 du 3 Juin 2005 et modifié en dernier lieu suivant acte notarié, en date du 17 Décembre 2013 par le notaire
instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1042 du 24 Avril 2014.

A COMPARU:

L'associé unique de la Société, WM Merl (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.003 (l'«Associé
Unique»),

ici représenté par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée sous seing privé.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire de la partie comparante et par le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d'enregistrer comme suit:
I.- Que les 22 (vingt-deux) parts sociales de la Société avec une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américain)

chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été dûment informé par avance.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit et formalités de convocation;
2. Changement du nom de la Société;
3. Approbation de la modification subséquente du de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau nom

de la Société suivant les résolutions ci-dessus;

4. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée;

l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué

162203

L

U X E M B O U R G

et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la
documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps
suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé que le nom de la Société soit effectivement et immédiatement changé par Sirius Group International S.à

r.l. et que les statuts de la Société soient amendés par la suite pour refléter le changement de nom.

<i>Troisième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article

2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 8. Le nom de la Société est SI Vianden (Luxembourg) S.à r.l.»
Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec l'augmentation de son capital social, ont été estimés à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été rédigé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme décrit ci-dessus, dont le nom,

prénom, statut civil et lieu de résidence sont connus du notaire, la mandataire de la partie comparante a signé avec Nous,
notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 octobre 2015. 2LAC/2015/22914. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172895/125.
(150191024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

SI Vianden (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 105.994.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015172896/14.
(150191086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

ZAB Prop Co. C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 200.846.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of October,
before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

162204

L

U X E M B O U R G

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, a special limited partnership (société en commandite spéciale)

organized as a specialised investment fund (fonds d’investissement spécialisé), incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 189.416, represented by
its manager ECE Real Estate Partners S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter,
L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 157.549 and a share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-).

here represented by José María Ortiz, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 15 October 2015.

Such  power  of  attorney,  after  having  been  signed  ne  varietur  by  the  representative  of  the  appearing  party  and  the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is”ZAB Prop Co. C S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Contern, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution  of  the  board  of  managers.  Where  the  board  of  managers  determines  that  extraordinary  political  or  military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances.
Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer
of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition, directly or indirectly, of real estate property in Luxembourg or

abroad, in particular shopping centres, and the holding and managing of the assets required for the management of the real
estate property.

3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s share capital is set at twenty five thousand euro (EUR 25,000.-), represented by (i) twelve thousand

five hundred (12,500) ordinary, (ii) one thousand two hundred and fifty shares of class A (the “Class A Shares”), (iii) one
thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class B (the “Class B Shares”), (iv) one thousand two hundred and fifty
(1,250) of class C (the “Class C Shares”), (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class D (the “Class D
Shares”), (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class E (the “Class E Shares”), (vii) one thousand two
hundred and fifty (1,250) shares of class F (the “Class F Shares”), (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares
of class G (the “Class G Shares”), (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class H (the “Class H Shares”),

162205

L

U X E M B O U R G

(x) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class I (the “Class I Shares”) and (xi) one thousand two hundred
and fifty (1,250) shares of class J (the “Class J Shares”); each in registered form fully paid-up with a nominal value of one
euro (EUR 1) each.

5.2 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid on

the ordinary shares of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium account
may be used to provide for the payment of any ordinary shares which the Company may repurchase from its shareholder
(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds
to the legal reserve.

5.3. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a

resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution adopted in the manner required for
amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than twenty five
thousand Euro (EUR25,000.-). Notwithstanding the above, the share capital of the Company may be reduced through the
cancellation of a class of shares, in whole but not in part, consisting in the repurchase and cancellation of all shares in issue
in such class as may be determined from time-to-time by the board of managers and approved at the General Meeting or
by way of Shareholders Circular Resolution, provided however that the Company may not at any time repurchase and
cancel the ordinary Shares. In the case of any repurchase and cancellation of a whole class of shares, such repurchase and
cancellation of shares shall be made in the following order: (i) Class A Shares; (ii) Class B Shares; (iii) Class C Shares;
(iv) Class D Shares; (v) Class E Shares; (vi) Class F Shares; (vii) Class G Shares; (viii) Class H Shares; (ix) Class I Shares
and (x) Class J Shares.

5.4. In the event of a reduction of share capital through the cancellation of a whole class of shares consisting in the

repurchase and cancellation of all shares in issue in such class (in the order provided for above), each such class of shares
entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class of shares) to such portion of the Total Cancellation Amount
with respect to the class of shares to be redeemed, and the holders of shares of the repurchased and cancelled shares shall
receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class of
shares.

5.5. A reduction of share capital through the repurchase of a class of shares may only be made within the respective

Class Periods, e.g.:

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 16 October 2015 and ending

no later than on 31 December 2015 (the “Class A Period”).

The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later than

31 December 2016 (the “Class B Period”).

The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than on

31 December 2017 (the “Class C Period”).

The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on

31 December 2018 (the “Class D Period”).

The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later than

31 December 2019 (the “Class E Period”).

The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than

31 December 2020 (the “Class F Period”).

The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than

31 December 2021 (the “Class G Period”).

The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than on

31 December 2022 (the “Class H Period”).

The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on

31 December 2023 (the “Class I Period”).

The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on

31 December 2024 (the “Class J Period”).

5.6. Where a class of shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption

and cancellation of such class(es) of shares can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the
date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of
another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on
the day after the Class J Period and the class of shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period
shall come in the order from class A to class J (to the extent not previously repurchased and cancelled).

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of shares shall take place prior to

the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case
may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of shares and shall continue
to end on the day such as initially defined in the Articles above.

162206

L

U X E M B O U R G

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and

payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt the
Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

5.7. The Company may repurchase its shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by Law.
5.8. For the purpose of this article:
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the

extent shareholders would have been entitled to dividend distributions according to these Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium account up to the amount of losses
including carried forward losses) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve
reduction relating to the class of shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward
losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles, each
time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves (including the share premium account up to the amount of L)
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles.
OD = any annual fixed dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to these Articles.
PE = Profit Entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the classes of Shares is entitled pursuant

to these Articles.

The Available Amount, as determined by using the formula described here above, can be increased by any surplus cash

or/and assets available to the Company at the time of the redemption, such surplus cash or/and assets being paid from the
share premium account up to the amount of the share premium at the time of the redemption.

“Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining

maturity  exceeding  six  (6)  months),  (ii)  any  readily  marketable  money  market  instruments,  bonds  and  notes  and  any
receivable which in the opinion of the Board of Managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness
or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating
to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of
other kind held by the Company.

“Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period

(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period).

“Cancellation Value Per Share” means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the class of shares to be cancelled.

“Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class E Period, the

Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

“Interim Accounts” means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim

Account Date.

“Interim Account Date” means the date no earlier than eight (8) days before the date of the cancellation of a class of

shares.

“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the board of managers or as the case may be the sole

manager and approved at the General Meeting (or as the case may be the sole shareholder of the Company) or by way of
Shareholders Circular Resolution on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall be
lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of shares unless otherwise
resolved at the General Meeting (or as the case may be by the sole shareholder of the Company) or by way of Shareholders
Circular Resolution in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation
Amount shall never be higher than such Available Amount.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives). The shares are indivisible and the

Company recognises only one (1) owner per share.

6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

162207

L

U X E M B O U R G

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for that

purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the General

Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution, which sets the term of their office. The managers need not be
shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting or by

way of Shareholders Circular Resolution.

Art. 8. Board of managers. The Company will be managed by a board of managers (the Board). The Board shall be

composed of at least two (2) managers who will be A managers (hereafter each a Manager A) or B managers (hereafter
each a Manager B).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board that has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board shall not resolve on the following subject matters unless with (1) the approval of the investment committee

of ECE Real Estate Partners S.à r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of
all parties to any parallel investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre II A, SCSp SIF A, ECE
European Prime Shopping Centre II B, SCSp and ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF C and, as the case
may be, further parties and such consent shall be documented in writing:

(a) any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from

the proportion of the Company’s ownership) acquisition of shopping centres;

(b) any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from

the proportion of the Company’s ownership) disposal of shopping centres;

(c) any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion

of the Company’s ownership) real estate financings; and

(d) any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion

of the Company’s ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts or extensions
of a building.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except

in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if (a) a majority of its members is present or represented, and (b) at

least one Manager A is present or represented at the meetings. Resolutions of the Board are validly taken by a simple
majority of the managers present or represented provided that at least one Manager A votes in favour of the decision(s) to
be adopted. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman
has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers, including at least

the signature of one Manager A.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been

delegated.

162208

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i)  Resolutions  of  the  shareholders  are  adopted  at  a  general  meeting  of  shareholders  of  the  Company  (the  General

Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i)  The  shareholders  are  convened  to  General  Meetings  or  consulted  in  writing  at  the  initiative  of  any  manager  or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi)  Resolutions  to  be  adopted  at  General  Meetings  or  by  way  of  Shareholders  Circular  Resolutions  are  passed  by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters

of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

10.3. Subject-Matters of Resolutions
The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.

Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by

the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions

is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders

Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to

the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

162209

L

U X E M B O U R G

(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

(vi) the interim dividends shall be allocated and paid in the following order:
the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 1% (or alternatively 10%) of the nominal

value of the Class A Shares;

the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 2% (or alternatively 9%) of the nominal value

of the Class B Shares;

the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 3% (or alternatively 8%) of the nominal value

of the Class C Shares;

the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 4% (or alternatively 7%) of the nominal value

of the Class D Shares;

the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 5% (or alternatively 6%) of the nominal value

of the Class E Shares;

the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 6% (or alternatively 5%) of the nominal value

of the Class F Shares;

the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 7% (or alternatively 4%) of the nominal value

of the Class G Shares;

the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 8% (or alternatively 3%) of the nominal value

of the Class H Shares;

the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 9% (or alternatively 2%) of the nominal value

of the Class I Shares;

the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to 10% (or alternatively 1%) of the nominal value

of the Class J Shares;

the holders of the ordinary Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.5% of the nominal value of the

ordinary Shares.

VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one (1)
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and
remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets
and pay the liabilities of the Company.

14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders

Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board

meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original
or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject

to any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2016.

162210

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe

for twenty five thousand (25,000) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay
them in full by a contribution in cash in the amount of twenty five thousand euro (EUR 25,000,-).

The amount of twenty five thousand euro (EUR 25,000,-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been

given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed

are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately  after  the  incorporation  of  the  Company,  the  sole  shareholder  of  the  Company,  representing  the  entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed for an indefinite period:
a. as Manager A of the Company
- José María Ortiz, Manager, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond

Reuter, L-5326 Contern

b. as Manager B of the Company
- Hildegard Winnebeck, Manager, born on June 5, 1965 in Trier, Germany, with professional address at 17, rue Edmond

Reuter, L-5326 Contern

2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this deed

are drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German
text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Contern, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes

Am sechzehnten Tag des Monats Oktober im Jahre zweitausendfünfzehn,
ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Die ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, organisiert als spezialisierter Investmentfonds (fonds d’in-

vestissement spécialisé) in Form einer speziellen Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale), gegründet und
bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 189.416, vertreten durch
ihren Verwalter ECE Real Estate Partners S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326
Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer
B 157.549 und ein Gesellschaftskapital von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125,000.-) hat,

hier vertreten durch Herrn José María Ortiz, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Groß-

herzogtum Luxemburg, aufgrund der Vollmacht, welche am 15. Oktober 2015 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird der

vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen.

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „ZAB Prop Co. C S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann

durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

162211

L

U X E M B O U R G

Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die
Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland, insbesondere von Einkaufszentren, und der Erwerb und die Verwaltung von zur Bewirtschaftung der Immo-
bilien erforderlichen Gegenständen.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen
anderer  Gesellschaften  nachzukommen  und  im  Allgemeinen  zu  ihrem  eigenen  Vorteil  und  zum  Vorteil  jeder  anderen
Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche
Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,

Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundzwanzigtausendEuro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in (i) zwölftau-

senfünfhundert (12.500) Stammanteile, (ii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse A (die “Klasse
A Anteile”), (iii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse B (die “Klasse B Anteile”), (iv) eintausend
zweihundertundfünfzig  (1.250)  Anteile  der  Klasse  C  (die  “Klasse  C  Anteile”),  (v)  eintausend  zweihundertundfünfzig
(1.250) Anteile der Klasse D (die “Klasse D Anteile”), (vi) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse
E (die “Klasse E Anteile”), (vii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse F (die “Klasse F Anteile”),
(viii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse G (die “Klasse G Anteile”), (ix) eintausend zweihun-
dertundfünfzig  (1.250)  Anteile  der  Klasse  H  (die  “Klasse  H  Anteile”),  (x)  eintausend  zweihundertundfünfzig  (1.250)
Anteile der Klasse I (die “Klasse I Anteile”) und (xi) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse J (die
“Klasse J Anteile”); jede jeweils ausgegeben in voll liberierten Namensanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1).

5.2. Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital kann ein Rücklagenkonto für das Emmissionsagio eingerichtet

werden, auf welchem das auf die Stammanteile über deren Nominalwert eingezhalten Emissionsagio als Kapitalrücklage
verbucht werden kann. Der Betrag des Rücklagenkontos kann für Zahlungen der Gesellschaft an ihre(n) Gesellschafter im
Rahmen des Rückerwerbs von Stammanteilen, zum Ausgleich des realisierten Nettoverlusts, für Ausschüttungen an den/
die Gesellschafter in Form von Dividenden verwednet werden oder der gesetzlichen Kapitalrücklage zugeführt zu werden.

5.3. Durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungs-

änderung erforderlichen Bestimmungen zu fassen ist, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die Ausgabe von
Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag von fünfund-
zwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) fallen. Dessen ungeachtet kann das Gesellschaftskapital der Gesellschaft verringert
werden durch die Löschung einer gesamten Anteilsklasse (nicht jedoch eines Teils Anteilsklasse), welche durch Rücker-
werb  und  Annullierung  aller  in  dieser  Klasse  ausgegebenen  Anteilen  erfolgt,  wie  es  von  Zeit  zu  Zeit  durch  den
Geschäftsführungsrat festgestellt und durch die Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesell-
schafter bestätigt wird; der Rückerwerb und die Annullierung von Stammanteilen durch die Gesellschaft sind ausgeschlos-
sen. Sofern der Rückerwerb und die Annullierung einer gesamten Klasse beabsichtigt sind, haben diese in der folgenden
Reihenfolge zu erfolgen: (i) Klasse A Anteile; (ii) Klasse B Anteile; (iii) Klasse C Anteile; (iv) Klasse D Anteile; (v) Klasse
E Anteile; (vi) Klasse F Anteile; (vii) Klasse G Anteile; (viii) Klasse H Anteile; (ix) Klasse I Anteile und (x) Klasse J
Anteile.

162212

L

U X E M B O U R G

5.4. Im Falle der Kapitalherabsetzung durch Löschung einer gesamten Anteilsklasse durch Rückerwerb und Annullie-

rung aller ausgegebenen Anteile in der betreffenden Klasse (gemäß obiger Reihenfolge) steht jedem Inhaber von Anteilen
dieser Anteilsklasse (pro rata gemäß der gehaltenen Anteile in der jeweiligen Anteilsklasse) ein anteiliger Anspruch aus
dem Gesamtannullierungsbetrag in Bezug auf die einzuziehende Anteilsklasse zu; jeder Inhaber von rückerworbenen oder
annullierten Anteilen erhält von der Gesellschaft einen Betrag, der dem Annullierungswert pro Anteil für jeden Anteil der
relevanten Anteilsklasse entspricht.

5.5. Eine Verminderung des Gesellschaftskapitals durch Rückerwerb einer Anteilsklasse kann nur innerhalb der be-

treffenden Klassenperiode erfolgen, z.B.:

Die Periode für die Anteile der Klasse A ist die Periode beginnend vom Zeitpunkt der notariellen Urkunde vom 16.

Oktober 2015 bis längstens 31. Dezember 2015 (die Klasse A Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse B ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse A Periode bis längstens 31.

Dezember 2016 (die Klasse B Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse C ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse B Periode bis längstens 31.

Dezember 2017 (die Klasse B Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse D ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse C Periode bis längstens 31.

Dezember 2018 (die Klasse D Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse E ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse D Periode bis längstens 31.

Dezember 2019 (die Klasse E Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse F ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse E Periode bis längstens 31.

Dezember 2020 (die Klasse F Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse G ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse F Periode bis längstens 31.

Dezember 2021 (die Klasse G Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse H ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse G Periode bis längstens 31.

Dezember 2022 (die Klasse H Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse I ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse H Periode bis längstens 31.

Dezember 2023 (die Klasse I Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse J ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse I Periode bis längstens 31.

Dezember 2024 (die Klasse J Periode).

5.6. Im Falle, dass eine Anteilsklasse nicht zurückerworben und aufgelöst wurde innerhalb der relevanten Klassenpe-

riode, kann die Rückgabe und Auflösung dieser Anteilsklasse(n) innerhalb einer neuen Periode (die Neue Periode) erfolgen,
welche am Datum nach der letzten Klassenperiode (oder gegebenenfalls dem Datum nach der unmittelbar vorangehenden
Neuen Periode einer anderen Klasse) und spätestens ein Jahr nach dem Datumbeginn einer solchen Neuen Periode enden.
Die erste neue Periode beginnt am Tag nach der Klasse J Periode und die in ihrer betreffenden Klassenperiode nicht
zurückerworbene und nicht aufgelöste Anteilsklasse erfolgt der Reihe nach von Klasse A bis Klasse J (soweit sie nicht
zuvor zurückerworben und aufgelöst wurde9:

Um Zweifel zu vermeiden, im Falle, dass ein Rückerwerb und eine Auflösung einer Anteilsklasse vor dem letzten Tag

ihrer betreffenden Klassenperiode erfolgt (oder gegeben falls Neuen Periode), beginnt die nachfolgende Klassenperiode
(oder gegeben falls die Neue Periode) am Tag nach dem Rückerwerb und der Auflösung dieser Anteilsklasse und endet an
demjenigen Tag wie ursprünglich in den obigen Artikeln definiert.

Mit Rückerwerb und Auflösung der gesamten relevanten Klassen wird die Auflösungssumme fällig und zahlbar durch

die Gesellschaft an die Gesellschafter(in) anteilsmäßig gemäss deren Klassenanteil(en). Die Gesellschaft kann ihre Zah-
lungsverpflichtung in bar, durch Sachleistung oder Aufrechnung erfüllen.

Für Zwecke dieses Artikels:
“Verfügbarer Betrag” bedeutet den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (einschließlich vorgetragener Ge-

winne) soweit Gesellschafter gemäß dieser Satzung zum Erhalt von Dividendenausschüttungen berechtigt gewesen wären,
erhöht um (i) alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zur Höhe
der Verluste einschließlich vorgetragener Verluste) und (ii) gegebenenfalls den Betrag der Kapitalherabsetzung und der
Verringerung der gesetzlichen Rücklagen im Hinblick auf die einzuziehenden/zu löschenden Anteilsklassen, jedoch ver-
ringert um (i) alle Verluste (einschließlich vorgetragener Verluste), und (ii) aller Beträge, welche aufgrund des Gesetzes
oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden müssen, jedes Mal wie in den betreffenden Zwischenbilanzen dar-
gestellt (jedoch ohne doppelte Buchung) so dass:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + OD + PE)
Wobei:
AA= Verfügbarer Betrag
NP= Nettogewinn (einschließlich vorgetragener Gewinne)
P= alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zu einem Betrag

von L)

162213

L

U X E M B O U R G

CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage bezogen auf diejenige An-

teilsklasse, welche aufgelöst werden soll

L= Verluste (einschließlich vorgetragene Verluste)
LR = alle Beträge, welche aufgrund Anforderungen des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden

müssen.

OD = sämtliche jährlich festgelegten Dividenden, zu welchen der/die Inhaber der Stammanteile gemäß diesen Artikeln

berechtigt ist/sind.

PE = Gewinnanspruch (die jährlich festgelegten Dividenden, zu welchen der/die Inhaber von Anteilsklassen gemäß

diesen Artikeln berechtigt ist/sind.

Der Verfügbare Betrag, basierend auf obiger Formel, kann um sämtliche der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rücknahme

zur Verfügung stehende überschüssige Liquidität und/oder Vermögenswerte, erhöht werden, wobei überschüssige Liqui-
dität und Vermögenswerte aus dem Rücklagenkonto des Emissionsagio bis zur Höhe des Betrags der an das Emissionsagio
gebundenen Kapitalrücklage zum Zeitpunkt der Rücknahme zu zahlen sind.

„Verfügbare Liquidität“ bedeutet (i) alles Bargeld, das von der Gesellschaft gehalten wird (mit Ausnahme von Fest-

geldanlagen mit einer Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten, (ii) sämtliche leicht vermarktbaren Geldmarktinstru-
mente, Bonds, Banknoten und alle Forderungen, welche nach Meinung des Geschäftsführungsrats in Kürze gezahlt werden
abzüglich jeglicher Schuldenlast oder anderer Verbindlichkeiten der Gesellschaft, welche auf Grundlage der Zwischenbi-
lanzen der betreffenden Klassenperiode (oder gegebenen falls Neuen Periode) in weniger als sechs (6) Monaten fällig sind
und (iii) sämtliche Vermögenswerte wie Anteile, Wertpapiere oder Sicherheiten oder sonstige Vermögenswerte, welche
die Gesellschaft besitzt.

„Annullierungsbetrag“ bedeutet ein Betrag, welcher den zu der betreffenden Klassenperiode (oder gegeben falls Neuen

Periode) gehörenden verfügbaren Betrag nicht übersteigt, vorausgesetzt, dass der Annullierungsbetrag Neuen Periode).

“Annullierungswert pro Anteil” bedeutet den durch Division des Gesamtannullierungsbetrages durch die ausgegebene

Anzahl von Anteilen in der von der Annullierung betroffenen Anteilsklasse errechneten Wert.

„Klassenperiode“ bedeutet jede der Klasse A Periode, Klasse B Periode, Klasse C Periode, Klasse D Periode, Klasse E

Periode, Klasse F Periode, Klasse G Periode, Klasse H Periode, Klasse I Periode und Klasse J Periode.

“Zwischenbilanzen” bedeuten die Zwischenbilanzen der Gesellschaft gemäß Luxemburger GAAP zum betreffenden

Zwischenbilanzzeitpunkt.

“Zwischenbilanzzeitpunkt” bedeutet das Datum frühestens acht (8) Tage vor dem Datum der Löschung einer Anteils-

klasse.

“Gesamtannullierungsbetrag” bedeutet der vom Geschäftsführungsrat oder gegebenenfalls dem Alleingeschäftsführer

festgelegten und von der Hauptversammlung (oder gegebenenfalls dem Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im
Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter bestätigten Betrag, basierend auf den relevanten Zwischenbilanzen. Der
Gesamtannullierungsbetrag muss niedriger oder gleich dem gesamten Verfügbaren Betrag zum Zeitpunkt der Löschung
der betreffenden Anteilsklasse sein, es sei denn, dass dies anderweitig durch die Hauptversammlung (oder gegebenenfalls
durch den Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter gemäß den
Bestimmungen  zur  Änderung  dieser  Satzung  beschlossen  worden  ist,  vorausgesetzt  jedoch,  dass  der  Gesamtannullie-
rungsbetrag nie höher sein darf als der Verfügbare Betrag.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile (parts sociales nominatives). Die Geschäftsanteile sind unteilbar

und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690

des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter

eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über

ausreichend ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch

einen Beschluss der Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter bestellt, welcher auch
ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung oder im Wege

eines Umlaufbeschlusses abberufen werden.

162214

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführungsrat (der Rat) verwaltet. Der Rat soll

aus  mindestens  zwei  (2)  Geschäftsführern  bestehen,  die  entweder  A  Geschäftsführer  (Geschäftsführer  A)  oder  B  Ge-
schäftsführer (Geschäftsführer B) sein sollen.

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-

lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

(iii) In Bezug auf die folgenden Entscheidungen soll der Rat nur Beschlüsse fassen sofern (1) die Genehmigung des

Investment Komitees der ECE Real Estate Partners S.à r.l. vorliegt, und eine solche Genehmigung schriftlich festgehalten
wurde und (2) der einstimmigen Entscheidung aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen der
ECE European Prime Shopping Centre II A, SCSp SIF, der ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSp und der
ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung
schriftlich festgehalten worden ist:

(a) eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren;

(b) eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren;

(c) eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung; und

(d) eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren,
dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.

8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-

nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vier-

undzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann
in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn (a) die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind

und (b) wenigstens ein Geschäftsführer A bei der Versammlung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates
sind wirksam, wenn sie mit einer einfachen Mehrheit der von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst
werden, wobei mindestens ein Geschäftsführer A für den Beschluss oder die Beschlüsse gestimmt haben muss. Die Be-
schlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn
kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet
werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommuni-

kationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind und im Umlaufverfahren gefasst

worden sind (die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in
einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt
hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei

(2) Geschäftsführern gebunden, wobei stets mindestens ein Geschäftsführer A unterzeichnet haben muss.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.

(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

162215

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Ver-

bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.

IV. Gesellschafter

Art. 10. Hauptversammlung und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Hauptversammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder

durch Beschlüsse im Umlaufverfahren (die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse

gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage

im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen  Gesellschafter  erklären,  dass  ihnen  die  Tagesordnung  im  Voraus  bekannt  gegeben  wurde  und  sich  selbst  als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse

werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter
per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die
Beschlüsse oder die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals

vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

10.3. Gegenstände von Beschlüssen
Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.

Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch

der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Umlaufbeschluss der Gesellschafter

innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,

welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines

Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

162216

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage

zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des
Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu

verfügen  ist.  Sie  können,  in  Übereinstimmung  mit  den  geltenden  gesetzlichen  Regelungen,  mit  dem  Überschuss  eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive des Emissionsagio) zur

Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende
des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten

ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-

tung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so

müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

(vi) die Abschlagsdividenden werden in folgender Reihefolge ausgezahlt:
die Inhaber der Klasse A Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 1% (oder alternativ 10%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse A entspricht

die Inhaber der Klasse B Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 2% (oder alternativ 9%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse B entspricht

die Inhaber der Klasse C Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 3 % (oder alternativ 8%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse C entspricht

die Inhaber der Klasse D Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 4% (oder alternativ 7%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse D entspricht

die Inhaber der Klasse E Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 5% (oder alternativ 6%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse A entspricht

die Inhaber der Klasse F Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 6% (oder alternativ 5%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse F entspricht

die Inhaber der Klasse G Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 7 % (oder alternativ 4%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse G entspricht

die Inhaber der Klasse H Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 8% (oder alternativ 3%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse H entspricht

die Inhaber der Klasse I Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 9% (oder alternativ 2%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse I entspricht

die Inhaber der Klasse J Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 10% (oder alternativ 1%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse J entspricht die Inhaber der Stammanteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 0,5% des Nomi-
nalwerts der Stammanteile entspricht.

VI. Auflösung - Liquidation

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter,

welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen
(1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der
Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die
Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.

14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaf-

tern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Umlaufbe-

schlüsse der Geschäftsführer und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-
Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

162217

L

U X E M B O U R G

15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden

alle  gesetzlichen  Erfordernisse  für  handschriftliche  Unterschriften  entsprechend  erfüllt.  Unterschriften  auf  Umlaufbe-
schlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst
werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche
zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-

enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.

<i>Zeichnung und Zahlung

ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet fünfund-

zwanzigtausend (25.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige
Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000.-).

Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR

25.000.-) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-) betragen.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeich-

neten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum ernannt:
a. als Geschäftsführer A der Gesellschaft
- José María Ortiz, Geschäftsführer, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17, rue Edmond

Reuter, L-5326 Contern

b. als Geschäftsführer B der Gesellschaft
- Hildegard Winnebeck, Geschäftsführerin, geboren am 5. Juni 1965 in Trier, Germany, geschäftsansässig in 17, rue

Edmond Reuter, L-5326 Contern

2. Sitz der Gesellschaft sind in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt

hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichneten

Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. M. ORTIZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 19 octobre 2015. Relation: DAC/2015/17406. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 21. Oktober 2015.

Référence de publication: 2015172903/781.
(150191179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162218

L

U X E M B O U R G

A.E. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 71.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015172911/10.
(150192099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

L.B.F. S.A., Luxemburgische Beteiligungs- und Foerderungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 24.231.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2015 a:
- pris acte du décès de Monsieur Norbert THEISEN, commissaire aux comptes de la société;
- nommé Monsieur Georges BENERE, né le 29 mars 1936 à Rodange (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant à

B-6791 Athus, 42, rue du Panorama, en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la société, jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de 2020 et ratifie également sa mission de contrôle des comptes du 31 décembre 2003 au 31
décembre 2013 préalablement à sa nomination;

- ratifié la nomination, en qualité d'administrateur-délégué, de Madame Jeanny PUNDEL VON KUNITZKI coopté par

le Conseil d'Administration lors de sa réunion en date du 18 février 2008, en remplacement de Monsieur Norbert VON
KUNITZKI, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir;

- renouvelé Madame Jeanny PUNDEL VON KUNITZKI, née le 16 mai 1961 à Luxembourg, demeurant à L-8077

Bertrange, 257, rue de Luxembourg, dans son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020;

- renouvelé Monsieur René QUERE, né le 17 février 1963 à Nancy (France), demeurant à F-54 920 Morfontaine, 1, rue

Saint Louis, dans son mandat d'administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020;

- accepté la démission de Monsieur Gaston SCHANEN de ses fonctions d'administrateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 22 octobre 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015173241/25.
(150191789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Lotus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 27.692.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015173236/11.
(150191987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Lux Germes Compléments Vitalité S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 17, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 178.272.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015173218/10.
(150191585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

162219

L

U X E M B O U R G

Lux Technology S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.797.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement des actionnaires de la société,

tenue en date du 18 septembre 2015, que

a) L'assemblée a pris note de la démission de Monsieur Frédéric LECLERCQ de sa fonction d'administrateur et admi-

nistrateur-délégué.

b) L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur unique en remplacement de l'administrateur sortant.
Le conseil d'administration est dorénavant composé comme suit:
Monsieur Christos KAKOURIDES, né le 16 octobre 1978 à Lefkosia, (Chypre) administrateur-unique demeurant pro-

fessionnellement au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Il pourra engager la société par sa seule signature.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de l'an 2020
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015173219/22.
(150192126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

LVS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 188.349.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 11 septembre 2015 qui ont été acceptées:
- la démission de Mme Pamela Valasuo en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet au 31 août 2015;
- la démission de Mme Miranda Lansdowne en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet au 15 septembre

2015;

- la nomination de Castle Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée, domiciliée au 68/70 boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
152622, en tant que gérant de catégorie B la Société avec effet au 1 

er

 septembre 2015;

- la nomination de Elizabeth Verwaltung S.à r.l., une société à responsabilité limitée, domiciliée au 68/70 boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 152587, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet au 16 septembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015173244/22.
(150191726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

GT Global S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 175.823.

Les comptes annuels au 31.07.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172509/9.
(150191458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162220

L

U X E M B O U R G

GT Satellite Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 104.868.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172510/9.
(150190989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

H.K. Studio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4953 Hautcharage, 12, Cité Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 163.187.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172511/10.
(150190956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Hailey Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 182.192.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015172513/14.
(150190999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

HaPP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 158.570.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2015.

<i>Pour compte de HaPP Sàrl
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2015172518/12.
(150190476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Harrods Property Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 91.830.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 137.537.

<i>Contrat de cession de parts du 21 octobre 2015

Ancienne situation associé:
QH Property Holdings Limited: 918.300 parts sociales
Nouvelle situation associé:

162221

L

U X E M B O U R G

Harrods Group (Holding) Limited, ayant son siège social à 87-135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL,

enregistrée auprès du Registre de Commerce d'Angleterre et Pays de Galles sous le numéro 5990648: 918.300 parts sociales

Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Harrods Property Investments S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015172514/18.
(150190857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Havsund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 163.709.

Les statuts coordonnés au 17 juillet 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015172517/11.
(150190917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Jost Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 1, am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 93.001.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 08 septembre 2015

- Il est décidé, à l'unanimité, de renouveler les mandats des membres du conseil d'administration pour une durée de 6

ans, et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes de l'année 2020.

Les membres du conseil d'administration sont donc:
Monsieur Roland Ernst Kurt Rolf JOST, Administrateur, domicilié à B-4970 Stavelot, 12, route de Malmedy;
Monsieur Dominique Jean L WANSART, Administrateur, domicilié à B-4950 Waimes, 65, rue de la Gare;
Jost Group S.A., Administrateur, dont le siège social est situé au 1, Am Hock, L-9991 Weiswampach, enregistrée auprès

du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B99394 et dûment représentée par Monsieur Roland Ernst Kurt
Rolf JOST, représentant permanent.

- Il est décidé, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Monsieur Roland JOST, domicilié à B-4970 Stavelot, 12, Route

de Malmedy, en tant qu' Administrateur-délégué. Son mandat prendra effet en date de ce jour jusqu'à l’assemblée générale
qui approuvera les comptes de l'année 2020.

- Il est décidé, à l'unanimité, de renouveler le mandat de VPC Luxembourg, Réviseurs d'entreprises, avec siége social

au 4, Op der Haart, L-9999 Wemperhardt, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B172513 et dûment représentée par Monsieur Jean-Louis PRIGNON, Représentant Permanent. Ce mandat est attribué
jusqu'au 31/12/2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>L'Administrateur-délégué

Référence de publication: 2015173194/25.
(150191548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Highland VI - CAS (A) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 145.252.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société Highland VI - CAS (A) S.à r.l., décidée par acte auprès du notaire Maître Henri Hellinckx,

en date du 18 septembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du
29 décembre 2014.

162222

L

U X E M B O U R G

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172519/16.
(150191421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Highland VI - CAS (B) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 145.253.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société Highland VI - CAS (B) S.à r.l, décidée par acte auprès du notaire Maître Henri Hellinckx,

en date du 18 septembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du
29 décembre 2014.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172520/16.
(150191420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

JFA &amp; Interfaces Est., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 144.285.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la cession de parts sociales

En vertu d'une convention de cession de parts sociales passée sous seing privé en date du 11 août 2015,
- Monsieur Joseph PARRILLA, né le 07 février 1968 à Metz (France), demeurant à 27, Rue Pasteur à F - 57 525 Talange

(France),

a cédé 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la Société à la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

MAGIKI, sise 28, Rue du Commerce à L - 3450 Dudelange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B199198,

- Madame Marie BOUNOUGHAZ, née le 14 mars 1972 à Metz (France), 27, Rue Pasteur à F - 57 525 Talange (France),
a cédé 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société à la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

MAGIKI, sise 28, Rue du Commerce à L - 3450 Dudelange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B199198,

Dudelange, le 11 août 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015173193/22.
(150191676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Hub Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.700,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.498.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

162223

L

U X E M B O U R G

<i>Pour Hub Investments S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015172522/11.
(150190609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

HABA Assurances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 132.609.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172523/9.
(150190621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Hiltonian International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 122.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172528/9.
(150191040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Les Amis de l'Orgue Saint-Martin Dudelange, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3552 Dudelange, 14, rue Nic Conrady.

R.C.S. Luxembourg F 4.575.

Ancien texte.

Art. 9. L'association est gérée par un conseil d'administration de onze membres. Le curé de la paroisse, un vicaire désigné

par lui et le titulaire des grandes orgues sont membres de plein droit.

Les autres administrateurs sont nommés parmi les associés par l'assemblée générale pour trois ans.
La fabrique d'église, la chorale Sainte-Cécile et la chorale Saint-Martin peuvent désigner chacune un délégué avec voix

consultative.

Art. 10. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres élus un président, un vice-président, un trésorier et un

secrétaire pour une durée de trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Nouveau texte.

Art. 9. L'association est gérée par un conseil d'administration de dix-neuf membres au maximum. Le curé de la paroisse,

un vicaire ou un membre de l'équipe pastorale désigné par lui et les organistes titulaires des grandes orgues sont membres
de plein droit. Les autres administrateurs sont nommés parmi les associés par l'assemblée générale pour trois ans.

En plus, la fabrique d'église, la chorale Sainte-Cécile et la chorale Saint-Martin peuvent désigner chacune un délégué

avec voix consultative.

Art. 10. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres élus un président, un vice-président, un secrétaire, deux

secrétaires adjoints, un trésorier et un trésorier adjoint pour une durée de trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

La répartition des charges est définie par un règlement interne.
Tous les autres articles restent inchangés.
Référence de publication: 2015173228/25.
(150192483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Horsmans s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7448 Lintgen, 10-12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 38.978.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172529/9.
(150190705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162224

L

U X E M B O U R G

HRGT Shopping Centres Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 182.272.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société, par décision du 30 septembre 2015, a décidé d'accepter les démissions de Jabir Chakib

et Hugo Neuman en tant que gérants de la Société, avec effet au 30 septembre 2015.

L'associé unique a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet au 30 septembre

2015 et pour une durée indéterminée

- Martin Eckel, résidant professionnellement au 26A, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg;
- Paul Lawrence, résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HRGT Shopping Centres Holdco S.à r.l.

Référence de publication: 2015172530/17.
(150190833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

HRGT Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 171.689.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 Octobre 2015.

HRGT Topco S.à r.l.
TMF Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2015172531/14.
(150190904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Jean-Charles Manes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2536 Luxembourg, 3, rue Sigefroi.

R.C.S. Luxembourg B 172.997.

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Document faisant l’objet de la rectification:
Référence: L150108547
Déposé le 24/06/2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2015172584/14.
(150191092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

HWB Consulting &amp; Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 3, Wengertswee.

R.C.S. Luxembourg B 57.903.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HWB CONSULTING &amp; REAL ESTATE SARL

Référence de publication: 2015172532/10.
(150190926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162225

L

U X E M B O U R G

Hypomath S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 182.847.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 6 juillet 2015

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale nomme en remplacement de Monsieur Patrick WEINACHT, administrateur, Madame Johanna

FISCHMANN (demeurant professionnellement à 7a rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, née le 7 novembre 1953 à Paris),
administrateur, jusqu'à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra dans l'année 2019.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015172533/16.
(150191212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

H2O LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.676.

EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par les associés de la Société en date du 14 octobre 2015, les gérants Monsieur Alan Botfield

et Madame Zena Yates ont été remplacé par les personnes suivantes:

- Monsieur Petr Klimo, résidant professionnellement au 51 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Szymon Dec, résidant professionnellement au 51 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015172534/17.
(150190849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

InterV Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 10, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 171.844.

En qualité de gérant de catégorie E de la société InterV Investment S.à r.l., ayant son siège social au 10, rue des Romains,

L-2444, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 171.844, je souhaite vous faire part de ma démission de ce poste avec effet immédiat.

Le 13 octobre 2015.

M. Michael Tennenbaum.

Référence de publication: 2015172541/11.
(150191007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

H3O S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 183.009.

L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois d'octobre.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc DELENS, commerçant, né le 12 avril 1977 à Liège, Belgique, demeurant à B-6730 Saint-Vincent,

12, rue des Groseilliers.

162226

L

U X E M B O U R G

2. Monsieur Frédéric BOTIN, commerçant, né le 14 mars 1972 à Ixelles, Belgique, demeurant à B-1457 Walhain, 4,

cours Gilles de Lerinnes,

ici représenté par Monsieur Marc DELENS, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont

requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée «H3O S.à r.l.», avec siège social à L-1940

Luxembourg, 174, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro
B 183.009, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, en date du 25 no-
vembre 2015, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 398 en date du 13 février
2014, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (ci-après «la Société»).

II.- Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par dix mille (10.000)

parts sociales d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents euros (EUR 1,25,-) chacune, toutes les parts sociales
étant entièrement souscrites et appartenant aux associés comme suit:

Monsieur Frédéric BOTIN, prénommé,
Six mille six cent soixante-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.666

Monsieur Marc DELENS, prénommé,
Trois mille trois cent trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.334

Total: dix mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

III. Les associés pré-qualifiés, présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité, les
résolutions suivantes, qu'ils ont demandé au notaire d'acter comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy à l'adresse suivante: L-3346 Leudelange,

35, rue de Bettembourg;

2. Modification subséquente de l'article 2 (alinéa 1) des statuts de la Société;
3. Divers.
Après en avoir délibéré, les comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, ont pris, à l'unanimité, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de l'adresse actuelle L-1940 Luxembourg, 174, route de

Longwy à l'adresse suivante: L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier en conséquence l'article 2, alinéa 1, des statuts de la Société pour lui donner à la teneur

suivante:

Art. 2. (alinéa 1). «Le siège de la Société est établi dans la commune de Leudelange.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société en raison du

présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. DELENS, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 19 octobre 2015. Relation: DAC/2015/17411. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 21 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172535/60.
(150191085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162227

L

U X E M B O U R G

I.G. Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 66.562.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015172536/10.
(150191275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

I.S.H. Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 74.692.

Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015172537/12.
(150191217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Inimm Due S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 240.950,00.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 80.276.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015172538/10.
(150190535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Ibersports Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 115.694.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015172546/11.
(150191131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Icamm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R.C.S. Luxembourg B 105.684.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172547/9.
(150191082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162228

L

U X E M B O U R G

Icamm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R.C.S. Luxembourg B 105.684.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172548/9.
(150191518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

MSREF Danube Lux Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.759.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 24 septembre 2015

L'associé unique de MSREF Danube Lux Holding II Sarl (la "Société") a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Marcus Wolsfeld en tant que gérant de catégorie A et la démission de Susanne Muntinga-

van den Houten en tant que gérant de catégorie B;

Et de nommer gérant de catégorie B suivant avec effet au 24/09/2015 et pour une durée indéterminée:
- Jan-Dries Mulder, né le 07 février 1973 à Veendam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au Kabelweg 37, 1014

BA Amsterdam, Pays-Bas

Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172669/15.
(150190765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

ICG Senior Debt Partners SV 1, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 175.072.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172549/10.
(150190470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

ID Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 7, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 121.990.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172550/9.
(150190865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

IF 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.301.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 9 juillet 2015

<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014

Le mandat des gérants:
79. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
80. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
81. Monsieur David BANNERMAN, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en

décembre 2015.

162229

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 Juillet 2015.

Référence de publication: 2015172551/18.

(150191237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

OPTrust Infrastructure Europe I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 419.712,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 144.584.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession daté du 20 octobre 2015, que l'actionnaire de la Société, OPSEU Pension Plan Trust

Fund a transférer la totalité de ses parts sociales, soit 287,212 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 chacune, au
second actionnaire OPTRUST Infrastructure Europe IV Inc.

En  conséquence,  OPTRUST  Infrastructure  Europe  IV  Inc.  devient  l'actionnaire  unique  de  la  société,  détenteur  des

419,712 parts sociales de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172697/17.

(150191101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

IF 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.301.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015172552/9.

(150191238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Igloo JV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 167.283.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 21 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172553/10.

(150190817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Immo T.P., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 34.609.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2015.

GERARD Rachel

Référence de publication: 2015172556/10.

(150190560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162230

L

U X E M B O U R G

Sincro Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 116.661.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 30 septembre 2015 («l'Assemblée Générale») a pris acte de la démission en date du 26 juin

2015, de Monsieur Sylvain Feraud.

L'Assemblée Générale du 30 septembre 2015 ("l'Assemblée Générale") a ratifié la cooptation de Monsieur Mauro Poroli

Inselmo, avec adresse professionnelle, 2, Via Valdani, CH-6830 Chiasso (Suisse), et l'a nommé d'Administrateur du Fonds,
et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

L'Assemblée Générale a également approuvé la nomination de Madame Balerna Bommartini en qualité de Présidente

du Conseil d'administration du Fonds.

L'Assemblée Générale a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:
- Madame Margherita Balerna Bommartini, Présidente et Administrateur, avec adresse professionnelle Via L. Zuccoli

19, CH-6900 Paradiso Lugano (Suisse); et

- Monsieur Jonathan Malacrida, Administrateur, avec adresse professionnelle, 2, Via Valdani, CH-6830 Chiasso (Suis-

se).

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
L'Assemblée Générale du 30 septembre 2015 a également renouvelé le mandat du réviseur d'entreprise:
- Deloitte Audit S.à.r.L., réviseur d'entreprise, 560 Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016

<i>Pour SINCRO SICAV

Référence de publication: 2015173384/25.
(150192090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Immo-Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d'Itzig.

R.C.S. Luxembourg B 25.644.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015172557/10.
(150191274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Incarta Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 89.194.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172558/9.
(150190563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Intercity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 145.019.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015172560/11.
(150191016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162231

L

U X E M B O U R G

International Chemical Investors III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 128.405.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172561/9.
(150190981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Peakside Forum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 194.334.

En date du 14 octobre 2015, l'associé unique de la Société a pris acte des décisions suivantes:
- Démission de M. Frank Hans Stefan Aumann de son poste de gérant avec effet au 14 octobre 2015;
- Election de M. Nikhil Gupta, né le 14 août 1984 à New Delhi, Inde et résidant professionnellement au Bundesplatz

14, CH-6300 Zug, Suisse, au poste de gérant avec effet au 14 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015172706/15.
(150191397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

International Chemical Investors IX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 177.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172562/9.
(150190977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

International Chemical Investors VI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 172.527.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172563/9.
(150190980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

IS EF Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.334.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 9 juillet 2015

<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014

Le mandat des gérants:
127. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
128. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
129. Monsieur David BANNERMAN, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en

décembre 2015.

162232

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 Juillet 2015.

Référence de publication: 2015172571/18.
(150191239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

International Chemical Investors VII S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 172.526.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172564/9.
(150190979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

International Chemical Investors VIII S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 173.087.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172565/9.
(150190978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

International Chemical Investors X S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 180.600.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172566/9.
(150190976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

International Chemical Investors XI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 180.543.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172567/9.
(150190975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

INVESCO PIT (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 121.720.

Der Jahresabschluss zum 31. März 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172568/9.
(150190969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

IQ Industrial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 179.429.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

162233

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015172570/11.
(150190797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Lux Fourstar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 200.547.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat d'apport de parts sociales daté du 9 octobre 2015 que ADS Foreign Holdings, Inc. a cédé les 20.000

parts sociales qu'il détenait dans le capital social de la Société à Alliance Data Foreign Holdings Inc, une société constituée
selon les lois du Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, États-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du secrétaire d'État du Delaware sous le numéro 4220754.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Lux Fourstar S.à r.l.

Référence de publication: 2015172609/16.
(150190945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

IS EF Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.334.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172572/9.
(150191240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

IS EF Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 117.042.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172574/9.
(150191197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

NovEnergia II - Energy &amp; Environment (SCA), Sicar, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 21, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 124.550.

<i>Extrait rectificatif de:

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 14 avril 2015 réf. L150069036 déposé le

<i>23 avril 2015

En date du 14 avril 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler le mandat de Deloitte Audit SARL, en qualité de réviseur d'entreprises agréé, jusqu'à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 22 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Novenergia II - Energy &amp; Environment (SCA), SICAR
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015172689/18.
(150190741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162234

L

U X E M B O U R G

ISAR BS Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.756.

Der Jahresabschluss zum 31. März 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172575/9.
(150190970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

ISAR FR Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.757.

Der Jahresabschluss zum 31. März 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172576/9.
(150190971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Italtriest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 65.122.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172577/9.
(150191428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

ITW Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 85.382.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 octobre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015172578/11.
(150191017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Matrix Technologie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9125 Schieren, 119, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 105.704.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
C.F.N. GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P.80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015172649/16.
(150190484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162235

L

U X E M B O U R G

Japan Universal Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 100.089.362,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 118.003.

Le bilan rectificatif au 30 juin 2014 (du bilan déposé le 11/02/2015 sous la référence L-150027364) a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172579/11.
(150191316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Juliette Films S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 25-27, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 166.360.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/10/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2015172581/12.
(150191361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Jamiva S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 170.324.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale en date du 21 octobre 2015

L'assemblée générale a pris acte de la démission de Monsieur Francesco ZITO de son mandat d'administrateur unique

de la Société et a décidé de nommer en qualité de nouvel administrateur unique Monsieur Stéphane RAMEAU, demeurant
6, rue Fernand D'Huart, L-1739 Luxembourg, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172583/12.
(150191279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 149.616.

<i>Extrait des Résolutions du Conseil de Gérance datées du 20 septembre 2015

Avec effet au 1 

er

 octobre 2015, le Conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de a Société du 22, avenue

Marie Thérèse L-2132 Luxembourg au 2, Rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg.

Avec effet au 1 

er

 octobre 2015, le Conseil de gérance a décidé aussi de transférer les adresses professionnelles de les

gérants de Classe B Monsieur Thomas Heymans et Madame Nathalie Canzerini du 22, avenue Marie Thérèse L-2132 au
2, Rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg.

Avec effet au 1 

er

 octobre 2015, le Conseil de gérance a décidé de transférer l'adresse de gérant de Classe A Monsieur

Alexandre Machkevich du 36-42 Herbert Samuel Street, Tel Aviv, Israel au Apartment 2100, 19 Hayarkon Street, Tel Aviv
6801120, Israel.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172950/19.
(150191771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

162236

L

U X E M B O U R G

JIH Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 189.157.

<i>Dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt N° L150109494 du 25/06/2015

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2015172585/12.
(150191396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Karmorneftegaz Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.600,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 21, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 174.883.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 16 octobre 2015 de la Société que le siège de la Société

a été transféré de L-2163 Luxembourg, 40 avenue Monterey à L-1637 Luxembourg, 21 rue Goethe.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015172586/13.
(150191118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Karmorneftegaz SARL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 21, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 175.395.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 16 octobre 2015 de la Société que le siège de la Société

a été transféré de L-2163 Luxembourg, 40 avenue Monterey à L-1637 Luxembourg, 21 rue Goethe.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015172587/13.
(150191114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

MBERP II (Luxembourg) 24 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 197.459.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 20 octobre 2015 que la société MEYER BERGMAN EUROPEAN

RETAIL PARTNERS II HOLDINGS S.àr.l. a cédé 12.500 parts sociales de la Société à la société MEYER BERGMAN
EUROPEAN RETAIL PARTNERS III HOLDINGS S.àr.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2015.

<i>Pour la société MBERP II (Luxembourg) 24 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015172650/16.
(150191054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

162237

L

U X E M B O U R G

KAG Europe S.C.S., Société en Commandite simple,

(anc. Kag Italy 1 S.C.S.).

Capital social: EUR 100,01.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 198.328.

EXTRAIT

L'assemblée extraordinaire des associés de la Société a décidé en date du 19 octobre 2015 de changer la dénomination

de la Société de “KAG Italy 1 S.C.S.” en “KAG Europe S.C.S.”.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KAG Italy 1 S.C.S.

Référence de publication: 2015172591/13.
(150190714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

KAG Italy S.C.S., Société en Commandite simple,

(anc. Kag Italy 2 S.C.S.).

Capital social: EUR 100,01.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 198.327.

EXTRAIT

L'assemblée extraordinaire des associés de la Société a décidé en date du 19 octobre 2015 de changer la dénomination

de la Société de “KAG Italy 2 S.C.S.” en “KAG Italy S.C.S.”.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KAG Italy 2 S.C.S.

Référence de publication: 2015172592/13.
(150190715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Kecha S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 54.309.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172593/9.
(150191436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Avesta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 109.197.

<i>Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon exceptionnelle en date du 20 octobre

<i>2015

<i>6 

<i>ème

<i> Résolution:

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Yves THIEBAUT, Nicolas

MIN et Andréas TARTORAS jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2021.

<i>7 

<i>ème

<i> Résolution:

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la Société A3T SA., ayant son siège social au 44, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg à la fonction de Commissaire de la Société jusqu'à la tenue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

162238

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

<i>Pour AVESTA S.A.

Référence de publication: 2015172962/19.
(150192186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Kita S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 153.107.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172595/9.
(150190458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

KS Machines Agricoles et Viticoles S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5741 Filsdorf, 3, Kabesbierg.

R.C.S. Luxembourg B 67.558.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172597/9.
(150191537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Kumming Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de L'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 190.270.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015172598/9.
(150190900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Kyra Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 147.702.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015172599/10.
(150190490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Pavane Investments S.à r.l., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.943.

EXTRAIT

Changement de nom des associés au 30 juin 2015:
- La société Tangelo Gestion a changé de nom et porte désormais la dénomination suivante:
Manzana K II S.L.
- La société Buperum Investments a changé de nom et porte désormais la dénomination suivante:
Manzana K I S.L.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

162239

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 20/10/2015.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015172718/17.

(150191174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Digital Services XXVI (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.499.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 19 octobre 2015

En date du 19 octobre 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer Monsieur Stefan HAUBOLD, né le 8 février 1980 à Jena, Allemagne, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: Sonnenburgerstrasse 73, D-10437 Berlin, Allemagne, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la
Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Christian SENITZ, gérant de catégorie A

- Monsieur Stefan HAUBOLD, gérant de catégorie A

- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B

- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Digital Services XXVI (GP) S.à r.l.

Référence de publication: 2015172394/21.

(150191305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

SALON ANDRE, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 99.289.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015172142/10.

(150190179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Société Luxembourgeoise d'Entreprises et de Constructions, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 4.473.

Les «autorisations signatures» et «la liste nominative des personnes autorisées» ont été déposées au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Frank HALMES
<i>Directeur Administratif et Financier

Référence de publication: 2015172132/13.

(150190006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

162240


Document Outline

A.E. Holding S.A.

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l.

Avesta S.A.

Digital Services XXVI (GP) S.à r.l.

GT Global S.A.

GT Satellite Systems S.A.

H2O LuxCo S.à r.l.

H3O S.à r.l.

HABA Assurances S.à r.l.

Hailey Holdings S.à r.l.

HaPP S.à r.l.

Harrods Property Investments Sàrl

Havsund S.à r.l.

Highland VI - CAS (A) S.à r.l.

Highland VI - CAS (B) S.à r.l.

Hiltonian International S.à r.l.

H.K. Studio S.à r.l.

Horsmans s.à r.l.

HRGT Shopping Centres Holdco S.à r.l.

HRGT Topco S.à r.l.

Hub Investments S.à r.l.

HWB Consulting &amp; Real Estate S.à r.l.

Hypomath S.A.

Ibersports Sàrl

Icamm S.A.

Icamm S.A.

ICG Senior Debt Partners SV 1

ID Concept S.à r.l.

IF 1 Sàrl

IF 1 Sàrl

I.G. Investments S.A.

Igloo JV Holding S.à r.l.

Immo-Service S.A.

Immo T.P.

Incarta Development S.A.

Inimm Due S.àr.l.

Intercity S.A.

International Chemical Investors III S.A.

International Chemical Investors IX S.A.

International Chemical Investors VIII S.A.

International Chemical Investors VII S.A.

International Chemical Investors VI S.A.

International Chemical Investors XI S.A.

International Chemical Investors X S.A.

InterV Investment S.à r.l.

INVESCO PIT (Luxembourg) S.à r.l.

IQ Industrial Holding S.à r.l.

ISAR BS Lux S.à r.l.

ISAR FR Lux S.à r.l.

IS EF Three S.à r.l.

IS EF Three S.à r.l.

IS EF Two S.à r.l.

I.S.H. Finance S.A.

Italtriest International S.A.

ITW Participations S.à r.l.

Jamiva S.A.

Japan Universal Investments S.àr.l.

Jean-Charles Manes S.A.

JFA &amp; Interfaces Est.

JIH Luxembourg S.A.

Jost Management S.A.

Juliette Films S.A.

KAG Europe S.C.S.

Kag Italy 1 S.C.S.

Kag Italy 2 S.C.S.

KAG Italy S.C.S.

Karmorneftegaz Holding Sàrl

Karmorneftegaz SARL

Kecha S.A.

Kita S.à r.l.

Kizoku Investments S.à r.l.

Komatsu Capital Europe S.A.

KS Machines Agricoles et Viticoles S.àr.l.

Kumming Finance S.A.

Kyra Investissements S.A.

Les Amis de l'Orgue Saint-Martin Dudelange

Lotus S.A.

Luxemburgische Beteiligungs- und Foerderungsgesellschaft S.A.

Lux Fourstar S.à r.l.

Lux Germes Compléments Vitalité S.à r.l.

Lux Technology S.A.

LVS Holdings S.à r.l.

Matrix Technologie S.A.

MBERP II (Luxembourg) 24 S.à.r.l.

MSREF Danube Lux Holding II S.à r.l.

NovEnergia II - Energy &amp; Environment (SCA), Sicar

OPTrust Infrastructure Europe I

Pavane Investments S.à r.l.

Peakside Forum S.à r.l.

SALON ANDRE, société à responsabilité limitée

Sincro Sicav

SI Olm (Luxembourg) S.à r.l.

SI Vianden (Luxembourg) S.à r.l.

SI Vianden (Luxembourg) S.à r.l.

Société Luxembourgeoise d'Entreprises et de Constructions

WCMG (Working Capital Management Group) S.A.

Western Investments Capital S.A.

White Gatsby

Wildrosen S.à r.l.

Wingust Management S.A., SPF

WM Olm (Luxembourg) S.à r.l.

WM Vianden (Luxembourg) S.à r.l.

ZAB Prop Co. C S.à r.l.