logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3081

11 novembre 2015

SOMMAIRE

Alandsbanken Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147843

Assur.Lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147847

Biotoscana Investments & Cy S.C.A.  . . . . . . .

147845

Biotoscana Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

147845

Blueground Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147888

BNT Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147850

BOSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147842

Brasserie Les Arcades S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

147842

Brothers Event Management Sàrl  . . . . . . . . . .

147866

Café Beim Susy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147846

Carix S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147846

CCWP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147845

Ceria S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147851

Chall'O Music International S.A.  . . . . . . . . . .

147850

Cogestilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147847

Colorblind S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147843

Compass Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147843

Copaco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147849

CTI Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147851

Energy Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147868

Ermax SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147868

European Services and Equipment S.à r.l.  . . .

147845

Fedora S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147849

Gef Real Estate Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147842

Hasenkamp Luxemburg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

147847

Hovemag A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147847

Integer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147845

K1 Family Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

147848

K1 Family Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

147848

Koratrade Asset Management S.A.  . . . . . . . . .

147844

Koratrade Asset Management S.A.  . . . . . . . . .

147848

L&C LuxHoldCo Poland S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

147848

LOPES Frères S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147844

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l.  . . .

147847

Marcenaire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147846

Maris S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147849

Mindjam S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147846

Multipoints Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

147863

Musana Property Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

147846

NRG 6 S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147849

Oasis Holding 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147866

Palis Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147844

PAN European Value Added Venture Feeder

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147853

RCR Industrial Flooring S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

147857

SCI CÉSAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147851

SCI La Bella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147864

Silver Arrow S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147844

Somuchmore Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

147868

Ter Kameren Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

147843

VF Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147848

Vox Teneo Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

147866

Want Brothers Accounting S.A. . . . . . . . . . . . .

147888

Wine & Spirit Investment S.A. . . . . . . . . . . . . .

147842

147841

L

U X E M B O U R G

Wine & Spirit Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 111.645.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015157709/9.
(150173325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

BOSC, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.819.258,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 179.249.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157797/10.
(150174287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Brasserie Les Arcades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 5-7, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 111.961.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015157798/10.
(150174073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Gef Real Estate Holding, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 21.066.

The Board of Liquidators convenes the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders Extraordinarily held. The Board of Liquidators convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders

to be held extraordinarily on <i>November 20, 2015 at 11.30 a.m. at the registered office of the Company with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. " Acknowledgement and approval of the report of the board of liquidators and of the report of the Commissaire to

the liquidation on the liquidation and approval of the liquidation accounts as of September 30, 2015;

2. Discharge for the performance of their duties to:

a. All the directors of the company in office from time to time up to the date of dissolution of the company;
b. The liquidators
c. The Commissaire to the liquidation

3. Closure of the liquidation;
4. Decision to keep the books and records of the company at the offices of Gefinor Finance S.A., 30 Quai Gustave-

Ador, 1207 Geneva, Switzerland, for a period of 5 years;

5. Decision to instruct the liquidators to carry out the remaining actions linked to the closing of the liquidation;
6. Decision to authorise and instruct and authorise Alter Domus Luxembourg S.à r.l. to execute and implement or take

any steps for or in relation with any publication or registration formalities which may be required in relation to the
liquidation."

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015168742/581/25.

147842

L

U X E M B O U R G

Ter Kameren Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5222 Sandweiler, 5, an der Wiewerbach.

R.C.S. Luxembourg B 170.900.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015157671/9.
(150173198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Compass Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 164.128.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158431/10.
(150174723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Colorblind S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 14, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 157.825.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015158463/10.
(150175321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Alandsbanken Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 153.290.

The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of the SICAV to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held before public notary at the registered office of the SICAV on <i>20 November 2015 at 11:30 a.m. (the "Meeting")

with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approve the documents related to the merger of Alandsbanken SICAV : Swedish Bond, Alandsbanken SICAV :

Brig 6 and Alandsbanken SICAV : Money Market SEK in the respective Finnish mutual funds Alandsbanken Swedish
Bond Fund, Bank of Åland Premium 30 Fund and Alandsbanken Short Term Bond Fund SEK of Alandsbanken
Funds Ltd, according to article 1 (20) a) of the law of 17 December 2010 (the "2010 Law")

2. Fix the effective date of the merger on 30 November 2015, according to the 2010 Law
3. Declare the dissolution of the SICAV with effect on 30 November 2015 by virtue of the merger by absorption of the

remaining sub-funds of the SICAV.

Shareholders are advised that a quorum of fifty percent of the share capital of the SICAV is required for the Meeting

and that decisions will be taken by a majority of two thirds of the votes cast. Proxies are available free of charge at the
registered office of the SICAV. Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (Fax nr:
+352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the Meeting.

Shareholders  may  consult  the  documents  of  the  merger  with  the  registered  office  of  the  SICAV  and  at

fond@alandsbanken.fi.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015177225/755/25.

147843

L

U X E M B O U R G

Silver Arrow S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.345.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015157629/9.
(150173310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

LOPES Frères S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 43, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 89.211.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LOPES Frères S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015158055/12.
(150174224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Koratrade Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 52.469.

Veuillez noter que le siège social de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S. à r. l., R.C.S. Luxembourg B

58545, se situe désormais à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015158029/13.
(150174106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Palis Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 167.975.

EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique en date du 17 septembre 2015:
Les démissions, avec effet au 17 septembre 2015, des personnes suivantes ont été acceptées:
1- Monsieur Alan Dundon, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et
2- Monsieur Fabrice Meeuwis, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
La personne suivante a été nommée en tant que gérant unique de la Société, avec effet au 17 septembre 2015 et ce pour

une durée illimitée:

1 - Cambridge Terrace (Director) Ltd, une société à responsabilité limitée de droit de Guernsey, ayant son adresse au

16 Finchley Road, Londres, NW8 6EB, et immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 09228360.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158113/20.
(150173934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

147844

L

U X E M B O U R G

European Services and Equipment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 112.910.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015157904/9.
(150174064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Biotoscana Investments &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.861.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158383/10.
(150174688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Biotoscana Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.840.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158384/10.
(150174687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

CCWP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 3A, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 152.676.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015158446/11.
(150174619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Integer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 190.703.

Il est porté à la connaissance de tous que le siège social de la société a fait l'objet d'un changement avec effet au 1 

er

Septembre 2015. A savoir:

Transfert au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015157987/14.
(150174098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

147845

L

U X E M B O U R G

Musana Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 169.508.

Le bilan au 31.12.2014 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015158071/9.
(150173749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Carix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 149.880.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 25/09/2015.

Référence de publication: 2015158439/10.
(150174750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Café Beim Susy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 86, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 176.497.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2015158419/10.
(150174467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Mindjam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7777 Bissen, 19, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.086.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Alex Sinner
<i>Gérant

Référence de publication: 2015158068/12.
(150174338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Marcenaire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 62.139.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MARCENAIRE S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015158076/13.
(150174225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

147846

L

U X E M B O U R G

Assur.Lu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1236 Luxembourg, 5, rue Mathias Birton.

R.C.S. Luxembourg B 104.280.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015158363/9.
(150174815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Hovemag A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 59, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 101.943.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 25 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158646/10.
(150174831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Cogestilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4518 Differdange, 2, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 145.432.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015158462/11.
(150174486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Hasenkamp Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1360 Findel, Luxair Cargo Center Office I 2060.

R.C.S. Luxembourg B 115.850.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2015.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2015158634/11.
(150175297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 137.972.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

<i>Pour Maranello Properties Luxembourg S.à r.l.
Représenté par M. Julien François
<i>Gérant

Référence de publication: 2015158797/13.
(150174921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

147847

L

U X E M B O U R G

L&amp;C LuxHoldCo Poland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 175.412.

Les comptes annuels au 31/03/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015158737/9.
(150175205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

K1 Family Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 141.239.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015158735/10.
(150175348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

K1 Family Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 141.239.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015158736/10.
(150175349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Koratrade Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 52.469.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015158731/11.
(150175019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

VF Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 79.198.

Le Bilan consolidé de la société mère (VF Corporation) au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Septembre 2015.

VF Investments S.à.r.l.
Fabrice Rota
<i>Gérant A

Référence de publication: 2015159042/14.
(150174972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

147848

L

U X E M B O U R G

Fedora S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 181.945.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015158582/10.
(150174497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Copaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 28.206.

<i>Extrait de la résolution prise par les associés en date du 08 juin 2015

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 juin 2015.

<i>Pour COPACO S.à r.l.
Les gérants

Référence de publication: 2015157854/13.
(150174004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Maris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 188.684.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 14 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2506 du
17 septembre 2014.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Maris S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015158066/15.
(150173722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

NRG 6 S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 165.949.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 février 2015

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission, de son poste d'administrateur, de la société MALIBARO SA

SPF avec effet au 10 février 2015. Il décide de procéder par cooptation à la nomination, avec effet à cette même date, de
la société AMBRYM INVESTMENT SA ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, Route d'Esch 7, inscrite au registre
du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B194.886 et représentée par Madame Marie-Rose HART-
MAN  domiciliée  professionnellement  à  Bohey  24  L-9647  Doncols.  Ce  mandat  d'administrateur  prendra  fin  lors  de
l'Assemblée Générale de 2020.

La présente décision sera confirmée lors de la prochaine Assemblée Générale.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015158106/16.
(150174317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

147849

L

U X E M B O U R G

Chall'O Music International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 75.883.

<i>Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique en date du 10 septembre 2015

- L'actionnaire unique a accepté la démission de Monsieur François Georges de sa position d'administrateur de la société

avec effet immédiat.

- L'actionnaire unique a décidé de nommer avec effet immédiat Monsieur Alexandre Taskiran, né le 24 avril 1968 à

Karaman (Turquie), demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, au poste d'admi-
nistrateur de la société et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CHALL'O MUSIC INTERNATIONAL S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015157842/16.
(150174346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

BNT Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8372 Hobscheid, 16a, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 194.696.

L'an deux mil quinze, le onze septembre.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,

A comparu:

- Monsieur Marc LEOKA, gérant de société, né à Ottignies (Belgique), le 19 novembre 1970, demeurant à B-6700 Arlon

(Belgique), 20, rue du Vallon.

Lequel comparant est l’unique associé de «BNT S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son

siège social à L-8287 Kehlen, 15, Zone Industrielle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 194.696, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 janvier 2015, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 862 du 28 mars 2015, et dont les statuts n’ont pas été
modifiés depuis.

Lequel comparant, représentant l’intégralité du capital social de la Société, agissant en lieu et place de l’assemblée

générale extraordinaire, a requis le notaire instrumentant d'acter l’unique résolution prise suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de transférer le siège de la Société de L-8287 Kehlen, 15, Zone industrielle, à L-8372 Hobscheid,

16a, Grand-Rue, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts comme suit:

«  Art. 2. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social de la société est établi dans la commune de Hobscheid.

(…)».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à

sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 970,-.

Fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: LEOKA, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29399. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 24 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157796/37.
(150174289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

147850

L

U X E M B O U R G

Ceria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 176.483.

Le bilan au 30 juin 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158451/10.
(150174598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

CTI Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 12, Op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 94.647.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

René JOST
<i>Chief Executive Officer

Référence de publication: 2015158474/11.
(150174899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

SCI CÉSAR, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg E 5.733.

STATUTS

L'an deux mille quinze,
Le seize septembre,
Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Jonathan PRIOUX, directeur technique, né le 9 février 1992 à Thionville (France), demeurant à L-3441

Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte

2.- Madame Patricia JAROCH, gérante, née le 7 septembre 1967 à Thionville (France), demeurant à L-3377 Leudelange,

37, rue de la Gare.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont décidé d’arrêter comme suit les statuts d’une société civile immo-

bilière qu'ils constituent entre eux:

I. - Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les associés ci-avant une société civile immobilière qui prend la dénomination de «SCI

CÉSAR».

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, l’aménagement, la construction, la gestion et la location de tous

immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que la prise de participations ou intérêts dans toutes
autres sociétés immobilières de même objet, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet, la gérance pouvant effectuer toutes opérations non susceptibles de porter atteinte à la nature civile de
l’activité sociale.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision unanime des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Sa dissolution requiert l’assentiment unanime des associés.
La société n’est pas dissoute par le décès, la déconfiture ou la faillite d’un ou de plusieurs associés et les héritiers ou

ayants-droit ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les biens de la société.

II. - Capital social, Transmission des parts, Associés

Art. 5. Le capital social est fixé à mille euros (€ 1.000.-) divisé en cent (100) parts d’intérêt à dix euros (€ 10.-) chacune.

Art. 6. Toute cession de parts, sans préjudice des formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s’opérera par

acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l’article 1690 de Code Civil.

147851

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés. En cas de cession de part(s) à des non-associés, l’accord unanime

de tous les autres associés est requis.

En cas de cession à des non-associés, les autres associés disposent d’un droit de préemption et le cédant sera tenu

d’informer par lettre recommandée les autres associés des conditions de la vente projetée et ils disposeront alors d’un délai
d’un mois pour faire connaître leur intention. Faute d’avoir fait connaître leur intention dans le délai imparti, ils seront
censés ne pas exercer leur droit de préemption.

Au cas où plusieurs associés font valoir leur droit de préemption, ils l'exerceront proportionnellement au nombre de

parts qu'ils détiennent dans la société.

Art. 8.  Chaque  part  donne  droit  dans  la  propriété  de  l’actif  social  et  dans  la  répartition  des  revenus  à  une  fraction

proportionnelle au nombre des parts d’intérêt existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre

de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article
1863 du Code Civil.

III. - Gérance, Année sociale, Assemblées

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.

Art. 11. Le ou les gérant(s) a(ont) les pouvoirs lui (leur) conférés par l’assemblée des associés.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les assemblées des associés sont convoquées par le ou les gérant(s), aussi souvent que l’intérêt de la société

l’exige, moyennant notification écrite de la date, du lieu et de l’heure de chaque assemblée à chaque associé au moins cinq
(5) jours avant l’assemblée.

Cette notification sera donnée en personne ou par courrier ordinaire, télex, télégramme, transmission télégraphique ou

par toute autre transmission écrite.

Les convocations contiendront l’ordre du jour complet. Toutefois, pour autant que tous les associés soient présents ou

représentés et d’accord à ce sujet, des questions ne figurant pas à l’ordre du jour peuvent être valablement discutées et
votées.

Art. 14. Les associés se réunissent chaque année en assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 15. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un autre associé.

Chaque associé a autant de voix qu'il possède et représente de parts d’intérêt, sans limitation.
Lorsqu'une part est en indivision ou grevé d’un usufruit, les indivisaires ou le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent

désigner une seule personne pour se faire représenter à l’égard de la société et pour voter aux assemblées.

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire est celle qui arrête les comptes annuels, entend le rapport du (des) gérant(s) sur

les affaires sociales, nomme et révoque le gérant, accorde ou refuse la décharge au gérant, délibère sur toutes propositions
portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs

liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le

cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnel-

lement au nombre de parts d’intérêt possédées par chacun d’eux.

V. - Disposition générale

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts et par les conventions sous seing privé entre les associés.

<i>Souscription - Libération

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Jonathan PRIOUX, prénommé:
cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Patricia JAROCH, prénommée:
cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

147852

L

U X E M B O U R G

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de mille euros (€ 1.000.-)

se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2015.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en rapport avec les présentes, est

estimé à neuf cents euros (900.-€).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
2.- L’assemblée générale décide de fixer le nombre des gérants à un (1).
3.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
- Madame Patricia JAROCH, prénommée.
4.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. PRIOUX, P. JAROCH, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21552. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 22 septembre 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2015157644/112.
(150173755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

PAN European Value Added Venture Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 186.798.

In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of September,
before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Ms. Pascale Stammet, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in her capacity as proxyholder of Pan European Value Added Venture General Partner S.A., a public limited

company (société anonyme) with registered office at 21, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 186286,
acting as general partner (the “General Partner”) of the company PAN EUROPEAN VALUE ADDED VENTURE FEE-
DER S.C.A., herewith designated,

by virtue of the authority granted to her by resolutions of the board of directors of the General Partner (the "Board of

Directors") on 3 August 2015,

a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the

present deed.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
1. That the company PAN EUROPEAN VALUE ADDED VENTURE FEEDER S.C.A., abbreviated PEVAVF, orga-

nized as a partnership limited by shares (société en commandite par actions) with registered office at 21, Boulevard Grande
Duchesse  Charlotte,  L-1331  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and
Companies' Register under number B 186.798 (the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
ELVINGER, notary residing then in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 28 April 2014, and its articles of
incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°1793 dated
10 July 2014 (the “Mémorial”).

147853

L

U X E M B O U R G

2. That the subscribed share capital of the Company is currently set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided

into (i) one thousand (1,000) class A unlimited shares of unlimited shareholder (the “Class A Unlimited Shares”), and (ii)
thirty thousand (30,000) class B shares of limited shareholder (the “Class B Shares”), each Class A Unlimited Shares and
Class B Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-). The Class B Shares were initially subscribed by AXA Real Estate
Investment Manager UK Ltd for an amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) and the Class A Unlimited Shares were
initially subscribed by the General Partner for an amount of one thousand Euro (EUR 1,000.-) (the "Initial Shareholders").

3. That the increase of the share capital by way of authorised capital, shall be realised within the strict limits defined in

article 6 of the Articles, which reads as follows:

“ Art. 6. Authorised capital.
6.1. The Company has an authorised capital (including its issued capital) of a maximum amount of one billion euro

(Euro 1,000,000,000.-) to be used in order to issue new Shares.

6.2. The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Shares in exchange of contribution in

cash or in kind made in execution of capital calls made by the General Partner in compliance with the provisions of any
agreement entered into from time to time among the Shareholders.

6.3. Until 23 April 2019 at the latest, and in compliance with provisions of any agreement entered into from time to time

among the Shareholders, the General Partner is authorised to increase, from time to time, the capital, within the limits of
the authorised capital, by the issue of new Shares to the Shareholders or to any other person as approved by the Shareholders
in compliance with any applicable provision of the 1915 Law, these Articles or any agreement possibly entered into from
time to time by the Shareholders. The General Partner is specially authorised to issue the new Shares without reserving for
the existing Shareholders the preferential right to subscribe for new Shares.

6.4. These new Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined by the General Partner

within the strict limits stated in any agreement entered into from time to time among the Shareholders.

6.5. In particular, the General Partner may decide to issue the new Shares subject to the constitution of a share premium,

the amount and the allocation of which will be freely decided by the General Partner in accordance with the provisions of
any agreement entered into from time to time among the Shareholders.

6.6. The General Partner may also determine the date of the issue and the number of new Shares having to be eventually

subscribed and issued.

6.7. The rights attached to the new Shares will be strictly similar to the rights attached to the existing respective class

of Shares.

6.8. The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for new Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

6.9. The General Partner shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of capital,

the issue of new Shares and the subsequent amendment of these Articles enacted by a notary by virtue of a notarial deed
on the basis of all the necessary documents evidencing the decision of the General Partner, the above power of attorney,
the subscription and the paying up of the new Shares.”.

4. That pursuant to the first resolution of the Board of Directors’ circular resolutions dated 3 August 2015, the Board of

Directors resolved to ratify the details of issuance of Class B Shares to new investors (the "New Class B Shares"), resulting
in the increase of the share capital of the Company in relation to the issuance of New Class B Shares (the "Capital Call N
°1").

5. That in the same resolution, the General Partner approved to enact the increase of the share capital of the Company

before a public notary. The share capital of the Company, is increased as of 13 August 2015 by an amount of six thousand
two hundred sixty-six Euro (EUR 6,266.-) in order to raise it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-) to thirty-seven thousand two hundred sixty-six Euro (EUR 37,266.-) by issuing an overall six thousand two
hundred sixty-six (6,266) New Class B Shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-) and a share premium of nine
Euro (EUR 9.-). Such share capital increase has been recorded by the undersigned notary as of this date.

All these New Class B Shares have been entirely subscribed to and their pair value and share premium have been fully

paid-in, so that the total amount of sixty-two thousand six hundred sixty Euro (EUR 62,660.-) corresponding to the share
capital increase of an amount of six thousand two hundred sixty-six Euro (EUR 6,266.-) and the share premium of an
amount of fifty-six thousand three hundred ninety-four Euro (EUR 56,394.-) is forthwith at the free disposal of the Com-
pany, as has been proved to the notary.

6. That as a consequence of such increase of the share capital of the Company article 5.1 of the Articles is amended and

now reads as follows:

5. Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed capital of the Company is fixed at thirty-seven thousand two hundred sixty-six euro (EUR 37,266.-),

represented by:

- one thousand (1,000) class A unlimited shares of unlimited shareholder (“actions de commandité”, herein defined as

“Class A Unlimited Shares”);

147854

L

U X E M B O U R G

- thirty-six thousand two hundred sixty-six (36,266) class B shares of limited shareholder (“actions de commanditaire”,

herein defined as “Class B Shares”);

- class C shares as may be issued in the future (the “Class C Shares”, together with the Class A Unlimited Shares and

the Class B Shares, referred to as the “Shares”), with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The holders of the Class A Unlimited Shares are hereafter referred to as the “Class A Unlimited Shareholders”. The

holders of the Class B Shares are hereafter referred to as the “Class B Shareholders”. The holders of the Class C Shares
are hereafter referred to as the “Class C Shareholders”. The holders of the Shares are hereafter referred to as the “Share-
holders”.”.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result

of the present increase of capital, are estimated EUR 1,300.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her surname, first name, civil status

and residence, she signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le huitième jour de septembre.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Mademoiselle Pascale Stammet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de Pan European Value Added Venture General Partner S.A., une société anonyme

de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
189286, agissant en sa qualité de gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société PAN EUROPEAN VALUE
ADDED VENTURE FEEDER S.C.A., ci-après désignée,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par résolutions écrites adoptées par le conseil d’administration du Gérant

Commandité (le «Conseil d’Administration») le 3 août 2015,

dont une copie, signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations suivantes:
1. Que la société PAN EUROPEAN VALUE ADDED VENTURE FEEDER S.C.A., abrégée PEVAVF, une société en

commandite par actions dont le siège social est situé au 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
186.798 (la «Société»), a été constituée le 28 avril 2014 suivant acte de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et ses statuts (les «Statuts») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n°1793 en date du 10 juillet 2014 (le «Mémorial»).

2. Que le capital social émis de la Société s’élève actuellement à trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté

par (i) mille (1.000) actions de commandité de catégorie A d’actionnaire commandité (les «Actions de Commandité de
Catégorie A»), et (ii) trente mille (30.000) actions de commanditaire de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), chacune
des Actions de Commandité de Catégorie A et Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-).
Les Actions de Catégorie B initiales ont été souscrites par AXA Real Estate Investment Managers UK Ltd pour un montant
de trente mille Euros (EUR 30.000,-) et les Actions de Commandité de Catégorie A initiales ont été souscrites par le Gérant
Commandité pour un montant de mille Euros (EUR 1.000,-) (les «Actionnaires Initiaux»).

3. Que l’augmentation du capital social par voie de capital autorisé devra être réalisée dans les strictes limites définies

à l’article 6 des Statuts comme suit:

« Art. 6. Capital autorisé.
6.1  La  Société  a  un  capital  autorisé  (en  ce  compris  le  capital  émis)  d'un  montant  maximal  d'un  milliard  d'euros

(1.000.000.000,- EUR) à être utilisé de manière à émettre de nouvelles Actions.

6.2 Le capital autorisé a pour seul objectif de permettre la création de nouvelles Actions à émettre en contrepartie

d'apports en numéraire ou en nature effectués en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant Commandité aura procédé
conformément aux dispositions de tout contrat pouvant être conclu à tout moment entre les Actionnaires.

6.3 Jusqu'au 23 avril 2019 au plus tard, et conformément aux dispositions de tout contrat conclu à tout moment entre

les Actionnaires, le Gérant Commandité pourra augmenter à tout moment le capital social dans les limites du capital autorisé
par émission de nouvelles Actions aux Actionnaires ou toutes autres personnes agréées par les Actionnaires conformément
aux dispositions de la Loi de 1915, de ces Statuts ou de tout contrat pouvant être conclu à tout moment par les Actionnaires.

147855

L

U X E M B O U R G

Le Gérant Commandité est en particulier autorisé à émettre de nouvelles Actions sans réserver aux Actionnaires existants
le droit préférentiel de souscrire aux nouvelles Actions.

6.4 Ces nouvelles Actions pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminés par le Gérant Commandité, dans

les limites strictes énoncées dans tout contrat pouvant être conclu à tout moment entre les Actionnaires.

6.5 Le Gérant Commandité peut en particulier décider d'émettre les nouvelles Actions sous réserve de la constitution

d'une prime d'émission. Le montant et l’affectation de cette prime d'émission seront déterminés à la discrétion du Gérant
Commandité conformément aux dispositions de tout contrat pouvant être conclu à tout moment entre les Actionnaires.

6.6 Le Gérant Commandité déterminera également la date d'émission et le nombre de nouvelles Actions devant être, le

cas échéant, souscrites et émises.

6.7 Les droits attachés aux nouvelles Actions seront identiques à ceux attachés aux Actions de même catégorie déjà

émises.

6.8 Le Gérant Commandité pourra déléguer à toute personne dûment autorisée la charge d'accepter des souscriptions et

de recevoir des paiements pour les nouvelles Actions représentant tout ou partie des montants augmentés du capital social.

6.9 Le Gérant Commandité désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux fins

de constater l’émission des nouvelles Actions, l’augmentation du capital et la modification des présents Statuts qui en
résulte, sur présentation des documents nécessaires pour justifier de la décision du Gérant Commandité, en ce comprise la
délégation de pouvoir ainsi que les souscriptions et libérations des nouvelles Actions.».

4. Que conformément à la première résolution des résolutions circulaires du Conseil d’Administration prises en date du

3 août 2015, le Conseil d’Administration a décidé de ratifier les détails de l’émission d’Actions de Catégorie B à de nouveaux
investisseur (les «Nouvelles Actions de Catégorie B») suivie d’une augmentation du capital social de la Société en relation
avec cette émission de Nouvelles Actions de Catégorie B (l’«Appel de Fonds N°1»).

5. Que dans la même résolution, le Gérant Commandité a décidé de faire acter l’augmentation du capital social de la

Société devant un notaire. Le capital social de la Société est augmenté, à compter du 13 août 2015, d’un montant de six
mille deux cent soixante-six Euros (EUR 6.266,-) afin de l’augmenter de son montant actuel de trente et un mille Euros
(EUR 31.000,-) à trente-sept mille deux cent soixante-six Euros (EUR 37.266,-) par l’émission d’un ensemble de six mille
deux cent soixante-six (6.266) Nouvelles Actions de Catégorie B, chacune ayant une valeur nominale de un Euro (EUR
1,-) et une prime d’émission de neuf Euros (EUR 9,-). Cette augmentation de capital social a été constatée par le notaire
instrumentant à la date de la présente.

Toutes ces Nouvelles Actions de Catégorie B ont été intégralement souscrites et leur valeur nominale ainsi que la prime

d’émission y relative ont été intégralement libérées, de sorte que le montant total de soixante-deux mille six cent soixante
Euros (EUR 62.660,-) correspondant à l’augmentation du capital social d’un montant de six mille deux cent soixante-six
Euros (EUR 6.266,-), ainsi que la prime d’émission d’un montant total de cinquante-six mille trois cent quatre-vingt-
quatorze Euros (EUR 56.394,-) se trouvent dès à présent à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire
instrumentant.

6. Suite à la réalisation de l’augmentation du capital social souscrit susmentionnée, l’article 5.1 des Statuts est modifié

en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

« 5. Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-sept mille deux cent soixante-six Euros (EUR 37.266,-)

représenté par:

- mille (1.000) actions de commandité de catégorie A d'Actionnaire Commandité (ci-après les «Actions de Commandité

de Catégorie A»);

- trente-six mille deux cent soixante-six (36.266) actions de commanditaire de catégorie B (ci-après les «Actions de

Catégorie B»);

- des actions de catégorie C qui pourront être émises dans le futur (les «Actions de Catégorie C», ensemble avec les

Actions de Commandité de Catégorie A et les Actions de Catégorie B, désignées comme les «Actions»).

Les détenteurs d'Actions de Commandité de Catégorie A sont désignés ci-après comme les «Actionnaires Commandités

de Catégorie A». Les détenteurs d'Actions de Catégorie B sont désignés ci-après comme les «Actionnaires de Catégorie
B». Les détenteurs d’Actions de Catégorie C sont désignés ci-après comme les «Actionnaires de Catégorie C». Les dé-
tenteurs d'Actions sont ci-après désignés comme les «Actionnaires».»

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de EUR 1.300.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

147856

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses noms, prénom usuel,

état et demeure, le comparant susnommé a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. STAMMET, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 Septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/28908. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 Septembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015156362/206.
(150172083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2015.

RCR Industrial Flooring S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 102.358.

In the year two thousand and fifteen, on the ninth of September;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1) Primopiso Acquisition S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157942,

2) Mr. Jean Pierre MAIER, with address at 278, Avenue de Fabron, 06200 Nice, France,
3) Mr. Claude TORRENTE, with address at 4, Allée du Pampre, 38330 St Ismier, France,
4) Mr. Marc BRUNEAU, with address at 10, Rue Angevines, 84310 Morières-Lès-Avignon, France,
5) Mr. Emilio Esteban, with address at c/ Toledo 172, Madrid 28005, Madrid, Spain;
6) Mr. Emilio Oñate, with address at c/ Navia 23, Madrid 28044, Spain;
7) Mr. José Luis Calvo, with address at c/ Suiza 8, Villalbilla 28810, Spain;
8) Mr. Angel Yagüe, with address at c/ Moreno Carbonero, 1 Azuqueca de Henares 19200, Spain;
9) Mr. José Luis Gabella, with address at Avda. Dinamarca 33, Villalbilla 28810, Spain;
10) Mr. Pietro Bortoluzzi, with address at Lindenweg 25, 71120 Grafenau, Germany;
11) Mr. Oto Herrmann, with address at Zbuzkova 175 / 51, 190 00 Praha 9, Vysocany, Czech Republic;
12) Mr. Christophe Cortinovis, with address at 3, C/ Playa de Mojacar, Urbanización Bonanza, 28660 Boadilla del

Monte, Madrid, Spain;

13) Mr. Juan Ignacio Jorge Ucieda, with address at Av. Navacerrada 4. Portal 7. 1ºA, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid),

Spain;

All of them here duly represented by Mrs. Carla ALVES SILVA, private employee, residing professionally at 4l2F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of thirteen (13) proxies given under private
seal.

The said proxies, after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the officiating notary, shall remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties listed from 1) to 13) above are collectively referred to as the "Shareholders".
The Shareholders have requested the officiating notary to document that the Shareholders are all the shareholders of the

"société à responsabilité limitée" established in Luxembourg under the name of RCR Industrial Flooring S.à r.l., with
registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et
des Sociétés under number B 102358 and incorporated on 21 July 2004 under the denomination of "Highbridge/Zwirn
Rinol Holdings Offshore, S.à r.l." pursuant to a deed of Me Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1062 of 22 October 2004 (the "Company"). The
articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been amended several times and for the last time pursuant
to a deed of Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on 28 June 2013, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 2296 of 18 September 2013.

The Shareholders, represented as above mentioned, recognise to be fully informed of the resolutions to be taken on the

basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the corporate capital by an amount of three hundred thirty one thousand six hundred euro (EUR 331,600.-)

so  as  to  raise  it  from  its  present  amount  of  four  million  five  hundred  seventy  two  thousand  five  hundred  euro  (EUR

147857

L

U X E M B O U R G

4,572,500.-) to the amount of four million nine hundred four thousand one hundred euro (EUR 4,904,100.-) by the creation
and the issue of seven hundred forty five (745) Ordinary A Shares and twelve thousand five hundred nineteen (12,519)
Ordinary B Shares, to be fully paid up.

2. To accept the subscriptions of the newly issued shares.

3. To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the increase of the corporate

capital of the Company.

4. In accordance with article 189 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended,

to approve Mr. Fabien Menu as new shareholder of the Company.

5. Miscellaneous.

The Shareholders have requested the officiating notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the corporate capital of the Company by an amount of three hundred thirty-one

thousand six hundred euro (EUR 331,600.-) so as to raise it from its present amount of four million five hundred seventy-
two thousand five hundred euro (EUR 4,572,500.-) to the amount of four million nine hundred four thousand one hundred
euro (EUR 4,904,100.-) by the creation and the issue of seven hundred forty-five (745) Ordinary A Shares and twelve
thousand five hundred nineteen (12,519) Ordinary B Shares, each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-)
and to be fully paid up (the "New Shares").

<i>Subscription - Payment

The Shareholders resolve to accept subscriptions and payments in cash as follows and to allot the New Shares to the

following subscribers as fully paid shares:

a) Primopiso Acquisition S.à r.l., prenamed, declared to subscribe for the following New Shares, with a nominal value

of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to make payment in full by a contribution in cash allocated to the Company's
share capital, together with a share premium as follows:

Class of shares

Number

of shares

Share

capital
(EUR)

Share

premium

(EUR)

Ordinary B Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,519

312,975.- 1,197,158.-

b) Mr. Daniel Maidana, with address at C/Durillo 1, Portal 4, Bajo B, 28232 Las Rozas de Madrid, Spain,

here represented by Mrs. Carla ALVES SILVA, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

declared to subscribe for the following New Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to

make payment in full by a contribution in cash allocated to the Company's share capital, together with a share premium as
follows:

Class of shares

Number

of shares

Share

capital
(EUR)

Share

premium

(EUR)

Ordinary A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

1,025.-

3,920.72

c) Mr. Augustín Escamez, with address at Plaza José Celestino Mutis 6, 2do. C, 28522 Rivas Vaciamadrid, Spain;

here represented by Mrs. Carla ALVES SILVA, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

declared to subscribe for the following New Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to

make payment in full by a contribution in cash allocated to the Company's share capital, together with a share premium as
follows:

Class of shares

Number

of shares

Share

capital
(EUR)

Share

premium

(EUR)

Ordinary A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

3,100.-

11,857.78

d) Mr. Jesùs Librán, with address at C/ De Albadalejo 040 C 5 C, 28037 Madrid, Spain;

here represented by Mrs. Carla ALVES SILVA, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

declared to subscribe for the following New Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to

make payment in full by a contribution in cash allocated to the Company's share capital, together with a share premium as
follows:

147858

L

U X E M B O U R G

Class of shares

Number

of shares

Share

capital
(EUR)

Share

premium

(EUR)

Ordinary A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

3,100.-

11,857.78

e) Mr. Andrew Keen, with address at Abbots Mead, Exeter Road, Ivybridge, Devon, PL21 0BG, United Kingdom;
here represented by Mrs. Carla ALVES SILVA, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

declared to subscribe for the following New Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to

make payment in full by a contribution in cash allocated to the Company's share capital, together with a share premium as
follows:

Class of shares

Number

of shares

Share

capital
(EUR)

Share

premium

(EUR)

Ordinary A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

2,075.-

7,937.06

f) Mr. Denis Barat, with address at 31 Allée Georges Brassens, 77600 Bussy St. Georges, France;
here represented by Mrs. Carla ALVES SILVA, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

declared to subscribe for the following New Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to

make payment in full by a contribution in cash allocated to the Company's share capital, together with a share premium as
follows:

Class of shares

Number

of shares

Share

capital
(EUR)

Share

premium

(EUR)

Ordinary A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

3,100.-

11,857.78

g) Mrs. Nathalie Busseau, with address at 45 Rue Grande, 13410 Lambesc, France;
here represented by Mrs. Carla ALVES SILVA, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

declared to subscribe for the following New Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to

make payment in full by a contribution in cash allocated to the Company's share capital, together with a share premium as
follows:

Class of shares

Number

of shares

Share

capital
(EUR)

Share

premium

(EUR)

Ordinary A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

2,075.-

7,937.06

h) Mr. Gilles Vergier, with address at Étage RDJ, Escalier B, 37 Av Chateau, 92190 Meudon, France;
here represented by Mrs. Carla ALVES SILVA, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

declared to subscribe for the following New Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to

make payment in full by a contribution in cash allocated to the Company's share capital, together with a share premium as
follows:

Class of shares

Number

of shares

Share

capital
(EUR)

Share

premium

(EUR)

Ordinary A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

2,075.-

7,937.06

i) Mr. Julien Andrade, with address at 78Bis, rue d'Anjou, 49450 St. Macaire en Mauges, France;
here represented by Mrs. Carla ALVES SILVA, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

declared to subscribe for the following New Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to

make payment in full by a contribution in cash allocated to the Company's share capital, together with a share premium as
follows:

Class of shares

Number

of shares

Share

capital
(EUR)

Share

premium

(EUR)

Ordinary A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

2,075.-

7,937.06

The amount of one million six hundred thousand euro and thirty cents (EUR 1,600,000.30) is at the free disposal of the

Company as it has been proved to the officiating notary who expressly acknowledges it.

147859

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders unanimously resolve to amend article 5 of the Articles

of the Company. Such article shall henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital. The Company's share capital is set at four million nine hundred four thousand one hundred euro

(EUR 4,904,100.-) represented by sixty-one thousand seventeen (61,017) Ordinary A Shares and one hundred thirty five
thousand one hundred forty seven (135,147) Ordinary B Shares, with a par nominal of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

<i>Third resolution

In accordance with article 189 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended,

the Shareholders resolve to approve Mr. Fabien Menu, with address at Les 13 Vents, 49370 Becon les Granits, France, as
new shareholder of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at two thousand six hundred euro (EUR 2,600.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said proxyholder signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le neuf septembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), sous-

signé;

ONT COMPARU:

1) Primopiso Acquisition S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 5,

rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 157942,

2) Monsieur Jean Pierre MAIER, avec adresse au 278, Avenue de Fabron, 06200 Nice, France,
3) Monsieur Claude TORRENTE, avec adresse au 4, Allée du Pampre, 38330 St Ismier, France,
4) Monsieur Marc BRUNEAU, avec adresse au 10, Rue Angevines, 84310 Morières-Lès-Avignon, France,
5) Monsieur Emilio Esteban, avec adresse à c/ Toledo, 172 Madrid 28005, Espagne;
6) Monsieur Emilio Oñate, avec adresse à c/ Navia, 23 Madrid 28044, Espagne;
7) Monsieur José Luis Calvo, avec adresse à c/ Suiza 8, Villalbilla 28810, Espagne,
8) Monsieur Angel Yagüe, avec adresse à c/ Moreno Carbonero, 1 Azuqueca de Henares 19200, Espagne;
9) Monsieur José Luis Gabella, avec adresse à Avda. Dinamarca 33, Villalbilla 28810, Espagne;
10) Monsieur Pietro Bortoluzzi, avec adresse à Lindenweg 25, 71120 Grafenau, Allemagne;
11) Monsieur Oto Herrmann, avec adresse à Zbuzkova 175 / 51, 190 00 Prague 9, Vysocany, République Tchèque;
12) Monsieur Christophe Cortinovis, avec adresse au 3, C/ Playa de Mojacar, Urbanización Bonanza, 28660 Boadilla

del Monte, Madrid, Espagne;

13) Monsieur Juan Ignacio Jorge Ucieda, avec adresse à Av. Navacerrada 4. Portal 7. 1ºA, 28224 Pozuelo de Alarcón

(Madrid), Espagne;

Tous ici dûment représentés par Madame Carla ALVES SILVA, employée privée, demeurant professionnellement au

4l2F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en vertu de treize (13) procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparants énumérés ci-dessus sous les points 1) à 13) sont collectivement dénommés les "Associés".
Les Associés ont requis le notaire instrumentant de documenter que les Associés sont tous les associés de la société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de RCR Industrial Flooring S.à r.l., avec siège social
à 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 102358, et constituée le 21 juillet 2004 sous la dénomination de "Highbridge/Zwirn Rinol Holdings Offshore,
S.à r.l." suivant acte de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1062 du 22 octobre 2004 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont

147860

L

U X E M B O U R G

été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à
Luxembourg, le 28 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2296 du 18 septembre
2013.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissent être entièrement informés des décisions à prendre sur

base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trois cent trente et un mille six cents euro (EUR 331.600,-)

pour le porter de son montant actuel de quatre millions cinq cent soixante-douze mille cinq cents euros (EUR 4.572.500,-)
à quatre millions neuf cent quatre mille cent euros (EUR 4.904.100,-) par la création et l'émission de sept cent quarante-
cinq (745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A et douze mille cinq cent dix-neuf (12.519) Parts Sociales Ordinaires
de Catégorie B, à libérer intégralement.

2. Accepter les souscriptions des nouvelles parts sociales émises.
3. Modifier l'article 5 des statuts de la Société en conséquence de l'augmentation du capital social de la Société.
4. En conformité avec l'article 189 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifié, approbation de M. Fabien Menu en tant que nouvel associé de la Société.

5. Divers.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois cent trente et un

mille six cents euros (EUR 331.600,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cinq cent soixante-douze
mille cinq cents euros (EUR 4.572.500,-) à quatre millions neuf cent quatre mille cent euros (EUR 4.904.100,-) par la
création et l'émission de sept cent quarante-cinq (745) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A et douze mille cinq cent
dix-neuf (12.519) parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) et devant être libérée intégralement (les "Nouvelles Parts Sociales").

<i>Souscription - Paiement

Les Associés décident d'accepter les souscriptions et paiements en numéraire et d'allouer les Nouvelles Parts Sociales

aux souscripteurs comme parts sociales intégralement libérées de la manière suivante:

a) Primopiso Acquisition S.à r.l., prénommée, a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales suivantes, avec une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire alloué au
capital social de la Société, ensemble avec une prime d'émission comme suit:

Catégorie de Parts Sociales

Nombre

de Parts

Sociales

Capital

social

(EUR)

Prime

d'émission

(EUR)

Parts Sociales Ordinaires de catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.519

312.975,- 1.197.158,-

b) Monsieur Daniel Maidana, avec adresse au C/Durillo 1, Portal 4, Bajo B, 28232 Las Rozas de Madrid, Espagne;
ici représenté par Madame Carla ALVES SILVA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement,

a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales suivantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire alloué au capital social de la Société, ensemble avec une
prime d'émission comme suit:

Catégorie de Parts Sociales

Nombre

de Parts

Sociales

Capital

social

(EUR)

Prime

d'émission

(EUR)

Parts Sociales Ordinaires de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

1.025,-

3.920,72

c)  Monsieur  Augustín  Escamez,  avec  adresse  au  Plaza  José  Celestino  Mutis  6,  2do.  C,  28522  Rivas  Vaciamadrid,

Espagne;

ici représenté par Madame Carla ALVES SILVA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement,

a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales suivantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire alloué au capital social de la Société, ensemble avec une
prime d'émission comme suit:

Catégorie de Parts Sociales

Nombre

de Parts

Sociales

Capital

social

(EUR)

Prime

d'émission

(EUR)

Parts Sociales Ordinaires de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

3.100,-

11.857,78

d) Monsieur Jesùs Librán, avec adresse au C/ De Albadalejo 040 C 5 C, 28037 Madrid, Espagne;

147861

L

U X E M B O U R G

ici représenté par Madame Carla ALVES SILVA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement,

a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales suivantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire alloué au capital social de la Société, ensemble avec une
prime d'émission comme suit:

Catégorie de Parts Sociales

Nombre

de Parts

Sociales

Capital

social

(EUR)

Prime

d'émission

(EUR)

Parts Sociales Ordinaires de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

3.100,-

11.857,78

e) Monsieur Andrew Keen, avec adresse à Abbots Mead, Exeter Road, Ivybridge, Devon, PL21 0BG, Royaume-Uni;
ici représenté par Madame Carla ALVES SILVA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement,

a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales suivantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire alloué au capital social de la Société, ensemble avec une
prime d'émission comme suit:

Catégorie de Parts Sociales

Nombre

de Parts

Sociales

Capital

social

(EUR)

Prime

d'émission

(EUR)

Parts Sociales Ordinaires de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

2.075,-

7.937,06

f) Monsieur Denis Barat, avec adresse au 31 Allée Georges Brassens, 77600 Bussy St. Georges, France;
ici représenté par Madame Carla ALVES SILVA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement,

a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales suivantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire alloué au capital social de la Société, ensemble avec une
prime d'émission comme suit:

Catégorie de Parts Sociales

Nombre

de Parts

Sociales

Capital

social

(EUR)

Prime

d'émission

(EUR)

Parts Sociales Ordinaires de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

3.100,-

11.857,78

g) Madame Nathalie Busseau, avec adresse au 45 Rue Grande, 13410 Lambesc, France;
ici représentée par Madame Carla ALVES SILVA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement,

a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales suivantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire alloué au capital social de la Société, ensemble avec une
prime d'émission comme suit:

Catégorie de Parts Sociales

Nombre

de Parts

Sociales

Capital

social

(EUR)

Prime

d'émission

(EUR)

Parts Sociales Ordinaires de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

2.075,-

7.937,06

h) Monsieur Gilles Vergier, avec adresse au Étage RDJ, Escalier B, 37 Av Chateau, 92190 Meudon, France;
ici représenté par Madame Carla ALVES SILVA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement,

a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales suivantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire alloué au capital social de la Société, ensemble avec une
prime d'émission comme suit:

Catégorie de Parts Sociales

Nombre

de Parts

Sociales

Capital

social

(EUR)

Prime

d'émission

(EUR)

Parts Sociales Ordinaires de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

2.075,-

7.937,06

i) Monsieur Julien Andrade, avec adresse au 78Bis, rue d'Anjou, 49450 St. Macaire en Mauges, France;
ici représenté par Madame Carla ALVES SILVA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement,

a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales suivantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire alloué au capital social de la Société, ensemble avec une
prime d'émission comme suit:

147862

L

U X E M B O U R G

Catégorie de Parts Sociales

Nombre

de Parts

Sociales

Capital

social

(EUR)

Prime

d'émission

(EUR)

Parts Sociales Ordinaires de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

2.075,-

7.937,06

Le montant de un million six cent mille euros et trente centimes (EUR 1.600.000,30) est à la libre disposition de la

Société tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le confirme expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident à l'unanimité de modifier l'article 5 des Statuts de

la Société. Ledit article aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à quatre millions neuf cent quatre mille cent euros (EUR

4.904.100,-) représenté par soixante et un mille dix-sept (61.017) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A et cent trente-
cinq mille cent quarante-sept (135.147) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, avec une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25.-) chacune."

<i>Troisième résolution

Conformément à l'article 189 de la loi luxembourgeoise datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, les Associés décident d'approuver Monsieur Fabien Menu, avec adresse à Les 13 Vents, 49370 Becon les Granits,
France, en tant que nouvel associé de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société en raison de la présente augmen-

tation de capital sont estimés à deux mille six cents euros (EUR 2.600,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties

comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes
parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état civil et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: C. ALVES SILVA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 15 septembre 2015. 2LAC/2015/20548. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157601/352.
(150173897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Multipoints Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 80.453.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 7 septembre 2015 lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société

<i>Multipoints Investments S.A.

- Le siège social de la société a été transféré du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 127, rue de Münlenbach,

L-2168 Luxembourg.

- Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de

Mühlenbach, a été nommé le Président du Conseil d'Administration de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Multipoints Investments S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015158094/16.
(150174347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

147863

L

U X E M B O U R G

SCI La Bella, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg E 5.734.

STATUTS

L'an deux mille quinze,
Le seize septembre,
Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Philippe GRUNEISEN, gérant de société, né le 21 juillet 1961 à Thionville (France), demeurant à F-57100

Thionville, 9, boulevard Charlemagne,

2.- Madame Myriam JAROCH, directrice commerciale, née le 13 décembre 1968 à Thionville (France), demeurant à

L-3377 Leudelange, 37, rue de la Gare.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont décidé d’arrêter comme suit les statuts d’une société civile immo-

bilière qu'ils constituent entre eux:

I. - Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les associés ci-avant une société civile immobilière qui prend la dénomination de «SCI LA

BELLA».

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, l’aménagement, la construction, la gestion et la location de tous

immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que la prise de participation ou intérêts dans toutes autres
sociétés immobilières de même objet, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet, la gérance pouvant effectuer toutes opérations non susceptibles de porter atteinte à la nature civile de l’activité
sociale.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision unanime des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Sa dissolution requiert l’assentiment unanime des associés.
La société n’est pas dissoute par le décès, la déconfiture ou la faillite d’un ou de plusieurs associés et les héritiers ou

ayants-droit ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les biens de la société.

II. - Capital social, Transmission des parts, Associés

Art. 5. Le capital social est fixé à mille euros (€ 1.000.-) divisé en cent (100) parts d’intérêt à dix euros (€ 10.-) chacune.

Art. 6. Toute cession de parts, sans préjudice des formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s’opérera par

acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l’article 1690 de Code Civil.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés. En cas de cession de part(s) à des non-associés, l’accord unanime

de tous les autres associés est requis.

En cas de cession à des non-associés, les autres associés disposent d’un droit de préemption et le cédant sera tenu

d’informer par lettre recommandée les autres associés des conditions de la vente projetée et ils disposeront alors d’un délai
d’un mois pour faire connaître leur intention. Faute d’avoir fait connaître leur intention dans le délai imparti, ils seront
censés ne pas exercer leur droit de préemption.

Au cas où plusieurs associés font valoir leur droit de préemption, ils l'exerceront proportionnellement au nombre de

parts qu'ils détiennent dans la société.

Art. 8.  Chaque  part  donne  droit  dans  la  propriété  de  l’actif  social  et  dans  la  répartition  des  revenus  à  une  fraction

proportionnelle au nombre des parts d’intérêt existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre

de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article
1863 du Code Civil.

III. - Gérance, Année sociale, Assemblées

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.

Art. 11. Le ou les gérant(s) a(ont) les pouvoirs lui (leur) conférés par l’assemblée des associés.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

147864

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Les assemblées des associés sont convoquées par le ou les gérant(s), aussi souvent que l’intérêt de la société

l’exige, moyennant notification écrite de la date, du lieu et de l’heure de chaque assemblée à chaque associé au moins cinq
(5) jours avant l’assemblée.

Cette notification sera donnée en personne ou par courrier ordinaire, télex, télégramme, transmission télégraphique ou

par toute autre transmission écrite.

Les convocations contiendront l’ordre du jour complet. Toutefois, pour autant que tous les associés soient présents ou

représentés et d’accord à ce sujet, des questions ne figurant pas à l’ordre du jour peuvent être valablement discutées et
votées.

Art. 14. Les associés se réunissent chaque année en assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 15. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un autre associé.

Chaque associé a autant de voix qu'il possède et représente de parts d’intérêt, sans limitation.
Lorsqu'une part est en indivision ou grevé d’un usufruit, les indivisaires ou le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent

désigner une seule personne pour se faire représenter à l’égard de la société et pour voter aux assemblées.

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire est celle qui arrête les comptes annuels, entend le rapport du (des) gérant(s) sur

les affaires sociales, nomme et révoque le gérant, accorde ou refuse la décharge au gérant, délibère sur toutes propositions
portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs

liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le

cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnel-

lement au nombre de parts d’intérêt possédées par chacun d’eux.

V. - Disposition générale

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts et par les conventions sous seing privé entre les associés.

<i>Souscription - Libération

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Philippe GRUNEISEN, prénommé:
cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Myriam JAROCH, prénommée:
cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de mille euros (€ 1.000.-)

se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2015.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en rapport avec les présentes, est

estimé à neuf cents euros (900.-€).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
2.- L’assemblée générale décide de fixer le nombre des gérants à un (1).
3.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Philippe GRUNEISEN, prénommé.
4.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.

147865

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. GRUNEISEN, M. JAROCH, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21554. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 22 septembre 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2015157645/112.
(150173779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Vox Teneo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 20, rue Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 144.178.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015157702/9.
(150173394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Brothers Event Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 114.170.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2015157800/11.
(150174164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Oasis Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, Place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 199.124.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of September ,
before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Macquarie (UK) Group Services Limited, a company limited by shares incorporated under the Laws of United Kingdom,

having its registered office at Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, EC2Y 9HD, London (United Kingdom) and regis-
tered with the UK trade register under number 06287793, represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary
clerk, residing professionally in Pétange, by virtue of a power of attorney, given under private seal (the Sole Shareholder).

Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- it holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing

under the name of Oasis Holdings 2 Sarl, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B 199.124, with registered office at 46, place Guillaume II L-1648 Luxembourg (the Company);

- the Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 29 July 2015, in process of being published in

the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C;

- the Company’s by-laws have not been amended since its incorporation;
- the Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 12,500 (twelve

thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1.- (one Euro) each;

- the Sole Shareholder hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;

147866

L

U X E M B O U R G

- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known

liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the assets
and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in
particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself;

- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and

to hear a report of an auditor to the liquidation;

- consequently the Company is liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the

financial situation of the Company;

- the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their

respective appointments up to the date of the present meeting; and

- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting

at the registered office of the Company.

Whereof, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le seize septembre,
par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Macquarie (UK) Group Services Limited, une société limitée par action de droit anglais, ayant son siège social au

Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, EC2Y 9HD, Londres (Royaume-Uni) et enregistrée auprès du Registre de Com-
merce d’Angleterre sous le numéro 06287793, représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de
notaire, demeurant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration sous seing privé (l’Actionnaire Unique).

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au

présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- la comparante détient toutes les actions de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise existant sous la déno-

mination Oasis Holdings 2 Sarl, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 199.124, avec siège social à 46, place Guillaume II L-1648 Luxembourg (la Société);

- la Société a été constituée en vertu d'un acte notarié du 29 juillet 2015, en cours de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, C;

- les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis sa constitution;
- le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) représenté par 12.500 (douze mille

cinq cent) actions d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune;

- par la présente l`Actionnaire Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- l`Actionnaire Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
- l`Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa
charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour
avant tout paiement à sa personne;

- l`Actionnaire Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un

rapport du commissaire à la liquidation;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
- la comparante donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société pour leur mandat à compter de la

date de leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la

présente assemblée au siège de la Société.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

147867

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les
versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21605. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015157554/91.
(150174402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Energy Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 173.515.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158523/10.
(150175251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Ermax SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 156.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ERMAX SA
Société Anonyme

Référence de publication: 2015158552/11.
(150174768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Somuchmore Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.023,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.134.

In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of August,
before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), a Societas Europaea existing under the laws of Germany, registered

with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (“Rocket”),

being the holder of fourteen thousand forty-two (14,042) common shares and nine hundred fifty-eight (958) series A1

shares,

here represented by Mrs. Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, Germany, on 10 August 2015;
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 191.426 (“Holtzbrinck”),

being the holder of two thousand eight hundred seventy-four (2,874) series A1 shares,
here represented by Mrs. Xiaoshu Tang, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 11 August 2015; and

147868

L

U X E M B O U R G

3. Landerfield Enterprises Limited, a limited liability company under the laws of Cyprus, registered with the Cyprus

Registrar of Companies under no. 210960 having its business address at Naousis 1, Karapatakis Building, 6018, Larnaca,
Cyprus (“Ru-Net”),

becoming the holder of one thousand one hundred forty-nine (1,149) series A3 shares,
here represented by Mrs. Xiaoshu Tang, LL.M., prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Larnaca Cyprus, on 11 August 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Rocket and Holtzbrinck (the “Existing Shareholders”) are all the current shareholders of Somuchmore Global S.à r.l.

(the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 194.134 and incorporated under the name of “Digital
Services XXXVIII S.à r.l.” pursuant to a deed of the notary Cosita Delvaux, residing in Luxembourg, on 7 January 2015,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 669 dated 11 March 2015. The articles of
association were amended for the last time pursuant to a deed of the same notary on 3 June 2015, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general

meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda
whereby Ru-Net participates and votes for purpose of agenda points 4. et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares in the share capital of the Company, referred to as the series A3

shares (hereinafter the “Series A3 Shares”, and together with series A1 shares, the “Series A Shares”), so that the Company
will hence have three (3) classes of shares, the common shares, the series A1 shares and the Series A3 Shares.

2. Acceptance of Landerfield Enterprises Limited, a limited liability company under the laws of Cyprus, registered with

the Cyprus Registrar of Companies under no. 210960 having its business address at Naousis 1, Karapatakis Building, 6018,
Larnaca, Cyprus, as new shareholder of the Company.

3. Increase of the Company’s share capital by an amount of one thousand one hundred and forty-nine euro (EUR 1,149)

so as to raise it from its current amount of seventeen thousand eight hundred seventy-four euro (EUR 17,874) up to nineteen
thousand twenty-three euro (EUR 19,023) by issuing one thousand one hundred forty-nine (1,149) Series A3 Shares with
a nominal value of one euro (EUR 1) each.

4. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read

as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at nineteen thousand twenty-three euro (EUR 19,023.00), represented by:
5.1.1 fourteen thousand and forty-two (14,042) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 three thousand eight hundred thirty-two (3,832) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)

each, and

5.1.3 one thousand one hundred forty-nine (1,149) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

(together with the series A1 shares, the “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

5. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Somuchmore

Global S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

147869

L

U X E M B O U R G

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may

be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at nineteen thousand and twenty-three euros (EUR 19,023.00), represented by
5.1.1 fourteen thousand and forty-two (14,042) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 three thousand eight hundred thirty-two (3,832) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)

each, and

5.1.3 one thousand one hundred forty-nine (1,149) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

(together with the series A1 shares, the “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of

147870

L

U X E M B O U R G

any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet SE (“Roc-

ket”), the shareholder HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”) and the shareholder Landerfield Enterprises
Limited (“Ru-Net”, Ru-Net jointly with Rocket and Holtzbrinck the “Investors” and each also an “Investor”) to a company
affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct
or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or
“Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a con-
tractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies
of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one
or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation proce-

dures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company,
if the shareholders of the Company hold more than 50% in any surviving legal entity after such transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of

first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased
shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is

rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such

enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of
redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share
register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;

independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).

Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts

including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator

147871

L

U X E M B O U R G

shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The
decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the
requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and
the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption
price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person

named  by  the  Company  (including  another  shareholder  of  the  Company),  including  also  partial  redemption  or  partial
assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

11.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also

be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be

specified in the respective convening notices of meeting.

12.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or regis-

tered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of
notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary share-
holders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’ meeting
is not counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another shareholder

authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders’
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’ meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.

Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

147872

L

U X E M B O U R G

13.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders are
only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no
quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article
12.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was
pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.

Art. 16. Shareholders’ resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-

holders (ii) who also constitute a Super Majority:

16.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company; and

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German

Stock Corporation Act (AktG));

16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in
the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases; and
16.2.4 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and

transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

16.3 Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all
the issued shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

147873

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

21.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board (as defined below) for the legal transactions and

measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and
have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board (as defined below):

21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.2 future transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other trans-

actions with derivative financial instruments;

21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

21.8.6 transfer of industrial property rights or documented knowhow by the Company to a third party, excluding, ho-

wever,  such  dispositions  (i)  in  the  ordinary  course  of  business  and  (ii)  between  the  Company  and  direct  and  indirect
subsidiaries of the Company;

21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or
indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent
requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of
the Company and is at arm’s length;

147874

L

U X E M B O U R G

21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options) outside

the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders’ agreement, if
any.

21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required

for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Advisory Board (as defined below). The Advisory Board (as defined below) may
give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board (“Advisory Board”). It shall consist of three (3) voting members. The

shareholders may by way of unanimous shareholders’ consent increase or decrease the number of voting members of the
Advisory Board.

24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous

shareholders’ consent.

24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s respective

appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

24.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, each having two (2) votes, shall be nominated by Rocket in its

sole discretion; and

24.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Holtzbrinck in its sole

discretion.

24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other

representative of the respective party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Rocket and Holtzbrinck are entitled to appoint one substitute member for each Advisory Board
member.

24.5 The Advisory Board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
24.6 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide for further
provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with
the simple majority of votes cast. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar
quarter.

24.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

147875

L

U X E M B O U R G

25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the
provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent per-
mitted by Luxembourg law.

30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

6. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Ms. Magdalena

Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register
of the Company.

7. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

147876

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares in the share capital of the

Company, referred to as the series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”, and together with series A1 shares, the
“Series A Shares”), so that the Company will hence have three (3) classes of shares, the common shares, the series A1
shares and the Series A3 Shares.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders accepts Landerfield Enterprises Limited, aforementioned, as new shareholder of

the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand

one hundred and forty-nine euro (EUR 1,149) so as to raise it from its current amount of seventeen thousand eight hundred
seventy-four euro (EUR 17,874) up to nineteen thousand twenty-three euro (EUR 19,023) by issuing one thousand one
hundred forty-nine (1,149) Series A3 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The one thousand one hundred forty-nine (1,149) Series A3 Shares have been duly subscribed by Ru-Net, aforemen-

tioned, represented as stated above, for the price of one thousand one hundred and forty-nine euro (EUR 1,149).

<i>Payment

The one thousand one hundred forty-nine (1,149) Series A3 Shares subscribed by Ru-Net, have been entirely paid up

through a contribution in cash in an amount of one thousand one hundred and forty-nine euro (EUR 1,149).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand one hundred and fortynine euro (EUR 1,149) is entirely allocated to the

share capital of the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article five (5) of the articles of association of the Company so

that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at nineteen thousand twenty-three euro (EUR 19,023.00), represented by:
5.1.1 fourteen thousand and forty-two (14,042) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 three thousand eight hundred thirty-two (3,832) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)

each, and

5.1.3 one thousand one hundred forty-nine (1,149) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

(together with the series A1 shares, the “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

<i>Fifth resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders decides to fully restate the articles of association

of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well

as Ms. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the
shareholders register of the Company.

<i>Costs and expenses

The  expenses,  costs,  remunerations  or  charges  in  any  form  whatsoever  which  shall  be  borne  by  the  Company  are

estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,000).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.

147877

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by her name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zwölften August,
vor uns, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) bestehend

nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 165662 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaberin von vierzehntausendzweiundvierzig (14.042) Stammanteilen und neunhundertachtundfünfzig (958) Anteilen

der Serie A1,

hier vertreten durch Frau Mrs. Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 10. August 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend

unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter
der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),

Inhaberin von zweitausendachthundertvierundsiebzig (2.874) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Frau Mrs. Xiaoshu Tang, vorgenannt,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 11. August 2015, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg; und

3. Landerfield Enterprises Limited, eine Gesellschaft (limited liability company) nach dem Recht Zyperns, eingetragen

im Cyprus Registrar of Companies unter der Nummer 210960, mit Geschäftsadresse in Naousis 1, Karapatakis Building,
6018, Larnaca, Zypern („Ru-Net“),

zukünftige Inhaberin von eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Frau Mrs. Xiaoshu Tang, vorgenannt,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 11. August 2015, ausgestellt in Larnaca, Zypern.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert

wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Rocket und Holtzbrinck sind die Gesellschafter (die „Bestehenden Gesellschafter“) der Somuchmore Global S.à r.l. (die

„Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 194.134, gegründet am
7. Januar 2015 unter dem Namen „Digital Services XXXVIII S.à r.l.“ gemäß einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux,
mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 11. März 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
669, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 3. Juni 2015 gemäß einer Urkunde der selben
Notarin geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und erklären, auf jegliche Ladungsfor-

malitäten verzichtet zu haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam
über jeden Punkt der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei Ru-Net ausschließlich für die Punkte 4. ff. der Tages-
ordnung teilnahmeund stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, be-

zeichnet als Anteile der Serie A3 (im Folgenden die „Anteile der Serie A3“ und gemeinsam mit den Anteilen der Serie A1
die „Anteile der Serie A“), sodass die Gesellschaft nunmehr drei (3) Anteilsklassen hat, bestehend aus den Stammanteilen
(die „Stammanteile“), den Anteilen der Serie A1 und den Anteilen der Serie A3.

2. Aufnahme der Landerfield Enterprises Limited, eine Gesellschaft (limited liability company) nach dem Recht Zy-

perns, eingetragen im Cyprus Registrar of Companies unter der Nummer 210960, mit Geschäftsadresse in Naousis 1,
Karapatakis Building, 6018, Larnaca, Zypern, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von siebzehntausendachthun-

dertvierundsiebzig Euro (EUR 17.874) um einen Betrag von eintausendeinhundertneunundvierzig Euro (EUR 1.149) auf
einen Betrag von neunzehntausenddreiundzwanzig Euro (EUR 19.023) durch die Ausgabe von eintausendeinhundertneu-
nundvierzig (1.149) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

4. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

147878

L

U X E M B O U R G

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunzehntausenddreiundzwanzig Euro (EUR 19.023,00), beste-

hend aus

5.1.1 vierzehntausendzweiundvierzig (14.042) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 dreitausendachthundertzweiunddreißig (3.832) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00), und

5.1.3 eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(1,00) (zusammen mit den Anteilen der Serie A1 die „Anteile der Serie A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch

das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

5. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Somuchmore Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch  Aufnahme  von  Darlehen  in  jeglicher  Form  oder  mittels  Ausgabe  aller  Arten  von  Anleihen,  Wertpapieren  und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sons-
tige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  Beschluss  des  Rates  der  Geschäftsführer  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

147879

L

U X E M B O U R G

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunzehntausenddreiundzwanzig Euro (EUR 19.023,00), beste-

hend aus

5.1.1 vierzehntausendzweiundvierzig (14.042) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 dreitausendachthundertzweiunddreißig (3.832) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00), und

5.1.3 eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(1,00) (zusammen mit den Anteilen der Serie A1 die „Anteile der Serie A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch

das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten

darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von
Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter

Rocket Internet SE („Rocket“), den Gesellschafter HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“) und den Ge-
sellschafter Landerfield Enterprises Limited („Ru-Net“, Ru-Net gemeinschaftlich mit Rocket und Holtzbrinck die „Inves-
toren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen

Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder
indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem
Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert
Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a) die Leitung der
Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten
der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder
indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberech-
tigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere
Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten, welcher

Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen
Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

147880

L

U X E M B O U R G

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwand-

lungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmel-
zung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als
fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikeln 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters
für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an
Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen
Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile ent-

spricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.

147881

L

U X E M B O U R G

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-

ten des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschaf-
terversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der

entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  einer  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit
einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen  wurden  notariell  beurkundet.  Die  Niederschrift  ist  von  allen  bei  der  Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals

vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung

147882

L

U X E M B O U R G

ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.

Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit

der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft; und 16.1.2 Beschluss hinsichtlich der
Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.

16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen; Und
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

16.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Ge-

schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1  Der  bzw.  die  Geschäftsführer  werden  durch  die  Gesellschafterversammlung  ernannt,  welche  ihre  Bezüge  und

Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

19.2  Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem  Amt  ausscheidet,  muss  die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

147883

L

U X E M B O U R G

20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-

punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der
Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-

ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-

führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der für die
Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

21.2  Sitzungen  des  Rates  der  Geschäftsführer  werden,  falls  vorhanden,  durch  den  Vorsitzenden  des  Rates  der  Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) für die unten genannten Rechts-

geschäfte und Maßnahmen im Einklang mit Artikel 24.5. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechts-
geschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) genehmigt wurden:

21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transak-

tionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streitwert

von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft

an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen. Als

solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15
der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam -direkt oder indirekt eine Mehrheitsbetei-

147884

L

U X E M B O U R G

ligung halten. Die Zustimmung gemäß diesem Artikel 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum gewöhnlichen
Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,

so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) erfordern. Der Beirat (wie unten definiert) kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen
und Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art.  22.  Protokoll  von  Sitzungen  des  Rates  der  Geschäftsführer;  Protokoll  der  Entscheidungen  des  alleinigen  Ge-

schäftsführers.

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Ver-
treter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine
Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat („Beirat“). Dieser besteht aus drei (3) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-

sellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.

24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-

schafter festlegen und/oder verändern.

24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

24.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit je zwei (2) Stimmen werden von Rocket nach eigenem

Ermessen ernannt; und

24.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Holtzbrinck nach eigenem Ermessen

ernannt.

24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von jedem anderen Mitglieds des Beirats oder einem Vertreter der jeweiligen Partei

vertreten werden. In diesem Fall muss bei der jeweiligen Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden.
Zu diesem Zweck sind Rocket und Holtzbrinck berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes Beiratsmitglied zu ernennen.

24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimmbe-

rechtigtes  Mitglied  ist  der  Vorsitzende  des  Beirats.  Die  Geschäftsordnung  des  Beirats  kann  weitere  Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der

147885

L

U X E M B O U R G

Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der

Gesellschaft.

25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.

25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-

klang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

27.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-

falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare  Rücklagen,  beziehungsweise  vermindert  durch  vorgetragene  Verluste  und  Summen,  die  einer  Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die

Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und

147886

L

U X E M B O U R G

durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

6. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau

Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Ersetzungsbefugnis zu aktualisieren und zu unterzeichnen.

7. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Anteilsklasse im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu

schaffen, bezeichnet als Anteile der Serie A3 (im Folgenden die „Anteile der Serie A3“ und gemeinsam mit den Anteilen
der Serie A1 die „Anteile der Serie A“), sodass die Gesellschaft nunmehr drei (3) Anteilsklassen hat, bestehend aus den
Stammanteilen (die „Stammanteile“), den Anteilen der Serie A1 und den Anteilen der Serie A3.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung nimmt Landerfield Enterprises Limited, vorbenannt, als neue Gesellschafterin der Ge-

sellschaft an.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag

von siebzehntausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 17.874) um einen Betrag von eintausendeinhundertneunund-
vierzig Euro (EUR 1.149) auf einen Betrag von neunzehntausenddreiundzwanzig Euro (EUR 19.023) durch die Ausgabe
von eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteile der Serie A3 wurden ordnungsgemäß von Ru-Net, vorbenannt,

vertreten wie vorgenannt, zum Preis von eintausendeinhundertneunundvierzig Euro (EUR 1.149) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Ru-Net gezeichneten eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteile der Serie A3 wurden vollständig

eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendeinhundertneunundvierzig Euro (EUR 1.149).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichneten Notar erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendeinhundertneunundvierzig Euro (EUR 1.149) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital der Gesellschaft zugeführt.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunzehntausenddreiundzwanzig Euro (EUR 19.023,00), beste-

hend aus

5.1.1 vierzehntausendzweiundvierzig (14.042) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 dreitausendachthundertzweiunddreißig (3.832) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00), und

5.1.3 eintausendeinhundertneunundvierzig (1.149) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(1,00) (zusammen mit den Anteilen der Serie A1 die „Anteile der Serie A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch

das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

147887

L

U X E M B O U R G

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet

seiner Kategorie, sowie Frau Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und
mit uneingeschränkter Ersetzungsbefugnis zu aktualisieren und zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die  Kosten,  Auslagen,  Honorare  und  Gebühren  jeglicher  Art,  die  von  der  Gesellschaft  zu  tragen  sind,  werden  auf

ungefähr zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) geschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der  unterzeichnende  Notar,  die  die  englische  Sprache  beherrscht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen

und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Signé: X. Tang, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 14 août 2015. GAC/2015/7100. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157635/1092.
(150173327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Want Brothers Accounting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 146.193.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue au siège de la société, en date du 1 

<i>er

<i>avril 2015

1. Nomination comme commissaire aux comptes Monsieur Christophe MAGIS, né le 17/11/1989 à Namur (Belgique),

domicilié professionnellement au 26 rue Glesener, L-1630 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2016.

Fait à Luxembourg, le 23 septembre 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015157705/14.
(150173365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Blueground Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 184.828.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Extraordinaire des Actionnaires de Blueground Invest S.a. tenue au siège

<i>social le 30 avril 2015 à 11 heures

<i>Résolutions

1. L'Assemblée approuve le transfert du siège social de la société de L-2763 Luxembourg, Rue Sainte-Zithe, 2 à L-1931

Luxembourg, avenue de la Liberté, 11. Le siège social est donc établi à L-1931 Luxembourg, Avenue de la Liberté, 11.

2. L'Assemblée accepte la démission en date du 06 Février 2015 de l'Administrateur Unique Monsieur Nicolas van Beek.
3. L'Assemblée nomme au poste d'Administrateur Unique et Administrateur-délégué avec les pouvoirs les plus étendus

pour une durée indéterminée Monsieur Emmanuel ABRAMCZYK, gérant de sociétés, né à Alençon (France), le 22 août
1967, demeurant professionnellement au 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2015157781/17.
(150174451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

147888


Document Outline

Alandsbanken Sicav

Assur.Lu

Biotoscana Investments &amp; Cy S.C.A.

Biotoscana Investments S.à r.l.

Blueground Invest S.A.

BNT Sàrl

BOSC

Brasserie Les Arcades S.à r.l.

Brothers Event Management Sàrl

Café Beim Susy S.à r.l.

Carix S.à r.l.

CCWP S.à r.l.

Ceria S.A.

Chall'O Music International S.A.

Cogestilux S.A.

Colorblind S.A.

Compass Finance S.A.

Copaco S.à r.l.

CTI Systems S.A.

Energy Real Estate S.A.

Ermax SA

European Services and Equipment S.à r.l.

Fedora S.A.

Gef Real Estate Holding

Hasenkamp Luxemburg S.à r.l.

Hovemag A.G.

Integer S.à r.l.

K1 Family Investments S.A.

K1 Family Investments S.A.

Koratrade Asset Management S.A.

Koratrade Asset Management S.A.

L&amp;C LuxHoldCo Poland S.à r.l.

LOPES Frères S.à r.l.

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l.

Marcenaire S.A.

Maris S.à r.l.

Mindjam S.à r.l.

Multipoints Investments S.A.

Musana Property Holdings S.à r.l.

NRG 6 S.A. SPF

Oasis Holding 2 S.à r.l.

Palis Limited

PAN European Value Added Venture Feeder S.C.A.

RCR Industrial Flooring S.à r.l.

SCI CÉSAR

SCI La Bella

Silver Arrow S.A.

Somuchmore Global S.à r.l.

Ter Kameren Luxembourg S.à r.l.

VF Investments S.à r.l.

Vox Teneo Luxembourg S.à r.l.

Want Brothers Accounting S.A.

Wine &amp; Spirit Investment S.A.