logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2915

23 octobre 2015

SOMMAIRE

Aleph Holdings Limitied I S.à r.l., SPF  . . . . . .139909
GL Europe RE Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .139874
JPRF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139902
Jushel Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139902
K200 Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139902
Kamille S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139904
Kamsa Luxco 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139903
Kayalov Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .139903
KC Esther S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139904
KF Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139904
KH III Lending 801 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .139905
KH III Properties 701 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139905
KH III Properties 702 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139906
KH III Properties 703 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139906
KH III Properties 704 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139907
KH III Properties 705 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139907
KH III Properties 706 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139908
KH III Properties 707 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139908
KONYA Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139903
Kronospan Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .139909
La Concorde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139910
Lafor 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139911
La Gardenia Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139904
Lami II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139912
Lawson S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139910
Lazarus Investments Limited . . . . . . . . . . . . . .139910
Le Flamboyant S.àr.l., Spf, Société de gestion

de Patrimoine Familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . .139911

Les Pierres Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .139905
LGSL Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139911
Libra Project Parent S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .139912
L.O.P.D. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139909
L.O.P.D. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139909
Lux 30 Starlight EUR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139911
Malebis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139915
Marcarini Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .139907

MAT Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139892
MAT Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139906
MAT Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139915
MAT Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139910
Matterhorn Mobile S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .139912
Matterhorn Telecom Holding S.A.  . . . . . . . . .139913
Matterhorn Telecom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .139913
MCH LUX I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139915
Medforyou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139913
Meenie GP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139914
Meif 3 Luxembourg A Holdings, S.à r.l.  . . . . .139914
MEIF 3 Luxembourg B Holdings, S.à r.l.  . . . .139916
MEIF 3 Luxembourg C Holdings, S.à r.l.  . . . .139912
Melies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139916
Melies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139916
Melies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139917
Melies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139916
Merovimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139917
Moselle Parc S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139917
Netco Industries S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139913
Norma Lux Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139917
Office Park Findel Exupéry S.A.  . . . . . . . . . . .139918
Pacific Real Estate Basket S.à r.l.  . . . . . . . . . .139908
Paradocs Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .139914
Peters Maschinenbau A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . .139917
Progressive Enterprises S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .139919
PTC Essen Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139919
Pumbaa Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .139918
Puro Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139919
Rémy Cointreau Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .139920
Riskelia Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139920
River Green Settlements S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .139920
Roberta Di Camerino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .139915
Silver Moss B 2014 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .139918
Touax Investment S.C.A., SICAV-SIF  . . . . . .139892

139873

GL Europe RE Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.631,72.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.625.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of August.
Before us Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

GL Europe Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 114.977,

here represented by Philipp Metzschke, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of GL Europe RE Holdings S.à r.l. (hereinafter

the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg,  having  its  registered  office  at  25A,  boulevard  Royal,  L-2449  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 179.625, incorporated pursuant to a deed
of Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 August 2013, published
in the Mémorial C, Recueil des Société et Associations n° 2504 on 9 October 2013. The articles of association have not
been amended since.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Reduction of the nominal value of the Company’s shares from its current amount of one pound sterling (GBP 1) per

share to one penny (GBP 0.01) per share;

2. Creation of three (3) classes of shares namely ordinary shares, B ordinary shares and C ordinary shares with a nominal

value of one penny (GBP 0.01) each;

3. Conversion of all the one million two hundred thousand (1,200,000) shares into one million two hundred thousand

(1,200,000) ordinary shares having a nominal value of one penny (0.01) each;

4. Increase of the Company's share capital by an amount of six hundred thirty-one pounds sterling and seventy-two

pence (GBP 631.72) so as to increase it from its current amount of twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000) up to
an amount of twelve thousand six hundred thirty-one pounds sterling and seventy-two pence (GBP 12,631.72), through
the issuance of twelve (12) B ordinary shares and sixty-three thousand one hundred sixty (63,160) C ordinary shares having
a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.

5. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company;
6. Full restatement of the articles of association of the Company; and
7. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the undersigned notary to

enact the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to change the nominal value of the Company’s shares from its current amount of one

pound (GBP 1) per share to one penny (GBP 0.01) per share and consequently approves the resulting increase of the number
of shares of the Company from twelve thousand (12,000) shares to one million two hundred thousand (1,200,000) shares
with a par value of one penny (GBP 0.01) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to create three (3) classes of shares in the Company’s share capital, namely (i) ordinary

shares (the “Ordinary Shares”), (ii) B ordinary shares (the “B Ordinary Shares”) and (iii) C ordinary shares (the “C Ordinary
Shares”) with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.

The new class of shares shall have the rights attached as set out in article 5 of the articles of association of the Company

as amended pursuant to the sixth resolution hereof.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to convert all existing one million two hundred thousand (1,200,000) shares into one

million two hundred thousand (1,200,000) ordinary shares having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.

139874

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of six hundred thirty-one pounds

sterling and seventy-two pence (GBP 631.72) so as to increase it from its current amount of twelve thousand pounds sterling
(GBP 12,000) up to an amount of twelve thousand six hundred thirty-one pounds sterling and seventy-two pence (GBP
12,631.72), through the issuance of twelve (12) B ordinary shares and sixty-three thousand one hundred sixty (63,160) C
ordinary shares having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each (each a "New Share" and together the "New Shares").

The New Shares are subscribed and fully paid up through respective contributions (the "Contributions") in cash as

follows:

(a) four (4) B ordinary shares having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, have been subscribed by Jason

Ross, born on 01 September 1978, in Nottingham, United Kingdom, having its residence at Saucy Cottage, Clay Street,
Knotty Green, HP9 2TY, United Kingdom, here represented by Philipp Metzschke, Avocat, residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal, for a total subscription price of four pence (GBP 0.04);

(b) one (1) B ordinary share having a nominal value of one penny (GBP 0.01), has been subscribed by Stephen Rigby,

born on 3 Avril 1986, in St. Albans, United Kingdom, having its residence at 75, Bernard Street, St. Albans, ALE 5QL,
United Kingdom, here represented by Philipp Metzschke, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal, for a total subscription price of one penny (GBP 0.01);

(c) seven (7) B ordinary shares and sixty-three thousand one hundred sixty (63,160) C ordinary shares having a nominal

value of one penny (GBP 0.01) each, have been subscribed by Timothy Butler, born on 15 December 1958, in Bedford,
having its residence at Tarquins, Manor Way, Oxshott, KT22 0HU, United Kingdom, here represented by Philipp Metzsch-
ke, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, for a total subscription price of six
hundred thirty-one pounds sterling and sixty-seven pence (GBP 631.67);

The shares so subscribed have been fully paid-up by the Contributions in cash so that the amount of six hundred thirty-

one pounds sterling and seventy-two pence (GBP 631.72) is as of now available to the Company, as it has been justified
to the undersigned notary.

The total amount of the Contribution is entirely allocated to the share capital of the Company.
The Sole Shareholder has in the proxy for the capital increase pursuant to this resolution, inter alia, waived any transfer

restrictions, pre-emptive rights, rights of first refusal, tag-along rights, drag-along rights and or any other rights contained
in any subscription agreement with respect to the Company to which the Sole Shareholder is a party in connection with
this general meeting of the shareholders.

Then, the parties listed above, join the general meeting of the shareholders and resolve together with the other shareholder

present or represented, on the subsequent items of the agenda. The proxies of all subscribing new shareholders, intialled
“ne varietur” by the proxy holder of the appearing shareholders and the notary will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company so that

it shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand six hundred thirty-one pounds sterling and seventy-two

pence (GBP 12,631.72) represented by one million two hundred thousand (1,200,000) ordinary shares, twelve (12) B
ordinary shares and sixty-three thousand one hundred sixty (63,160) C ordinary shares with a nominal value of one penny
(GBP 0.01) each.”

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of association of the Company which shall

henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

GL Europe RE Holdings S.à r.l. which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the “Law”), as well as by the present Articles.

Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is (i) the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, (ii) the holding of loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances,
claims, participations and sub-participations in bank debt and other debt of Luxembourg or foreign companies acting as
debtors, borrowers or obligors and other debt instruments and securities, whether unsecured or secured by equipment,
personal property, real property, receivables and other collateral, issued or assumed by companies domiciled either in the
Grand Duchy of Luxembourg or abroad, and (iii) the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of
its portfolio.

139875

2.2. The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3. The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2. It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the General Meeting of Shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these Articles.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the Board. It may

be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the General
Meeting, adopted in the manner required for an amendment of these Articles.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the Board.

4.4 In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural

disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the tem-
porary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand, six hundred and thirty one pounds and eighty three pence

sterling (GBP 12,631.72), represented by one million two hundred thousand (1,200,000) Ordinary Shares, twelve (12) B
Ordinary Shares and sixty-three thousand one hundred and sixty (63,160) C Ordinary Shares each with a nominal value of
0.01 pound sterling (GBP 0.01).

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in the

manner required for an amendment of these Articles.

5.3 The Company may redeem its own Shares with the written consent of the applicable Shareholder(s).

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into three classes of Shares; Ordinary Shares, B Ordinary Shares and C

Ordinary Shares, each having the same nominal value.

6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several Shareholders, with a maximum of forty (40) Shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the Shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 B Ordinary Shares and C Ordinary Shares may be issued by the Company to any Relevant Employee at any time as

determined by the Board (in its sole discretion) and there shall be no rights of pre-emption for any existing holder of
Ordinary Shares, B Ordinary Shares or C Ordinary Shares when such B Ordinary Shares or C Ordinary Shares are issued.

Art. 7. Voting in General Meeting.
7.1 The Shareholders shall have the right to receive notice of, attend and vote at a General Meeting.
7.2 The Shareholders shall vote their Shares in a manner giving maximum effect to the provisions of these Articles.

Art. 8. Rights to Capital.
8.1 Subject to Article 8.2, on a return of assets on a Liquidation, reduction in capital or otherwise, the Net Assets of the

Company shall be distributed to the Ordinary Shareholders in proportion to the number of Ordinary Shares held by them.

8.2 On a return of assets on a Liquidation, reduction in capital or otherwise, where the Adjusted NAV is in excess of

GBP 207,530,000:

(i) the B Ordinary Shareholders shall be entitled to a payment per B Ordinary Share equal to the value of the Adjusted

NAV, less GBP 207,530,000, multiplied by 0.25%; and

(ii) the C Ordinary Shareholders shall be entitled to a payment per C Ordinary Share equal to the value of the Adjusted

NAV, less GBP 207,530,000, multiplied by 0.0000435402%,

and the Ordinary Shareholders shall be entitled to receive a pro-rated share of the remainder.

139876

Art. 9. Register of shares - Transfer of shares.
9.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any Shareholder. This register shall contain all the information required by the Law.

9.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that Share until such representative has been appointed.

9.3 Ordinary Shares are freely transferable among the Ordinary Shareholders.
9.4 B Ordinary Shares and C Ordinary Shares may only be transferred on an Exit or in accordance with Article 10.
9.5 Inter vivos, Ordinary Shares may only be transferred to new Ordinary Shareholders subject to the approval of such

transfer given by the Shareholders at a majority of three quarters of the share capital on the proposed date of transfer.

9.6 Any transfer of Ordinary Shares, B Ordinary Shares and C Ordinary Shares shall become effective towards the

Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company
in accordance with article 1690 of the Civil Code.

9.7 In the event of death, Ordinary Shares of the deceased Ordinary Shareholder may only be transferred to new Ordinary

Shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving holders of Ordinary Shares at a majority of
three quarters of the Ordinary Shares in issue at the proposed date of transfer. Such approval is, however, not required in
case the Ordinary Shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. Compulsory Transfers.
10.1 The provisions of this Article 10 shall apply to any B Ordinary Shareholder, any B Ordinary Shares, any C Ordinary

Shareholder and any C Ordinary Shares.

In the event that a B Ordinary Shareholder or a C Ordinary Shareholder becomes a Bad Leaver, the Company or any

nominee of the Company will repurchase each B Ordinary Share or C Ordinary Share held by such B Ordinary Shareholder
or C Ordinary Shareholder for the lower of:

(i) the Subscription Price; or
(ii) the Market Value.
10.2 In the event that a B Ordinary Shareholder or a C Ordinary Shareholder is a Good Leaver, the Company or any

nominee of the Company will repurchase each B Ordinary Share or C Ordinary Share held by such B Ordinary Shareholder
or C Ordinary Shareholder for a per Share price equal to the higher of the:

(i) the Subscription Price; or
(ii) the Market Value.
10.3 Any repurchase of B Ordinary Shares or C Ordinary Shares pursuant to this Article 10 shall take place immediately

after a B Ordinary Shareholder or a C Ordinary Shareholder ceases to be a Relevant Employee and payment shall be made
to the selling Shareholder as soon as practicable, provided that the Company may delay payment in the event the Board
(in its sole discretion) determines that there is insufficient free cash flow and payment should be made at the time of an
Exit.

10.4 In the event that a B Ordinary Shareholder or a C Ordinary Shareholder becomes a Good Leaver and prior to

payment in respect of the repurchase of B Ordinary Shares or C Ordinary Shares as set out in Article 10.2 the B Ordinary
Shareholder or C Ordinary Shareholder breaches any restrictive covenant contained in their employment contract which
remains in force, that B Ordinary Shareholder or C Ordinary Shareholder shall be treated as a Bad Leaver immediately
following such breach and to the extent any payment has been made pursuant to Article 10.2, the company may require
repayment of any amount which exceeded the Subscription Price.

10.5 Market Value shall be determined by an independent share valuation specialist appointed by the Company with

the agreement of the B Ordinary Shareholder whose B Ordinary Shares or the C Ordinary Shareholder whose C Ordinary
Shares are subject to compulsory transfer. If no agreement can be reached, the Company shall apply to the president for
the time being of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and request that a suitable firm of accountants
is appointed and the president’s decision shall be binding on the parties.

Art. 11. Payments on an Exit.
11.1 The proceeds of sale in respect of an Exit other than a Liquidation (for which see Article 8) shall be payable to the

Ordinary Shareholders in proportion to the number of Ordinary Shares held by them, provided that where the Adjusted
NAV is in excess of GBP 207,530,000, each holder of B Ordinary Shares and C Ordinary Shares will be entitled to a
payment as set out in Articles 11.2 to 11.5 below.

11.2 In the event of a Sale (or a sale of Shares pursuant to Article 12.2 or 12.3),
(i) the B Ordinary Shareholders shall be entitled to a payment per B Ordinary Share equal to the Adjusted NAV on Exit,

less GBP 207,530,000, multiplied by 0.25 per cent; and

(ii) and the C Ordinary Shareholders shall be entitled to a payment per C Ordinary Share equal to the Adjusted NAV

on Exit, less GBP 207,530,000, multiplied by 0.0000435402 per cent,

139877

provided that in the event that the Sale is effected pursuant to a share for share exchange, B Ordinary Shareholders shall

be entitled to sell their B Ordinary Shares and C Ordinary Shareholders shall be entitled to sell their C Ordinary Shares to
the Company or its nominee immediately before completion of the Sale or to participate in a share for share exchange if
the buyer elects to offer such an opportunity.

11.3 In the event of an Asset Sale, (a) B Ordinary Shareholders and C Ordinary Shareholders shall participate in any

post - Asset Sale Liquidation or (b), provided that at least 95% of the Company’s undertakings and assets are sold;

(i) the B Ordinary Shareholders shall be entitled to sell their B Ordinary Shares to the Company or its nominee following

completion of the relevant transaction(s) for a payment per B Ordinary Share equal to the Adjusted NAV on Exit, less GBP
207,530,000, multiplied by 0.25 per cent; and

(ii) and the C Ordinary Shareholders shall be entitled to sell their C Ordinary Shares to the Company or its nominee

following completion of the relevant transaction(s) for a payment per C Ordinary Share equal to the Adjusted NAV on
Exit, less GBP 207,530,000, multiplied by 0.0000435402 per cent.

11.4 In the event of an IPO:
(i) the B Ordinary Shareholders shall be entitled to sell their B Ordinary Shares to the Company or its nominee imme-

diately before completion of the transaction for a payment per B Ordinary Share equal to the Adjusted NAV on Exit, less
GBP 207,530,000, multiplied by 0.25 per cent; and

(ii) and the C Ordinary Shareholders shall be entitled to sell their C Ordinary Shares to the Company or its nominee

immediately before completion of the transaction for a payment per C Ordinary Share equal to the Adjusted NAV on Exit,
less GBP 207,530,000, multiplied by 0.0000435402 per cent,

provided that each B Ordinary Shareholder and C Ordinary Shareholder may elect to exchange some or all of their B

Ordinary Shares or C Ordinary Shares for shares that are subject to the IPO and the Company may require such replacement
shares to be subject to any period of lock-up required by the Company’s financial advisers.

11.5 Any payments due to a B Ordinary Shareholder or a C Ordinary Shareholder pursuant to Articles 11.2 to 11.4 shall

be paid as soon as is reasonably practicable following completion of the relevant transaction.

Art. 12. Tag along and Drag Along Transfers.
12.1 The following provisions shall apply in respect of any transfer of Ordinary Shares, or of any interests or rights in

Ordinary Shares (whether through a single transaction or a series of transactions), by any holder or holders of Ordinary
Shares (a “Proposed Transferor”).

12.2 The Proposed Transferor shall, prior to making any transfer referred to in Article 12.1, procure that the proposed

acquirer or acquirers of Shares (the “Proposed Transferee”) (i) makes a binding offer to each holder of Ordinary Shares
(excluding any holder who is a Proposed Transferee) to acquire the Relevant Proportion of that Ordinary Shareholder’s
Ordinary Shares; and (ii) in the event that a proposed transfer occurs when Adjusted NAV exceeds GBP 207,530,000,
makes  a  binding  offer  to  each  holder  of  B  Ordinary  Shares  to  acquire  the  Relevant  Proportion  of  that  B  Ordinary
Shareholder’s B Ordinary Shares and each holder of C Ordinary Shares to acquire the Relevant Proportion of that C Ordinary
Shareholder’s C Ordinary Shares (together the “Tag Along Shareholders”).

12.3 In the event of a transaction which, if completed would result in a Sale, the Proposed Transferor may serve a notice

(the “Compulsory Purchase Notice”) on all of the holders of Ordinary Shares, B Ordinary Shares and C Ordinary Shares
(excluding any holder who is a Proposed Transferee or who has otherwise agreed to transfer their Shares pursuant to Article
12.2) (“Drag Along Shareholders”) and, upon receipt of a Compulsory Transfer Notice, all Drag Along Shareholders shall
be required to sell all their Shares and beneficial interests and rights in such Shares to the Proposed Transferee (or such
other person or persons as the Proposed Transferee shall specify).

12.4 The amount payable to Tag Along Shareholders and Drag Along Shareholders shall be:
(i) in respect of Ordinary Shares, the price per Ordinary Share payable to the Proposed Transferor; and
(ii) in respect of B Ordinary Shares and C Ordinary Shares, the price per B Ordinary Share and per C Ordinary Share

calculated in accordance with Article 11.

12.5 Within seven days of the Proposed Transferor serving a Compulsory Transfer Notice on the Drag Along Share-

holders, the Drag Along Shareholders shall deliver stock transfer forms for their Shares, together with the relevant share
certificates, to the Company.

12.6 If a Drag Along Shareholder fails to deliver stock transfer forms for their Shares to the Company upon the expiration

of such seven day period, the directors of the Company shall, if requested by the Proposed Transferee, be considered to be
(and hereby are) authorised by such Drag Along Shareholder to transfer such Drag Along Shareholder’s Shares on such
Drag Along Shareholder’s behalf to the Proposed Transferee (or its nominee(s)). Subject to the Proposed Transferee com-
plying with any obligations it may have in respect of such transfer, the Board shall then authorise registration of the transfer
once appropriate stamp duty has been paid.

12.7 While the provisions of Article 12.3 apply to a Drag Along Shareholder’s shares, those shares may not be transferred

otherwise than under Article 12.3.

139878

C. Decisions of the shareholders

Art. 13. Collective decisions of the shareholders.
13.1 The General Meeting of Shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these Articles.
13.2 Each Shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
13.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) Shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the General Meeting may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each Shareholder
shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

13.4 In the case of a sole Shareholder, such Shareholder shall exercise the powers granted to the General Meeting under

the provisions of section XII of the Law and by these Articles. In such case, any reference made herein to the “General
Meeting” shall be construed as a reference to the sole Shareholder, depending on the context and as applicable, and powers
conferred upon the General Meeting shall be exercised by the sole Shareholder.

Art. 14. General Meetings of Shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) Ordinary Shareholders,

at least one General Meeting shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the
registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other
meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of
meeting. If all of the Shareholders are present or represented at a General Meeting and have waived any convening requi-
rement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 15. Quorum and vote.
15.1 Each Shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
15.2 Save for a higher majority provided in these Articles or by law, collective decisions of the Company’s Shareholders

are only validly taken in so far as they are adopted by Shareholders holding more than half of the share capital. If this
majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the Shareholders may be convened a second time
with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, at which point decisions
shall be validly approved in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of
the share capital represented.

Art. 16. Change of nationality. The Shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 17. Amendments of the Articles of association. Any amendment of the Articles requires the approval of (i) a majority

of the Shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 18. Powers of the sole manager - Composition and powers of the Board.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be shareholders of the Company.

If the Company has several managers, the managers form a Board composed of at least one (1) class A manager and one
(1) class B manager.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these Articles, a reference to the “Board” used in these Articles is to be construed as a reference to
the “sole manager”.

18.3 The Board is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary

or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these
Articles to the General Meeting.

Art. 19. Appointment, removal and term of office of managers.
19.1 The manager(s) shall be appointed by the General Meeting which shall determine their remuneration and term of

office.

19.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time upon proposal by the Ordinary

Shareholders, with or without cause, by a decision of the Shareholders representing more than half of the Company’s share
capital.

Art. 20. Convening meetings of the Board.
20.1 The Board shall meet upon call by any manager. The meetings of the Board shall be held at the registered office

of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the Board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

139879

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the Board.

Art. 21. Conduct of meetings of the Board.
21.1 The Board may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a

manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board.

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the Board. In his absence, the Board may appoint another manager

as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

21.3 Any manager may act at any meeting of the Board by appointing another manager as his proxy either in writing,

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the Board may also be held by conference-call or video conference or by any other means of com-

munication initiated from Luxembourg by a class B Manager, allowing all persons participating at such meeting to hear
one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these
means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office
of the Company.

21.5 The Board may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a

meeting of the Board, among which at least one (1) class A manager and one (1) class B manager must be present or
represented.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting provided that

at least one (1) class A manager and one (1) class B manager vote in favour of a resolution. The chairman, if any, shall not
have a casting vote.

21.7 The Board may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by fac-

simile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately,
the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the
last signature.

Art. 22. Minutes of the meeting of the Board; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by the chairman

pro tempore and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be
produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, (i) by the joint signature of one (1) class A manager
and one (1) class B manager, (ii) by the joint signature of two (2) class B managers (excluding, however, for the operation
of the Company’s bank accounts), or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the Company within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 24. Auditor(s).
24.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) Ordinary Shareholders, the operations of the

Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The General Meeting shall appoint the
internal auditor(s) and shall determine their term of office.

24.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the General Meeting.
24.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
24.4 If the Shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

24.5 An independent auditor may only be removed by the General Meeting with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.
26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

139880

26.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a Shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing Shareholder agrees to such allocation.

26.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

26.5 Upon recommendation of the Board, the General Meeting shall determine how the remainder of the Company’s

profits shall be used in accordance with the Law and these Articles.

26.6 Distributions shall be made to the Ordinary Shareholders in proportion to the number of Ordinary Shares they hold

in the Company.

26.7 B Ordinary Shareholders and C Ordinary Shareholders shall be entitled exclusively to the payments set out in

Article 8.2.

Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
27.1 The Board may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the Board

showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits
since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by
losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these Articles do not allow to be distributed.

27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the Shareholders

subject to the provisions of the Law and these Articles.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.
28.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these Articles, the Liquidation shall

be carried out by one or several liquidators who are appointed by the General Meeting deciding such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most ex-
tensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

28.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the Shareholders in accordance with Article 8.

H. Final clause - Governing law

Art. 29. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

Art. 30. Defined Terms. In these Articles (“Articles”), unless the context otherwise requires the following words shall

have the following meanings:

“Adjusted NAV” means the gross value received by the Company (or any other relevant Group Company) or otherwise

attributable to the Company in respect of an Exit, less GBP 136,500,000 and all transaction costs, including (without
limitation) all legal, financial and agency fees;

“Affiliate” means in respect of any undertaking, an undertaking which is its subsidiary undertaking or parent undertaking,

or an undertaking which is a subsidiary of a parent undertaking;

“Asset Sale” means the disposal by the Company of all or substantially all of its undertakings and assets. Subject to

Article 11.3(b), any question of whether substantially all of the undertakings and assets of the Company are disposed of
shall be determined by the Board in its sole discretion;

“B Ordinary Shares” means the B Ordinary Shares of 0.01 pound sterling (GBP 0.01) each in the share capital of the

Company;

“B Ordinary Shareholder” means any holder of B Ordinary Shares;
“Bad Leaver” means any B Ordinary Shareholder who ceases to be a Relevant Employee and is not a Good Leaver;
“Board” means the managers of the Company elected pursuant to Article 19;
“C Ordinary Shares” means the C Ordinary Shares of 0.01 pound sterling (GBP 0.01) each in the share capital of the

Company;

“C Ordinary Shareholder” means any holder of C Ordinary Shares;
“Cause” means circumstances in which a B Ordinary Shareholder’s employment with the Company may be terminated

immediately by the Company without prior notice, including (without limitation) if a B Ordinary Shareholder at any time:

(A) commits any serious or repeated or continual breach of any of the obligations under their employment agreement;

or

(B) is guilty of any serious misconduct or serious neglect in the discharge of their duties under the employment agree-

ment; or

139881

(C) has a bankruptcy order made against them or if they make any arrangement or composition with their creditors or

have an interim order made against them pursuant to Section 252 of the UK’s Insolvency Act 1986; or

(D) is convicted of any criminal offence other than an offence which, in the reasonable opinion of the Company, does

not affect their position as an employee of the Company; or

(E) by their actions or omissions, brings the name or reputation of the Company or any Group Company into serious

disrepute or materially prejudices the interests of the business of the Company or any other Group Company; or

(F) becomes of unsound mind or is or becomes a patient for the purpose of any statute relating to mental health; or
(G) is convicted of an offence under any present or future statutory enactment or regulation relating to insider dealing;

or

(H) is or becomes prohibited by law from being a director.
Any delay by the Company in exercising any right to termination for Cause shall not constitute a waiver that right;
“Civil Code” means the Luxembourg Civil Code;
“Company” means GL Europe RE Holdings S.à r.l.;
“Drag-Along Shareholders” has the meaning given in Article 12.3;
“Exit” means an Asset Sale, IPO, Liquidation or Sale;
“Group Company” means any Affiliate of the Company (and Group shall be construed accordingly);
“General Meeting” means a meeting of the Shareholders called by the Board;
“Good Leaver” means a B Ordinary Shareholder or a C Ordinary Shareholder who ceases to be a Relevant Employee

as a result of disability or ill-health (in either case evidenced to the satisfaction of the Board), death, retirement, involuntary
termination by the Company for any reason other than Cause or any other reason (as determined by the Board in its sole
discretion) other than Cause;

“IPO” means the initial public offering of shares in the Company (or any related listing vehicle) on a recognised stock

exchange;

“ITEPA” means the UK’s Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003;
“Liquidation” means the making of a winding up order by the court or the passing of a resolution by the Shareholders

that the Company be wound up or a reduction in capital or other return of assets;

“Market Value” means the value of a Share as determined in accordance with Section 226(A)7 of ITEPA;
“Net Assets” means the assets of the Company less the liabilities of the Company;
“Ordinary Shares” means the ordinary shares of 0.01 pound sterling (GBP 0.01) each in the share capital of the Company;
“Ordinary Shareholder” means any holder of Ordinary Shares;
“Relevant Employee” means an officer or employee of the Company (and for the purposes of these Articles, a person

ceases to be an officer or employee when he ceases to perform duties as an officer or employee or, if earlier, when he gives
or receives notice that he is to cease to be a Relevant Employee);

“Relevant Percentage” means (i) the proportion of an Ordinary Shareholder’s Shares that is equal to the proportion of

Ordinary Shares a Proposed Transferor proposes to sell when measured against the entire issued share capital of the Com-
pany (the “Sale Percentage”) and (ii) the proportion of a B Ordinary Shareholder shares or a C Ordinary Shareholder shares
that has a value equal to the Sale Percentage multiplied by the total value of B Ordinary Shares held by that B Ordinary
Shareholder or C Ordinary Shares held by that C Ordinary Shareholder at completion of a relevant transaction, rounded
up to the nearest whole share;

“Sale” means the transfer (whether through a single transaction or a series of transactions) of shares as a result of which

the purchaser or transferee (or purchasers or transferees that are connected with each other or acting in concert with each
other) would have the legal or beneficial ownership over all or substantially all of the Shares, other than a transfer to another
Group Company. Any question of whether substantially all of the Shares are transferred shall be resolved by the Board in
its sole discretion;

“Share” means an Ordinary Share, a B Ordinary Share or a C Ordinary Share.
“Shareholder” means a holder of Ordinary Shares, B Ordinary Shares or C Ordinary Shares;
“Subscription Price” means the amount paid to acquire a Share;
“Tag-Along Shareholders” has the meaning given in Article 12.1.”

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

139882

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour du mois d’août.
Par-devant nous Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

GL Europe Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2499 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
inscrite auprès du Registre des Société et de Commerce du Luxembourg sous le numéro B 114.977,

dûment ici représentée par Philipp Metzschke, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration.

Laquelle procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La comparante est l’associé unique (l’«Associé Unique») de GL Europe RE Holdings S.à r.l. (ci-après la “Société”),

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2499
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre des Société et de Commerce du Luxembourg sous
le numéro B 179.625, constituée selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 13 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2504 le 9 octobre 2013. Les statuts n’ont
pas été modifiés depuis lors.

La  comparante,  représentant  l’intégralité  du  capital  social,  déclare  avoir  renoncé  à  toute  formalité  de  convocation.

L’assemblée  générale  des  associés  est  ainsi  régulièrement  constituée  et  peut  valablement  délibérer  sur  tous  les  points
figurant à l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduction de la valeur nominale du capital social de la Société de son montant actuel d’une livre sterling (GBP 1)

par part sociale à un penny (GBP 0,01) par part sociale;

2. Création de trois (3) catégories de parts sociales nommées parts sociales ordinaires, parts sociales ordinaires B et parts

sociales ordinaires C ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;

3. Conversion des un million deux cent mille (1.200.000) parts sociales en un million deux cent mille (1.200.000) parts

sociales ordinaires ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;

4. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de six cent trente-et-un livres sterling et soixante-douze

pence (GBP 631,72) afin d’augmenter le montant actuel de douze mille livres sterling (GBP 12.000) à un montant de douze
mille six cent trente-et-un livres sterling et soixante-douze pence (GBP 12.631,12) par l’émission de douze (12) parts
sociales ordinaires B et soixante-trois mille cent soixante (63.160) parts sociales ordinaires C ayant une valeur nominale
d’un penny (GBP 0,01) chacune.

5. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société;
6. Refonte des statuts de la Société; et
7. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’Associé Unique adopte, et requiert le notaire

instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de changer la valeur nominale du capital sociale de la Société de son montant actuel d’une

livre sterling (GBP 1) par part sociale à un penny (GBP 0,01) par part sociale et consécutivement approuve l’augmentation
du numéro des parts sociales de la Société de douze mille (12.000) parts sociales à un million deux cent mille (1.200.000)
parts sociales ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de créer trois (3) catégories de parts sociales nommées (i) parts sociales ordinaires (les «Parts

Sociales Ordinaires») (ii) parts sociales ordinaires B (les «Parts Sociales Ordinaires B») et (iii) parts sociales ordinaires C
(les «Parts Sociales Ordinaires C») ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.

Les nouvelles catégories de parts sociales auront les droits décrits dans l’article 5 des statuts de la Société, tels que

modifiés suite à la sixième résolution ci-dessous.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de convertir les un million deux cent mille (1.200.000) parts sociales en un million deux cent

mille (1.200.000) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de six cent trente-et-un livres

sterling et soixante-douze pence (GBP 631,72) afin d’augmenter le montant actuel de douze mille livres sterling (GBP

139883

12.000) à un montant de douze mille six cent trente-et-un livres sterling et soixante-douze pence (GBP 12.631,12) par
l’émission de douze (12) parts sociales ordinaires B et soixante-trois mille cent soixante (63.160) parts sociales ordinaires
C ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune (chacune une "Nouvelle Part Sociale" et ensemble les "Parts
Sociales").

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites et intégralement payées en numéraire par les apports suivants (les «Ap-

ports»):

(a) Quatre (4) parts sociales ordinaires B ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune, ont été souscrites

par Jason Ross, né le 1 

er

 septembre 1978 à Nottingham, Royaume-Uni, résidant au Saucy Cottage, Clay Street, Knotty

Green, HP9 2TY, Royaume-Uni, ici représenté par Philipp Metzschke, Avocat, résidant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, pour le prix de quatre pence (GBP 0,04);

(b) une (1) part sociale ordinaire B ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01), a été souscrite par Stephen Rigby,

né le 3 avril 1986 à St. Albans, Royaume-Uni, résidant au 75, Bernard Street, St. Albans, ALE 5QL, Royaume-Uni, ici
représenté par Philipp Metzschke, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé, pour le prix d’un penny (GBP 0,01); et

(c) sept (7) parts sociales ordinaires B et soixante-trois mille cent soixante (63.160) parts sociales ordinaires C ayant

une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune, ont été souscrites par Timothy Butler, né le 15 décembre 1958 à
Bedford, résidant au Tarquins, Manor Way, Oxshott, KT22 0HU, Royaume-Uni, ici représenté par Philipp Metzschke,
Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, pour le prix de
six cent trente-et-un livres sterling et soixante-sept pence (GBP 631,67);

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par les Apports en numéraire de sorte que le montant de

six cent trente-et-un livres sterling et soixante-douze pence (GBP 631,72) est dès à présent disponible à la Société, comme
il a été justifié au notaire soussigné.

La totalité des Apports est entièrement allouée au capital social de la Société.
L’Associé Unique a dans les procurations pour l’augmentation de capital conformément à la présente résolution, inter

alia, renoncé à toutes restrictions de transfert, droits de préemption, droits de premier refus, droit de rachat forcé, droit de
sortie forcée, et / ou tous autres droits contenus dans tout accord de souscription à l’égard de la Société auxquels l’Associé
Unique comparants est partie dans le cadre de la présente assemblée générale des associés.

Par la suite, les parties listées ci-dessus, rejoignent l’assemblée générale des associés et se prononcent avec l’autre associé

présent ou représenté, sur les points suivants de l’agenda. Les procurations des tous les nouveaux associés souscripteurs,
paraphées ne variateur par les mandataires des associés comparants et par le notaire resteront annexées au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des associés décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société afin qu'il soit désormais

rédigé comme suit:

5.1. «Le capital social de la Société est fixé à douze mille six cent trente-et-un livres sterling et soixante-douze pence

(GBP 12.631,12) représenté par un million deux cent mille (1.200.000) parts sociales ordinaires, douze (12) parts sociales
ordinaires B et soixante-trois mille cent soixante (63.160) parts sociales ordinaires C ayant une valeur nominale d’un penny
(GBP 0,01) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale des associés décide de refondre entièrement les statuts de la Société qui seront désormais rédigés

comme suit:

«A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination GL Europe RE Holdings

S.à r.l. qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi
que par les présents Statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet (i) la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, et (ii) la détention de prêts, instruments de dettes, reconnais-
sances de dette, obligations, autres titres ou droits assimilés, avances, droits, participations et sous-participations de la dette
bancaire et autres dettes d'une société luxembourgeoise ou d'une société étrangère agissant en tant que débiteur, emprunteur
ou débiteur d'une obligation et autres instruments de dette et valeurs mobilières, qu'elles soient sécurisées ou pas par des
équipements,  des  biens  meubles,  immeubles,  créances  et  autres  garanties  supplémentaires,  émises  ou  assumés  par  les
sociétés domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg, ou ailleurs, (iii) l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

139884

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des

sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d'appel publique à l’épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute

forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’Assemblée Générale, adoptée selon les

conditions requises pour une modification des présents Statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du Conseil de Gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’Assemblée Générale, adoptée selon
les conditions requises pour une modification des présents Statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, par décision

du Conseil de Gérance.

4.4 Dans l’hypothèse où le Conseil de Gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, écono-

mique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l’activité
normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts Sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille six cent trente-un livres sterling et soixante-douze pence (GBP

12.631,72), représenté par un million deux cent mille (1.200.000) Parts Sociales Ordinaires, douze (12) Parts Sociales
Ordinaires B et soixante-trois mille cent soixante (63.160) Parts Sociales Ordinaires C (les «Parts Sociales Ordinaires C»)
ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale de la Société,

adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents Statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres Parts Sociales avec le consentement écrit de(s) l’Associé(s) concerné(s).

Art. 6. Parts Sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en trois catégories de Parts Sociales: les Parts Sociales Ordinaires, les Parts

Sociales Ordinaires B et les Parts Sociales Ordinaires C ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les Parts Sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs Associés, avec un nombre maximal de quarante (40) Associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre

événement similaire d'un des Associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 Les Parts Sociales Ordinaires B et les Parts Sociales Ordinaires C peuvent être émises par la Société à tout Employé

Concerné à tout moment tel que déterminé par le Conseil de Gérance (dans sa seule discrétion) et aucun droit de préemption
ne sera prévu pour les existants détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, Parts Sociales Ordinaires B et Parts Sociales
Ordinaires C lorsque tels Parts Sociales Ordinaires B et Parts Sociales Ordinaires C sont émises.

Art. 7. Votation dans l’Assemblée Générale.
7.1 Les Associés doivent avoir le droit de recevoir un avis de participer et voter à l’Assemblée Générale.
7.2 Les Associés votent leurs Parts Sociales dans une manière donnent plein effet aux dispositions des présents Statuts.

Art. 8. Droits au Capital.
8.1 Sous réserve de l’Article 8.2, sur un retour d’actifs dans une Liquidation, réduction en capital social ou autrement,

les Actifs Nets de la Société seront distribués aux Associés Ordinaires en proportion du nombre des Parts Sociales Ordinaires
qu’ils détiennent.

8.2 Sur un retour d’actifs dans une Liquidation, réduction en capital ou autrement, lorsque le NAV Ajusté excède GBP

207.530.000:

(i) les Associés Ordinaires B auront le droit à un paiement par Part Sociale B égal à la valeur du NAV Ajusté, moins

GBP 207.530.000 multiplié par 0,25%; et

139885

(ii) les Associés Ordinaires C auront le droit à un paiement par Part Sociale C égal à la valeur du NAV Ajusté, moins

GBP 207.530.000 multiplié par 0,0000435402%.

Art. 9. Registre des Parts Sociales - Transfert des Parts Sociales.
9.1 Un registre des Parts Sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque Associé

pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi.

9.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par Part Sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits relatifs à
cette Part Sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

9.3 Les Parts Sociales Ordinaires sont librement cessibles entre les Associés Ordinaires.
9.4 Les Parts Sociales Ordinaires B et les Parts Sociales Ordinaires C ne peuvent être transférées que lors d’une Sortie

ou en conformité avec l’Article 10.

9.5 Inter vivos, les Parts Sociales Ordinaires seront uniquement transférables à des nouveaux Associés Ordinaires sous

réserve qu'une telle cession ait été approuvée par les Associés représentant une majorité des trois quarts du capital social
lors de la date proposée pour le transfert.

9.6 Toute cession de Parts Sociales Ordinaires, Parts Sociales Ordinaires B et Parts Sociales Ordinaires C est opposable

à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après consentement à la cession par la Société conformément
aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

9.7 En cas de décès, les Parts Sociales Ordinaires de l’Associé Ordinaire décédé pourront être uniquement transférées

au nouvel Associé sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires survivants
à  une  majorité  des  trois  quarts  des  Parts  Sociales  Ordinaires  émises  lors  du  transfert  proposée.  Un  tel  agrément  n'est
cependant pas requis dans l’hypothèse où les Parts Sociales Ordinaires sont transférées soit aux ascendants, descendants
ou au conjoint survivant.

Art. 10. Transferts Obligatoires.
10.1 Les dispositions de cet Article 10 s’appliquent à tout Associé Ordinaire B, à toute Part Sociale Ordinaire B, à tout

Associé Ordinaire C et à toute Part Sociale Ordinaire C.

Dans le cas où un Associé Ordinaire B ou un Associé Ordinaire C quitte en mauvais termes (Bad Leaver), la Société ou

tout candidat de la Société rechantera toutes les Partes Sociales Ordinaires B ou Parts Sociales Ordinaires C détenues par
ledit Associé Ordinaire B ou Associé Ordinaire C pour le plus bas:

(i) Du Prix de Souscription; ou
(ii) De la Valeur du Marché
10.2 Dans le cas où un Associé Ordinaire B ou un Associé Ordinaire C qui quitte en bons termes (Good Leaver), la

Société ou tout candidat de la Société rechantera toutes les Parts Sociales Ordinaires B ou Parts Sociales Ordinaires C
détenues par ledit Associé Ordinaire B ou Associé Ordinaire C pour le plus haut:

(i) Du Prix de Souscription; ou
(ii) De la Valeur du Marché
10.3 Tout rachat des Parts Sociales Ordinaires B ou des Parts Sociales Ordinaires C en vertu de cet Article 10 aura lieu

immédiatement  après  que  ledit  Associé  Ordinaire  B  ou  Associé  Ordinaire  C  cesse  d’être  un  Employé  Concerné  et  le
paiement sera effectué à l’Associé vendeur dès que possible, cependant la Société peut retarder le paiement si le Conseil
de Gérance (en sa seule discrétion) détermine qu’il y ait un insuffisant cash-flow libre et des lors le paiement devra être
effectué au moment de la Sortie.

10.4 Dans le cas où un Associé Ordinaire B ou un Associé Ordinaire C est un Good Leaver et avant le paiement par

rapport au repaiement des Parts Sociales Ordinaires B ou Parts Sociales Ordinaires C tel que prévu à l’Article 10.2, l’Associé
Ordinaire B ou l’Associé Ordinaire C viole toute clause restrictive contenue dans son contrat de travail qui demeure en
vigueur, cet Associé Ordinaire B ou Associé Ordinaire C devra être traité comme un Bad Leaver immédiatement après
cette violation et dans la mesure où tout paiement a été effectué en vertu de l’Article 10.2, la Société pourra demander le
repaiement de tout montant qui excède le Prix de Souscription.

10.5 La Valeur du Marché devra être déterminée suivant une évaluation d’un spécialiste indépendant nommé par la

Société sous l’agrément de l’Associé Ordinaire B des Parts Sociales Ordinaires B ou de l’Associé Ordinaire C des Parts
Sociales Ordinaires C dont ses Parts Sociales Ordinaires B sont sujettes à un transfert obligatoire. Si aucun agrément ne
peut être trouvé, la Société devra consulter le président de l’Institue of Chartered Accountants in England and Wales et
demander qu’une apte entreprise de comptables soit nommée et la décision du président liera les parties.

Art. 11. Paiement dans un Evènement de Sortie.
11.1 Les produits d’une vente en respect d’une Sortie autre qu’une Liquidation (pour laquelle il faut se référer à l’Article

8) devront être payés aux Associés Ordinaires en proportion du nombre de Parts Sociales Ordinaires détenues par eux, à
condition que lorsque le NAV Ajusté excède GBP 207.530.000, chaque détenteur de Parts Sociales Ordinaires B et Parts
Sociales Ordinaires C aura le droit à un paiement tel que prévu aux Articles 11.2 et 11.5 ci-dessous.

11.2 Dans le cas d’une Vente (ou une vente de Parts Sociales en vertu de l’Article 12.2 ou 12.3),

139886

(i) les Associés Ordinaires B auront le droit de recevoir un paiement par Part Sociale Ordinaire B égal au NAV Ajusté

de Sortie, diminué GBP 207.530.000, multiplié par 0,25 pour cent, et

(ii) les Associés Ordinaires C auront le droit de recevoir un paiement par Part Sociale Ordinaire B égal au NAV Ajusté

de Sortie, diminué GBP 207.530.000, multiplié par 0,0000435402 pour cent

à condition que, si la Vente est effectuée moyennant échange de parts sociales, les Associés Ordinaires B et les Associés

Ordinaires C auront le droit de vendre leurs Parts Sociales Ordinaires B et Parts Sociales Ordinaires C à la Société ou à
son candidat immédiatement avant l’achèvement de la vente ou de participer dans un échange de parts sociales si le vendeur
décide d’offrir une telle opportunité.

11.3 Dans le cas d’une Vente d’Actifs, (a) les Associés Ordinaires B et les Associés Ordinaires C participeront à toute

post - Vente d’Actifs en Liquidation ou (b), à condition qu’au moins 95% des entreprises et actifs de la Société soient
vendues:

(i) les Associés Ordinaires B auront le droit de vendre leurs Parts Sociales Ordinaires B à la Société ou à ses candidats

suivant achèvement de(s) la transaction(s) concernée(s) pour un paiement par Part Sociale Ordinaire B égal au NAV Ajusté
de Sortie, moins GBP 207.530.000, multiplié par 0,25 pour cent, et

(ii) les Associés Ordinaires C auront le droit de vendre leurs Parts Sociales Ordinaires C à la Société ou à ses candidats

suivant achèvement de(s) la transaction(s) concernée(s) pour un paiement par Part Sociale Ordinaire C égal au NAV Ajusté
de Sortie, moins GBP 207.530.000, multiplié par 0,000435402 pour cent, et

11.4 Dans le cas d’un IPO:
(i) les Associés Ordinaires B auront le droit de vendre leurs Parts Sociales Ordinaires B à la Société ou à ses candidats

immédiatement avant l’achèvement de la transaction pour un paiement par Part Sociale Ordinaire B égal au NAV Ajusté
de Sortie, moins GBP 207.530.000, multiplié par 0,25 pour cent, et

(ii) les Associés Ordinaires B auront le droit de vendre leurs Parts Sociales Ordinaires B à la Société ou à ses candidats

immédiatement avant l’achèvement de la transaction pour un paiement par Part Sociale Ordinaire B égal au NAV Ajusté
de Sortie, moins GBP 207.530.000, multiplié par 0,0000435402 pour cent,

à condition que chaque Associé Ordinaire B et Associé Ordinaire C puisse décider d’échanger toute ou partie de ses

Parts Sociales Ordinaires B ou Parts Sociales Ordinaires C pour des parts sociales qui sont sujettes à l’IPO et la Société
peut demander que le remplacement de parts sociales soit soumis à une période de lock-up demandée par des conseillers
financiers de la Société.

11.5 Tout paiement du à un Associé Ordinaire B ou à un Associé Ordinaire C en vertu des Articles 11.2 à 11.4 doit être

effectué dès que cela est raisonnablement possible après l’achèvement de la transaction concernée.

Art. 12. Droit de Sortie Conjointe et Droit de Cession Forcée.
12.1 Les dispositions suivantes s’appliquent au respect de tout transfert de Parts Sociales Ordinaires, ou de tout intérêt

ou droits dans les Parts Sociales Ordinaires (que ce soit par une seule transaction ou une série de transactions), par un
détenteur ou détenteurs de Parts Sociales Ordinaires (le «Cédant Proposé»).

12.2 le Cédant Proposé doit, avant de effectuer tout transfert prévu à l’Article 12.1, faire en sorte que le candidat acquéreur

ou les candidats acquéreurs des Parts Sociales (le «Candidat Acquéreur») (i) fasse une offre ferme à chaque détenteur de
Parts Sociales Ordinaires (en excluant tout détenteur qui est un Cédant Proposé) d’acquérir la Proportion Concernée de
telle Part Sociale Ordinaire de l’Associé Ordinaire, et (ii) dans le cas qu’un projet de cession se produit lorsque le NAV
Ajusté excède GBP 207.530.000, il devra faire une offre ferme à chaque détenteur de Parts Sociales Ordinaires B d’acquérir
la Proportion Concernée de telle Part Sociale Ordinaire B de l’Associé Ordinaire B et chaque détenteur de Parts Sociales
Ordinaires C d’acquérir la Proportion Concernée de telle Part Sociale Ordinaire C de l’Associé Ordinaire C (ensemble les
«Associés par Sortie Conjointe»).

12.3 Dans le cas d’une transaction qui, si conclue résultera dans une vente, le Cédant Proposé peut signifier un avis (un

«Avis de Cession Forcée») à tous les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, Parts Sociales Ordinaires B et Parts Sociales
Ordinaires C (en excluant tout détenteur qui est un Cédant Proposé ou qui a donné son accord au transfert de ses Parts
Sociales en vertu de l’article 12.2) (les «Associés par Cession Forcée») et, lors de la réception d’un Avis de Cession Forcée,
tout Associé par Cession Forcée sera tenu de vendre toutes ses Parts Sociales et intérêts bénéficiaires et droits sur ces Parts
Sociales au Candidat Acquéreur (ou tout autre personne ou personnes spécifiée(s) par le Candidat Acquéreur).

12.4 Le montant à payer aux Associés par Sortie Conjointe et aux Associés par Cession Forcée sera:
(i) par rapport aux Parts Sociales Ordinaires, le prix par Part Sociale Ordinaire payable au Cédant Proposé; et
(ii) par rapport aux Parts Sociales Ordinaires B et Parts Sociales Ordinaires C, le prix par Part Sociale Ordinaire B et

par Part Sociale Ordinaire C calculé en conformité avec l’Article 11.

12.5 Dans les sept jours de l’Avis de Cession Forcée signifié par le Cédant Proposé aux Associés par Cession Forcée,

les Associés par Cession Forcée remettront à la Société les formes de transfert de stock pour leurs Parts Sociales, ainsi que
les certificats pertinents des Parts Sociales.

12.6 Si un Associé par Cession Forcée ne parvient pas à remettre à la Société des formes de transfert de stock pour ses

Parts Sociales à l’expiration de ces sept jours, les gérants de la Société devront, si demandé par le Cédant Proposé, se
considérer autorisés (et par les présents le seront) par cet Associé par Cession Forcée de céder les Parts Sociales au nom

139887

de l’Associé par Cession Forcée en question au Candidat Acquéreur (ou son(ses) candidat(s)). Sous réserve que le Candidat
Acquéreur se conforme à toute obligation qu'il peut avoir à l’égard d'un tel transfert, le Conseil de Gérance doit ensuite
autoriser l’enregistrement du transfert une fois que le droit du timbre approprié a été payé.

12.7 Puisque les dispositions de l’Article 12.3 sont applicables aux Parts Sociales des Associés par Cession Forcée, ces

parts sociales ne peuvent être transférées autrement qu'en vertu de l’Article 12.3.

C. Décisions des Associés

Art. 13. Décisions collectives des Associés.
13.1 L'Assemblée Générale est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents

Statuts.

13.2 Chaque Associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales

qu'il détient.

13.3 Dans l’hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) Associés, des décisions collectives qui

relèveraient d'ordinaire de la compétence de l’assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque Associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.

13.4 En cas d'Associé unique, cet Associé exercera les pouvoirs dévolus à l’Assemblée Générale en vertu des dispositions

de la section XII de la Loi et des présents Statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’Assemblée Générale»
devra être entendue comme une référence à l’Associé unique selon le contexte et le cas échéant et les pouvoirs conférés à
l’Assemblée Générale seront exercés par l’Associé unique.

Art. 14. Assemblées Générales des Associés. Dans l’hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) Associés

Ordinaires, une Assemblée Générale devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice social
au Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'Associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
[aux assemblées générales] correspondantes. Si tous les Associés sont présents ou représentés à l’Assemblée Générale et
renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 15. Quorum et vote.
15.1 Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
15.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents Statuts ou la Loi, les décisions collectives des Associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des Associés détenant plus
de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les Associés
peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec la même agenda, au cours de laquelle
les décisions seront valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 16. Changement de nationalité. Les Associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement

unanime des Associés.

Art. 17. Modification des Statuts. Toute modification des Statuts requiert l’accord d'une (i) majorité des Associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 18. Pouvoirs du Gérant unique - Composition et pouvoirs du Conseil de Gérance.
18.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs Gérants, qui ne doivent pas être actionnaires de la Société. Si la

Société a plusieurs Gérants, les Gérants forment un Conseil de Gérance, composé au moins d'un (1) Gérant de classe A et
d'un (1) Gérant de classe B.

18.2 Lorsque la Société est gérée par un Gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «Gérant unique» n'est pas

expressément mentionné dans ces Statuts, une référence au «Conseil de Gérance» dans ces Statuts devra être entendue
comme une référence au «Gérant unique».

18.3 Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents Statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 19. Nomination, révocation des Gérants et durée du mandat des Gérants.
19.1 Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’Assemblée Générale qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de

son (leur) mandat.

19.2 Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment sur proposition des

Associés Ordinaires, avec ou sans motif, par une décision des Associés représentant plus de la moitié du capital social de
la Société.

139888

Art. 20. Convocation aux réunions du Conseil de Gérance.

20.1 Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de tout Gérant. Les réunions du Conseil de Gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

20.2 Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance doit être donné aux Gérants au minimum vingt-quatre (24) heures

à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
Gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un Conseil de Gérance
dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent Conseil de Gérance, communiquée
à tous les membres du Conseil de Gérance.

20.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où les tous les Gérants seront présents ou représentés

à un Conseil de Gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites et ap-
prouvées par tous les membres du Conseil de Gérance.

Art. 21. Conduite des réunions du Conseil de Gérance.

21.1 Le Conseil de Gérance peut élire un président du Conseil de Gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du Conseil de Gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du Conseil de Gérance.

21.2 Le président du Conseil de Gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du Conseil de Gérance. En son

absence, le Conseil de Gérance peut nommer provisoirement un autre Gérant comme président temporaire par un vote à la
majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

21.3 Tout Gérant peut se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant tout autre Gérant comme

son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en
constituant une preuve suffisante. Un Gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l’intégralité des membres du Conseil
de Gérance.

21.4 Les réunions du Conseil de Gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire initialisées au Luxembourg par un Gérant de classe B, initié au Luxembourg par
un Gérant de classe B, permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et
garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social
de la Société.

21.5 Le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente

ou représentée à une réunion du Conseil de Gérance, parmi lesquels doivent être présents ou représentés au moins un (1)
Gérant de classe A et un (1) Gérant de classe B.

21.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à chaque réunion du Conseil

de Gérance, pourvu qu'au moins un (1) Gérant de classe A et un (1) Gérant de classe B ait voté en faveur de la décision.
Le président du Conseil de Gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

21.7 Le Conseil de Gérance peut, à l’unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque Gérant peut exprimer son
consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l’adoption des décisions. La date de ces décisions
sera la date de la dernière signature.

Art. 22. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance; Procès-verbaux des décisions du Gérant unique.

22.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,

en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) Gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) Gérants.

22.2 Les décisions du Gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le Gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le Gérant unique.

Art. 23. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la

signature du Gérant unique, ou, si la Société a plusieurs Gérants, (i) par la signature conjointe d'un (1) Gérant de classe A
et d'un (1) Gérant de classe B, (ii) par la signature conjointe de deux (2) Gérants de classe B (à l’exception de la gestion
des comptes bancaires de la Société), ou (iii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à
laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par la Société dans les limites de cette délégation.

139889

E. Audit et surveillance

Art. 24. Commissaire - Réviseur d'entreprises agréé.
24.1 Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) Associés, les opérations de la Société seront

surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'Assemblée Générale désigne les commissaires et détermine la durée de
leurs fonctions.

24.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l’Assemblée Générale.
24.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
24.4 Si les Associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l’article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

24.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l’Assemblée Générale que pour juste motif ou avec son

accord.

F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 25. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente et un décembre de la même année.

Art. 26. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
26.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le Conseil de Gérance dresse un inventaire de

l’actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

26.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

26.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un Associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet Associé consent à cette affectation.

26.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

26.5 Sur proposition du Conseil de Gérance, l’Assemblée Générale décide de l’affectation du solde des bénéfices dis-

tribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents Statuts.

26.6 Les distributions aux Associés Ordinaires sont effectuées en proportion du nombre de Parts Sociales Ordinaires

qu'ils détiennent dans la Société.

26.7 Les Associés Ordinaires B et les Associés Ordinaires C n’ont droit qu’aux paiements prévus à l’Article 8.2.

Art. 27. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et Primes assimilées.
27.1 Le Conseil de Gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable

intermédiaire préparé par le Conseil de Gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents Statuts interdisent la distribution.

27.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux Associés con-

formément à la Loi et aux présents Statuts.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.
28.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents Statuts, la Liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée Générale ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les
pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.

28.2 Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera distribué entre les Associés en conformité avec

l’Article 8.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 29. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents Statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

Art. 30. Termes Définis. Dans ces statuts (les «Statuts»), à moins que le contexte ne s'y oppose les mots suivants ont la

signification suivante:

«Actifs Nets» signifie les actifs de la Société après déduction des passifs de la Société;
«Affilié» signifie par rapport à une entreprise, une entreprise qui est sa filiale ou sa société mère, ou une entreprise qui

est une filiale d’une société mère;

«Assemblée Générale» signifie toute réunion des Associés convoquée par le Conseil de Gérance;

139890

«Associé Ordinaire» signifie tout détenteur de Parts Sociales Ordinaires;
«Associé Ordinaire B» signifie tout détenteur de Parts Sociales Ordinaires B;
«Associé Ordinaire C» signifie tout détenteur de Parts Sociales Ordinaires C;
«Associé par Sortie Conjointe» a le sens donné dans l’Article 12.1.
«Associé» signifie un détenteur de Parts Sociales Ordinaires, Parts Sociales Ordinaires B ou Parts Sociales Ordinaires

C;

«Associés par Cession Forcée» a la sens donné dans l’Article 12.3;
«Bad Leaver» signifie tout Associé Ordinaire B qui cesse d’être un Employé Concerné et il n’est pas un Good Leaver;
«Cas de Réalisation» signifie la vente des actifs d’investissement;
«Cause» signifie les circonstances dans lesquelles le contrat de travail d’un Associé Ordinaire B auprès de la Société

peut être résolu immédiatement par la Société sans aucun préavis, en incluant (sans limitation) si un Associé Ordinaire B
à tout moment:

(a) Commet toute violation grave ou violation répétée ou continue des obligations en vertu de son contrat de travail; ou
(b) Il est coupable de toute faute une négligence grave dans l’exercice de ses fonctions en vertu du contrat de travail;

ou

(c) A un ordre de faillite contre lui ou s’il fait un arrangement ou une composition avec leurs créanciers ou une ordonnance

provisoire rendue contre lui en vertu de la Section 252 de l’UK Insolvency Act de 198; ou

(d) Il est déclaré coupable de toute infraction pénale sauf celles qui, selon l’opinion raisonnable de la Société, ne portent

pas atteint à sa position d’employé de la Société; ou

(e) Par ses actions ou omissions, met le nom ou la réputation de la Société ou de tout Groupe de la Société en discrédit

grave ou préjudicie de façon importante les intérêts de la Société ou de tout autre Groupe de la Société; ou

(f) Devient faible d’esprit ou est ou devient un patient rentrant dans les conditions de toute loi relative à la santé mentale;

ou

(g) est déclaré coupable d'une infraction en vertu de tout texte législatif actuel, futur ou réglementaire relative aux

opérations d'initiés; ou

(i) il est ou sera interdit par la loi d’être gérant.
Tout retard par la Société dans l’exercice de tout droit de résolution pour Cause ne constitue pas une renonciation à ce

droit;

«Code Civil» signifie le Code Civil luxembourgeois;
«Conseil de Gérance» signifie les gérants de la Société nommés en vertu de l’Article 19;
«Employé Concerné» signifie un fonctionnaire ou employé de la Société (et aux fins de ces Articles, une personne cesse

d’être un fonctionnaire ou un employé lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions en tant que fonctionnaire ou employé ou,
lorsqu’il donne ou reçois un avis qu’il cessera d’être un Employé Concerné);

«Good Leaver» signifie un Associé Ordinaire B ou un Associé Ordinaire C qui cesse d’être un Employé Concerné en

raison d'un handicap ou mauvaise santé (dans tous les deux cas à la satisfaction du Conseil de Gérance), décès, retraite,
résiliation par la Société pour toute raison autre que la Cause (tel que décidé par le Conseil de Gérance en sa seule discrétion);

«Groupe de la Société» signifie tout Affilié de la Société (et Groupe doit être interprété en conséquence);
«IPO» signifie offre publique initiale de parts sociales de la Société (ou toute liste de véhicules connexes) dans une

bourse reconnue;

«ITEPA» signifie l’UK Income Tax (Earning and Pensions) Act de 2003;
«Liquidation» signifie la mise en place d’une liquidation par les tribunaux ou la prise de décision par les Associés de la

Société par laquelle la Société sera mise en liquidation ou une diminution de capital ou un retour des actifs;

«NAV Ajusté» signifie la valeur brute reçue par la Société (ou toute autre Groupe de la Société concerné) au autrement

attribuable à la Société à l’égard d’une Sortie, moins GBP 136.500.000 et tous les coûts transactionnels, incluant (sans
limitation) tous les frais légaux, financiers et d’agence;

«Part Sociale» signifie une Part Sociale Ordinaire, une Part Sociale Ordinaire B ou une Part Sociale Ordinaire C;
«Parts Sociales Ordinaires» signifie les Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)

chacune dans le capital social de la Société;

«Parts Sociales Ordinaires B» signifie les Parts Sociales Ordinaires B d’une valeur d’un penny (GBP 0,01) chacune

dans le capital social de la Société;

«Parts Sociales Ordinaires C» signifie les Parts Sociales Ordinaires C d’une valeur d’un penny (GBP 0,01) chacune

dans le capital social de la Société;

«Pourcentage Concerné» signifie (i) la proportion de Parts Sociales Ordinaires des Associés Ordinaires qui égale à la

proportion de Parts Sociales qu’un Cédant Proposé propose de vendre lorsqu’elle mesurée avec l’entièreté du capital social
émis de la Société (le «Pourcentage de Vente») et (ii) la proportion de Parts Sociales des Associés Ordinaires B ou Parts
Sociales des Associés Ordinaires C qui a une valeur égal au Pourcentage de Vente multiplié par la valeur totale des Parts

139891

Sociales Ordinaires B détenues par l’Associé Ordinaire B ou totale des Parts Sociales Ordinaires C détenues par l’Associé
Ordinaire C à l’achèvement d’une transaction en question, à la hausse par rapport à la part social entière.

«Prix de Souscription» signifie le montant payé pour acheter les Parts Sociales;
«Société» signifie GL Europe RE Holdings S.à r.l.
«Valeur du Marché» signifie la valeur d’une Part Sociales telle que décidée en conformité avec la Section 226(A)7 de

l’ITEPA;

«Vente d’Actifs» signifie la mise à disposition par la Société de tout ou la quasi-totalité de toutes ses entreprises et actifs.

Sous réserve de l’Article 11.3(b), toute question de savoir si la quasi-totalité des entreprises et des actifs de la Société sont
éliminés doit être déterminé par le Conseil de Gérance à sa seule discrétion;

«Vente» signifie la cession (que ce soit par une unique transaction ou une série de transactions) de parts sociales ayant

comme résultat que l’acheteur ou cessionnaire (ou acheteurs ou cessionnaires qui sont liés entre eux ou qui agissent en
concert) aura la propriété légale ou véritable sur toutes ou la quasi-totalité des Parts Sociales, autre qu’une cession à un
autre Groupe de la Société. Toute questions sur la cession totale ou quasi-totale des Parts Sociales devra être résolue par
le Conseil de Gérance à sa seule discrétion.

«Sortie» signifie une Vente d’Actifs, IPO, Liquidation ou Vente.»

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate, sur demande des comparantes, que le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Metzschke, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 août 2015. Relation: EAC/2015/19635. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015149656/1015.
(150163995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

MAT Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 184.427.

Par la présente, j'ai l'honneur de démissionner de mon mandat d'Administrateur au sein de la société MAT ESTATE

S.A., inscrite au RSCL sous le numéro B184427, dans le cadre de la convention signée le 2 décembre 2013, et ce avec effet
immédiat.

Strassen, le 1 

er

 septembre 2015.

Madame Aurélie GERARD.

Référence de publication: 2015150443/11.
(150165160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Touax Investment S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 199.760.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen (2015), on the sixth (6) day of August
Before Maître Jacques CASTEL, notary public, residing in Grevenmacher, acting in replacement of Maître Martine

SCHAEFFER, notary public, residing in Luxembourg-City, to whom second named notary will remain the present deed.

THERE APPEARED:

1. Touax Management S.à r.l., incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at

28-32 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, not yet registered with the RCS, as unlimited
shareholder (“associé gérant commandité”) (the “General Partner”),

duly represented by Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, professionally residing in 10, rue des Carrières, L-1316

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, which initialed ne varietur by the
appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities, and,

139892

2. Touax S.C.A., a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), incorporate under the

laws of France, with registered office at 100-101 Terrasse Boieldieu - Tour Franklin, F-92042 Paris La Défense Cedex,
France (“Associé Commanditaire”) (the “Shareholder”),

duly represented by Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, professionally residing in 10, rue des Carrières, L-1316

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, which initialed ne varietur by the
appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The appearing parties, acting in the above stated capacities, have required the undersigned notary to enact the deed of

incorporation of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions, the articles of incorporation
(the "Articles of Incorporation") of which shall be read as follows:

Art. 1. Name - Form.
1.1 There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued,

a corporate partnership limited by shares (“société en commandite par actions”) qualifying as an investment company with
variable capital (société d'investissement à capital variable) - specialised investment fund (fonds d'investissement spécia-
lisé) (“SIF”) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, to be governed by the Luxembourg law of 13 February
2007 relating to specialised investment funds (fonds d’investissement specialisés), published in the Mémorial A under
number 13 on 13 February 2007, as amended from time to time (the "2007 Law") under the name “Touax Investment
S.C.A., SICAV-SIF” (the “Fund”).

1.2 The Fund shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the 2007 Law and the

law of 10 August 1915 on commercial companies (published in the Mémorial A under number 90 as of 30 October 1915),
as amended from time to time (the “1915 Law”).

Art. 2. Duration.
2.1 The Fund is incorporated for an unlimited period of time.
2.2 The General Partner may, however, decide to establish Sub-Fund(s) (as defined in the Issuing Document of the

Fund) for a limited duration, as indicated for each Sub-Fund in the relevant Fact Sheet(s) (as defined in the Issuing Document
of the Fund) of the Issuing Document.

Art. 3. Purpose.
3.1 The purpose of the Fund is to invest the funds raised from its Well-Informed Investors in various securities and any

other authorized assets, with the aim of spreading the investment risks and providing to its Shareholders (as defined in the
Issuing Document of the Fund) the results of management of its portfolio within the widest meaning as permitted under
the 2007 Law, while reducing investment risk through diversification, in accordance with the CSSF (as defined in the
Issuing Document of the Fund) circular of 3 

rd

 August 2007 regarding risk-spreading in the context of specialised investment

funds, as may be amended or replaced from time to time (the “Circular CSSF 07/309”).

3.2 The Fund has an umbrella structure and may consist of several Sub-fund(s) (each a Sub-Fund and together the Sub-

Funds) within the meaning of article 71 of the 2007 Law for one class of shares or for multiple classes of shares in the
manner described in article IX of the present Articles of Incorporation.

3.3 The Fund may take all measures and perform all operations, which it shall judge to be expedient in terms of achieving

or furthering its object in the broadest sense within the framework of the 2007 Law and Circular CSSF 07/309.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Fund is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Subject to the CSSF’s prior approval, the General Partner is authorised to change the address of the Fund within the

municipality of the statutory registered office.

4.3 The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a

resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to
the Articles of Incorporation.

4.4 In the event that the General Partner determines that extraordinary political or economic events have occurred or

are imminent which would interfere with the normal activities of the Fund at its registered office or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these abnormal circumstances. Such provisional measures, however, shall have no effect on the
nationality of the Fund, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a company governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the 2007 Law. The decision as to the transfer abroad of the registered office
will be taken, subject to the CSSF’s prior information, by the General Partner.

Art. 5. Liability.
5.1 The General Partner is liable without any limits for any obligations that cannot be met out of the assets of the Fund.
5.2 The Shareholders shall only be liable to the extent of their contributions to the Fund.

139893

Art. 6. Share Capital.
6.1 The share capital of the Fund shall be at any time equal to the net asset value of the Fund (the “Net Asset Value”)

and is divided into shares without nominal value.

6.2 The share capital is denominated in Euros (“EUR”). For the purpose of determining the capital of the Fund, the value

of the assets attributable to the Fund or any of its Sub-Funds shall, if not expressed in EUR, be converted into EUR.

6.3 The Fund was incorporated with a subscribed share capital of thirty one thousand Euros (EUR 31.000,-). Upon

incorporation, the first Sub-Fund was divided into one (1) management Share - Share subscribed by the General Partner
(associé gérant commandité), and three hundred ten (310) limited Shares, subscribed by the limited Shareholders (action-
naires commanditaires), with no par value. Upon incorporation, the management share and all limited Shares were fully
paid-up. The minimum subscribed capital of the Fund, as prescribed by 2007 Law, is one million two hundred fifty thousand
Euros (EUR 1,250,000.). This minimum must be reached within a period of twelve (12) months following the authorization
of the Fund as an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) - specialised
investment fund (fonds d'investissement spécialisé) under the 2007 Law.

Art. 7. Shares and Classes of Shares.
7.1 The General Partner and the AIF Manager (as defined in article XXII of the present Articles of Incorporation) shall

determine the investment objectives and policies of the Fund as well as the course of conduct of the management and the
business affairs of the Fund in relation thereto, as set forth in the Issuing Document, in compliance with applicable laws
and regulations.

7.2 Shares may, as the General Partner shall determine, be of one (1) or more different Classes, the features, terms and

conditions of which shall be established by the General Partner. Features are described in the Issuing Document of the
Fund and in the relevant Fact Sheet(s).

7.3 Shareholders will be treated equally pro-rata to the number of Shares held by them.

Art. 8. Form of Shares.
8.1 All Shares are issued in registered form only. They may not be converted into bearer Shares.
8.2 The Shares of the Fund shall be entered in the register of Shareholders (the “Register”), which shall be kept by the

Fund or by another entity designated therefore by the Fund. Such Register shall contain the name of each Shareholder, his
residence, registered office or elected domicile, the number and class of Shares held by him, the amount paid up on each
such Share, the transfers and the respective dates thereof, the conversion of Shares and banking references.

8.3 Every Shareholder must provide the Fund with an address to which all notices and other correspondence from the

Fund may be sent. Such address will also be entered in the Register.

8.4 Until written notification to the contrary shall have been received by the Fund at its registered office, or at such other

address as may be determined by the Fund from time to time, it may treat the information contained in the Register, including
the indicated address and banking references, as accurate and up to date. The Shareholders will receive a confirmation of
their registration in the Register. Except as otherwise decided by the General Partner no Share certificates are issued for
registered Shares. If Share certificates are issued and a Shareholder desires that more than one Share certificate is issued
for his Shares, the cost of such additional certificates may be charged to such Shareholder.

Art. 9. Issue of Shares.
9.1 The AIF Manager (as defined below) is authorized, without limitation, to issue an unlimited number of Shares within

each Sub-Fund at any time. Existing Shareholders are authorized to subscribe for new shares under the same conditions
than new Shareholders without having a preferential right to subscribe for the Shares to be issued

9.2 The General Partner may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Class and/or

in any Sub-Fund; the General Partner may, in particular, decide that Shares of any Class and/or of any Sub-Fund shall only
be offered for subscription continuously at a specified periodicity, as indicated and detailed in the relevant Fact Sheet(s)
of the Issuing Document.

9.3 The issue conditions of the shares determined by the General Partner may include, without limitation, a minimum

subscription amount, the subscription price and conditions for the subsequent issue of shares.

9.4 Unless expressly prohibited in the Issuing Document, the Fund may, subject to the prior approval of the AIF Manager,

accept payment in whole or in part by an in kind subscription of suitable investments, provided that such investments
comply with the investment objectives, policies and restrictions of the relevant Sub-fund and the conditions set forth by
the laws and regulations applicable in the Grand Duchy of Luxembourg. The investments forming the in kind subscription
will be valued and a valuation report will be obtained from the Fund’s auditor (réviseur d’entreprises agrée). The transaction
costs  (including  the  auditor’s  valuation  report)  incurred  in  connection  with  the  acceptance  by  the  Fund  of  an  in  kind
subscription will be borne directly by the incoming Shareholder. The value so determined, together with the Net Asset
Value calculated for the Class of Shares concerned in the relevant Sub-fund, will determine the number of Shares to be
issued to the incoming Shareholder. The purpose of the foregoing policy is to ensure that the existing Shareholders in a
Sub-fund do not bear the transaction costs of acquiring additional assets for a large incoming Shareholder.

139894

Art. 10. Transfer of Shares.
10.1 Without prejudice to article 22.2 of the present Articles of Incorporation, the management share(s) held by the

General Partner may only be transferred, pledged or otherwise disposed of with the prior approval of the general meeting
of Shareholders adopted with the quorum and majority requirements for the amendment of the Articles of Incorporation
and in accordance with any applicable law.

10.2 Subject to any transfer restrictions/specifications stated below and/or in the relevant Fact Sheet(s), Shares are freely

transferable to other Well-Informed Investors, provided that such transfer of Shares may not result in a Restricted Person
(as defined in the Issuing Document of the Fund) holding Shares.

10.3 Shares may not be transferred without the prior written consent of the General Partner. In particular (but without

limitation), the General Partner will be entitled to withhold its consent to a proposed transfer on the following reasons:

a. if the General Partner reasonably considers that the transfer would cause the Fund to be terminated;
b. if the General Partner considers that the transfer would violate any applicable law, regulation or any term of the Fund’s

Issuing Document or the present Articles of Incorporation;

c. if the General Partner reasonably considers that the contemplated transfer would result in a breach of any limitation

of the number of Shareholders in the Fund or a Sub-fund, either as an immediate consequence or in the future.

10.4 No transfer of Shares will become effective unless and until:
a. the transferee agrees in writing to fully and completely assume any outstanding or future obligations of the transferor

in relation to the transferred Shares under the relevant Subscription Form (as defined in the Issuing Document of the Fund)
and agrees in writing to be bound by the terms of the Issuing Document and Subscription Form, whereupon the transferor
shall be released from (and shall bear no further liability for) such liabilities and obligations; and

b. the transfer has been reflected in the register of Shareholders of the Fund.

Art. 11. Redemption of Shares.
11.1 Unless otherwise provided for in the relevant Fact Sheet(s), all Sub-Funds of the Fund are of the open end type.

Therefore, unless otherwise provided for in the relevant Fact Sheet(s), Investors are entitled to request the Fund to redeem
all or part of their Shares in accordance with the provisions of the Issuing Document.

Art. 12. Well-Informed Investors.
12.1 Except for the management Share(s), limited Shares may only be held by Well-Informed Investors within the

meaning of article 2 of the 2007 Law (“Well-Informed Investors”), providing that: “a well-informed investor shall be an
institutional investor, a professional investor or any other investor who meets the following conditions:

a) he has confirmed in writing that he adheres to the status of well-informed investor, and
b) (i) he invests a minimum of 125,000 Euro in the specialised investment fund, or
(ii) he has been the subject of an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC,

by an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of
“Directive 2009/65/EC”4 certifying his expertise, his experience and his knowledge in adequately apprising an investment
in the specialised investment fund.”

12.2 The AIF Manager and the General Partner may restrict or place obstacles in the way of the ownership of Shares in

the Fund by any person if the Fund considers that this ownership involves a violation of the law of the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad, or may involve the Fund in being subject to taxation in a country other than the Grand Duchy of
Luxembourg or may in some other manner be detrimental to the Fund.

12.3 To that end, the AIF Manager and the General Partner may:
a) decline to issue any Shares and decline to register any transfer of Shares when it appears that such issue or transfer

might or may have as a result the allocation of ownership of the Shares to a person who is not authorized to hold Shares in
the Fund;

b) proceed to a compulsory redemption of the Shares if a Shareholder ceases to or appears not to be an Well-Informed

Investor. In the event of compulsory redemption, the redemption price shall be the subscription price effectively paid in
by the Shareholders to whom the AIF Manager or the General Partner is redeeming the Shares. However, if the AIF Manager
or the General Partner determines that the Net Asset Value of the Sub-fund has increased or decreased in a substantial
manner since the subscription by the concerned shareholder, the AIF Manager and the General Partner shall be entitled to
modify the redemption price such as it will be equivalent to the Net Asset Value of the Shares as at the relevant Valuation
Day.

c) refuse, during any general meeting of Shareholders, the right to vote of any person who is not authorized to hold

Shares in the Fund.

Art. 13. Distributions.
13.1 Dividends may be distributed, either in cash or Shares in accordance with the 2007 Law and the 1915 Law. Dividends

may include a capital distribution, provided that after distribution the net assets of the Fund total more than one million
two hundred fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-).

139895

13.2 The AIF Manager may determine to the payment of interim dividends in the form and under the conditions as

provided by law.

13.3 Dividends, if any, will be declared and distributed on an annual basis. Moreover, interim dividends may be declared

and distributed from time to time at a frequency determined by the AIF Manager within the conditions set forth by law, as
further described in the relevant Fact Sheet(s).

13.4 The AIF Manager may, at its sole discretion, determine that no distributions will be made by the Fund before the

end of the first (1 

st

 ) year after the incorporation of the Fund. Prior to that date, such proceeds may, at the discretion of the

AIF Manager, be reinvested by the Fund. All income and realization proceeds to the extent not retained in the Fund will,
after satisfying any expenses and liabilities of the Fund and subject to payment of the Management Fee and re-investment
rights, be distributed to the Shareholders according to the Fact Sheets.

13.5 Payments will be made in the Reference Currency of the relevant Sub-fund and/or Class. Dividends remaining

unclaimed for five (5) years after their declaration will be forfeited and revert to the relevant Sub-fund.

Art. 14. Payments.
14.1 Any payment to a Shareholder will be made by wire transfer to the bank account specified at the time of subscription.
14.2 Upon payment or deposit of the amount due, no person interested in the relevant Shares shall have any further

interest in the relevant Shares or any of them, or any claim against the Fund or its assets with respect to such payment.

Art. 15. Determination of the Net Asset Value.
15.1 The Reference Currency of the Fund is the Euro (EUR). Each Sub-fund may have a different Reference Currency,

as further detailed, if applicable in the relevant Fact Sheet(s).

15.2 The Net Asset Value is calculated by the Central Administrative Agent under the ultimate responsibility of the AIF

Manager, in accordance with the applicable laws and regulations. The AIF Manager (Quilvest Asset Management S.A.) is
the ultimate responsible for the correct evaluation of the assets of the Fund and its Sub-funds, its calculation, and its
publication. The fact that the AIF Manager delegates this task does not affect its liability. A rigorous methodology of
valuation and comprehensive approach is used to guarantee an objective valuation at fair value.

15.3 The Net Asset Value (being the assets less the liabilities) is calculated on a Class by Class basis on such frequency

as set forth in the relevant Fact Sheet(s).

15.4 The AIF Manager sets the Valuation Days, and the methods whereby the Net Asset Value is made public, in

compliance with the legislation in force. Each Sub-fund’s Net Asset Value will be the value of all the assets of the Sub-
fund  (including  cash  and  accrued  interest  and  dividends)  less  all  of  the  liabilities  of  the  Sub-fund  (including  accrued
expenses) as at the Valuation Day.

15.5 Unless otherwise specified in the relevant Sub-fund(s) Fact Sheet(s), the assets of each Sub-fund include:
1. all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued inTerest;
2. all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
3. all securities, shares, bonds, time notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market

instruments, and all other investments and transferable securities belonging to the relevant Sub-fund;

4. all dividends payable to the Sub-fund(s) either in cash or in the form of stocks and shares (the Fund may, however,

make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities resulting from practices
such as ex-dividend or ex-claim negotiations);

5. all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the Sub- Fund, unless this interest is

included in the principal amount of such securities;

6. the Fund’s or relevant Sub-fund’s preliminary expenses, to the extent that such expenses have not already been written-

off;

7. the Fund’s or relevant Sub-fund’s other fixed assets, including office buildings, equipment and fixtures; solar pho-

tovoltaic

8. all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.
15.6 Each Sub-fund’s liabilities shall include:
1. all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
2. all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,

involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
Fund regarding the Sub-fund but not yet paid;

3. a provision for capital tax and income tax accrued on the Valuation Day and any other provisions authorized or

approved by the AIF Manager;

4. all other liabilities of the Fund of any kind with respect to the Sub-fund, except liabilities represented by shares in the

Fund. In determining the amount of such liabilities, the Fund shall take into account all expenses payable by the Fund
including, but not limited to:

a) formation expenses;

139896

b) expenses in connection with and fees payable to, accountants, Depositary and correspondents, registrar, transfer

agents, paying agents and auditors;

c) administration, domiciliary, services, promotion, printing, reporting, publishing (including advertising or preparing

and printing of issuing documents, explanatory memoranda, registration statements, annual and semi-annual (if any) re-
ports) and other operating expenses;

d) the cost of buying and selling assets;
e) interest and bank charges; and
f) taxes and other governmental charges;
15.7 the Fund may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated basis for

yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

15.8 Unless otherwise specified in the relevant Sub-Fund(s) Fact Sheet(s), the value of the Fund’s assets shall be de-

termined as follows:

16.1 the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid

expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be equal to the entire
amount thereof;

16.2 the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock

exchange or traded on any other regulated market will be based on the last available price on the principal market on which
such securities, money market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognized pricing service approved
by the AIF Manager. If such prices are not representative of the fair value, such securities, money market instruments or
derivatives as well as other permitted assets may be valued at a fair value at which it is expected that they may be resold,
as determined under the direction of the AIF Manager;

16.3 the value of securities and money market instruments which are not quoted or traded on a regulated market will be

valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined by and under the direction of the AIF
Manager;

16.4 investments in private equity securities other than the securities mentioned herein will be valued with the assistance

of one or several independent valuer(s) and the Auditor designated by the AIF Manager on the basis of the reasonably
foreseeable sales price of the assets concerned, as determined by the relevant independent valuer in accordance with the
standards of the valuers’ profession, such as the most recentValuation Guidelines published by the European Venture
Capital Association (EVCA);

16.5 the amortized cost method of valuation for short-term transferable debt securities in certain Sub-Funds of the Fund

may be used. This method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant amortization to maturity
of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the security. While
this method provides certainty in valuation, it may result during certain periods in values which are higher or lower than
the price which the Sub-Fund would receive if it sold the securities. For certain short term transferable debt securities, the
yield to a shareholder may differ somewhat from that which could be obtained from a similar sub-fund which marks its
portfolio securities to market each day;

16.6 the value of the participations in investment funds shall be based on the last available valuation. Generally, parti-

cipations in investment funds will be valued in accordance with the methods provided by the instruments governing such
investment funds. These valuations shall normally be provided by the Central Administrative Agent or valuation agent of
an investment fund. To ensure consistency within the valuation of each Sub-Fund, if the time at which the valuation of an
investment fund was calculated does not coincide with the valuation time of any Sub- Fund, and such valuation is determined
to have changed materially since it was calculated, then the Net Asset Value may be adjusted to reflect the change as
determined by and under the direction of the AIF Manager;

16.7 the value of other assets will be determined at fair value by the Central Administrative Agent and under the direction

of the AIF Manager according to general accepted accounting standards.

15.9 All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted

LuxGAAP accounting principles.

15.10 For each Sub-Fund, adequate provisions will be made for expenses incurred and due account will be taken of any

off-balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.

15.11 For each Sub-Fund and for each Class, the Net Asset Value per Share shall be calculated in the relevant Reference

Currency on each Valuation Day by dividing the net assets attributable to such Sub-Fund and to such Class (which shall
be equal to the assets minus the liabilities attributable to such Sub-Fund and to such Class) by the number of Shares issued
and  in  circulation  in  such  Sub-Fund  and  to  such  Class.  Assets  and  liabilities  expressed  in  foreign  currencies  shall  be
converted into the relevant Reference Currency, based on the relevant exchange rates.

15.12 The Fund's net assets shall be equal to the sum of the net assets of all its Sub-Funds.
15.13 In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision to determine the net asset value

taken by the AIF Manager, shall be final and binding on the Fund and present, past or future Shareholders.

15.14 In the event of it being impossible, or incorrect, to carry out a valuation in accordance with the above rules owing

to particular circumstances, the board of directors of the AIF Manager is entitled to use other generally recognized valuation

139897

principles, which can be examined by an independent auditor, in order to reach a proper valuation of its assets. In any event,
the board of directors of the AIF Manager ensures the proper independent valuation of the assets of each Sub-Fund. Where
the nature of the assets of a Sub-Fund requires expert valuation, an external valuer will be appointed by the AIF Manager
in accordance with the provisions of the 2013 Law. The external valuer shall perform its functions impartially and with the
requested due skill, care and diligence, and shall not delegate the valuation function to a third party. The external valuer
will value the properties using a formal set of guidelines on the basis of widely-accepted valuation standards, adapted as
necessary to respect individual market considerations and practices.

15.15 The Fund applies the materiality thresholds set out in CSSF Circular 02/77 in case of NAV computation errors.

Art. 16. Suspension of the Determination of the Net Asset Value.
16.1 The Fund is authorized to temporarily suspend the calculation of the Net Asset Value and the issue of any Class

in any Sub-fund in the following cases:

(a) when for any reason the prices of any investments owned by the Fund attributable to any Sub-fund cannot promptly

or accurately be ascertained; or

(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the AIF Manager as a

result of which disposals or valuation of assets owned by the Fund attributable to such Sub-fund would be impracticable;
or

(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any

of the investments of such Sub-fund or the current price or values on any stock exchange or other market in respect of the
assets attributable to such Sub-fund; or

(d) during any period when the AIF Manager is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of the Shares of such Sub-fund or during which any transfer of funds involved in the realization or acquisition,
of investments or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the AIF Manager be effected at normal
rates of exchange;

(e) if a resolution calling for the liquidation of the Fund has been adopted;
(f) if an underlying asset in which the Fund has invested in excess of five percent (5%) of the Net Asset Value of the

Fund suspends the redemption of its shares; or

(g) in exceptional circumstances which might adversely affect the interests of the Shareholders.
16.2 Where possible all reasonable steps will be taken to bring any period of suspension to an end as soon as possible.

Art. 17. General Meeting of Shareholders.
17.1  Any  regularly  constituted  general  meeting  of  the  Shareholders  of  the  Fund  shall  represent  the  entire  body  of

Shareholders of the Fund. Without prejudice to the provision of article XXII of the present Articles of Incorporation, and
to any other powers reserved to the General Partner by virtue of law or the present Articles of Incorporation, it shall have
the broadest powers to undertake or to ratify any act relating to the activities of the Fund.

17.2 The general meeting of Shareholders does not undertake or ratify any act that concerns the Fund with regard to

third parties or that modifies these Articles of Incorporation without the approval of the General Partner.

Art. 18. Date and Place of Meetings of Shareholders.
18.1 The annual general meeting of the Shareholders of the Fund will be held each year at the registered office of the

Fund in Luxembourg on 30 

th

 of June of each year at 10h30 AM ((Luxembourg time) or, if such day is not a Business Day

(as defined in the Issuing Document of the Fund), on the next following Business Day.

18.2 Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices

of meeting.

Art. 19. Organisation of Meetings of Shareholders.
19.1 All general meetings of Shareholders shall be presided over by the General Partner.
19.2 Notices of a general meeting and other notices will be given in accordance with Luxembourg law. Notices will

specify the place and time of the meetings, the conditions of admission, the agenda, the quorum and the voting requirements
will be given at least eight (8) calendar days prior to the meetings. If all the Shareholders are present or represented at a
general meeting of the Shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the
Shareholders can waive all convening requirements and formalities.

19.3 A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person who need not be a Shareholder.
19.4 The General Partner may determine any and all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to

take part in any meeting of Shareholders.

19.5 Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

Art. 20. Correspondence to Shareholders.
20.1 Any notice or other correspondence to a Shareholder is sent to the Shareholder at the Shareholder's address.

139898

Art. 21. The Management of the Fund.
21.1 The Fund shall be managed by the General Partner in its capacity as general partner (“associé gérant commandité”)

of the Fund and by the AIF Manager (as defined below). The limited Shareholders (“Actionnaires commanditaires”) of the
Fund may in no event participate or interfere in the management of the Fund.

21.2In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from acting

as manager of the Fund, the Fund shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the general meeting of
Shareholders appoints, in accordance with the quorum and majority requirements for the amendment of the Articles of
Incorporation and subject to the prior approval of the CSSF, a successor manager. Any such appointment of a successor
manager shall not be subject to the approval of the General Partner. Failing such appointment, the Fund shall be dissolved
and liquidated. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the AIF Manager from
acting as manager of the Fund, the Fund shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the General Partner
appoints, subject to the prior approval of the CSSF, a successor AIF Manager. Any such appointment of a successor AIF
Manager shall not be subject to the approval of the previous AIF Manager. Failing such appointment, the Fund shall be
dissolved and liquidated.

21.3 For the purpose of the alternative investment fund manager directive 2011/61/EU of the European Parliament and

of the Council of 8 June 2011 on alternative investment fund managers and amending directives 2003/41/EC and 2009/65/
EC and Regulations (EC) N° 1060/2009 and (EU) N° 1095/2010 (AIFM Directive) and the law of 12 July 2013 relating
to alternative investment fund managers (gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs) (published in the Mémorial
A under number, N° 119 on 15 July 2013), as the same may be amended from time to time, the Fund is an "externally
managed alternative investment fund" with:

a. Quilvest Asset Management S.A., a Luxembourg based alternative investment fund manager, authorised under Chap-

ter 2 of the 2013 Law or under Chapter II of Directive 2011/61/EU, incorporated in the legal form of a public limited
liability company (société anonyme) and having its registered office at 48, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, governed by the laws applicable in the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the 2013 Law,
Chapter XVI “Other management companies” of the law of 17 December 2010 on undertakings of collective investment
(published in Mémorial A in 2010, under number 239), as amended from time to time (the “2010 Law”) and the 1915 Law,

21.4 acting as the Fund’s external alternative investment fund manager (the “AIF Manager”).
21.5 The General Partner may, subject to the CSSF’s prior approval, form committees and give them advisory function,

as set forth, if applicable, in the Issuing Document of the Fund, and in the relevant Sub-Fund(s) Fact Sheet(s).

Art. 22. Powers of the General Partner.
22.1 The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within

the Fund stated purpose save for those that are expressly reserved by law or these Articles of Incorporation to the general
meeting of Shareholders.

22.2 The General Partner and the AIF Manager may, subject to the CSSF’s prior approval, appoint, under their full

responsibility, investment advisors, investment managers as well as any other advisory or administrative agents. In accor-
dance with the applicable laws and regulations, the General Partner and the AIF Manager may enter into agreements with
such persons for the rendering of their services, the delegation of powers to them and the determination of their remuneration
to be borne by the Fund.

Art. 23. Representation of the Fund.
23.1The Fund will be bound towards third parties by the sole signature of the General Partner or by the individual or

joint signatures of any other person, as designated and determined by the General Partner at its sole discretion and under
his full responsibility, or by any such person(s) to whom such power has been delegated.

Art. 24. Conflict of Interests.
24.1 The AIF Manager, the Depositary, the Central Administrative Agent and their respective affiliates, managers of

the General Partner, officers and Shareholders (collectively the “Parties”) may be involved in other financial, investment
and professional activities which may cause conflict of interest with the management and administration of the Fund.

24.2 These include the management of other funds, purchases and sales of securities, depositary and safekeeping services

and serving as managers of the General Partner, officers, advisors or agents of other funds or other companies, including
companies in which the Fund may invest. Each of the Parties will respectively ensure that the performance of their respective
duties will not be impaired by any such other involvement that they might have. In the event that a conflict of interest does
arise, the relevant Parties shall notify the General Partner. The General Partner and the relevant Parties involved shall
endeavour to ensure that it is resolved fairly within reasonable time and in the interest of the Shareholders.

24.3 Any kind of conflict of interest is to be fully disclosed to the General Partner and the AIF Manager.
24.4 In the event that any member of the board of managers of the General Partner has an interest conflicting with that

of the Fund in a transaction which is subject to the approval of the board of managers of the General Partner and/or of the
Fund (or Sub-fund, as appropriate), that member must make such interest known to the board of managers of the General
Partner and to the Fund (or Sub-fund as appropriate) and cause a record of his/her statement to be included in the minutes

139899

of the meeting. This member must not deliberate or vote upon any such transaction. Any such transaction must be speci-
fically reported at the next meeting before any other resolution is put to a vote.

24.5 The AIF Manager strive to manage any conflicts in a manner consistent with the highest standards of integrity and

fair dealing. For this purpose, the AIF Manager implemented procedures that shall ensure that any business activities
involving a conflict which may harm the interests of the Fund or its investors, are carried out with an appropriate level of
independence and that any conflicts are resolved fairly.

24.6 Each of the Parties will respectively ensure that the performance of their respective duties will not be impaired by

any such involvement that they might have. In the event that a conflict of interest does arise, the General Partner and the
relevant parties shall endeavour to ensure that it is resolved fairly within reasonable time and in the interest of the Share-
holders of the Fund. The Fund is required to maintain a conflicts of interest policy in accordance with the applicable laws
and regulations, in particular, the 2007 Law and Delegated Regulation (EU) No. 231 / 2013.

Art. 25. Indemnification.
25.1 The General Partner and each of its managers and employees, to the extent directly involved in the business of the

relevant Sub-fund(s), (each referred to as “Indemnified Person”) are entitled to be indemnified, out of the relevant Sub-
fund's assets against any and all liabilities, fines, taxes and interest and penalties thereon, claims, demands, actions, suits,
proceedings and litigation costs, expenses and disbursements which may be imposed on, incurred by, or asserted at any
time against that person in any way related to or arising out of such Indemnified Person being involved in the business of
the relevant Sub-fund, provided that no Indemnified Person shall be entitled to such indemnification for any action or
omission resulting from any behaviour which qualifies as fraud, wilful misconduct, reckless disregard or gross negligence.

25.2 In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the General Partner is advised by counsel selected in good faith by the General Partner that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which such person may be entitled.

Art. 26. Depositary.
26.1 To the extent required by the 2007 Law, the Fund shall enter into a depositary agreement with a bank registered

on the CSSF’s official list of banks established in Luxembourg in accordance with the law of 5 April 1993 on the financial
sector, published in the Mémorial A under number 27 on 10 April 1993, as amended from time to time and authorised to
carry on its activities pursuant to article 2 of the same law.

26.2 The Depositary shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by the 2007 Law and the law of 12 July

2013 relating to alternative investment fund managers (gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs) (published in
the Mémorial A under number, N° 119 on 15 July 2013), as the same may be amended from time to time.

26.3 If the Depositary desires to retire, the General Partner shall use its best endeavours to find a successor depositary

and will appoint, subject to the CSSF’s prior approval, it in replacement of the retiring Depositary. The General Partner
may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until a successor Depositary
shall have been appointed to act in the place thereof.

Art. 27. Auditor.
27.1 The accounting data included in the annual report of the Fund, in accordance with Annex I of the 2007 Law

“Information to be included in the annual report”, shall be examined by an independent auditor (réviseur d’entreprises
agréé) appointed by the Fund, represented by the General Partner. The Auditor shall fulfil the duties prescribed by the 2007
Law.

Art. 28. Financial Year.
28.1The financial year of the Fund shall begin on the first (1 

st

 ) day of January of each year and shall terminate on the

last day of December of the same year.

Art. 29. Annual Report.
29.1 The Fund shall publish one annual report within a period of six (6) months as of the end of the financial year

concerned.

Art. 30. Dissolution.
30.1 The Fund may be dissolved by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment

of these Articles of Incorporation and subject to the consent of the General Partner.

Art. 31. Applicable Law.
31.1All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 2007 Law,

the 1915 Law and any other applicable Luxembourg law.

<i>Transitory provisions

<i>Accounting Year

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 

st

 December 2016.

139900

<i>Subscription - Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe to the whole capital

as follows:

PARTY

NUMBER

OF

SHARES

CLASS OF SHA-

RES

Touax Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

management Sha-

re

Touax S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

limited Shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

and declare to have them all fully paid up in cash of an amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31.000,-) is now

available to the Fund, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Fund as a result of its

incorporation are estimated at approximately three thousand Euros (EUR 3000)

<i>General meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have

immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of the meeting, the
meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.

1. The registered office of the Fund is set at 28-32 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

2. The independent auditor for the Fund shall be Deloitte Audit S.à r.l. with registered address at 560, rue de Neudorf.

L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 67.895.The term of office of the auditor shall
expire at the close of the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts of the year 2016.

3. The Fund shall enter into a depositary agreement with Société Générale Bank &amp; Trust S.A., a public limited liability

company (société anonyme), having its registered office at 28-32 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg,  registered  with  the  R.C.S.  under  number  B0006061  and  registered  on  the  CSSF’s  official  list  of  banks
established in Luxembourg in accordance with the law of 5 April 1993 on the financial sector and authorised to carry on
its activities pursuant to article 2 of the law of 5 April 1993 on the financial sector, published in the Mémorial A under
number 27 on 10 April 1993, amended from time to time;

4. The Fund appointed Quilvest Asset Management S.A., a Luxembourg based alternative investment fund manager,

authorised under Chapter 2 of the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers or under Chapter
II of Directive 2011/61/EU, incorporated in the legal form of a public limited liability company (société anonyme) and
having its registered office at 48, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, governed by the
laws applicable in the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the 2013 Law, Chapter XVI “Other management com-
panies” of the Law of 17 December 2010 on undertakings of collective investment, published in the Mémorial A in 2010,
under number 239 as amended from time to time as its AIF Manager.

<i>Declaration

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the mandatory of the companies appearing, said person appearing signed together

with the notary the present deed.

Signé: P.-A. Delagardelle et J. Castel.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 août 2015. Relation: 2LAC/2015/18750. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Référence de publication: 2015149960/516.

(150163805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

139901

JPRF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue JF Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.923.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 20 mars 2015

<i>Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à l'adresse suivante

avec effet au 20 mars 2015:

44, Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

Pour copie conforme
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015150363/15.

(150164686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Jushel Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 128.779.

Suite à la cession de 50 parts sociales de la Société par M. Jean-Christophe Furgoni, demeurant à 7, rue des Bouleaux,

F-57185  Clouange,  à  Monsieur  Humbert  Furgoni,  demeurant  à  15,  avenue  Lou  Hemmer,  L-5627  Mondorf-les-Bains,
suivant acte de cession de parts sociales du 30 août 2015, M. Humbert Furgoni est devenu l'associé unique de la Société
dont le capital social est divisé en 504 (cinq cent quatre) parts sociales.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015150365/15.

(150164973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

K200 Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 139.415.

EXTRAIT

En date du 7 septembre 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- La démission de Aleksandra Teresa Lipinski-Hauck en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 17 août

2015;

- Le mandat de Jean-Marc McLean en tant que gérant de la Société est révoqué avec effet au 31 juillet 2015;

- Peter Lundin, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant

de la Société avec effet au 17 août 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau

gérant de la Société avec effet au 31 juillet 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150396/19.

(150164677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139902

Kamsa Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.909.761,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 177.677.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 28 août 2015

1. M. Liu GUANGCAI a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 28 août 2015.
2. Mme. Dong YAO, administratrice de sociétés, née à Nei Mongol (Chine), le 22 décembre 1971, demeurant profes-

sionnellement à An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Allemagne, a été nommée comme gérante avec effet au 28
août 2015 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Kamsa Luxco 1 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015150367/17.
(150164993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Kayalov Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.194.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 juin 2015

En date du 29 juin 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat des personnes suivantes

avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui statuera sur
les comptes arrêtés au 31 décembre 2015:

- Monsieur Peter MANN, gérant A
- Monsieur Thomas SCHULZ, gérant A
- Madame Helen LOVELY FRANCIS, gérant A
- Madame Marie DRUINAUD, gérant B
- Madame Laetitia ANTOINE, gérant B
- PricewaterhouseCoopers, réviseur d'entreprises agréé
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Kayalov Holdings S.àr.l.
Signature

Référence de publication: 2015150369/22.
(150164843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

KONYA Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 36.783.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 Août 2015

L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de Monsieur Luigi MAULA, employé privé, avec adresse

professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui se tiendra
en 2020.

Luxembourg, le 24 Août 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015150388/15.
(150164663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139903

Kamille S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 104.167.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Delphine Munier.

Référence de publication: 2015150371/10.
(150164610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

KC Esther S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 174.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015150373/10.
(150165010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

KF Investment S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 186.517.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 septembre 2015

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2020

<i>Administrateur de catégorie A:

- Mr Alexander KOLIKOV, administrateur de société, demeurant au 6, rue du X Septembre, L- 8048 Strassen;

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Mr Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L- 1653 Luxembourg, Président;

- Mr Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L- 1653 Luxembourg;

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2020:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150377/22.
(150164653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

La Gardenia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 184.446.

Le bilan pour la période du 03/02/2014 au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150401/10.
(150164486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139904

KH III Lending 801 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 192.235.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 03 septembre 2015, qui ont acceptées:
- la nomination de Mr Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement

au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre
2015;

- la nomination de Mr Fabrice Léonard, né le 04 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au

68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre 2015;

- la démission de Mme Miranda Lansdowne de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 03 septembre 2015;
- la démission de Mme Pamela Morag Valasuo de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 August 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 septembre 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150380/20.
(150165109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

KH III Properties 701 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 189.353.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 03 septembre 2015, qui ont acceptées:
- la nomination de Mr Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement

au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre
2015;

- la nomination de Mr Fabrice Léonard, né le 04 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au

68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre 2015;

- la démission de Mme Miranda Lansdowne de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 03 septembre 2015;
- la démission de Mme Pamela Valasuo de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 août 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 septembre 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150381/20.
(150164580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Les Pierres Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 158.784.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 août 2015

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert SCHMITZ en tant que Gérant de la société, à la date du 21 mai 2015.
Acceptation de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia (Algérie), domiciliée

professionnellement au 3 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme nouveau Gérant de la société, avec effet au 21 mai
2015.

<i>Pour la société
LES PIERRES INVESTMENT Sàrl

Référence de publication: 2015150419/14.
(150165023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139905

KH III Properties 702 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 181.264.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 03 septembre 2015, qui ont acceptées:
- la nomination de Mr Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement

au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre
2015;

- la nomination de Mr Fabrice Léonard, né le 04 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au

68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre 2015;

- la démission de Mme Miranda Lansdowne de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 03 septembre 2015;
- la démission de Mme Pamela Valasuo de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 août 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 septembre 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150382/20.
(150164583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

MAT Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 184.427.

Par la présente, j'ai l'honneur de démissionner de mon mandat d'Administrateur au sein de la société MAT ESTATE

S.A., inscrite au RSCL sous le numéro B184427, dans le cadre de la convention signée le 2 décembre 2013, et ce avec effet
immédiat.

Strassen, le 1 

er

 septembre 2015.

Madame Isabelle SCHAEFER.

Référence de publication: 2015150444/11.
(150165160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

KH III Properties 703 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 193.215.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 03 septembre 2015, qui ont acceptées:
- la nomination de Mr Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement

au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre
2015;

- la nomination de Mr Fabrice Léonard, né le 04 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au

68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre 2015;

- la démission de Mme Miranda Lansdowne de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 03 septembre 2015;
- la démission de Mme Pamela Valasuo de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 August 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 septembre 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150383/20.
(150164723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139906

KH III Properties 704 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 194.813.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 03 septembre 2015, qui ont acceptées:
- la nomination de Mr Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement

au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre
2015;

- la nomination de Mr Fabrice Léonard, né le 04 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au

68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre 2015;

- la démission de Mme Miranda Lansdowne de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 03 septembre 2015;
- la démission de Mme Pamela Valasuo de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 August 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 septembre 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150384/20.
(150164779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Marcarini Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 158.798.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 août 2015

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert SCHMITZ en tant que Gérant de la société, à la date du 21 mai 2015.
Acceptation de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia (Algérie), domiciliée

professionnellement au 3 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme nouveau Gérant de la société, avec effet au 21 mai
2015.

<i>Pour la société
MARCARINI INVESTMENTS Sàrl

Référence de publication: 2015150442/14.
(150165022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

KH III Properties 705 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 195.763.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 03 septembre 2015, qui ont acceptées:
- la nomination de Mr Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement

au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre
2015;

- la nomination de Mr Fabrice Léonard, né le 04 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au

68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre 2015;

- la démission de Mme Miranda Lansdowne de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 03 septembre 2015;
- la démission de Mme Pamela Valasuo de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 August 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 septembre 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150385/20.
(150165049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139907

KH III Properties 706 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 196.687.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 03 septembre 2015, qui ont acceptées:
- la nomination de Mr Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement

au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre
2015;

- la nomination de Mr Fabrice Léonard, né le 04 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au

68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre 2015;

- la démission de Mme Miranda Lansdowne de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 03 septembre 2015;
- la démission de Mme Pamela Valasuo de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 Août 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 septembre 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150386/20.
(150164877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Pacific Real Estate Basket S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 19.786,25.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 130.170.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 août 2015, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat

de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxem-
bourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150493/14.
(150164862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

KH III Properties 707 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 199.300.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 03 septembre 2015, qui ont acceptées:
- la nomination de Mr Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement

au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre
2015;

- la nomination de Mr Fabrice Léonard, né le 04 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au

68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 03 septembre 2015;

- la démission de Mme Miranda Lansdowne de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 03 septembre 2015;
- la démission de Mme Pamela Valasuo de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 Août 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 septembre 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150387/20.
(150164887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139908

Kronospan Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R.C.S. Luxembourg B 163.883.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenue le 6 novembre 2014

Acceptation de la démission de Monsieur Gilles Breuer en sa qualité d'administrateur de la société, avec effet immédiat.
Référence de publication: 2015150394/9.
(150164730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

L.O.P.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 132.551.

EXTRAIT

Par lettre en date du 4 septembre 2015, Monsieur Gianluca NINNO a démissionné de son mandat d'administrateur de

la société L.O.P.D. S.A, société anonyme dont le siège est 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B132551, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150398/13.
(150164691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Aleph Holdings Limitied I S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 147.925.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Carsten SÖNS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150669/12.
(150165190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

L.O.P.D. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 132.551.

EXTRAIT

Par lettre en date du 4 septembre 2015, la société FIDUCIA GENERAL SERVICES S.à.r.l., ayant son siège social au

44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,

A dénoncé le domicile établi au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
De la Société anonyme L.O.P.D, S.A., immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 132551, de sorte que celle-ci se trouve jusqu'à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2015.

FIDUCIA GENERAL SERVICES S.à r.l.
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2015150399/16.
(150165071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139909

Lawson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 122.774.

EXTRAIT

Il convient de noter que l'adresse de l'associé Yves Munoz est désormais située au:
Avenida Chacao 1
Residencia Monte Mauro
Appartamento PH.A
Macaracuay – Caracas
Venezuela
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150403/17.
(150164894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Lazarus Investments Limited, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 182.557.

EXTRAIT

En date du 3 septembre 2015, l'actionnaire unique a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Mme Barbara Neuerburg, en tant qu'administrateur unique, est acceptée avec effet immédiat.
- Mme Lisa White, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée nouvel

administrateur de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui sera tenue
en 2018.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150404/15.
(150164520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

La Concorde, Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 54.078.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue en date du 10 avril

2015 que Madame Christelle MATHIEU a été nommée Président du Conseil d'Administration, et ce jusqu'au terme de son
mandat d'administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150412/13.
(150165017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

MAT Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 184.427.

Par la présente, j'ai l'honneur de démissionner de mon mandat d'Administrateur au sein de la société MAT ESTATE

S.A., inscrite au RSCL sous le numéro B184427, dans le cadre de la convention signée le 2 décembre 2013, et ce avec effet
immédiat.

Strassen, le 1 

er

 septembre 2015.

Madame Kahrien LERBS.

Référence de publication: 2015150445/11.
(150165160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139910

Lux 30 Starlight EUR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 181.209.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150410/10.
(150164804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Le Flamboyant S.àr.l., Spf, Société de gestion de Patrimoine Familial, Société à responsabilité limitée - Société de

gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 131.917.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150405/10.
(150164817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Lafor 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.606.000,00.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 159.618.

<i>Extrait du contrat de cession d'actions du 3 septembre 2015

Il résulte d'un transfert de 3.181.800 parts sociales de classe A Lafor 1 SARL par Opéra Finance International S.A. à

Monsieur Eric Grabli, né le 28 février 1964 à Boulogne Billancourt (France), domicilié au 18, rue du Magistrat B-1000
Bruxelles, et ce avec effet au 3 septembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015150415/16.
(150164891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

LGSL Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 187.800.

<i>Extrait des décisions de l'assemblée générale annuelle

En date du 29 juin 2015, l'assemblée générale annuelle a adopté les résolutions suivantes:
- Le mandat de l'administrateur Peter Bun, demeurant professionnellement au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

est reconduit jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en 2016;

- Le mandat de l'administrateur Marta Lavaroni, demeurant professionnellement au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxem-

bourg, est reconduit jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en 2016;

- Le mandat de l'administrateur Etienne Mouthon, demeurant professionnellement au 8, rue Philippe II, L-2340 Lu-

xembourg, est reconduit jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en 2016;

- Le mandat de Commissaire aux comptes, ISOSTRESS, ayant son siège social au 29, rue Joseph Hansen, L-1716

Luxembourg, est reconduit jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en 2016.

139911

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08/09/2015.

Référence de publication: 2015150420/19.
(150165039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Lami II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 263, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 144.146.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LAMI II S.à r.l.

Référence de publication: 2015150416/10.
(150164936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Libra Project Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 139.702.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015150421/10.
(150165019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

MEIF 3 Luxembourg C Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 142.792.

Il est à noter que Hllko SCHOMERUS, gérant B de la Société, a changé son adresse professionnelle comme suit:
2-4 Bockenheimer Landstrasse, 60306 Frankfurt am Main (Allemagne).
Il est à noter de plus que le nom correct du lieu de naissance de ce même gérant est «Köln».
Il est à noter de plus que le siège social de l'associé unique de la Société a changé et se trouve désormais au:
46, Place Guillaume II, 1648 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150452/15.
(150165127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Matterhorn Mobile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 165.835.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 25 août 2015 que Monsieur Marcel Huber,

né le 16 janvier 1970 à Oberrieden (Suisse), demeurant professionnellement au 4 Rue du Caudray, 1020 Renens (Suisse)
a été nommé aux fonctions d'administrateur de catégorie B de la Société, avec effet au 25 août 2015.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150429/13.
(150164459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139912

Matterhorn Telecom Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 195.766.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 25 août 2015 que Monsieur Marcel Huber,

né le 16 janvier 1970 à Oberrieden (Suisse), demeurant professionnellement au 4 Rue du Caudray, 1020 Renens (Suisse)
a été nommé aux fonctions d'administrateur de catégorie B de la Société, avec effet au 25 août 2015.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150430/13.
(150164460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Matterhorn Telecom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 195.769.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 25 août 2015 que Monsieur Marcel Huber,

né le 16 janvier 1970 à Oberrieden (Suisse), demeurant professionnellement au 4 Rue du Caudray, 1020 Renens (Suisse)
a été nommé aux fonctions d'administrateur de catégorie B de la Société, avec effet au 25 août 2015.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150431/13.
(150164461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Netco Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 57.203.

EXTRAIT

Il résulte d'un courrier du 3 septembre 2015 que je démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur de

la société NETCO INDUSTRIES S.A., établie et ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange,
inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 57 203.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

<i>Pour le mandataire
Signature

Référence de publication: 2015150483/15.
(150164692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Medforyou, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 176.977.

Je vous informe par la présente de ma démission, avec effet au 30 juin 2014, de mon mandat de gérante de la société

MEDFORYOU S.à.r.l, ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B. sous le numéro 176.977.

Luxembourg, le 07 septembre 2015.

Florence GRILLIERE
<i>Gérante

Référence de publication: 2015150432/13.
(150165055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139913

Meenie GP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.630.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 29 juin 2015

En date du 29 juin 2015, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat

des personnes suivantes avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la
Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015:

- Monsieur Peter MANN, administrateur de catégorie A
- Monsieur Thomas SCHULZ, administrateur de catégorie A
- Madame Marie DRUINAUD, administrateur de catégorie A
- Monsieur Patrick FENN, administrateur de catégorie B
- Monsieur Gérard LOUIS-DREYFUS, administrateur de catégorie B
- Monsieur Olivier DORIER, administrateur de catégorie B
- PricewaterhouseCoopers, réviseur d'entreprises agréé
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Meenie GP S.A.
Signature

Référence de publication: 2015150433/22.
(150164844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Paradocs Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.655.943,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 193.478.

En  date  du  28  juillet  2015,  l'associé  Paradocs  Research  S.A.,  avec  siège  social  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882

Luxembourg a cédé 175 309 parts sociales à l'associé Paradocs Bis S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, qui les acquiert.

En conséquence, les associés sont les suivants:
- Paradocs Research S.A, précité, avec 11 277 655 parts sociales;
- Paradocs Manco, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec 5 893 000 parts sociales;
- Paradocs Bis S.à r.l., précité, avec 17 941 791 parts sociales;
- Paradocs Ter S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec 14 104 324 parts sociales;
- Staffco Malta Holding Limited, précité, avec 1 439 173 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150495/19.
(150164864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Meif 3 Luxembourg A Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 140.896.

Il est à noter que Hllko SCHOMERUS, gérant B de la Société, a changé son adresse professionnelle comme suit:
2-4 Bockenheimer Landstrasse, 60306 Frankfurt am Main (Allemagne).
Il est à noter de plus que le nom correct du lieu de naissance de ce même gérant est «Köln».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150434/13.
(150165129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139914

Malebis, Société Civile.

Siège social: L-7780 Bissen, 4, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg E 1.987.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 1 

<i>er

<i> septembre 2015

Les associés décident à l'unanimité:
- de transférer le siège social de MALEBIS s.c.i. à l'adresse suivante:
4, Route De Mersch, 7780 Bissen

Pour extrait conforme
Thomas Lentz

Référence de publication: 2015150441/13.
(150164668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

MAT Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 184.427.

Dans le cadre de l'exécution de notre mandat, nous avons le regret de vous informer de notre décision de déposer, avec

effet immédiat, notre mandat de commissaire aux comptes de la société MAT ESTATE S.A..

Strassen, le 01/09/2015.

Fiduciaire Intercommunautaire S.à R.L.

Référence de publication: 2015150446/11.
(150165160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Roberta Di Camerino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 130.219.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 24 août 2015

1. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Mme Léonie TOULEMONDE, administrateur de sociétés, née à Roubaix (France) le 13 juillet 1986, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme administrateur, pour une durée
de 5 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2020 approuvant les comptes annuels de l'année
financière 2019.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ROBERTA DI CAMERINO S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015150532/17.
(150164749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

MCH LUX I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 264.250.573,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.617.

La décision suivante a été approuvée par l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui s'est tenue en date

du 19 août 2015:

- Renouvellement du mandat de la société KPMG Luxembourg, Société Coopérative ayant son siège social au 39, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 149133, en tant que reviseur d'entreprises agrée avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

139915

Luxembourg, le 07 septembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015150449/20.
(150165081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

MEIF 3 Luxembourg B Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 142.750.

Il est à noter que Hilko SCHOMERUS, gérant B de la Société, a changé son adresse professionnelle comme suit:
2-4 Bockenheimer Landstrasse, 60306 Frankfurt am Main (Allemagne).
Il est à noter de plus que le nom correct du lieu de naissance de ce même gérant est «Köln».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150451/13.
(150165128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Melies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 179.930.

Par la présente, j'ai l'honneur de démissionner de mon mandat d'Administrateur au sein de la société MELIES S.A.,

inscrite au RSCL sous le numéro B179930, dans le cadre de la convention signée le 08 août 2013, et ce avec effet immédiat.

Strassen, le 1 

er

 septembre 2015.

Madame Aurélie GERARD.

Référence de publication: 2015150456/10.
(150165119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Melies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 179.930.

Dans le cadre de l'exécution de notre mandat, nous avons le regret de vous informer de notre décision de déposer, avec

effet immédiat, notre mandat de commissaire aux comptes de votre société.

Strassen, le 01/09/2015.

Fiduciaire Intercommunautaire S.à R.L.

Référence de publication: 2015150459/11.
(150165119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Melies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 179.930.

Par la présente, j'ai l'honneur de démissionner de mon mandat d'Administrateur au sein de la société MELIES S.A.,

inscrite au RSCL sous le numéro B179930, dans le cadre de la convention signée le 08 août 2013, et ce avec effet immédiat.

Strassen, le 1 

er

 septembre 2015.

Madame Isabelle SCHAEFER.

Référence de publication: 2015150457/10.
(150165119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139916

Melies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 179.930.

Par la présente, j'ai l'honneur de démissionner de mon mandat d'Administrateur au sein de la société MELIES S.A.,

inscrite au RSCL sous le numéro B179930, dans le cadre de la convention signée le 08 août 2013, et ce avec effet immédiat.

Strassen, le 1 

er

 septembre 2015.

Madame Kahrien LERBS.

Référence de publication: 2015150458/10.
(150165119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Merovimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 178.514.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150462/9.
(150165072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Norma Lux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 194.914.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 3 août 2015 à 13h30

<i>Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de nommer comme Administrateur-délégué Monsieur Joseph

DE HAES né le 9 décembre 1954 à Wemmel (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 65, rue des Romains L-8041
Strassen. L'Administrateur-délégué peut engager la société par sa seule signature.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NORMA LUX INVEST SA

Référence de publication: 2015150485/15.
(150165014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Peters Maschinenbau A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 32, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.804.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2015150512/10.
(150164948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Moselle Parc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 148.841.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 31 août 2015

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Julien Sale en tant que gérant A de la Société avec effet au 31 août 2015;
- d'accepter la démission de Cyrus de Week en tant que gérant A de la Société avec effet au 31 août 2015;

139917

- de nommer Daniel Collins, né le 29 janvier 1962 au New York, New York, les États-Unis d'Amérique, ayant son siège

professionnel au 1177 Avenue of the Americas, 9 

th

 Floor, New York, NY 10036, les États-Unis d'Amérique, en tant que

gérant A de la Société avec effet au 31 août 2015 et ce pour une durée illimitée;

- de nommer Jing Chen, né le 14 octobre 1973 au Baoji, Chine, la République populaire de Chine, ayant son siège

professionnel au 1177 Avenue of the Americas, 9 

th

 Floor, New York, NY 10036, les États-Unis d'Amérique, en tant que

gérant B de la Société avec effet au 31 août 2015 et ce pour une durée illimitée;

- de nommer Sophie Schreiber-Ward en tant que gérante A de la Société avec effet au 31 août 2015 et ce pour une durée

illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150467/22.
(150164710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Office Park Findel Exupéry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 145.200.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2015

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2015
Le conseil d'administration se compose à partir de ce jour comme suit:
1. Monsieur Hans-Peter MAIER, administrateur et administrateur délégué
2. Monsieur le Dr Hanns MAIER, administrateur et administrateur délégué
3. SOMACO S.A, administrateur.
Est nommé commissaire aux comptes:
- AUXILIAIRE DES P.M.E. S.A.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016 statuant sur les comptes de l'exercice

2015

Luxembourg, le 31 août 2015.

Pour extrait conforme
OFFICE PARK FINDEL EXUPERY SA
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Signature

Référence de publication: 2015150488/22.
(150164942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Silver Moss B 2014 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 186.797.

Les comptes annuels de la société Silver Moss B 2014 S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150546/10.
(150164599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Pumbaa Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 163.575.

La décision suivante a été prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 2 septembre 2015:
- renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative en tant que réviseur d'entreprises agréé

de la Société, avec effet immédiat et pour une période arrivant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires à tenir en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

139918

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

<i>Pour la Société
TMF Corporate Services S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2015150505/18.
(150164572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Puro Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 152.975.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 26 mai

<i>2015

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:
FIN-CONTROLE S.A., établie et ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès

du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42.230

jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150507/15.
(150164635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Progressive Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 158.785.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 août 2015

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert SCHMITZ en tant que Gérant de la société, à la date du 21 mai 2015.
Acceptation de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia (Algérie), domiciliée

professionnellement au 3 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme nouveau Gérant de la société, avec effet au 21 mai
2015.

<i>Pour la société
PROGRESSIVE ENTERFRISES Sàrl

Référence de publication: 2015150517/14.
(150165021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

PTC Essen Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 117.290.

- Le mandat de Mons. Yazid Oudina, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-

bourg, est terminé, avec effet au 20 juillet 2015.

- Le mandat de Mons. Kailash Ramassur, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxembourg, est nommé administrateur de la société, avec effet au 7 septembre 2015.

- Le nouveau mandat de Mons. Kailash Ramassur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en

2016.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015150518/16.
(150165005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

139919

River Green Settlements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.420.

Suite à une erreur administrative, nous vous prions de bien vouloir prendre note de l'adresse des gérants suivants:

- Monsieur Tony Whiteman, Gérant de catégorie A, résidant au 14, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange

- Monsieur James Torchia, Gérant de catégorie B, 42, North Church Street, Grand Cayman, KY1-1108 Iles Caïmanes

- Monsieur Marc A. Celello, Gérant de catégorie B, 42, North Church Street, Grand Cayman, KY1-1108 Iles Caïmanes

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015150523/16.

(150164847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 7, rue de la Déportation.

R.C.S. Luxembourg B 7.910.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 20 juillet 2015

que:

- La démission de Madame Kieu-Hanh GUZELIAN de son poste d'administrateur est acceptée.

- Monsieur Spyridon GKIKAS, né le 18 novembre 1959 à Athènes, demeurant 7B, Chemin des Champs-de-Chaux à

CH-1222 Vesenaz est nommé administrateur de la société pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015150529/18.

(150164551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Riskelia Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 172.172.

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 21 août 2015 au siège social

L'Assemblée décide de nommer Mme Pascale Attuil résidant professionnellement au 7 rue Leo Delibes, 75116 Paris,

en tant qu'administrateur de la société pour un terme de un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale
qui se tiendra en 2016.

Référence de publication: 2015150531/11.

(150164732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

139920


Document Outline

Aleph Holdings Limitied I S.à r.l., SPF

GL Europe RE Holdings S.à r.l.

JPRF S.A.

Jushel Sàrl

K200 Finance S.à r.l.

Kamille S.A.

Kamsa Luxco 1 S.à r.l.

Kayalov Holdings S.à r.l.

KC Esther S.à r.l.

KF Investment S.A.

KH III Lending 801 S.à r.l.

KH III Properties 701 S.à r.l.

KH III Properties 702 S.à r.l.

KH III Properties 703 S.à.r.l.

KH III Properties 704 S.à r.l.

KH III Properties 705 S.à.r.l.

KH III Properties 706 S.à r.l.

KH III Properties 707 S.à r.l.

KONYA Spf S.A.

Kronospan Energy S.A.

La Concorde

Lafor 1 S.à r.l.

La Gardenia Holding S.à r.l.

Lami II S.à r.l.

Lawson S.à r.l.

Lazarus Investments Limited

Le Flamboyant S.àr.l., Spf, Société de gestion de Patrimoine Familial

Les Pierres Investment S.à r.l.

LGSL Finance

Libra Project Parent S.à r.l.

L.O.P.D. S.A.

L.O.P.D. S.A.

Lux 30 Starlight EUR S.à r.l.

Malebis

Marcarini Investments S.à r.l.

MAT Estate S.A.

MAT Estate S.A.

MAT Estate S.A.

MAT Estate S.A.

Matterhorn Mobile S.A.

Matterhorn Telecom Holding S.A.

Matterhorn Telecom S.A.

MCH LUX I

Medforyou

Meenie GP S.A.

Meif 3 Luxembourg A Holdings, S.à r.l.

MEIF 3 Luxembourg B Holdings, S.à r.l.

MEIF 3 Luxembourg C Holdings, S.à r.l.

Melies S.A.

Melies S.A.

Melies S.A.

Melies S.A.

Merovimmo S.A.

Moselle Parc S.à r.l.

Netco Industries S.A.

Norma Lux Invest S.A.

Office Park Findel Exupéry S.A.

Pacific Real Estate Basket S.à r.l.

Paradocs Holding S.à r.l.

Peters Maschinenbau A.G.

Progressive Enterprises S.à r.l.

PTC Essen Capital S.A.

Pumbaa Luxembourg S.à r.l.

Puro Group S.A.

Rémy Cointreau Luxembourg S.A.

Riskelia Fund

River Green Settlements S.à r.l.

Roberta Di Camerino S.A.

Silver Moss B 2014 S.à r.l.

Touax Investment S.C.A., SICAV-SIF