logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2324

31 août 2015

SOMMAIRE

Aberdeen Management Services S.A.  . . . . . . .

111518

Balfin Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111506

Balta Finance S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111511

BRE/Europe 7Q S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111524

Caribou Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111546

COF III Structured Finance Holdings (Lux)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111547

Daming Soparfi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111548

Datasud & PC Docter S.àr.l  . . . . . . . . . . . . . . .

111543

Direx  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111548

D-Tech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111547

Emerald First Layer "A" S.A.  . . . . . . . . . . . . .

111551

Eos Lakshmi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111511

Euro Ethnic Foods Global  . . . . . . . . . . . . . . . .

111546

Everget International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111551

Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l.  . . . . .

111552

Janus Global Technology Fund  . . . . . . . . . . . .

111520

Janus Global Technology Fund  . . . . . . . . . . . .

111520

Kandira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111549

KN Business and Management . . . . . . . . . . . . .

111544

Leasinvest Immo Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111521

Logistikê  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111515

LSF9 Balta Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

111515

LSF9 Balta Issuer S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111506

LSF9 Balta Issuer S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111516

Lux Insurance Consulting Services S.A.  . . . . .

111516

Lux Life Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111517

Luxsan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111551

Marino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111521

Nathys Conseil s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111520

Pentagon Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

111545

Porte des Ardennes Schmiede S.A.  . . . . . . . . .

111552

S.Invest I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111552

Warburg Value Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111552

111505

L

U X E M B O U R G

Balfin Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 179.197.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015143899/10.
(150157094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

LSF9 Balta Issuer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 198.084.

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of August.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholder of LSF9 Balta Issuer S.A., a public limited liability

company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office and address at Atrium Business Park-Vitrum, 33, Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy
of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S. Luxembourg) under the
number B 198.084 (the “Company”). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, dated 22 June 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a
deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, dated 10 August 2015, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations.

The Meeting appoints (i) Jacques Graas, lawyer, professionally residing in Luxembourg as chairman of the Meeting

(the “Chairman”), (ii) Tiphanie Grzeszezak, paralegal, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting
(the “Secretary”), and (iii) Maella Susini, paralegal, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting
(the “Scrutineer”). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the “Bureau”.

The shareholder(s) represented at the Meeting and the number of shares held by it/them are indicated on an attendance

list, which will remain attached to the present deed after having been signed by the shareholder(s) or holder(s) of power of
attorney and the members of the Bureau.

The power of attorney from the shareholder(s) represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur

by the holder(s) of powers of attorney, the members of the Bureau and the undersigned notary, will also remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. The entire share capital being duly represented at the Meeting (as appearing from the attendance list established and

certified by the members of the Bureau), and the shareholder(s) having waived the convening notices and stated that they
have been informed of the agenda of the Meeting, the Meeting is therefore validly constituted and may deliberate upon the
items on the agenda set forth below.

II. The agenda of the Meeting is as follows:
(1) Amendment of article 9 (Powers of the General Meeting) of the Articles;
(2) Amendment of article 13.2 (Procedure to convene a board meeting) and articles 13.5 (Proceedings) (a) (Quorum and

majority requirements) and (c) (Casting vote of chairman) of the Articles;

(3) Amendment of article 17.1 (Signatory powers of directors) of the Articles;
(4) Appointment of additional directors in the board of directors of the Company; and
(5) Granting of relevant powers and authorisations in relation to the appointment of the additional directors in the board

of directors of the Company.

III. the Meeting takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to amend article 9 (Powers of the General Meeting) of the Articles so that it shall from now on

read as follows:

“In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred on the General Meeting. In such

a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the General Meeting shall be a reference

111506

L

U X E M B O U R G

to decisions made or powers exercised by the Sole Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented
in the form of minutes or written resolutions, as the case may be.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

shareholders of the Company.

For the matters listed below, approval will be required from LSF9 Balta Midco S.à r.l. (registered with the Luxembourg

Trade and Companies Register under number B 197722) in addition to any approvals required by statutory law:

a. Share Issues - The allotment or issue of any shares or securities by an entity controlled by or under common control

with the Company (where “control” shall refer to the power to control directly or indirectly more than 50% of the votes
during a general shareholder's meeting) (a Group Company), or the grant of any right to require the allotment or issue of
any such shares or securities, other than to another Group Company.

b. Share Reorganisations - The increase, reduction, repayment, purchase or repurchase, sub-division, consolidation or

other variation of the share capital of a Group Company, or the reduction of the amount (if any) standing to the credit of
any  non-distributable  reserve  (including  the  share  premium  account  or  capital  redemption  reserve),  except  for  (a)  the
specific purposes set out in the Articles or (b) as permitted by the Companies Act.

c. Amendment to Articles - The amendment of any provision of the Articles.
d. Change in Nature of Business - The making of any change in the nature of the business of a Group Company, which

change would be material in the context of the Group as a whole.

e. Insolvency - The passing of any resolution to wind up a Group Company (whether solvent or otherwise), the taking

of any corporate action, legal proceedings or other procedure or step in relation to the dissolution of a Group Company,
the  appointment  of  a  liquidator,  receiver,  administrator,  administrative  receiver,  compulsory  manager  or  other  similar
officer in relation to a Group Company or any of its assets (in each case, whether out of court or otherwise)

f. Dividends - The declaration, making or payment of any dividend or other distribution to the holders of shares of a

Group Company which is not another Group Company.

g. Exit - The taking of any decision amounting whereby the Company ceases to be a Group Company, whether by sale,

listing or any other structure.”

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend article 13.2 (Procedure to convene a board meeting) of the Articles so that it shall from

now on read as follows:

“The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the meeting notice.
The majority of the meeting of the Board shall be held within the Grand Duchy of Luxembourg, except when exceptional

circumstances would prevent meetings to be held predominantly within the Grand Duchy of Luxembourg.

Written meeting notice of the Board shall be given to all the directors at least seven (7) Luxembourg business days in

advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency where one (1) Luxembourg business day
notice is required.

No such written meeting notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting

and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In addition, if
all the members of the Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to set the agenda
of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents

in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting
of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in
a schedule previously adopted by a resolution of the Board.” The Meeting further resolves to amend articles 13.5(a) (Quorum
and majority requirements) and 13.5(c) (Casting vote of chairman) of the Articles as follows:

“(a) Quorum and majority requirements
The Board may validly deliberate and make decisions only if at least three of its members is present or represented, the

majority of these members should be Luxembourg based directors, except in exceptional circumstances where such re-
quirement could not apply. Decisions are made by the majority of the votes expressed by the members present or represented.
If a member of the Board abstains from voting or does not participate to a vote, this abstention or non-participation are not
taken into account in calculating the majority.

(...)
(c) Casting vote of Chairman
In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall not have a casting vote.”

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 17.1 (Signatory powers of directors) of the Articles so that it shall from now on

read as follows:

111507

L

U X E M B O U R G

“ 17.1 Signatory powers of directors. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint

signature of any member of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director.”

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to appoint the following persons as additional members of the board of directors of the Company

with effect as of the date hereof until the date of the approval by the general shareholders' meeting of the annual accounts
relating to the financial year ending on 31 December 2015:

- Luca Destito, director, born on 16 February 1976 in Rome, Italy, having his professional address at Lone Star Europe

Acquisitions Ltd, 16 Queen Anne Street, London W1G 9LF, United Kingdom;

- Michael Kolbeck, director, born on 14 September 1969 in Munich, Germany, having his professional address at Lone

Star Germany Acquisitions GmbH, Hamburger Allee 14, 60486 Frankfurt am Main, Germany; and

- Hendrik Deruyck, director, born on 11 July 1951 in Izegem, Belgium, having his professional address at Atrium

Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to authorise and empower, with full power of substitution, any director of the Company and/or

any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l., to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company
to perform any formalities in connection with the appointment of the additional directors of the Company.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company

as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1.400,- (one thousand four hundred Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the members of the

Bureau, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the members of the Bureau,
it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the member of the Bureau, the members of the Bureau sign together the undersigned

notary, the present original deed, no shareholder requesting to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le onzième jour du mois d'août
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

une Assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de LSF9 Balta Issuer S.A., une société anonyme constituée et

existante sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social et son adresse au Atrium Business Park-
Vitrum, 33, Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès registre de
commerce et des sociétés ( RCSL) sous le numéro B 198084 (la «Société»). La Société a été constituée par un acte de
Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 22 juin 2015, non encore été publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et des Associations. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois
par un acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 10 août 2015,
non encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations.

L'Assemblée nomme (i) Jacques Graas, Avocat à la cour, profession, résidant professionnellement au Luxembourg en

tant  que  président  de  l'Assemblée  (le  «Président»),  (ii),  Tiphanie  Grzeszezak,  juriste,  résidant  professionnellement  au
Luxembourg en tant que secrétaire de L'Assemblée (le «Secrétaire»), et (iii) Maëlla Susini, juriste, résidant professionnel-
lement au Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le «Scrutateur»). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur
seront dès lors désignés: le «Bureau».

Le(s) actionnaire(s) représenté(s) à l'Assemblé et le nombre d'actions détenu par lui/eux sont indiqués sur une liste de

présence, qui restera jointe au présent acte après avoir été signée par le(s) actionnaire(s) ou par le(s) porteur(s) d'une
procuration ou par les membres du Bureau.

La procuration de le(s) actionnaire(s) représenté(s) à la présente Assemblée, après avoir été paraphée ne varietur par les

porteurs d'une procuration, par les membres du Bureau et par le notaire instrumentaire, restera également annexée au présent
acte pour être soumise avec celui-ci au même moment aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau constitué ayant été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. La totalité du capital social étant représentée à la présente Assemblée (tel qu'elle apparaît sur la liste de présence établie

et certifiée par les membre du Bureau), et les associés ayant renoncé aux formalités de convocation, se considérant dûment
informé de l'ordre du jour de l'Assemblé, l'Assemblée est alors validement constituée et peut délibérer sur les points de
l'ordre du jour établis ci-dessous.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée s'énonce comme suit:
(1) Modification de l'article 9 (Pouvoirs de l'Assemblée Générale) des Statuts;

111508

L

U X E M B O U R G

(2) Modification de l'article 13.2 (Procédure de convocation à une réunion du conseil d'administration) et de l'article

13.5 (Procédures) (a) (Conditions de quorum et de majorité) et (c) (Vote prépondérant du président) des Statuts;

(3) Modification de l'article 17.1 (Pouvoirs de représentation des administrateurs) des Statuts;
(4) Nomination d'administrateurs supplémentaires de la Société au conseil d'administration de la Société; et
(5) Attribution des pouvoirs et des autorisations nécessaires relatifs à la nomination des administrateurs supplémentaires

au conseil d'administration de la Société.

III. l'Assemblée prend les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier article 9 (Pouvoirs de l'Assemblée Générale) des Statuts qui dès lors s'énoncera comme

suit:

«Dans le cas d'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique possède tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

Dans ce cas, toute référence dans ces Statuts aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera
une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire
Unique sont enregistrées dans des procès-verbaux ou prises par des résolutions écrites, le cas échéant.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'ensemble

des actionnaires de la Société»

Les matières listées ci-dessous requièrent l'accord de LSF9 Balta Midco S.à r.l. (immatriculée auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197722) en plus de toute autorisation requise par le droit
commun:

a. Emissions Des Parts Sociales - L'attribution ou l'émission de toute part sociale ou valeur mobilière par une entité

contrôlé par ou sous le contrôle commun avec la Société ( où «contrôle» se réfère au pouvoir de contrôler directement ou
indirectement de plus de 50 % des droits de vote pendant l'assemblé générale des actionnaires) (une Société du Groupe)
ou l'octroi de tout droit de demander l'attribution ou l'émission d'une telle part sociale ou valeur mobilière, autre qu'à une
autre Société du Groupe.

b. Réorganisation Des Parts Sociales - L'augmentation, la réduction, le paiement, l'achat ou le rachat, la subdivision, la

consolidation ou autre modification du capital social d'une Société du Groupe, ou la réduction du montant (s'il y a) figurant
au crédit de toute réserve non distribuable (y compris le compte des primes d'émission ou la réserve de capital), à l'exception
de (a) les raisons spécifiques figurant dans les Statuts ou (b) comme permis par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.

c. Amendement Aux Statuts - La modification de toute provision des Statuts.
d. Changement Dans La Nature Des Affaires - La mise en place de tout changement dans la nature des activités d'une

Société du Groupe, lequel changement serait significatif pour l'ensemble du Groupe

e. Insolvabilité - L'adoption de toute résolution pour dissoudre une Société du Groupe (qu'elle soit solvable ou non), la

prise de toute mesure au niveau de l'entreprise, procédures légales ou autre procédure ou mesure relative à la dissolution
d'une Société du Groupe, la nomination d'un liquidateur, récepteur, administrateur, administrateur judiciaire, gestionnaire
obligatoire ou d'autres agents similaires relatifs à une Société du Groupe ou à chacun de ses actifs (dans chaque cas, que
ce soit de façon extra-judiciaire ou autrement)

f. Dividendes - La déclaration, la création ou le paiement de tout dividende ou de toute autre distribution aux détenteurs

des parts sociales d'une Société du Groupe qui n'est pas une autre Société du Groupe.

g. Exit - La prise de décision selon laquelle la Société cesserait d'être une Société du Groupe, que ce soit par vente,

listing ou par tout autre procédé.»

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 13.2 (Procédure de convocation à une réunion du conseil d'administration) des

Statuts en ce sens que désormais il sera lu comme suit:

«Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le Président ou par l'un des deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation de la réunion.

La majorité des réunions du conseil d'administration doit avoir lieu dans le Grand-Duché du Luxembourg, sauf en cas

de circonstances exceptionnelles qui empêcheraient les réunions d'être tenues principalement au sein du Grand-Duché du
Luxembourg.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration est donné à tous les administrateurs au moins sept (7) jours

ouvrables luxembourgeois avant une telle réunion, excepté dans les circonstances d'urgence où seulement un jour (1)
ouvrable luxembourgeois sera exigé.

La réunion peut être valablement tenue sans avis de convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors de la réunion du conseil d'administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion
et de son ordre du jour. En outre, si tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion
et décident à l'unanimité d'établir un ordre du jour, la réunion pourra être tenue sans convocation préalable effectuée de la
manière décrite ci-dessus.

111509

L

U X E M B O U R G

Tout membre du conseil d'administration peut décider de renoncer à la convocation écrite en donnant son accord par

écrit. Les copies de ces accords écrits qui sont transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve
des accords écrits à la réunion du conseil d'administration. Une convocation écrite spéciale n'est pas requise pour une
réunion du conseil d'administration se tenant aux lieux et dates prévus dans une résolution préalablement adoptée par le
conseil d'administration.»

L'Assemblée décide, de plus, de modifier les articles 13.5(a) (Conditions de quorum et de majorité) et 13.5(c) (Vote

prépondérant du président) des Statuts comme suit:

«(a) Conditions de quorum et de majorité
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si au moins trois (3) de ces

administrateurs sont présents ou représentés, la majorité des membres du conseil devraient être des administrateurs basés
au Luxembourg, sauf en cas de circonstances exceptionnelles quand de telles exigences ne pourraient pas s'appliquer. Les
décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents ou représentés. Si un membre du
conseil d'administration s'est abstenu de voter ou n'a pas pris part au vote, son abstention ou sa non-participation ne sera
pas prise en compte pour le calcul de la majorité.

(...)
(c) Voix prépondérante du Président
Au cas où il existe une parité des voix pour et contre une résolution, la voix du Président ou du président pro tempore

de la réunion, le cas échéant, n'est pas prépondérante.»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 17.1 (Pouvoirs de représentation des administrateurs) des Statuts, qui dès lors

s'énoncera comme suit:

« 17.1. Pouvoirs de représentation des administrateurs. La Société sera engagée envers les tiers pour toute question par

(i) la signature conjointe de tout membre du conseil d'administration, ou (ii) dans le cas d'un administrateur unique, la seule
signature de l'Administrateur Unique.»

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que membres supplémentaires au conseil d'Adminis-

tration de la Société avec effet en date des présentes jusqu'à la date d'approbation par l'assemblé générale des actionnaires
sur l'approbation des comptes annuels de l'année comptable; prenant fin le 31 Décembre 2015.

- Luca Destito, directeur, née le 16 février 1976 à Rome, Italie, résidant professionnellement à Lone Star Europe Ac-

quisitions Ltd, 16 Queen Anne Street, London W1G9LF, Royaume-Uni;

- Michael Kolbeck, directeur, née le 14 septembre 1969 à Munich, Allemagne, résidant professionnellement à Lone Star

Germany Acquisitions GmbH, Hamburger Allee 14, 60486 Francfort-sur-le-Main, Allemagne; et

- Hendrik Deruyck, directeur, né le 11 juillet 1951 à Izegem, Belgique, résidant professionnellement à Atrium Business

Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée prend la décision d'autoriser et d'habiliter, avec plein pouvoir de substitution, tout administrateur de la

Société et/ou tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l, à procéder, en vertu de son/sa seule signature, au nom
de la Société, à l'accomplissement de toute formalité relative à la nomination des administrateurs supplémentaires de la
Société.

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.400.- (mille quatre cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande des membres du Bureau le présent acte

est en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des membres du Bureau, et il est précisé que, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, en date des présentes, à Luxembourg au jour précisé au début de ce document.
Et après lecture faite au membre du Bureau, les membres du Bureau signent ensemble avec le notaire instrumentaire,

le présent acte, aucun associé n'étant obligé de signer.

Signé: J. Graas, T. Grzeszezak, M. Susini et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 12 août 2015. 2LAC/2015/18513. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

111510

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015142919/269.
(150156127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

Balta Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 101.261.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015143900/10.
(150157095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

Eos Lakshmi SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 192.824.

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of August,
before us, Maître Camille Mines, notary residing in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of EOS LAKSHMI S.A., a Luxembourg public

limited liability company (société anonyme), having its registered office at 61, rue d’Olm, L-8281 Kehlen, Grand Duchy
of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (the RCS) under number B
192.824 (the Company).

The share capital of the Company is fixed at one million four hundred and seventy thousand euro (EUR 1,470,000.-),

represented by one thousand four hundred and seventy (1,470) shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-)
each. The Sole Shareholder holds all of the shares of the Company.

The Meeting is chaired by Mr Guy Dauwe, residing professionally in Kehlen, Grand Duchy of Luxembourg (the Chair-

man).  The  Chairman  appoints  Mr  Luc  Delhaye,  residing  professionally  in  Kehlen,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  as
secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting appoints Ms Véronique Baraton, residing professionally in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, as

scrutineer of the Meeting (the Scrutineer; the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to as
the Bureau).

The Bureau thus being constituted, the Chairman requested the undersigned notary to enact the following:
The agenda of the Meeting was worded as follows:
1. Waiver of any convening notice requirements;
2. Presentation of the project for a merger by absorption between Amer-Sil S.A. (the Subsidiary), as absorbing entity,

and EOS LAKSHMI S.A. (the Company), as absorbed entity and decision to approve the merger;

3. Acknowledgement of effects of the merger;
4. Acknowledgement of the termination of the mandate of the members of the board of directors of the Company as a

result of the merger and the dissolution of the Company;

5. Acknowledgement that the books, records, files and other documents of the Company will be kept at the registered

office of the Sole Shareholder during the legal period of five years; and

6. Miscellaneous.
The Meeting then took the following resolutions:

<i>First Resolution

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting resolved to waive any convening

notice requirement.

<i>Second Resolution

The Meeting acknowledged that a project for a merger by absorption (the Merger Project) dated June 29, 2015, between

the Company, as absorbed entity, and AMER-SIL S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme),
having its registered office at 61, rue d’Olm, L-8281 Kehlen, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the RCS
under number B 8.871 (the Subsidiary), as absorbing entity (together, the Merging Companies), has been published on July
4, 2015, on pages 79458 et seq. of number 1656 of Part C of the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg

111511

L

U X E M B O U R G

(Mémorial - Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg - C - Recueil des Sociétés et Associations). The Merger
Project was approved by the respective boards of directors of the Merging Companies on June 29, 2015.

The Meeting noted that on July 14, 2015, extraordinary general meetings of the respective sole shareholders of the

Merging Companies were held in which these sole shareholders resolved to

(1) waive the requirement of a report drawn up by the boards of directors of the Merging Companies in accordance with

article 265 (3) of the Luxembourg law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Companies Law);

(2) waive the requirement of an examination of the merger project by an independent expert and of the corresponding

report in accordance with article 266 (5) of the Companies Law; and

(3) consent that no accounting statement in accordance with article 267 (1) c) of the Companies Law was required
(the waivers referred to in items (1) through and including (3) above are collectively referred to as the Waivers).
The Meeting resolved to acknowledge and approve, as far as the Company is concerned, (i) the Merger Project, drawn

up by the board of directors of the Company, as absorbed entity, and the board of directors of the Subsidiary, as absorbing
entity, (ii) the merger by the Company, as absorbed entity, and the Subsidiary, as absorbing entity, contemplated under the
Merger Project (the Merger), and (iii) to the extent necessary, the Waivers.

<i>Third Resolution

The Meeting acknowledged that:
(i) on the date hereof, the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Subsidiary (such sole shareholder

being the Company) has approved the Merger Project in the same terms as the Company, and that thereupon the Merger
took place between the Merging Companies with effect as of the date of the Meeting, pursuant to article 272 of the Com-
panies Law, with the consequence that all assets and liabilities of the Company, as absorbed entity, have been transferred
to the Subsidiary, as absorbing entity, and that the dissolution of the Company is a consequence of such a Merger;

(ii) from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out by the

Subsidiary as from January 1, 2015; and

(iii) the Merger will, pursuant to article 273 of the Companies Law, only be effective vis-à-vis third parties after the

publication prescribed by article 9 of the Companies Law.

The Meeting further acknowledged that the Subsidiary shall issue to the Sole Shareholder, further to the transfer of the

assets and liabilities of the Company as a result of the Merger and as contemplated in the Merger Project, fifty-eight thousand
and eight hundred (58,800) new ordinary shares of the Subsidiary with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each. The share capital of the Subsidiary will then amount to three million three hundred and twenty thousand euro (EUR
3,320,000.-).

The Meeting further acknowledged that the share capital of the Subsidiary will then be decreased by an amount of one

million eight hundred and fifty thousand euro (EUR 1,850,000.-) so as to bring it from its current amount of three million
three hundred and twenty thousand euro (EUR 3,320,000.-) to an amount of one million four hundred and seventy thousand
euro (EUR 1,470,000.-) by way of redemption and cancellation of seventy-four thousand (74,000) shares of the Subsidiary,
having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The  Meeting  further  acknowledged  that  the  existing  fifty-eight  thousand  and  eight  hundred  (58,800)  shares  of  the

Subsidiary, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, will be converted into one thousand four hundred
and seventy (1,470) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

Finally, the Meeting acknowledged that the Sole Shareholder will hold all of the one thousand four hundred and seventy

(1,470) shares of the Subsidiary with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

<i>Fourth Resolution

The Meeting acknowledged that, as a result of the Merger and the dissolution of the Company, the mandate of the

members of the board of directors of the Company will be terminated effective as of the date hereof.

<i>Fifth Resolution

The Meeting resolved to amend the register of registered shares of the Company in order to reflect the changes pursuant

to the above resolutions, with power and authority given to any director and/or employee of the Company, each acting
individually, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company with the registration of the same in said
register of the Company.

The Meeting further acknowledged that the books, records, files and other documents of the Company will be kept at

the registered office of the Sole Shareholder during the legal period of five years.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately € 1.500,-

111512

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary states, in accordance with article 271 (2) of the Companies Law, having verified and certifies

the existence and legality of all acts and formalities incumbent upon the Company and the Merger Project.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith furthermore that on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of divergences between
the English and the French versions, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Capellen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le septième jour du mois d’août,
par devant nous, Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de EOS LAKSHMI S.A., une société ano-

nyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 61, rue d’Olm, L-8281 Kehlen, Grand-Duché de Luxembourg, et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 192.824 (la Société).

L’Assemblée est présidée par M. Guy Dauwe, dont la résidence professionnelle se situe à Kehlen, Grand-Duché de

Luxembourg (le Président). Le Président nomme M. Luc Delhaye, dont la résidence professionnelle se situe à Kehlen,
Grand-Duché de Luxembourg, secrétaire de l’Assemblée (le Secrétaire).

L’Assemblée élit Mme. Véronique Baraton, dont la résidence professionnelle se situe à Capellen, Grand-Duché de

Luxembourg, scrutateur de l’Assemblée (le Scrutateur; le Président, le Secrétaire et le Scrutateur désignés collectivement
comme le Bureau).

Le Bureau étant valablement constitué, le Président a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Qu'il résulte d'une liste de présence établie et signée par les membres du Bureau mille quatre cent soixante-dix (1.470)

actions, ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la
Société s'élevant à un million quatre cent soixante-dix mille euros (EUR 1.470.000,-), sont dûment représentées à l'As-
semblée qui est dès lors valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour, tels que mentionnés
ci-après, et ce, sans convocation préalable, l’associée unique représentée à l'Assemblée ayant accepté de tenir l'Assemblée
après examen de l'ordre du jour.

La liste de présence qui a été signée par le représentant de l’associée unique représentée à l'Assemblée, les membres du

Bureau et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour y être soumise aux formalités d'enregistrement.

L'ordre du jour de l'Assemblée a été libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Présentation du projet de fusion par absorption entre Amer-Sil S.A. (la Filiale), en tant qu'entité absorbante, et EOS

LAKSHMI S.A. (la Société), en tant qu'entité absorbée et décision d’approbation de la fusion;

3. Constatation des effets de la fusion;
4. Constatation de la fin des mandats des membres du conseil d’administration de la Société comme conséquence de la

fusion et de la dissolution de la Société;

5. Constatation du fait que les livres comptables, registres, dossiers et autres documents de la Société seront tenus au

siège social de l’Associée Unique durant une période légale de cinq ans; et

6. Divers.
L’Assemblée a ensuite pris les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée à l’Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation.

<i>Deuxième Résolution

L’Assemblée prend acte qu'un projet de fusion par absorption (le Projet de Fusion) en date du 29 juin 2015, entre la

Société, en tant qu'entité absorbée, et AMER-SIL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 61, rue d’Olm, L-8281 Kehlen, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du RCS sous le numéro B
8.871 (la Filiale) en tant qu'entité absorbante (ensemble, les Sociétés Fusionnantes), a été publié le 4 juillet 2015, pages
79458 et suivantes au numéro 1656 du Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations. Le Projet de Fusion a été approuvé
par les conseils d’administration respectifs des Sociétés Fusionnantes le 29 juin 2015.

L’Assemblée note que le 14 juillet 2015 les assemblées générales extraordinaires des associés uniques respectifs des

Sociétés Fusionnantes ont été tenues et par lesquelles ces associés ont pris les résolutions suivantes:

111513

L

U X E M B O U R G

(1) renoncer à l'exigence d'un rapport établi par les conseils d'administration des Sociétés Fusionnantes conformément

à l'article 265 (3) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi);

(2) renoncer à l’exigence d'un examen du Projet de Fusion par un expert indépendant et d’un rapport correspondant

conformément à l'article 266 (5) de la Loi; et

(3) consentir à ce qu'aucune déclaration comptable conformément à l'article 267 (1) c) de la Loi n’ait été requise;
(les renonciations visées ci-dessus des points (1) à (3) inclus sont collectivement désignées les Renonciations).
L’Assemblée décide de reconnaître et approuver, en ce qui concerne la Société, (i) le Projet de Fusion, rédigé par le

conseil d’administration de la Société, en tant qu’entité absorbée, et le conseil d’administration de la Filiale, en tant qu'entité
absorbante, (ii) la fusion par la Société, en tant qu'entité absorbée par la Filiale, en tant qu’entité absorbante, tel que prévu
par le Projet de Fusion (la Fusion), et (iii) dans la mesure nécessaire, les Renonciations.

<i>Troisième Résolution

L’Assemblée prend acte que:
(i) en date des présentes, l’assemblée générale extraordinaire de l’associée unique de la Filiale (telle associée étant la

Société) a approuvé le Projet de Fusion dans les mêmes conditions que la Société, et dès lors la Fusion a eu lieu entre les
Sociétés Fusionnantes avec effet à la date de l’Assemblée, conformément à l'article 272 de la Loi, ayant pour conséquence
le transfert de tous les actifs et passifs de la Société, en tant qu'entité absorbée, à la Filiale, en tant qu'entité absorbante, et
que la dissolution de la Société est la conséquence d'une telle Fusion;

(ii) d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme ayant été effectuées par la Filiale

à compter du 1 

er

 janvier 2015; et

(iii) la Fusion, conformément à l'article 273 de la Loi, ne sera effective vis-à-vis des tiers qu'après la publication prescrite

par l'article 9 de la Loi.

L’Assemblée a également constaté que la Filiale doit émettre à l’Associée Unique, subséquemment au transfert de tous

les actifs et passifs de la Société comme conséquence de la Fusion et tel que prévu par la Projet de Fusion, cinquante-huit
mille huit cents (58.800) actions nouvelles de la Filiale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Le capital social de la Filiale s’élèvera alors à un montant de trois millions trois cent vingt mille euros (EUR 3.320.000,-).

L’Assemblée a également constaté que le capital social de la Filiale sera ensuite réduit d’un montant d’un million huit

cent cinquante mille euros (EUR 1.850.000,-) de sorte à le porter de son montant actuel de trois millions trois cent vingt
mille euros (EUR 3.320.000,-) à un montant d’un million quatre cent soixante-dix mille euros (EUR 1.470.000,-) par le
biais de l’annulation et la suppression de soixante-quatorze mille (74.000) actions de la Société, ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L’Assemblée a également constaté que les cinquante-huit mille huit cents (58.800) actions restantes de la Filiale, ayant

une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, seront converties en mille quatre cent soixante-dix (1.470)
actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Enfin, l’Assemblée a également constaté que l’Associée Unique détiendra l’ensemble des mille quatre cent soixante-

dix (1.470) actions de la Filiale ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

<i>Quatrième Résolution

L'Assemblée a constaté que, suite à la Fusion et à la dissolution de la Société, les mandats des membres du conseil

d'administration de la Société viennent à expiration à compter de la date en tête des présentes.

<i>Cinquième Résolution

L’Assemblée a décidé de modifier le registre des actions enregistrées de la Société afin de refléter les modifications

conformément aux résolutions ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout directeur et/ou employé de la Société,
chacun agissant individuellement, avec un pouvoir entier de substitution, afin de procéder au nom de la Société à l’enre-
gistrement de ce qui vient d’être décidé dans ledit registre de la Société.

L’Assemblée a également constaté que les livres comptables, registres, dossiers et autres documents de la Société seront

tenus au siège social de l’Associé Unique durant une période légale de cinq ans.

<i>Estimation des frais

Le montant total des coûts, dépenses, rémunérations ou frais, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ € 1.500,-

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, conformément à l’article 271 (2) de la Loi Commerciale, a vérifié et certifie l’existence et la

légalité de tous les actes et de toutes les formalités incombant à la Société et au Projet de Fusion.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

111514

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, rédigé et passé à Capellen, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec le notaire instrumentant le

présent acte original.

Signé: G. DAUWE, L. DELHAYE, V. BARATON, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 août 2015. Relation: 1LAC/2015/25691. Reçu soixante-quinze euros

75,-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015144038/213.
(150157592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

LSF9 Balta Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 197.728.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015144230/10.
(150157092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

Logistikê, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5886 Hesperange, 484, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 118.289.

L'an deux mil quinze, le dix août,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Robert SOJIC, employé privé, né à Ougrée, Belgique, le 21 décembre 1960, demeurant à L-7566 Mersch, 7,

rue du Comte Thierry,

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de son épouse
Madame Marianne Juliette Madeleine GOFFINET, employée privée, née à Arlon Belgique, le 07 avril 1964, demeurant

à L-7566 Mersch, 7, rue du Comte Thierry, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée ne
varietur par le notaire et le comparant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Après avoir établi qu'ensemble avec sa mandante, le comparant possède toutes les 126 parts de la société à responsabilité

limitée LOGISTIKÊ, dont le siège social se trouve à L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich, inscrite au Registre de
Commerce à Luxembourg sous le numéro B 118.289,

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du

07 août 2006, publié au Mémorial C numéro 1882 du 06 octobre 2006,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire reçue par

Maître Cosita DELVAUX, alors notaire de résidence à Redange/Attert, en date du 07 février 2014, publiée au Mémorial
C numéro 982 du 17 avril 2014,

le comparant s’est constitué en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d’acter comme suit la résolution

suivante:

Siège social:
Le siège de la société est transféré à L-5886 Hesperange, 484, route de Thionville.
La première phrase de l’article 2 des statuts est modifiée en conséquence comme suit:
«Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a signé

ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s’être identifié au moyen de sa carte d’identité.

Signé: R. SOJIC, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 août 2015. Relation: 1LAC/2015/25694. Reçu soixante-quinze euros

75,-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

111515

L

U X E M B O U R G

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015144211/39.
(150157227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

LSF9 Balta Issuer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 198.084.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2015.

Référence de publication: 2015144231/10.
(150157093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

L.I.C.S. S.A., Lux Insurance Consulting Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5886 Hesperange, 484, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 151.484.

L'an deux mil quinze, le dix août,

s’est tenue

par devant le soussigné Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme LUX INSURANCE CONSULTING SERVICES S.A. en

abrégé L.I.C.S. S.A., ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich,

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Karine REUTER, alors notaire de résidence à Redange/Attert en date

du 10 février 2010, publié au Mémorial C numéro 667 du 30 mars 2010,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 151484,
et dont les statuts n’ont pas encore été modifiés.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert SOJIC, administrateur de société, demeurant à L-7566

Mersch, 7, rue du Comte Thierry,

qui désigne comme secrétaire Madame Manon HOFFMANN, salariée, demeurant à Differdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique GILSON-BARATON, salariée, demeurant à Garnich.
Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été paraphée «ne varietur» sera enregistrée avec le présent acte.

Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu'il a donc pu

être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement dé-
libérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
Siège social:
Le siège de la société est transféré à L-5886 Hesperange, 484, route de Thionville.
La première phrase de l’article 2 des statuts est modifiée en conséquence comme suit:
«Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants

ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s’être identifiés au moyen de leur carte d’identité.

Signé: R. SOJIC, V. BARATON, M. HOFFMANN, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 août 2015. Relation: 1LAC/2015/25692. Reçu soixante-quinze euros

75,-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015144235/39.
(150157005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

111516

L

U X E M B O U R G

Lux Life Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 93.826.

DISSOLUTION

L'an deux mil quinze, le dix août,

s'est tenue

par devant le soussigné Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme LUX LIFE CONSULTING S.A., ayant son siège social à

L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich,

Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Martine DECKER, alors notaire de résidence à Wiltz en date du 27

septembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1584 du 05 novembre 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 93.826,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire reçue par

Maître  Karine  REUTER,  notaire  alors  de  résidence  à  Redange/Attert,  en  remplacement  du  soussigné  notaire  Camille
MINES empêché, en date du 10 février 2010, publiée au Mémorial C numéro 729 du 08 avril 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert SOJIC, administrateur de société, demeurant à L-7566

Mersch, 7, rue du Comte Thierry,

qui désigne comme secrétaire Madame Manon HOFFMANN, salariée, demeurant à Differdange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique GILSON-BARATON, salariée, demeurant à Garnich.
Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été paraphée «ne varietur» sera enregistrée avec le présent acte.

Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu

être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement déli-
bérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:
1. Les actions représentant le capital de la société sont détenues par:
- Monsieur Philippe GERAERTS pour 775 actions
- Monsieur Bernard COLLO pour 775 actions
- LOGISTIKE s.à r.l., (RCSL B 118289) pour 750 actions
- NATHYS CONSEIL s.à r.l. (RCSL B 147817) pour 750 actions
- Monsieur Kamel TRIKI pour 50 actions.
2. les actionnaires ont décidé de dissoudre et liquider la Société avec effet immédiat et, pour autant que de besoin,

Messieurs Robert SOJIC, né à Ougrée, Belgique, le 21 décembre 1960, demeurant à L-7566 Mersch, 7, rue Comte Thierry,
Michel AIDOUD, né à Montpellier, France, le 08 avril 1971, demeurant à F-57970 Koenigsmacker, 7, Impasse des Roses,
Philippe GERAERTS, né le 29 mars 1962 à Liège, Belgique, demeurant à B-4050 Chaudfontaine, 15, rue du Vieux Pré,
Bernard COLLO, né le 15 mai 1958 à Liège, Belgique, demeurant à B-4690 Bassenge, 57, rue Oborne et Kamel TRIKI,
né le 17 novembre 1973 à Thionville, France, demeurant à F-57970 Elzange, 2, rue de Provence, vont prendre la qualité
de liquidateurs;

3. les actionnaires déclarent reprendre par la présente tous les actifs de la Société et prendre en charge tout le passif de

la Société et en particulier le passif occulte et inconnu à ce moment;

5. la Société est partant dissoute et liquidée et la liquidation est clôturée;
6. les actionnaires donnent pleine et entière décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exercice

de leur mandat;

7. les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans à L-5886 Hesperange, 484,

route de Thionville.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 15.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. SOJIC, M. HOFFMANN, V. BARATON, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 août 2015. Relation: 1LAC/2015/25695. Reçu soixante-quinze euros 75-

€.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR COPIE CONFORME,

111517

L

U X E M B O U R G

Capellen, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015144237/59.
(150157234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

Aberdeen Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2b, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 119.541.

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth of August.
Before us Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Maître  Nirida  Nhouyvanisvong,  lawyer,  residing  professionally  in  Luxembourg,  acting  in  his  capacity  as  a  special

attorney-in-fact of:

- the board of directors of Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A., a société anonyme governed by the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 106.133 and
incorporated following a deed dated 16 February 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 566 of 11 June 2005 and amended for the last time by a deed dated 16 September 2005 published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 130 of 19 January 2006 (“Aberdeen Property Investors Luxembourg”);
and

- the board of directors of Aberdeen Management Services S.A., (formerly Aberdeen Global Property Multi Manager

S.A.), a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2B, rue
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 119.541, incorporated pursuant to a deed dated 20 September 2006, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1853 of 3 October 2006, which articles of association have been
amended for the last time following a deed dated 21 July 2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2844 of 9 October 2014 (“Aberdeen Management Services”),

by virtue of two proxies under private seal given on 26 June 2015.
The said appearing person, acting in such capacity, has requested the undersigned notary to record the following de-

clarations and statements:

- that in accordance with the joint merger proposal in notarial form recorded in a deed of the undersigned notary on 29

June 2015, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1720 of 13 July 2015 (the “Joint
Merger Proposal”), Aberdeen Management Services, as the absorbing company (the “Absorbing Company”), and Aberdeen
Property Investors Luxembourg, as the absorbed company (the “Absorbed Company”), contemplated to merge;

- that no shareholder of the Absorbing Company required, during the period of one (1) month following the publication

of the Joint Merger Proposal in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, an extraordinary general meeting of
the Absorbing Company, to be convened in order to resolve on the approval of the merger;

- that the merger became effective and entailed ipso jure the universal transfer, between the merging companies, of all

assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company on 14 August 2015 at 00:01 a.m.;

- that following the merger, the Absorbed Company ceased to exist;
- that following the absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed

Company have been cancelled and the books and documents of the Absorbed Company are kept during the legal period
(five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company: 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;

- that on the day of publication of this deed in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the merger will

take effect towards third parties.

The undersigned notary confirms that he has verified and hereby certifies, in compliance with articles 271(2), 273(1)

and 279 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the existence and the validity of the legal
acts and formalities to be accomplished by the Absorbing Company and by the Absorbed Company for the merger to
become effective.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version and that at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary this original deed.

111518

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt août.
Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Maître Nirida Nhouyvanisvong, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de manda-

taire spécial:

- du conseil d'administration de Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A, une société anonyme de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106133, constituée suivant un
acte en date du 16 février 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 566 du 11 juin 2005
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte en date du 16 septembre 2005, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 130 du 19 janvier 2006 («Aberdeen Property Investors Luxembourg»); et

- du conseil d'administration de Aberdeen Management Services S.A., (anciennement Aberdeen Global Property Multi

Manager S.A.), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2B, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 119541, constituée suivant un acte en date du 20 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1853 du 3 octobre 2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte
en date du 21 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2844 du 9 octobre 2014
(«Aberdeen Management Services»),

en vertu de deux procurations sous seing privé données en date du 26 juin 2015.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et constatations

suivantes:

- qu'aux termes d'un projet commun de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du

29 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1720 du 13 juillet 2015 (le «Projet
Commun de Fusion»), Aberdeen Management Services, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et Aber-
deen Property Investors Luxembourg, en tant que société absorbée (la «Société Absorbée»), ont projeté de fusionner,

- qu'aucun associé de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du Projet

Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale ex-
traordinaire de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la fusion;

- que la fusion est devenue définitive et a entrainé de plein droit la transmission universelle, entre les sociétés fusion-

nantes, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante le 14 août 2015 à 00h01;

- que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée a cessé d'exister;
- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée

sont annulées et les livres et documents de ces dernières sont conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la
Société Absorbante: 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- qu'au jour de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la fusion deviendra

définitive à l'égard des tiers.

Le notaire soussigné confirme qu'il a vérifié et atteste, conformément aux articles 271(2), 273(1) et 279 de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société
Absorbante et à la Société Absorbée en vue de la réalisation de la fusion.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la comparante et en cas de
divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire soussigné par son

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Nhouyvanisvong, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 août 2015. GAC/2015/7277. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 26 août 2015.

Référence de publication: 2015144558/106.
(150158419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.

111519

L

U X E M B O U R G

Janus Global Technology Fund, Fonds Commun de Placement.

L'acte modificatif au règlement de gestion de Janus Global Technology Fund au 31 août 2015 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Global Funds Management S.A.

Référence de publication: 2015144834/2.
(150158139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.

Janus Global Technology Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Janus Global Technology Fund au 31 août 2015 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Global Funds Management S.A.

Référence de publication: 2015144835/9.
(150158140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.

Nathys Conseil s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5886 Hesperange, 484, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 147.817.

L'an deux mil quinze, le dix août,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Robert SOJIC, employé privé, né à Ougrée, Belgique, le 21 décembre 1960, demeurant à L-7566 Mersch, 7,

rue du Comte Thierry,

Agissant tant en sa qualité de mandataire des associés:
1) Monsieur Michel AIDOUD, responsable financier et consultant, né à Montpellier (France), le 8 avril 1971, demeurant

à F-57970 Koenigsmacker, 7, Impasse des Roses et

2) Madame Christelle ROMANETTO, épouse AIDOUD, employée de banque, née à Thionville (France), le 23 no-

vembre 1970, demeurant à F-57970 Koenigsmacker, 7, Impasse des Roses,

en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et le comparant,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Après avoir établi que ses mandants possède toutes les 500 parts de la société à responsabilité limitée NATHYS CON-

SEIL s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich, inscrite au Registre de Commerce
à Luxembourg sous le numéro B 147817,

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12 août

2009, publié au Mémorial C numéro 1818 du 19 septembre 2009,

et dont les statuts n’ont pas encore été modifiés
le comparant s’est constitué au nom de ses mandants en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d’acter

comme suit la résolution suivante:

Siège social:
Le siège de la société est transféré à L-5886 Hesperange, 484, route de Thionville.
La première phrase de l’article 2 des statuts est modifiée en conséquence comme suit:
«Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange, il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a signé

ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s’être identifié au moyen de sa carte d’identité.

Signé: R. SOJIC, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 août 2015. Relation: 1LAC/2015/25693. Reçu soixante-quinze euros

75,-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR COPIE CONFORME,

111520

L

U X E M B O U R G

Capellen, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015144287/41.
(150157033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

Leasinvest Immo Lux, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 35.768.

Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Monsieur Vincent MACHARIS a démissionné de son

mandat d'administrateur de la Société avec effet au 26 août 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2015.

LEASINVEST IMMO LUX
Signature

Référence de publication: 2015145483/13.
(150159080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2015.

Marino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 56.112.

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am vierundzwanzigsten August,
Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "MARINO S.A." mit Sitz in L-1653 Luxemburg, 2 - 8, Avenue Charles de

Gaulle, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 56112,

gegründet durch Urkunde, aufgenommen durch den Notar Georges d'Huart mit dem Amtssitz in Pétange, am 20. August

1996,veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 588 vom 13. November 1996. Die
Satzungen wurden letztmalig abgeändert gemäß Urkunde des Notars Paul Bettingen vom 19. Dezember 2006, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 373 vom 14. März 2007,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten
Die Gesellschaft hat ein Kapital von einunddreißig tausend Euros (31.000,- EUR), eingeteilt in eintausend zweihundert

fünfzig (1.250) Anteile ohne Nennwert.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Gianpiero SADDI, Notarschreiber, mit professioneller Anschrift

in 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Marilyn KRECKE, Privatangestelltin, mit professioneller Anschrift in L-1750

Luxemburg, 74, Avenue Victor Hugo.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Gianpiero SADDI, vorbenannt.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde,

hervorgeht, dass die 1.250 Aktien ohne Nennwert, welche das gesamte Kapital von EUR 31.000 darstellen, hier in dieser
Versammlung gültig vertreten sind.

Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengestellt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung

abstimmen, da auch alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren,
ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet, bleibt zu-

sammen mit der Vollmacht des Alleinaktionärs, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage
beigefügt.

II. Die Aktionäre der Gesellschaft und der ANFINANZ HOLDING SPF S.A. haben, in Übereinstimmung mit Artikel

266 (5) des Gesetzes, auf die Untersuchung des Verschmelzungsplans durch einen unabhängigen Prüfer sowie auf die
Erstellung eines Berichts durch einen solchen unabhängigen Prüfer verzichtet.

III. Der Verschmelzungsplan wurde durch den Vorstand der Gesellschaft und den Verwaltungsrat der ANFINANZ

HOLDING SPF S.A. am 13. Juli 2015 unterzeichnet und am 21. Juli 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations Nummer 1799/2015 veröffentlicht, gemäß Artikel 262 des Gesetzes.

IV. Die Aktionäre der Gesellschaft und der ANFINANZ HOLDING SPF S.A. haben, in Übereinstimmung mit Artikel

265 (3) des Gesetzes, auf der Verschmelzungsberichte art.265 (1) und art.265 (2) verzichtet.

111521

L

U X E M B O U R G

V. Den Aktionären der Gesellschaft standen seit dem 13. Juli 2015 gemäß Artikel 267 (1) (a), (b) und (d) des Gesetzes

vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das „Gesetz") die folgenden Do-
kumente am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung:

-  gemeinsamer  Verschmelzungsplan  zwischen  der  Gesellschaft  und  ANFINANZ  HOLDING  SPF  S.A.  mit  Gesell-

schaftssitz in L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter
der Nummer B 38 739,, zur Verschmelzung der ANFINANZ HOLDING SPF S.A. mit und auf die Gesellschaft (der
„Verschmelzungsplan");

- Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte der Gesellschaft und der ANFINANZ HOLDING SPF S.A. der letzten drei

Jahre;

- Verschmelzungsbericht des Vorstandes der Gesellschaft vom 10. Juli 2015 und des Verwaltungsrats der ANFINANZ

HOLDING SPF S.A. ebenfalls vom 10. Juli 2015.

VI. dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1 - Änderung der statutarischen Sprache der Gesellschaft von Französisch in Deutsch;
2 - Bestätigung der beigebogenen deutschen Version der koordinierten Satzung;
3 - Kapitalerhöhung der Gesellschaft um den Betrag von EUR 1 116 000,00 durch die Ausgabe von 45 000 neuer Aktien;
Die genannte Kapitalerhöhung erfolgt durch Einbringung der Gesellschaft Luxemburger Rechts ANFINANZ HOLD-

ING SPF S.A. mit Gesellschaftssitz in L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, eingetragen im luxemburgischen
Handelsregister unter der Nummer B 38 739 entsprechend dem Bericht des Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Compagnie
Européenne de Révision S à r. l. mit Sitz in L-1130 Luxembourg, 37, Rue d‘Anvers.

4 - Abänderung von Artikel 3 der Gesellschaftssatzung, und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million einhundert siebenundvierzig tausend Eur (EUR 1 147 000,00),

eingeteilt in 46 250 Aktien ohne Nennwert.

VII. Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach

Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die statutarische Sprache der Gesellschaft zu ändern von Französich in Deutsch.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung bestätigt den Wortlaut der koordinierten Satzung entsprechend der beigebogenen Übersetzung.
Diese Übersetzung, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet,

bleibt zusammen mit der Vollmacht des Alleinaktionärs, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird,
als Anlage beigefügt

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, der Übertragung aller aktiven und passiven Vermögenswerte der ANFINANZ

HOLDING  SPF  S.A.  in  ihrer  Gesamtheit  an  die  MARINO  S.A.,  mit  buchhalterischer  Wirkung  zum  01.  Januar  2015
zuzustimmen; somit ist der Verschmelzungsplan vom 13. Juli 2015, veröffentlicht am 21. Juli 2015 im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations Nummer 1799/2015 angenommen.

Die Versammlung beschliesst, mit Wirkung wie obengenannt, die Einbringung der Gesellschaft ANFINANZ HOLD-

ING SPF S.A. in die Gesellschaft Luxemburg Rechts MARINO S.A..

Daraufhin beschließt die Generalversammlung, dass als Gegenleistung für die Übertragung aller aktiven und passiven

Vermögenswerte der ANFINANZ HOLDING SPF S.A. an die MARINO S.A.,

45 000 (fünfundvierzigtausend) neue, nennwertlose, voll eingezahlte Aktien an den Alleinaktionär der ANFINANZ

HOLDING SPF S.A. ausgegeben werden sollen,

und beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung in einem Gesamtbetrag von

EUR 1.116.000,00 (eine Million einhundertschzehntausend Euro),

um  es  von  seinem  jetzigen  Betrag  von  EUR  31.000  (einundreissigtausend  Euro)  auf  EUR  1.147.000  (eine  Million

einhundert siebenundvierzigtausend Euro), zu erhöhen.

Die neuen Aktien der Gesellschaft sollen mit buchhalterischer Wirkung ab dem 01. Januar 2015 das Recht zur Beteili-

gung an den seit dem 1. Januar 2015 erzielten Ergebnissen/Gewinnen der Gesellschaft verleihen. Die neuen Aktien werden
die Form von Namensaktien haben und ihre Eintragung in das Aktionärsregister der Gesellschaft wird am heutigen Tag
erfolgen.

Die Generalversammlung erkennt an, dass die neuen Aktien wie folgt gezeichnet werden:
RUNGE HOLDING Gmbh, mit Sitz in D-49328 MELLE, Westhoyeler Strasse 25, eingetragen beim Amtsgericht Os-

nabrück unter der Nummer HRB 18216,

einzige Aktionärin der ANFINANZ HOLDING SPF S.A.,

111522

L

U X E M B O U R G

hier vertreten durch Herrn Gianpiero SADDI, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, erklärt alle 45.000 neue

Aktien zu zeichnen.

Vorbezeichnete Vollmacht bleibt, nachdem diese «ne varietur" durch die Erschienenen und den unterzeichnenden Notar

unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

Die Generalversammlung beschließt, der Zeichnung der neuen Aktien durch RUNGE HOLDING GmbH zuzustimmen

und 45.000 (fünfundvierzigtausend) voll eingezahlte neue Aktien an RUNGE HOLDING GmbH auszugeben.

Gemäss Artikel 32-1 und 26-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wurde ein Bericht

über die Sacheinlage erstellt durch Compagnie Européenne de Révision Sàrl mit Sitz in L-8124 Bridel, 15 rue des Carre-
fours.

Die Schlussfolgerung dieses Berichtes, welcher auf Französich verfasst ist, lautet wie folgt:
„In Zuge unserer Arbeit haben wir von keinerlei Fakten Kenntnis erlangt die uns glauben ließen, dass der Wert der

Einbringung nicht mit dem der Anzahl der ausgegeben Aktien und deren Nennwert in Einklang steht.“

Der Bericht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Die  Generalversammlung  stellt  weiterhin  fest,  dass  nach  übereinstimmender  Beschlussfassung  zur  Umsetzung  der

Verschmelzung durch die Aktionäre der ANFINANZ HOLDING SPF S.A.im Rahmen einer am heutigen Tag abgehaltenen
außerordentlichen Generalversammlung, die Verschmelzung mit buchhalterischer Wirkung zum 01. Januar 2015 wirksam
erfolgen wird.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammling beschliesst, Artikel 3 der Gesellschaftssatzung abgeändert, und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million einhundert siebenundvierzig tausend Eur (EUR 1 147 000,00),

eingeteilt in 46.250 Aktien ohne Nennwert.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammling, angesichts vorernwähnte Beschlüsse, beschliesst der koordinierten Satzung folgenden Wortlaut zu

geben

KOORDINIERTE SATZUNG

Form, Bezeichnung, Sitz und Dauer

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „MARINO S.A.“.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann verlegt werden in jeden Ort des Grossherzogtums Luxemburg durch

einfache Entscheidung des Verwaltungsrats.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Gesellschaftszweck

Art. 2. Gesellschaftszweck ist die Beteiligung, unter irgendwelcher Form, an luxem-burgischen oder ausländischen

Unternehmen, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren und Rechten, auf dem Wege der Beteiligung, der Einbringung,
der Zeichnung sowie auf jede Art, insbesondere der Erwerb von Patenten und Lizenzen, ihre Verwaltung und Verwertung.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, auf dem Weger der Ausgabe von Schuldvers-

chreibungen, die wandelbat und / oder nachrangig sein können.

Die  Gesellschaft  kann  alle  geschäftlichen,  industriellen  und  finanziellen  Tätigkeiten  ausüben,  die  im  direkten  oder

indirekten Zusammenhang stehen mit dem Gesellschaftszweck oder diesem förderlich sind.

Gesellschaftskapital

Art. 3. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million einhundert siebenundvierzig tausend Eur (EUR 1 147

000,00), eingeteilt in 46.250 Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

Alle Aktien lauten auf Inhaber.
Die Gesellschaft kann eigene Aktien zurückkaufen mit Genehmigung der Generalversammlung und entsprechend den

gesetzlichen Vorschriften.

Verwaltung

Art. 4. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, deren

Amtsdauer sechs Jahre nicht überschreiten darf; sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine rückwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt zur Ausübung aller Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz

oder durch die Satzung der Generalver-sammlung vorbehalten sind.

Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind nur dann gültig, wenn die Mehrheit der amtierenden Verwal-

tungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern, in schriftlicher
oder fernschriftlicher Form, statthaft ist.

111523

L

U X E M B O U R G

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder.

Art. 6. Die Genralversammlung und / oder der Verwaltungsrat können Verwaltungs-befugnisse abtreten an ein Ver-

waltungsratsmitglied, einen Geschäftsführer oder eine andere Person.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten jederzeit durch die Unterschrift eines Verwaltungsratmitglieds gebunden.

Aufsicht

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Amtsdauer nicht länger als sechs

Jahre sein kann; sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine rückwählbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann Vorschüsse auf Dividenden nur gewähren mit dem Einverständnis des / der Kommis-

sare.

Geschäftsjahr

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Hauptversammlung

Art. 10. Die vorschriftsmäßig zusammengetretene Generalversammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Ge-

sellschaft.

Sie hat weitgehendste Vollmachten, um über alle Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Sie bestimmt die Verwendung oder die Ausschüttung des Nettogewinns. Jeder Aktionär hat das Recht, an den Beratungen

der Hauptversammlung teilzunehmen, selbst oder durch einen Vertreter.

Art. 11.  Die  ordentliche  Generalversammlung  tritt  jährlich  zusammen  Gesellschaftssitz  oder  an  einem  anderen,  im

Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg am ersten Montag des Monats Mai um 10:00 Uhr

Schlussbestimmung

Art. 12. Die Gesetze vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften sowie

deren Abänderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo die gegenwärtigen Satzungen keine Abweichungen bein-
halten.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt die Existenz und die Rechtmäßigkeit der Urkunden und der Formalitäten, die durch die

Gesellschaft und ANFINANZ HOLDING SPF S.A. im Hinblick auf die Verschmelzung unterzeichnet worden sind, fest.

Worüber Urkunde Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen und Übersetzung in die Sprache der Vertreter der Erschienenen, alle dem

Notar nach Vor- und Nachnamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.

Signé: G. Saddi, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 25 août 2015. 2LAC/2015/19255. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette Thill.

POUR COPIE CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2015.

Référence de publication: 2015145516/184.
(150158656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2015.

BRE/Europe 7Q S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 180.323.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of the month of June.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of BRE/Europe 7Q S.à r.l., a société à responsa-

bilité limitée (private limited liability company), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros
(EUR 12,500) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 180.323 (the

111524

L

U X E M B O U R G

"Company"), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 13 September 2013 pursuant to a deed
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 5 November 2013, number 2755.

The articles of association of the Company (the “Articles”) have never been amended.
The Meeting was opened under the chairmanship of Me Olivier Gaston-Braud, professionally residing in Luxembourg

(the “Chairman”),

who appointed as secretary Mr Kevin Annicchiarico, residing in Luxembourg and as scrutineer Me Vianney de Ba-

gneaux, professionally residing in Luxembourg.

After the constitution of the bureau of the Meeting, the Chairman declared and requested the notary to record:
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders

represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented, the members of the bureau of the Meeting and the
undersigned notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given
shall be initialled ne varietur by the members of the bureau of the Meeting and by the notary and shall be attached in the
same way to this document.

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue were represented at the Meeting, the same Meeting

waives the convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance

III. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on

the agenda.

IV. That the agenda of the Meeting is the following:
(a) Creation of a new class of A shares with the rights as set forth in the articles of association as amended pursuant to

the resolutions taken in accordance with the terms the present agenda;

(b) Creation of a new class of B shares with the rights as set forth in the articles of association as amended pursuant to

the resolutions taken in accordance with the terms the present agenda;

(c) Increase of the issued share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred Euro

(EUR 12,500.-) to thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) by the issue of (i) five hundred (500) shares
of class A of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) for a total subscription price of one million Euros (EUR
1,000,000) (the “Class A Subscription Price”) and (ii) five hundred (500) shares of class B of a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25) each for a total subscription price of five hundred thousand Euros (EUR 500,000) (the “Class B
Subscription Price” and together with the Class A Subscription Price, the “Subscription Price”); subscription of the class
A shares by the subscribers listed below, in the proportion as set in front of their respective name:

No

Name of the Class A Shares Subscriber

Number of

Class A

Shares

subscribed

1.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE 1-8 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

3.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

4.

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII-ESC LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

5.

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

6.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

7.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

8.

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

9.

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV - ESC L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

(together referred to as the “Class A Shares Subscribers”), by way of a contribution in kind consisting in the contribution

and transfer of receivables held by the Class A Shares Subscribers against the Company for an aggregate amount of one
million Euros (EUR 1,000,000) (the “Class A Contribution in Kind”); subscription of the class B shares by the subscribers
listed below, in the proportion as set in front of their respective name:

No

Name of the Class B Shares Subscriber

Number of

Class B

Shares

subscribed

1.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.1 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

3.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.2 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.3 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

111525

L

U X E M B O U R G

5.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.4 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

6.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.5 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

7.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.6 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

8.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.7 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

9.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.8 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

11.

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII-ESC LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

12.

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

13.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

14.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

15.

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

16

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV - ESC L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

(together referred to as the “Class B Shares Subscribers”), by way of a contribution in kind consisting in the contribution

and transfer of receivables held by the Class B Shares Subscribers against the Company for an aggregate amount of five
hundred thousand Euros (EUR 500,000) (the “Class B Contribution in Kind” and together with the Class A Contribution
in Kind, the “Contributions in Kind”);

(d) acknowledgement of the report of the sole manager of the Company dated 19 June 2015 on the valuation of the

Contributions in Kind (the “Valuation Report”); approval of the valuation of the Contributions in Kind and issue of the
class A shares and the class B shares; payment of the Subscription Price by way of the Contributions in Kind; and, allocation
of an amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) to the share capital account of the Company, an amount of nine
hundred eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 987,500) to the class A share premium, and an amount of four
hundred eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 487,500) to the class B share premium;

(e) amendment and restatement the articles of association of the Company in their entirety so that they shall read as set

forth in the second resolution below.

Thereafter the following resolutions were passed by the Meeting:

<i>First resolution

The Meeting resolved to approve the Class A Shares Subscribers and the Class B Shares Subscribers as new shareholders

of the Company for the purposes of the article 189 of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended.

The Meeting resolved to create new class of A shares with the rights as set forth in the articles of association as amended

below.

The Meeting resolved to create new class of B shares with the rights as set forth in the articles of association as amended

below.

The Meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of twelve thousand

five hundred Euro (EUR 12,500.-) to thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) by the issue of (i) five
hundred (500) shares of class A of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each and (ii) five hundred (500) shares
of class B of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

The Meeting approved the Class A Shares Subscribers and the Class B Shares Subscribers as new shareholders of the

Company.

Thereupon the Class A Shares Subscribers, each being represented by Me Olivier Gaston-Braud pursuant to a proxy

dated 19 June 2015 (the proxies given shall be initialled ne varietur by the members of the bureau of the Meeting and by
the notary and shall be attached to the present deed and registered therewith), have fully subscribed to all the new five
hundred (500) shares of class A of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each for their respective portion of the
Class A Contribution in Kind as set out in front of their name below:

No

Name of the Class A Shares Subscriber

Number of

Class A

Shares

subscribed

Portion of

the Class A

Subscription

Price in EUR

1.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

55,448.46

2.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE 1-8 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

51,118.66

3.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

91,192.88

4.

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII-ESC LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1,086.00

5.

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD LP  . . . . . . . . . . .

1

1,154.00

6.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

760,617.11

7.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

22,862.89

8.

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P.  . . . . . . . . . . . .

5

10,048.00

111526

L

U X E M B O U R G

9.

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV - ESC L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

6,472.00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

1,000,000

Thereupon the Class B Shares Subscribers, each being represented by Me Olivier Gaston-Braud pursuant to a proxy

dated 19 June 2015 (the proxies given shall be initialled ne varietur by the members of the bureau of the Meeting and by
the notary and shall be attached to the present deed and registered therewith), have fully subscribed to all the new five
hundred (500) shares of class B of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each for their respective portion of the
Class B Contribution in Kind as set out in front of their name below:

No

Name of the Class B Shares Subscriber

Number of

Class B

Shares

subscribed

Portion of

the Class B

Subscription

Price in EUR

1.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

27,724.23

2.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.1 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4,475.08

3.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.2 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4,345.96

4.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.3 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

10,394.08

5.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.4 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2,172.98

6.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.5 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

439.31

7.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.6 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1,973.13

8.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.7 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1,196.43

9.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.8 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

562.36

10.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

45,596.44

11.

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII-ESC LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

543.00

12.

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD LP  . . . . . . . . . . .

1

577.00

13.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

380,300.08

14.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

11,439.92

15.

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P.  . . . . . . . . . . . .

5

5,024.00

16.

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV - ESC L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3,236.00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

500,000

The Contributions in Kind are valued based on the Valuation Report at an aggregate amount of one million five hundred

thousand Euros (EUR 1,500,000).

The conclusions of the Valuation Report are as follows:
“On the basis of the aforementioned, the sole manager considers that the documentation and assurance received provide

adequate substantiation as to the existence and extent of the Contributions in Kind.

The sole manager is of the opinion that the Class A Contribution in Kind as described above is equal to an aggregate

amount of one million Euros (EUR 1,000,000) which corresponds at least to the nominal value of the five hundred (500)
shares of class A to be issued by the Company together with the amount of nine hundred eighty-seven thousand five hundred
Euros (EUR 987,500) to be allocated to the class A share premium account of the Company.

The sole manager is of the opinion that the Class B Contribution in Kind as described above is equal to an aggregate

amount of five hundred thousand euros (EUR 500,000) which corresponds at least to the nominal value of the five hundred
(500) shares of class B to be issued by the Company together with the amount of four hundred eighty-seven thousand five
hundred Euros (EUR 487,500) to be allocated to the class B share premium account of the Company.

Therefore the sole manager proposes to the shareholders’ meeting to value the Class A Contribution in Kind at one

million Euros (EUR 1,000,000) and the Class B Contribution in Kind at five hundred thousand Euros (EUR 500,000).”

The appearing party has confirmed that the Contributions in Kind are at least equal to the value of the shares to be issued

by the Company in consideration therefore.

Proof of the Contributions in Kind and the payment of the Subscription Price of one million five hundred thousand Euros

(EUR 1,500,000) by such Contributions in Kind has been shown to the undersigned notary.

Out of the Class A Subscription Price, the Meeting resolved to allocate, twelve thousand five hundred Euros (EUR

12,500) to the share capital account of the Company, and the balance to the Class A share premium account of the Company,
for an amount of nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 987,500).

Out of the Class B Subscription Price, the Meeting resolved to allocate, twelve thousand five hundred Euros (EUR

12,500) to the share capital account of the Company, and the balance to the Class B share premium account of the Company,
for an amount of four hundred eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 487,500).

Thereupon the Meeting acknowledged and approved that the Class A Shares Subscribers and the Class B Shares Sub-

scribers are new shareholders of the Company, are inscribed on the attendance list and shall participate to the Meeting and
vote on the remaining item of the agenda, having declared themselves duly informed thereof.

This resolution has been taken unanimously.

111527

L

U X E M B O U R G

<i>Structure of the capital

The Meeting unanimously acknowledged that the share capital of the Company is now of an amount of thirty-seven

thousand five hundred Euros (EUR 37,500) represented by (i) five hundred (500) class Z shares of a nominal value of
twenty-five Euros (EUR 25) each, (ii) five hundred (500) class A shares of a nominal value of twenty-five Euros (EUR
25) each, and (iii) five hundred (500) class B shares of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each, allocated as
follows:

Name of Shareholders

Number

of class

Z shares

Number

of class

A shares

Number

of class

B shares

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

28

28

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE1-8 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

26

0

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE1 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

0

4

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE2 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

0

4

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE3 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

0

10

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE4 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

0

2

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE5 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0

1

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE6 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

0

2

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE7 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0

1

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE8 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0

1

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

45

46

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0

0

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII-ESC L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

1

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD L.P. . . . . . . . . . . . .

1

1

1

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

380

380

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

11

11

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P. . . . . . . . . . . . . . .

0

5

5

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV - ESC L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

3

3

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

500

500

<i>Second resolution

The Meeting unanimously decided to fully amend and re-state the Company’s articles of association so that they shall

read as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “BRE/Europe 7Q

S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect

participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

111528

L

U X E M B O U R G

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at thirty-seven thousand and five hundred Euro

(EUR 37,500.-) represented by five hundred (500) Class A shares, five hundred (500) Class B shares, and five hundred
(500) Class Z shares, each share of each class having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The capital of
the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment
of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its
shareholders.

Each class of shares shall be issued in connection with the acquisition or making by the Company of a specific investment

directly or indirectly (each a "Specific Investment"), except as otherwise specified herein. The subscription price paid to
the Company upon the issuance of shares of a particular class (including for the avoidance of doubt any share premium)
(the "Subscription Price"), net of all costs payable by the Company in connection with such issuance including, but not
limited to, capital duty, notarial fees and publication costs ("Issuance Costs"), shall be invested directly or indirectly in one
and the same Specific Investment except for the Class Z shares for which it shall be invested directly or indirectly in one
or several Unallocated Assets (as defined below).

Class A relates to the Project Arcese Investment, being the investment by way of shares, share premium account, loans,

preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in Logicor Europe Holdings II S.à r.l., a
Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of EUR 12,500 and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg
under number B 181.528 (and the underlying assets, subsidiaries and entities) in relation with the indirect acquisition and
the holding of the Arcese logistic assets properties located in Italy which occurred in February 2014.

Class B relates to the Project Platinum Investment, being the investment by way of shares, share premium account,

loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in Platinum Office Topco S.à r.l.,
a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of EUR 12,500 and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg
under number B 184.153 (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Class Z is not linked to a Specific Investment but relates to all assets and liabilities of the Company which are not tracked

under another class of shares of the Company as described above (together, the “Unallocated Assets”).

In relation to each Specific Investment, the sole manager, or as the case may be, the board of managers will, in the

internal accounts of the Company, establish a separate compartment of assets and liabilities of the Company in the following
manner:

- the Subscription Price of the relevant class of shares, the payment to share premium account, and the proceeds of any

shareholder loans, certificates, debt or other instruments convertible or not which may from time to time be granted to, or
issued by, the Company by or to its shareholder(s) in connection with the relevant Specific Investment, as well as assets
acquired with such funds contributed to or borrowed by the Company, in each case shall be applied in the internal books
of the Company to the compartment established for such Specific Investment;

- any income or proceeds earned by the Company on, or any asset derived from, the assets allocated to a compartment

shall be allocated to that compartment;

111529

L

U X E M B O U R G

- any liability, costs and expenses (including provisions) relating to assets allocated to a compartment or to any action

taken in connection with a compartment or an asset of a particular compartment or in connection with the issuance of shares
or other instruments of the particular class (such as Issuance Costs) as well as all administration expenses, tax liabilities
and other costs and expenses of the Company attributable to the relevant Specific Investment or the operation or adminis-
tration of that compartment shall be allocated to that compartment;

- in the case where any liability or expense of the Company cannot be considered as being attributable solely to a

particular compartment, such liability or expense shall be allocated between all the existing compartments pro rata to the
net assets of each compartment or pro rata to the relevant compartments to which the liability or expense relates;

- any distributions or payments (including payments of the price payable by the Company for shares of the relevant class

repurchased by it) made to shareholders in respect of a compartment shall reduce the net assets of that compartment;

- the net assets of each compartment ("Net Assets") will be equal to the sum of the value of the Specific Investment of

that compartment and all other assets attributable to that compartment in accordance with these articles less all the liabilities,
costs and expenses allocated to that compartment in accordance with these articles of association.

Similarly, the sole manager, or as the case may be, the board of managers will, in the internal accounts of the Company,

establish a separate compartment of assets and liabilities of the Company with respect to all the Unallocated Assets and
the rules described above shall apply mutatis mutandi to the compartment dedicated to the Unallocated Assets.

For the avoidance of doubt, any reference to the Net Assets in these articles of association may be construed as a reference

to the Net Assets as calculated for any Specific Investment allocated to a specific class of shares in the compartment created
to that purpose in the internal accounts of the Company or for the Unallocated Assets gathered under the class Z shares in
the compartment created to that purpose in the internal accounts of the Company.

Any share premium paid in respect of a specific class of shares upon their issuance shall be allocated to a share premium

account corresponding to that specific class of shares of the Company. Any payment or contribution of any kind to any
share premium account established in accordance with Luxembourg law or accounting regulations shall be specified as to
which class of shares it relates, the sole manager or as the case may be, the board of managers, having the power to confirm
any allocation to a specific class of shares if this has not been specified otherwise. Any available share premium shall be
distributable.

Art. 6. Cancellation of an entire class of shares and reduction of share capital. The share capital of the Company may

be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire class of shares through
the repurchase and cancellation of all the shares in issue in the relevant class by approval at the general meeting of share-
holders resolving at the quorum and majorities provided for the amendment of the articles of association.

In case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more class of shares, the

holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the
Cancellation Value per Share (as defined below) for each share of the relevant class held by them and cancelled.

The board of managers shall, in case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a

class of shares, calculate the Class Available Amount for the repurchased class (always subject to the amount of available
profits, premium and reserves of the Company) on the basis of the interim accounts of the Company and interim internal
accounts relating to the relevant class which shall be prepared on the basis set out in Article 5, each time not older than
eight (8) days (together, the “Interim Accounts”).

“Class Available Amount” means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company

(including carried forward profits) relating to the Specific Investment (or the Unallocated Assets) to which the relevant
class of shares belongs (i) plus the amount of the share capital reduction relating to the class of shares repurchased (and if
any the amount equal to the decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such class)
but (ii) less any Investment Losses of that class (including carried forward losses) and (iii) less any sums to be placed into
reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles of association.

“Investment Losses” means any losses (including carry forward losses relating to the relevant Specific Investment (or

the Unallocated Assets)) and any costs, charges or expenses related to the relevant Specific Investment (or the Unallocated
Assets) (including repayment by the Company of any debt incurred to manage the respective Specific Investment (or the
Unallocated Assets)), and an amount corresponding to the pro rata portion (calculated of the Company's overhead expenses
(assessed fairly but irrevocably by the board of managers) and the Company's non-recoverable losses. The “Cancellation
Value per Share” shall be calculated by dividing the Class Cancellation Amount by the number of shares in issue in the
class of shares to be repurchased and cancelled.

The “Class Cancellation Amount” shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general

meeting of shareholders on the basis of the Interim Accounts.

Subject always to the amount of available net profits, reserves and premium of the Company, the Class Cancellation

Amount for the class of shares to be repurchased and cancelled shall be the Class Available Amount unless otherwise
resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the articles of association
provided however that the Class Cancellation Amount shall never be higher than the Class Available Amount and provided
further that the Class Cancellation Amount shall never be greater than the total amount of available net profits, reserves
and premium of the Company.

111530

L

U X E M B O U R G

Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class, the Cancellation Value per Share will become

due and payable by the Company.

Art. 7. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent (75%)
of the Company's share capital.

Art. 8. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers, including specific powers given
in specific provisions of these articles of association.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 9. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability”
and “expenses” shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

111531

L

U X E M B O U R G

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

Art. 10. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns (regardless of class) and may validly act at any meeting of shareholders through a
special proxy.

Art. 11. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 12. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2013.

Art. 13. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the sole

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on one or several classes of shares on the basis of statements of

accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the
last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law (regardless of the Investment Net Income of
a class of shares). Distribution to a class shall only be made out of the Investment Net Income related to that class (subject
to the above).

“Investment Net Income” means any income derived from the investment(s) relating to a class of shares being the net

return of any total or partial disposal of the relevant Specific Investment or of all or part of the Unallocated Assets (disposal
meaning transfers and contributions of any kind) as well as any dividends or other distributions, interest, yield, repayment
of principal or other income or return deriving from the relevant Specific Investment or Unallocated Asset(s) and assets
and reserve funds received by or attributable to the Company in respect of the issue of the relevant class of shares such as

111532

L

U X E M B O U R G

the share premium or any amounts of profit (related to the relevant Investment(s)) carried forward while deducting any
costs, charges or expenses related to the relevant Specific Investment or Unallocated Asset(s) (including repayment by the
Company of any debt incurred to manage the respective Specific Investment or Unallocated Asset(s)), and an amount
corresponding to the pro rata portion (calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by
the board of managers) and the Company's non-recoverable losses.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders,

but only to the shareholders of the class to which this share premium relates to. The general meeting of shareholders may
decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 15. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds of each class shall be the amount to which the class is entitled

as per the relevant Specific Investment if applicable, or, for the classes of non-tracking shares, as per the nominal value of
the shares as may be determined through the separate compartment of assets and liabilities that the board of managers has
established for them in the internal accounts of the Company. Each class of shares shall be entitled to proceeds of liquidation
determined as follows in relation to the relevant Specific Investment to which the class relates or as follows from the
nominal value of the shares for the classes of non-tracking shares:

First all debts and liabilities of the Company (regardless of Specific Investment) shall be paid. Such debts or liabilities

shall be attributed to the class of shares to which they specifically belong (i.e. because they relate to the relevant Specific
Investment for that class) or, if that is not possible, distributed rateably among all classes of shares in proportion of the
issued share capital of the Company which they represent.

Thereafter the relevant amount of liabilities for each class of shares shown in the separate category for the Specific

Investment to which they relate shall be set against the assets attributable to the relevant class including in particular the
Specific Investment of that class and any reserve funds attributable to such class. Assets not attributable to a specific class
shall be divided pro rata to all classes of shares.

To the extent that the amount so calculated for any class shall be negative, such class shall not be entitled to any liquidation

proceeds. The relevant negative amount shall be allocated rateably among all classes of shares which have a positive amount
up such positive amount. Any surplus remaining within a specific class of shares (the "Class Surplus") shall be distributed
to the relevant holders of such class of shares.

For the avoidance of any doubt, the provisions of this article 15 shall apply mutatis mutandi to the Class Z shares with

respect to the Unallocated Assets.

Art. 16. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies,

as amended; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

This resolution has been taken unanimously.
There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at EUR 4,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above

appearing party the present deed is worded in English followed by and German translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreißigsten Tag des Monats Juni.
Vor dem Notar Me Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Wurde eine ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschafter (die „Versammlung“) der BRE/Europe 7Q S.à

r.l. (die „Gesellschaft“) gehalten, eine société à responsablité limitée, gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg,  mit  einem  Gesellschaftskapital  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500,-)  und  beim  Handels-  und
Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer

111533

L

U X E M B O U R G

B 180.323 eingetragen, gegründet am 13. September 2013 durch Urkunde des Notars Me Henri Hellinckx, Notar mit
Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche am 5. November 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (das "Mémorial") unter der Nummer 2755 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde noch nie geändert.
Die Generalversammlung wurde unter dem Vorsitz von Me Olivier Gaston-Braud, geschäftsansässig in Luxemburg

eröffnet,

M. Kevin Annicchiarico, ansässig in Luxembourg, zum Protokollführer und Me Vianney de Bagneaux, geschäftsan-

sässig in Luxemburg, zum Stimmzähler ernannt.

Nachdem der Vorsitz der Hauptversammlung ordnungsgemäß bestimmt wurde, erklärte der Vorsitzende und beauftragte

den Notar, folgendes festzustellen:

I) Die Namen der anwesenden oder durch Vollmacht vertretenden Gesellschafter, der bevollmächtigten Vertreter, sowie

die Anzahl der Anteile die jeder Gesellschafter hält, sind auf einer Anwesenheitsliste eingetragen, die von den anwesenden
Gesellschaftern, den bevollmächtigten Vertretern, den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentier-
enden  Notar  unterzeichnet  ist.  Diese  Anwesenheitsliste  wird  diesem  Protokoll  als  Anlage  beigefügt  und  mit  diesem
registriert. Die Vollmachten werden ne variatur von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und von dem obenge-
nannten Notar unterzeichnet und sollen auf die gleiche Weise diesem Dokument als Anlage beigefügt werden.

II) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle ausgegebenen Gesellschaftsanteile in gegenwärtiger Versammlung

vertreten waren, die gleiche Versammlung verzichtet auf die Einberufung , die vertretenen Gesellschafter sehen sich als
ordnungsgemäß einberufen an und erklären vollumfassende Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihnen im Voraus
mitgeteilt worden ist.

III) Als Ergebnis des vorgenannten, ist die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß gebildet und kann rechtsgültig

über die Tagesordnungspunkte beraten und beschließen.

IV) Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist die Folgende:
(a) Erstellen einer neuen Anteilsklasse A, mit den Rechten und Pflichten, wie in der infolge der untenstehenden Be-

schlüsse geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen;

(b) Erstellen einer neuen Anteilsklasse B, mit den Rechten und Pflichten, wie in der infolge der untenstehenden Be-

schlüsse geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen;

(c) Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals von dem aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro

(EUR 12.500) auf siebenunddreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 37.500) durch Ausgabe von (i) fünfhundert (500) neuen
Anteilen der Klasse A mit einem Nominalwert in Höhe von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25), für einen Gesamtzeich-
nungspreis von einer Million Euro (EUR 1.000.000) (der „Klasse A Zeichnungspreis“), sowie (ii) 500 Anteilen der Klasse
B mit einem Nominalwert in Höhe von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25), für einen Gesamtzeichnungspreis von fünf-
hunderttausend Euro (EUR 500.000) (der „Klasse B Zeichnungspreis“, und zusammen mit dem Klasse A Zeichnungspreis,
der „Zeichnungspreis“); Zeichnung der Klasse A Anteile durch die folgend aufgeführten Zeichner, im angegebenen Ver-
hältnis:

No

Name der Klasse A Anteilszeichner

Anzahl der

gezeichneten

Klasse A

Anteile

1.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE 1-8 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

3.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

4.

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII-ESC LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

5.

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

6.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

7.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

8.

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

9.

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV - ESC L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

(Zusammen die „Klasse A Zeichner“), durch Sacheinlage, bestehend aus dem Beitrag der Forderungen der Klasse A

Zeichner  gegenüber  der  Gesellschaft,  für  den  Gesamtbetrag  von  einer  Million  Euro  (EUR  1.000.000)  (die  „Klasse  A
Sacheinlage“); Zeichnung der Klasse B Anteile durch die folgend aufgeführten Zeichner, im angegebenen Verhältnis:

No

Name der Klasse B Anteilszeichner

Anzahl der

gezeichneten

Klasse B

Anteile

1.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.1 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

111534

L

U X E M B O U R G

3.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.2 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.3 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.4 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

6.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.5 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

7.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.6 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

8.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.7 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

9.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.8 LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

11.

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII-ESC LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

12.

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

13.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

14.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

15.

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

16.

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV - ESC L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

(Zusammen die „Klasse B Zeichner“), durch Sacheinlage, bestehend aus dem Beitrag der Forderungen der Klasse B

Zeichner gegenüber der Gesellschaft, für den Gesamtbetrag von fünfhundertausend Euro (EUR 500.000) (die „Klasse B
Sacheinlage“, zusammen mit der Klasse A Sacheinlage, die „Sacheinlagen“);

(d) Bestätigung des Berichts des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft, datiert auf den 19. Juni 2015 über die

Bewertung der Sacheinlagen (der „Bewertungsbericht“); Genehmigung der Bewertung der Sacheinlagen und Ausgabe der
Anteile der Klasse A sowie der Klasse B; Zahlung des Zeichnungspreises durch die Sacheinlagen; und, Zuweisung der
Summe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) in das Gesellschaftskapitalkonto, die Summe von neunhundert-
siebenundachzigtausendfünfhundert Euro (EUR 987.500) in das Klasse A Anteilsprämienkonto, sowie die Summe von
vierhundertsiebenundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 487.500) in das Klasse B Anteilsprämienkonto;

(e) Änderung und Anpassung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, so dass sie wie in der dritten Resolution

angegeben, lauten soll.

Daraufhin hat die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung hat beschlossen, im Sinne des Artikels 189 des Gesetzes vom 10ten August 1915 über Handelsge-

sellschaften, in der geänderten Fassung, den Klasse A Zeichner, sowie den Klasse B Zeichner, als neue Gesellschafter
zuzustimmen.

Die Versammlung hat beschlossen eine neue Anteilsklasse A zu erstellen, mit den Rechten und Pflichten, wie in der

infolge der untenstehenden Beschlüsse geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen.

Die Versammlung hat beschlossen eine neue Anteilsklasse B zu erstellen, mit den Rechten und Pflichten, wie in der

infolge der untenstehenden Beschlüsse geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen.

Die Versammlung hat beschlossen das ausgegebene Gesellschaftskapital von dem aktuellen Betrag von zwölftausend-

fünfhundert Euro (EUR 12.500) auf siebenunddreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 37.500) zu erhöhen, durch Ausgabe
von (i) fünfhundert (500) neuen Anteilen der Klasse A mit einem Nominalwert in Höhe von je fünfundzwanzig Euro (EUR
25) , sowie (ii) fünfhundert (500) Anteilen der Klasse B mit einem Nominalwert in Höhe von je fünfundzwanzig Euro
(EUR 25).

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung die Klasse A Anteilszeichner sowie die Klasse B Anteilszeichner als neue

Gesellschafter bestätigt.

Daraufhin haben die Klasse A Zeichner, vertreten durch Me Olivier Gaston-Braud, gemäß Vollmacht datiert auf den

19. Juni 2015 (die Stimmrechtsvertretungen werden ne varietur von den Mitgliedern des Büros der Versammlung para-
phiert, sowie vom Notar und werden der vorliegenden Urkunde beigefügt sowie mit ihr registriert), alle fünfhundert (500)
neuen Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) gezeichnet, für ihren jeweiligen
Anteil an der Klasse A Sacheinlage, wie folgt aufgeführt:

No

Name des Klasse A Anteilszeichners

Anzahl der

gezeichneten

Klasse A

Anteile Anteil

des Klasse A

Zeichnungspreises

in EUR

1.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII LP  . . . . . . . . . . . . . . . .

28

55,448.46

2.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE 1-8 LP  . . . . . . . . . .

26

51,118.66

3.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F LP . . . . . . . . . . . . . . .

45

91,192.88

4.

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII-ESC LP  . . . . . . . . . . .

1

1,086.00

5.

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD LP  . . .

1

1,154.00

111535

L

U X E M B O U R G

6.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

760,617.11

7.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

22,862.89

8.

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P.  . . . .

5

10,048.00

9.

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV -ESC L.P.  . . . . . . . . . . . . .

3

6,472.00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

1,000,000

Daraufhin haben die Klasse B Zeichner, vertreten durch Me Olivier Gaston-Braud gemäß Vollmacht datiert auf den 19.

Juni 2015 (die Stimmrechtsvertretungen werden ne varietur von den Mitgliedern des Büros der Versammlung paraphiert,
sowie vom Notar und werden der vorliegenden Urkunde beigefügt sowie mit ihr registriert), alle fünfhundert (500) neuen
Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) gezeichnet, für ihren jeweiligen Anteil
an der Klasse B Sacheinlage, wie folgt aufgeführt:

No

Name des Klasse B Anteilszeichners

Anzahl der

gezeichneten

Klasse B

Anteile

Anteil des

Klasse B

Zeichnungspreises

in EUR

1.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII LP  . . . . . . . . . . . . . . . .

28

27,724.23

2.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.1 LP  . . . . . . . . . . . .

4

4,475.08

3.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.2 LP  . . . . . . . . . . . .

4

4,345.96

4.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.3 LP  . . . . . . . . . . . .

10

10,394.08

5.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.4 LP  . . . . . . . . . . . .

2

2,172.98

6.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.5 LP  . . . . . . . . . . . .

1

439.31

7.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.6 LP  . . . . . . . . . . . .

2

1,973.13

8.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.7 LP  . . . . . . . . . . . .

1

1,196.43

9.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.TE.8 LP  . . . . . . . . . . . .

1

562.36

10.

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F LP . . . . . . . . . . . . . . .

46

45,596.44

11.

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII–ESC LP  . . . . . . . . . . .

1

543.00

12.

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD LP  . . .

1

577.00

13.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

380,300.08

14.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

11,439.92

15.

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P.  . . . .

5

5,024.00

16.

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV - ESC L.P.  . . . . . . . . . . . .

3

3,236.00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

500,000

Die Sacheinlagen werden auf Grundlage des Bewertungsberichtes auf den Gesamtbetrag von einer Million fünfhun-

derttausend Euro (EUR 1.500.000) geschätzt.

Die Schlussfolgerungen des Bewertungsberichtes sind wie folgt:

„Im Hinblick auf das Vorgenannte, ist der Alleinige Geschäftsführer der Annahme, dass die erhaltene Dokumentation

sowie Sicherheiten, eine adäquate Substanz bezüglich der Existenz und des Ausmaßes der Sacheinlagen bieten.

Im Hinblick auf das Vorgenannte ist der Alleinige Geschäftsführer der Annahme, dass sich der Wert der Klasse A

Sacheinlage wie oben beschrieben auf eine Million Euro (EUR 1.000.000) beläuft, welches mindestens dem Gesamtzeich-
nungspreis  der  fünfhundert  (500)  von  der  Gesellschaft  ausgegebenen  Klasse  A  Anteilen  entspricht,  der  zur  Ausgabe
vorgeschlagen  wurde,  einschließlich  dem  Betrag  von  neunhundertsiebenundachtzigtausendfünfhundert  Euro  (EUR
987.500) der dem Klasse A Anteilsprämienkonto zugewiesen werden soll.

Im Hinblick auf das Vorgenannte ist der Alleinige Geschäftsführer der Annahme, dass sich der Wert der Klasse B

Sacheinlage wie oben beschrieben auf fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) beläuft, welches mindestens dem Ge-
samtzeichnungspreis  der  fünfhundert  (500)  von  der  Gesellschaft  ausgegebenen  Klasse  B  Anteilen  entspricht,  der  zur
Ausgabe vorgeschlagen wurde, einschließlich dem Betrag von vierhundertsiebenundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR
487.500) der dem Klasse B Anteilsprämienkonto zugewiesen werden soll.

Im Hinblick auf das Vorgenannte, schlägt der alleinige Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung vor, die Klasse

A Sacheinlage auf eine Million Euro (EUR 1.000.000) zu bewerten, sowie die Klasse B Sacheinlage auf fünfhunderttausend
Euro (EUR 500.000) zu bewerten.“ Die erscheinende Partei bestätigt, dass die Sacheinlagen mindestens dem Wert der von
der Gesellschaft in Gegenleistung dafür auszugebenden Anteile entsprechen.

Beweis der Sacheinlagen und der Zahlung des Zeichnungspreises in Höhe von einer Million fünfhunderttausend Euro

(EUR 1.500.000) wurde dem unterzeichnenden Notar gezeigt.

Die Versammlung beschließt aus dem Klasse A Zeichnungspreis zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) dem

Gesellschaftskapitalkonto zuzufügen, sowie den Saldo in Höhe von neunhundertsiebenundachtzigtausendfünfhundert Euro
(EUR 987.500) dem Klasse A Anteilsprämienkonto hinzuzufügen.

111536

L

U X E M B O U R G

Die Versammlung beschließt aus dem Klasse B Zeichnungspreis zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) dem

Gesellschaftskapitalkonto zuzufügen, sowie den Saldo in Höhe von vierhundertsiebenundachtzigtausendfünfhundert Euro
(EUR 487.500) dem Klasse B Anteilsprämienkonto hinzuzufügen.

Daraufhin hat die Generalversammlung anerkannt und beschlossen, dass die Klasse A Anteilszeichner sowie die Klasse

B Anteilszeichner, die neuen Gesellschafter der Gesellschaft sind, und erklären rechtmäßig informiert worden zu sein, auf
der Anwesenheitsliste eingetragen sind und an der Versammlung teilnehmen und für die verbleibenden Tagesordnungs-
punkte stimmenkönnen.

Dieser Beschluss wurde einstimmig getroffen.

<i>Kapitalstruktur

Die Versammlung hat einstimmig anerkannt, dass das Gesellschaftskapital ab jetzt siebenunddreißigtausendfünfhundert

Euro (EUR 37.500) beträgt, vertreten durch (i) fünfhundert (500) Klasse Z Anteile mit einem Nominalwert von je fünf-
undzwanzig Euro (EUR 25), (ii) fünfhundert (500) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro
(EUR 25), sowie (iii) fünfhundert Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25), wie
folgt:

Name des Anteilsinhabers

Anzahl

der

Klasse

Z Anteile

Anzahl

der

Klasse

A

Anteile

Anzahl

der

Klasse

B

Anteile

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

28

28

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE1-8 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

26

0

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE1 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

0

4

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE2 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

0

4

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE3 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

0

10

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE4 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

0

2

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE5 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0

1

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE6 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

0

2

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE7 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0

1

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII TE8 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0

1

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VII.F L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

45

46

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0

0

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VII-ESC L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

1

Blackstone Family Real Estate Partnership (Offshore) VII-SMD L.P. . . . . . . . . . . . .

1

1

1

Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

380

380

Blackstone Real Estate Partners Europe IV.F L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

11

11

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe IV - SMD L.P. . . . . . . . . . . . . . .

0

5

5

Blackstone Real Estate Holdings Europe IV - ESC L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

3

3

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

500

500

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung hat beschlossen, die Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern und/oder neu zu formulieren:

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

"BRE/Europe 7Q S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebe-
nenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch die vorliegende Satzung und durch
die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise sowie die Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direktem oder indirektem Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen

die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Ge-
sellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

111537

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-

geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzen oder Regulierungsmaßnahmen, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf siebenunddreißig-

tausendfünfhundert Euro (EUR 37.500), eingeteilt in fünfhundert Klasse A (500) Gesellschaftsanteile, fünfhundert Klasse
B (500) Gesellschaftsanteile, sowie fünfhundert Klasse Z (500) Gesellschaftsanteile jeder Gesellschaftsanteil jeder Klasse
mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25). Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Be-
schluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert
werden und die Gesellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Jede Anteilsklasse wird in Verbindung mit dem Erwerb oder der Durchführung eines spezifischen direkten oder indi-

rekten Investments ausgegeben (jedes ein „Spezifisches Investment“), soweit hiernach nicht anders angegeben wird. Der,
der Gesellschaft gezahlte Zeichnungspreis bei der Ausgabe der Anteile (um Zweifel zu vermeiden zuzüglich jedes Anteil-
sprämienkontos)  (der  „Zeichnungspreis“),  abzüglich  aller  durch  die  Gesellschaft,  bezüglich  der  Anteilsausgabe,  ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf, Gesellschaftssteuer, Notargebühren und Veröffentlichungskosten („Emissionskos-
ten“) zu zahlenden Kosten, soll direkt oder indirekt in ein und dieselbe spezifische Anlage investiert werden- mit Ausnahme
der Klasse Z Anteile, für welche er direkt oder indirekt in eine oder mehrere nicht zugeteilte Vermögenswerte (wie hiernach
definiert) investiert werden kann.

Klasse A bezieht sich auf das Projekt Arcese Investment, wobei die Investition über Anteile, Kapitalrücklagen, Kredite,

Vorzugsaktien oder andere Instrumente, wandelbar oder nicht oder auf andere Weise in Logicor Europe Holdings II S.à
r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts, inkorporiert
unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit
einem Stammkapital in Höhe von EUR 12.500, registriert beim Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter
der  Nummer  B  181.528  (und  die  zugrunde  liegenden  Vermögenswerte,  Tochtergesellschaften  und  Gesellschaften),  in
Zusammenhang mit dem indirekten Erwerb und Besitz der Arcese Logistikanlagen welche sich in Italien befinden, die im
Februar 2014 erfolgten.

Klasse B bezieht sich auf das Projekt Platinum Investment, wobei die Investition über Anteile, Kapitalrücklagen, Kredite,

Vorzugsaktien oder andere Instrumente, wandelbar oder nicht oder auf andere Weise in Platinum Office Topco S.à r.l.,

111538

L

U X E M B O U R G

eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts, inkorporiert unter
luxemburgischem Recht, mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem
Stammkapital in Höhe von EUR 12.500, registriert beim Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 184.153 (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte , Tochtergesellschaften und Gesellschaften).

Klasse Z ist nicht mit einem bestimmten Investment verknüpft, sondern bezieht sich auf jegliche Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht mit einem bestimmten Investment verbunden sind.

In Bezug auf jedes Spezifische Investment, wird der alleinige Geschäftsführer, beziehungsweise die Geschäftsführung

in der Buchführung der Gesellschaft wie folgt eine separate Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf-
stellen:

- Der Zeichnungspreis der relevanten Anteilsklasse, die Zahlung ins Kapitalkonto, Erlöse aus Gesellschafterdarlehen,

Zertifikate, Schuld oder andere Instrumente, wandelbar oder nicht, welche von Zeit zu Zeit der Gesellschaft gewährt, oder
durch die Gesellschaft gewährt werden, von oder an ihre(n) Anteilsinhabe(r), in Verbindung mit dem relevanten Spezifi-
schen Investment, sowie Vermögenswerte welche mit solchen Mitteln welche der Gesellschaft beigetragen oder von ihr
geliehen wurden, sollen in der Buchhaltung der Gesellschaft der, des spezifischen Investments zugeteilten separaten Ab-
teilung angewendet werden;

- Alle Einkommen sowie Einlöse welche die Gesellschaft verdient, oder irgendwelche Vermögenswerte, abgeleitet von

den Vermögenswerten die einer separaten Abteilung der Buchführung zugeteilt sind, werden dieser separaten Abteilung
zugeteilt;

- Jegliche Haftung, Kosten sowie Aufwendungen (zuzüglich Provisionen) bezüglich der Vermögenswerte die einer

separaten Abteilung zugerechnet werden, sowie jeglicher in Verbindung mit einer separaten Abteilung oder einem Ver-
mögenswertes einer separaten Abteilung , oder in Verbindung mit der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen oder anderer
Instrumente der betroffenen Klasse (z.B. Emissionskosten), sowie alle administrativen Kosten, Steuerverpflichtungen und
andere Kosten und Aufwendungen der Gesellschaft welche dem relevanten Spezifischen Investment zugerechnet werden
können, getroffenen Handlung, oder die Durchführung und Verwaltung dieser Abteilung sollen dieser separaten Abteilung
zugerechnet werden;

- Im Falle von Gebühren oder Ausgaben der Gesellschaft welche nicht einer separaten Abteilung zugerechnet werden

können, wird diese Verbindlichkeit oder Ausgabe pro rata zu den Nettovermögenswerten jeder separaten Abteilung zwi-
schen den existierenden Abteilungen oder pro rata zwischen den relevanten Abteilungen auf welche diese Verbindlichkeit
oder Ausgabe fällt aufgeteilt;

- Jedwede Ausschüttungen oder Auszahlungen (einschließlich Zahlungen welche im Falle eines Anteilsrückkaufs durch

die Gesellschaft fällig werden würden) an die Gesellschafter bezüglich einer Abteilung sollen die Nettovermögenswerte
dieser Abteilung mindern;

- Die Nettovermögenswerte jeder Abteilung („Nettovermögenswerte“) entsprechen der Summe des Wertes des spezi-

fischen Investments dieser Abteilung und aller weiteren Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, Kosten sowie
Ausgaben welche gemäß dieser Satzung dieser Abteilung zugerechnet werden können.

Des Weiteren wird der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung in der Buchführung der Ge-

sellschaft eine separate Abteilung der Vermögenswerte und Schulden des Unternehmens in Bezug auf alle nicht zugeord-
neten Vermögenswerte und die oben beschriebenen Regeln gelten sinngemäß für die Abteilung auf die nicht zugewiesenen
Vermögenswerte.

Zur Vermeidung jeglicher Zweifel, soll jeder Bezug auf die Nettovermögenswerte in dieser Satzung so verstanden

werden, dass er die berechneten Nettovermögenswerte der Spezifischen Investments die auf eine spezifische Anteilsklasse
zugeteilt sind, sowie für die nicht zugeordneten Vermögenswerte welche unter den Klasse Z Anteilen in der eigens dafür
geschaffenen separaten Abteilung zusammengefasst werden, umfasst.

Jedwede Anteilsprämie welche in Bezug auf die Ausgabe einer spezifischen Anteilsklasse eingezahlt wurde, wird auf

das Kapitalrücklagekonto eingezahlt welches der spezifischen Anteilsklasse der Gesellschaft entspricht. Bezüglich jegli-
cher Zahlung oder Einzahlung in eines der Kapitalrücklagenkonten, welche in Übereinstimmung mit luxemburgischem
Gesetz sowie Rechnungslegungsvorschriften getätigt wird, soll festgelegt werden auf welche Anteilsklasse sie sich bezieht.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung, haben die Befugnis jede Einzahlung an eine Spezi-
fische Anteilsklasse zu bestätigen falls nicht anders angegeben. Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Annullierung einer gesamten Anteilsklasse und Herabsetzung des Stammkapitals. Das Stammkapital der Ge-

sellschaft  kann  durch  die  Annullierung  von  Anteilen  herabgesetzt  werden,  einschließlich  der  Annullierung  einer  oder
mehrerer Anteilsklassen durch den Rückkauf und die Annullierung aller ausgegebenen Anteile bezüglich der relevanten
Anteilsklasse, durch Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit dem Quorum und der Mehrheit welche für eine
Änderung der Satzung nötig wären.

Im Falle einer Herabsetzung des Stammkapitals durch die Annullierung von Anteilen, einschließlich durch Annullierung

einer oder mehrerer Anteilsklassen, sollen die Anteilsinhaber der rückgekauften und annullierten Anteile, entsprechend
des Annullierungswertes pro Anteil (wie hierfolgt definiert) pro Anteil der relevanten Anteilsklasse welchen sie hielten
und welcher annulliert wurde.

111539

L

U X E M B O U R G

Der alleinige Geschäftsführer, beziehungsweise die Geschäftsführung soll im Falle einer Herabsetzung des Grundka-

pitals durch den Rückkauf und die anschließende Annullierung der Anteile, den Klassenausschüttfähigen Betrag für die
rückgekaufte Klasse berechnen (immer abhängig von der Summe der verfügbaren Gewinne, Anteilsprämien und Reserven
der Gesellschaft) anhand des Zwischenabschlusses der Gesellschaft sowie des internen Zwischenabschlusses bezüglich
der relevanten Klasse welcher gemäß Artikel 5 angefertigt werden soll, jeweils nicht älter als acht (8) Tage (zusammen die
„Zwischenabschlüsse“).

Der Klassenausschüttfähige Betrag bedeutet die Gesamtsumme der Nettogewinne, verfügbaren Reserven sowie An-

teilsprämien  der  Gesellschaft  (einschließlich  Gewinnvortrag)  betreffend  das  Spezifische  Investment  (oder  die  nicht
zugeordneten Vermögenswerte) zu welcher die relevante Anteilsklasse gehört (i) zuzüglich des Betrages der Herabsetzung
des Stammkapitals betreffend der zurückgekauften Anteilsklasse (und etwaiger Verringerung der gesetzlichen Reserven
betreffend die Reduzierung des Stammkapitals bezüglich der betroffenen Anteilsklasse) aber (ii) abzüglich etwaiger An-
lageverluste betreffend diese Klasse (zuzüglich Verlustvorträgen) und (iii) abzüglich etwaiger Summen welche gemäß
Gesetz oder Satzung in Reserve(n) platziert werden müssen.

Anlageverluste bezeichnet etwaige Verluste (zuzüglich Verlustvorträge des relevanten Spezifische Investment betref-

fend  (oder  die  nicht  zugewiesenen  Vermögenswerte))  sowie  etwaige  Kosten,  Gebühren  und  Ausgaben  betreffend  das
Spezifische Investment (oder die nicht zugewiesenen Vermögenswerte)(einschließlich der Rückzahlung jedweder Schul-
den welche in Folge der Verwaltung des relevanten Spezifischen Investments aufgetreten sind (oder der nicht zugewiesenen
Vermögenswerte)), und einen Betrag in Höhe des pro rata Teils (berechnet an den allgemeinen Geschäftskosten (fair aber
unwiderruflich festgesetzt vom alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführung)) und nicht erstattungs-
fähiger Verluste der Gesellschaft. Um den Anteilsannullierungswert zu berechnen wird der Klassenannullierungswert durch
die Anzahl der Anteile der betroffenen Klasse welche zurückgekauft und annulliert werden, geteilt.

Der Klassenannullierungswert wird vom alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung bestimmt

und von der Gesellschafterversammlung auf Basis des Zwischenberichts genehmigt.

Immer vorbehaltlich der Summe der verfügbaren Nettogewinne, Reserven oder Anteilsprämien der Gesellschaft, wird

der Klassenannullierungswert für die zurückzukaufende und annullierende Anteilsklasse, der Klassenausschüttfähige Be-
trag sein, sofern nicht anderweitig durch die Gesellschafterversammlung in der Art und Weise bestimmt wie für eine
Änderung der Satzung vorgesehen, vorausgesetzt dass der Klassenannullierungswert nie höher sein soll als der Klassen-
ausschüttfähige  Betrag  und  ferner,  dass  der  Klassenannullierungswert  nie  höher  sein  soll  als  die  Gesamtsumme  der
verfügbaren Nettogewinne, Reserven und Anteilsprämien der Gesellschaft.

Bei Rückkauf und Annullierung der Anteile einer relevanten Klasse, wird der Anteilsannullierungswert durch die Ge-

sellschaft fällig und zahlbar.

Art. 7. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht

anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 8. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die

keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer, beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichendsten Befugnissen aus-

gestattet, die Geschäfte der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers, beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer, beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichendsten Befugnisse

um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der

Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser

111540

L

U X E M B O U R G

Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichen Kommunikationsmitteln genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers und durch die Unterschrift eines einzelnen

Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 9. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder

leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig Eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage", „Streitsache", „Prozess" oder
„Verfahren" finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit"
und „Ausgaben" beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-

schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die  Rechte  zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.

Art. 10. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 11. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.

111541

L

U X E M B O U R G

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage

vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens  acht  (8)  Tage  bevor  der  Beschluss  wirksam  werden  soll,  an  alle  Gesellschafter  an  ihre  im  Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 12. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember
2013 enden.

Art. 13. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer, beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 14. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die  Gesellschafter  können  auf  der  Grundlage  eines  von  dem  alleinigen  Geschäftsführer,  beziehungsweise  der  Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

„Nettoanlageertrag“ umfasst jegliches Einkommen welches von den Investments einer bestimmten Anteilsklasse ab-

leitbar ist, einschließlich jeglicher teilweisen oder kompletten Veräußerung eines Spezifischen Investments oder einer
teilweisen oder kompletten Veräußerung der nicht zugewiesenen Vermögensanlagen (Veräußerung bedeutet Transfers
sowie Einlagen jeder Art) sowie jegliche Dividenden und andere Ausschüttungen, Zinsen, Renditen, Tilgungszahlungen,
sowie anderes Einkommen und Erträge welche sich vom relevanten Spezifischen Investment oder der nicht zugewiesenen
Vermögensanlagen, sowie Vermögenswerten und Reserven welche die Gesellschaft bekommen hat beziehungsweise ihr
zugerechnet werden können hinsichtlich der Ausgabe der relevanten Anteilsklassen wie beispielsweise das Agio oder
jedwede Gewinne (betreffend das relevante Investment(s)), vorgetragen, ableiten lassen; abzüglich jeder Kosten, Gebühren
und Ausgaben im Zusammenhang mit dem relevanten Spezifischen Investment oder der nicht zugewiesenen Vermögens-
anlage(n) (einschließlich Rückzahlungen der Gesellschaft jedweder im Zusammenhang mit der Verwaltung der Spezifi-
schen Investments oder der nicht zugewiesenen Vermögensanlage(n) aufgelaufenen Schulden), und einen Betrag in Höhe
des pro rata Teils (berechnet an den allgemeinen Geschäftskosten ( fair aber unwiderruflich festgesetzt vom alleinigen
Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführung)) und nicht erstattungsfähiger Verluste der Gesellschaft.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 15. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.

Bei Auflösung der Gesellschaft umfasst der Liquidationserlös jeder Klasse, die Summe welche dieser Klasse bezüglich

des relevanten Spezifischen Investments gegebenenfalls zusteht, oder, bezüglich der „non-tracking“ Anteile, den Nomi-
nalwert der Anteile wie anhand der separaten Klasse von Vermögenswerten und Schulden durch den alleinigen Geschäfts-

111542

L

U X E M B O U R G

führer  beziehungsweise  die  Geschäftsführung  anhand  der  internen  Buchführung  der  Gesellschaft  bestimmt.  Jede
Anteilsklasse ist am Liquidationserlös berechtigt, festgelegt anhand des relevanten Spezifischen Investments auf welches
sich die Klasse bezieht oder anhand des Nominalwertes der Anteile betreffend die Klassen von „non-tracking“ Anteilen.

Erstens werden alle Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft (unabhängig eines Spezifischen Investments) ge-

zahlt. Solche Schulden und Verpflichtungen werden der Anteilsklasse zugerechnet welcher sie angehören (z.B. weil sie in
Zusammenhang mit dem relevanten Spezifischen Investment dieser Klasse stehen) oder, sollte dies nicht umsetzbar sein,
proportional zwischen allen Anteilsklassen, zum Anteil des Gesellschaftskapital welches sie vertreten.

Anschließend werden alle relevanten Verpflichtungen bezüglich jeder Anteilsklasse, welche in separaten Kategorien

der Spezifischen Investments angezeigt werden, den Vermögensanlagen welche der spezifischen Klasse insbesondere dem
Spezifischen Investment dieser Klasse sowie jeglicher Reserven die dieser Klasse angerechnet werden können, entgegen-
gesetzt. Vermögenswerte welche keiner spezifischen Klasse zugerechnet werden können, werden pro rata zwischen allen
Anteilsklassen aufgeteilt.

In dem Maß, dass die so bestimmte Summe für eine Klasse negativ sein sollte, wird diese Klasse kein Anrecht auf

jeglichen  Liquidationserlös  haben.  Die  relevante  Negativsumme,  wird  unter  allen  Anteilsklassen  welche  eine  positive
Summe aufweisen können anteilig aufgeteilt bis zu dieser positiven Summe. Jeder innerhalb einer Klasse von Anteilen
verbleibende Überschuss (der „Klassenüberschuss“) wird unter den Anteilsinhabern dieser relevanten Anteilsklasse aus-
geschüttet.

Zur Vermeidung jeglicher Zweifel, finden die Bestimmungen des Artikel 15 mutatis mutandis Anwendung auf die

Klasse Z Aktien bezüglich der nicht Zugewiesenen Vermögenswerte.

Art. 16. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179

(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 in der jeweils gültigen Fassung über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1
und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 17. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

<i>Kosten

Die durch die Gesellschaft zu tragenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art werden auf un-

gefähr EUR 4.000,- geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Antrag der er-

schienenen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, auf Antrag derselben erschienenen Person ist im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, am vorgenannten Tag.
Nach Verlesung des Dokuments an die erschienene Person hat diese gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde

unterzeichnet.

Gezeichnet: O. GASTON-BRAUD, K. ANNICCHIARICO, V. DE BAGNEAUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/20992. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Juli 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015115267/1083.
(150124800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Datasud &amp; PC Docter S.àr.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3917 Mondercange, 20, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 100.779.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115375/9.
(150124659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

111543

L

U X E M B O U R G

KN Business and Management, Société Anonyme.

Siège social: L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.

R.C.S. Luxembourg B 194.687.

L'an deux mille quinze, le vingt-six juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «KN Business and Management», avec

siège social à L-6143 Junglinster, 4A, rue J.P. Ries, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 194.687, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 février 2015,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 847 du 27 mars 2015.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Cheikh-Ibrahima NIANG, gérant de sociétés, né à Sokone (Sé-

négal), le 28 septembre 1978, demeurant à L-1611 Luxembourg, 31, Avenue de la Gare.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude KREMER, gérant de

sociétés, né à Luxembourg, le 19 mars 1977, demeurant à L-6143 Junglinster, 4a rue J.P. Ries.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social vers L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 4 des statuts.
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa

de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille euros.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cheikh -Ibrahima NIANG, Claude KREMER, Jean SECKLER.

111544

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 1 

er

 juillet 2015. Relation GAC/2015/5508. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015115664/54.
(150123808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Pentagon Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 33.572.654,05.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 153.017.

EXTRAIT

Il est à noter que les transferts suivants de parts sociales de la Société ont été effectués le 26 juin 2015:
- Apax Europe VI Nominees Ltd., associé de la Société, a transféré (i) 177.199.737 parts sociales préférentielles et (ii)

51.511.552 parts sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock 6-A S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant
son siège sociale 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.484 («Pentagon Lock 6-A»);

- Apax Europe VI Nominees Ltd., associé de la Société, a contribué (i) 1.087.807 parts sociales préférentielles et (ii)

316.223 parts sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock 6-A;

- Apax Europe VI Nominees Ltd., associé de la Société, a transféré (i) 214.033 parts sociales préférentielles et (ii) 62.219

parts sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social
1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 197.454 («Pentagon Lock»);

- Apax Europe VI Nominees Ltd., associé de la Société, a contribué (i) 1.314 parts sociales préférentielles et (ii) 382

parts sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock;

- Apax Europe VII Nominees Ltd., associé de la Société, a transféré (i) 160.021.548 parts sociales préférentielles et (ii)

46.517.893 parts sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock 7-A S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant
son siège sociale 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.485 («Pentagon Lock 7-A»);

- Apax Europe VII Nominees Ltd., associé de la Société, a contribué (i) 982.352 parts sociales préférentielles et (ii)

285.567 parts sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock 7-A;

- Apax Europe VII Nominees Ltd., associé de la Société, a transféré (i) 301.119.567 parts sociales préférentielles et (ii)

87.534.759 parts sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock;

- Apax Europe VII Nominees Ltd., associé de la Société, a contribué (i) 1.848.535 parts sociales préférentielles et (ii)

537.365 parts sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock;

- Apax US VII, L.P., associé de la Société, a transféré (i) 34.742.130 parts sociales préférentielles et (ii) 10.099.457

parts sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock US S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège
sociale 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 197.483 («Pentagon Lock US»);

- Apax US VII, L.P., associé de la Société, a contribué (i) 213.278 parts sociales préférentielles et (ii) 61.999 parts

sociales ordinaires de la Société à Pentagon Lock US;

Il est à noter que suite à ces transferts:
- Apax Europe VI Nominees Ltd. n'est plus associé de la Société;
- Apax Europe VII Nominees Ltd. n'est plus associé de la Société;
- Apax US VII, L.P. n'est plus associé de la Société;
- Pentagon Lock, nouvel associé de la Société, détient (i) 303.183.449 parts sociales préférentielles et (ii) 88.134.725

parts sociales ordinaires de la Société;

- Pentagon Lock 6-A, nouvel associé de la Société, détient (i) 178.287.544 parts sociales préférentielles et (ii) 51.827.775

parts sociales ordinaires de la Société;

- Pentagon Lock 7-A, nouvel associé de la Société, détient (i) 161.003.900 parts sociales préférentielles et (ii) 46.803.460

parts sociales ordinaires de la Société;

- Pentagon Lock US, nouvel associé de la Société, détient (i) 34.955.408 parts sociales préférentielles et (ii) 10.161.456

parts sociales ordinaires de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

111545

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015115842/54.
(150124246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Caribou Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 90.946.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le vingt neuf juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Geoffrey AREND, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
Madame Brigitte Hubmann-Ballabey, demeurant au 17 chemin des Murailles CH-1233 Sezenove, Suisse,
ci-après dénommée: "le mandant",
en vertu d'une procuration lui donnée à Genève, le 19 juin 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:
I.- Que la société "CARIBOU FINANCES S.A.", une société anonyme, établie et ayant son siège social au 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
90946, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié en date du 20 décembre 2002, publié au Mémorial
C numéro 242 du 6 mars 2003.

II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à trente et un mille euro (31,000.- EUR), représenté par trois cents

(310.-) actions d'une valeur de cent euro (100.- EUR) chacune, intégralement libérées.

III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société ""CARIBOU FINANCES S.A.", a décidé de procéder à la

dissolution de ladite société.

V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société "CARIBOU

FINANCES S.A.", pré désignée.

VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare reprendre tous actifs, dettes et autres engagements de

la société dissoute, et assume la responsabilité des dettes et autres engagements connus et/ou inconnus de la société ainsi
que toutes les dettes envers les tiers n'ayant pas été réglées ou ne figurant pas dans les comptes de la société.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur unique de la société dissoute pour l'exécution son

mandat jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la

société.

Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. AREND, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 06 juillet 2015. Relation: EAC/2015/15683. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015115304/44.
(150124919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Euro Ethnic Foods Global, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 135.990.

Le bilan abrégé au 30 juin 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

111546

L

U X E M B O U R G

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2015115444/10.
(150124052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

COF III Structured Finance Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 183.007.

Les comptes annuels pour la période du 19 décembre 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2014 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2015.

Référence de publication: 2015115334/11.
(150124380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

D-Tech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 29.415.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le deux juillet.
par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Dionysios dit Dennis TSICHRITZIS, administrateur de sociétés, né à Athènes, Grèce, le 29 mai 1943, de-

meurant 2, route de Florissant, CH-1206 Genève;

«le Mandant»
ici représenté par Monsieur Frederic MATHOUILLOT, demeurant professionnellement à Luxembourg,
«le Mandataire»
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le

notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le Mandant, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses décla-

rations et constatations:

1. Que la société anonyme luxembourgeoise «D-Tech S.A.», ci-après "la Société", avec siège social à 11, Boulevard

Royal L - 2449 Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous B 29415, a été constituée par acte reçu le 6
décembre 1988, publié au Mémorial C n°60 du 9 mars 1989 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte du
29 décembre 1999, publié au Mémorial C n°232 du 27 mars 2000.

2. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros)

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
entièrement libérées.

3. Que le Mandant est actuellement propriétaire de toutes les actions et titres représentatifs du capital de la Société.
4. Que l'activité de la Société a cessé et que le Mandant, en sa qualité d'actionnaire unique, décide la dissolution volontaire

et anticipée de la Société avec effet immédiat et se nomme liquidateur de celle-ci.

5. Que le Mandant, en sa qualité de liquidateur de la Société, requiert le notaire d'acter que tout le passif de la Société

est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné.

6. Que le Mandant, en sa qualité d'actionnaire unique, déclare assumer irrévocablement et solidairement avec la Société

l'obligation de payer tout les engagements de celle-ci et tous ses passifs éventuels qui seraient actuellement inconnus et
non payés à l'heure actuelle.

7. Qu'elle a une parfaite connaissance de l'emploi des valeurs sociales ainsi que des comptes, pièces comptables et de

la gestion de la liquidation, qu'elle renonce à l'intervention d'un commissaire-vérificateur et que partant, la liquidation de
la Société est à considérer comme définitivement faite et clôturée.

8. Que le Mandant donne décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration et au commissaire de la

Société.

9. Que le Mandataire ou le notaire peut procéder à l'annulation du registre des actions de la société.
10.  Que  les  livres  et  documents  de  la  société  dissoute  seront  conservés  pendant  cinq  ans  au  siège  de  BDO  Tax  &amp;

Accounting, société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 147571.

111547

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à

raison de cet acte, est dès lors évalué à 950,- EUR

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au Mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: Frederic MATHOUILLOT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 juillet 2015. Relation GAC/2015/5653. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015115361/53.
(150124764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Direx, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 166.881.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115387/9.
(150124267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Daming Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 99, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 131.371.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le trente juin.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Albert DAMING, commerçant, demeurant à L-2124 Luxembourg 99, rue des Maraîchers, né à Colmarberg,

le 13 mai 1946,

«le comparant»
ici représenté par Monsieur Romain HILGER, employé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg,

«le mandataire»
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le

notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le comparant, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

1. Que la société à responsabilité limitée Daming Soparfi S. à r. l., R.C.S. Luxembourg B 131.371, ayant son siège social

au 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, a été constituée le 20 juillet 2007 suivant acte reçu par Maître Paul
BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2265 du
10 octobre 2007.

2. Que le capital social de la société Daming Soparfi S. à r. l. s'élève actuellement à EUR 12.394,68 (douze mille trois

cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales, entièrement libérées.

3. Que le comparant est le propriétaire de la totalité des parts sociales représentatives du capital souscrit de la société

Daming Soparfi S. à r. l.

4. Que le comparant, en tant qu'associé unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que l'activité de la société Daming Soparfi S. à r. l. a cessé; que l'associé unique est investi de tout l'actif et qu'en sa

qualité de liquidateur il réglera tout le passif, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant unique de la société.
7. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société

dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

111548

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Romain HILGER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 juillet 2015. Relation GAC/2015/5576. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2015115372/42.
(150123878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Kandira S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 53.301.

L'an deux mille quinze, le premier juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de "KANDIRA S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 53301, ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l'Eau, transféré au Grand-Duché de Luxembourg par acte de Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 20 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 100
du 27 février 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant profession-

nellement à Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc KOEUNE, précité.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les soixante (60) actions d'une

valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de soixante mille
francs suisses (CHF 60.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous
les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal

ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs suisses (CHF)

en euros (EUR) avec effet au 22 juin 2015 et au cours en vigueur au 22 juin 2015 défini par la banque centrale européenne.

2. Modification afférente de l'article 3 alinéa 1 

er

 des statuts;

3. Démission de trois administrateurs en la personne de Messrs. Emilio BIANCHI, Madame Maria Christina CARLINI

et Madame Bona GUIDOBONO CAVALCHINI et décharge à leur accorder;

4. Nomination de quatre administrateurs supplémentaires.
5. Création de deux catégories d'administrateurs A et B.
6. Modifications des pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société.
7. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective et détermination de leurs pouvoirs de signature respectifs.
8. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoirs quant à la gestion journalière de la société.
9. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée,

a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et décide de changer la devise du capital

social de francs suisses en euros avec effet au 22 juin 2015 et au cours en vigueur au 22 juin 2015 défini par la banque
centrale européenne de CHF 1,0435 pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est fixé à cinquante-sept mille
quatre cent quatre-vingt-dix-huit euro et quatre-vingts cents (EUR 57.498,80)

111549

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 alinéa 1 

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

 Art. 3. Alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-

vingts cents (EUR 57.498,80) représenté par 60 (soixante) actions sans valeur nominale."

<i>Troisième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de trois administrateurs en la personne Messrs. Emilio BIANCHI, Madame

Maria Christina CARLINI et Madame Bona GUIDOBONO CAVALCHINI.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs sortants.

<i>Quatrième résolution

Il est procédé à la nomination de quatre administrateurs supplémentaires:
- Monsieur Nicola WULLSCHLEGER, administrateur de sociétés, né le 29 juillet 1967 à Sorengo Suisse, et domicilié

professionnellement au 2a, Via alla Campagna, 6904 Lugano -Suisse

- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an

2020.

<i>Cinquième résolution

Il est créé deux catégories d'administrateurs A et B, administrateurs auxquels l'assemblée donnera pouvoir de signature

"A" ou pouvoir de signature "B" lors de leur nomination.

En conséquence, il est inséré à l'article 5 des statuts un alinéa qui aura la teneur suivante, les autres alinéas étant renu-

mérotés en conséquence:

Art. 5. Alinéa 2. Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d'un admi-

nistrateur, l'assemblée générale lui donnera pouvoir de signature "A" ou pouvoir de signature "B".

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide que la société se trouvera désormais engagée par les signatures conjointes d'un adminis-

trateur de la catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B.

En conséquence, l'article 5 dernier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 5. Dernier alinéa. La société se trouve engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie

A et d'un administrateur de la catégorie B."

<i>Septième résolution

Les administrateurs de la société sont affectés aux catégories A et B de la manière suivante:
1) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs de la catégorie A:
- Monsieur Pietro GUIDOBONO CAVALCHINI, demeurant à 16, Via Manzoni, I-20124 Milan;
- Monsieur Nicola WULLSCHLEGER, préqualifié;
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs de la catégorie B:
- Monsieur Marc KOEUNE, préqualifié;
- Monsieur Michaël ZIANVENI, préqualifié;
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, préqualifié;

<i>Huitième résolution

Toute référence à une délégation de pouvoirs de la gestion journalière de la société est supprimée.
En conséquence, il est mis fin au mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Pietro GUIDOBONO CAVALCHINI.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, G. Saddi et M. Schaeffer.

111550

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 3 juillet 2015. 2LAC/2015/14948. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): André Muller.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Référence de publication: 2015115656/101.
(150123998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Emerald First Layer "A" S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 78.472.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115398/9.
(150124389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Everget International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.326.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Everget International S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115408/13.
(150124258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Luxsan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 100.392.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2015

Les actionnaires de la société LUXSAN S.A. réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai, ont décidé à l'unani-

mité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs de:
- Madame Magdalena DE ROECK, administrateur de société, B-9770 Kruishoutem, (Administrateur + président du

conseil d'administration)

- Comtesse Caroline ALEXIS D'OULTREMONT, administrateur de société B-9770 Kruishoutem, (Administrateur)
sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de cinq années, soit

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

Suite à la démission de Monsieur Peter VAN MARCKE, l'Assemblée générale décide de nommer:
- la société VAN MARCKE TRADING GROUP en abrégé «VMT», société de droit belge, ayant son siège social à

B-8500 Kortrijk, Weggevoerdenlaan 5, numéro d'entreprise 0437251254 ici représentée par son administrateur-délégué,
Madame Magdalena DE ROECK, demeurant à B-9770 Kruishoutem, 6, Kasteelstraat

au poste d'administrateur pour une période de cinq années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2020.

D'autre part, l'assemblée générale, constatant que les mandats des administrateurs délégués
- Madame Magdalena DE ROECK, administrateur de société, B-9770 Kruishoutem,
sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de cinq années, soit

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

D'autre part, le mandat de:
- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie,

111551

L

U X E M B O U R G

étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de cinq années, soit

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 19 mai 2015.

Référence de publication: 2015115733/32.
(150124239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

S.Invest I S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 174.218.

Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Monsieur Vincent MACHARIS a démissionné de son

mandat d'administrateur de la Société avec effet au 26 août 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2015.

S. INVEST I S.A.
Signature

Référence de publication: 2015145622/13.
(150159079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2015.

Warburg Value Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Koordinierte Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2015145731/8.
(150158641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2015.

Porte des Ardennes Schmiede S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 171.588.

Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Monsieur Vincent MACHARIS a démissionné de son

mandat d'administrateur de la Société avec effet au 26 août 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2015.

PORTE DES ARDENNES SCHMIEDE S.A.
Signature

Référence de publication: 2015145587/13.
(150159081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2015.

Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 175.734.

RECTIFICATIF

Ceci est une mention rectificative suite au dépôt effectué le 14/07/2014 sous le numéro L140120259, concernant le bilan

au 31 décembre 2014 qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115528/11.
(150124710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

111552


Document Outline

Aberdeen Management Services S.A.

Balfin Services S.à r.l.

Balta Finance S.à.r.l.

BRE/Europe 7Q S.à r.l.

Caribou Finances S.A.

COF III Structured Finance Holdings (Lux) S.à r.l.

Daming Soparfi S.à r.l.

Datasud &amp; PC Docter S.àr.l

Direx

D-Tech S.A.

Emerald First Layer "A" S.A.

Eos Lakshmi SA

Euro Ethnic Foods Global

Everget International S.A.

Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l.

Janus Global Technology Fund

Janus Global Technology Fund

Kandira S.A.

KN Business and Management

Leasinvest Immo Lux

Logistikê

LSF9 Balta Investments S.à r.l.

LSF9 Balta Issuer S.A.

LSF9 Balta Issuer S.A.

Lux Insurance Consulting Services S.A.

Lux Life Consulting S.A.

Luxsan S.A.

Marino S.A.

Nathys Conseil s.à r.l.

Pentagon Holdings S.à r.l.

Porte des Ardennes Schmiede S.A.

S.Invest I S.A.

Warburg Value Fund