This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2325
31 août 2015
SOMMAIRE
BPI 16 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111554
CGM Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111574
Erable Rouge Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
111567
Europe Air Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111566
European Public Infrastructure Managers -
EPIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111568
European Robot S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111568
Euro Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111568
Every-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111568
F9 Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111589
FACS C General Partner . . . . . . . . . . . . . . . . .
111570
Facs Investments Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . .
111582
Facs SV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111583
Fair Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111570
Faraway S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111583
Finexeo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111570
Finexim S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111587
FINN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111567
Five Arrows Credit Solutions . . . . . . . . . . . . . .
111570
Five Arrows Credit Solutions General Partner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111570
Five Financials Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
111587
Flexfinance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111587
Fourteen Willow S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111573
Frin Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111589
FR Transport S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111587
FR Transport S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111587
FR Transport S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111588
Générale Alimentaire Franco-Luxembour-
geoise Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111588
Goodman Aventurine Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111599
Goodman Celestite Logistics (Lux) S.à r.l. . . .
111599
Goodman Chrome Logistics (Lux) S.à r.l. . . .
111599
Goodman Coriander Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111599
Jardin de Portugal II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
111600
JR Partnership GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
111600
JR Partnership S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111600
KFK Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111599
Lincoln Investment Fund-SICAV-SIF . . . . . .
111583
Ocalux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111571
Pathway Finance USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111600
Selenium Retail Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
111574
Société d'Etudes et de Réalisations Commer-
ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111568
Swiss Life German CRE S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
111589
WOW SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111583
111553
L
U X E M B O U R G
BPI 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 198.388.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth of June.
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
1. Baupost Limited Partnership 1983 A-1, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583745, (“Baupost LP A-1”);
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.
2. Baupost Limited Partnership 1983 B-1, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583749, (“Baupost LP B-1”);
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private
seal.
3. Baupost Limited Partnership 1983 C-1, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583752, (“Baupost LP C-1”);
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private
seal.
4. Baupost Value Partners, L.P. - I, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered office
at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of Ame-
rica, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3186829, (“BVP-I”);
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private
seal.
5. Baupost Value Partners, L.P. - II, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3191682, (“BVP-II”);
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private
seal.
6. Baupost Value Partners, L.P. - III, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3289794, (“BVP-III”);
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private
seal.
7. Baupost Value Partners, L.P. - IV, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4520054, (“BVP-IV”);
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private
seal.
8. HB Institutional Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583754, (“HBILP”);
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private
seal.
9. PB Institutional Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583757, (“PBILP”);
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private
seal.
10. YB Institutional Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583760, (“YBILP”);
111554
L
U X E M B O U R G
here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private
seal.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated above, have requested the officiating notary to enact the deed of incorpo-
ration of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following
articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
BPI 16 S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind, or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one million
two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
111555
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers which shall be composed of one or more class A managers (the “Class A Manager(s)”) and one
or more class B managers (the “Class B Manager(s)”).
13.2 Any reference made hereinafter to the “managers” shall in such case be construed as a reference to the Class A
Manager(s) and/or the Class B Manager(s), depending on the context and as applicable. If the Company is managed by
one manager, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is to be construed as a reference
to the sole manager.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
111556
L
U X E M B O U R G
13.4 The board of managers shall respect any requirements for approval by the majority shareholders of matters set forth
in any agreement among the shareholders, as may be amended or replaced from time to time.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The managers shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital and in accordance with the provisions of
any agreement between the shareholders, as such agreement may from time to time be amended or replaced.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager. In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal
incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time
not exceeding the initial mandate of the replaced manager in accordance with the provisions of any agreement between the
shareholders, as such agreement may from time to time be amended or replaced, by the remaining managers until the next
meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal pro-
visions.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B
Manager are present or represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by the vote of a majority of managers present or represented at such meeting, including
at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager present or represented subject to any agreement between
the shareholders, as may be amended or replaced from time to time.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall
be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any) or by one (1)
Class A Manager together with one (1) Class B Manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in
judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by one (1) Class A Manager together with
one (1) Class B Manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
joint signatures of one (1) Class A Manager together with one (1) Class B Manager, or (ii) by the joint signatures of any
person to whom such power to sign may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.
111557
L
U X E M B O U R G
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares issued have been subscribed as follows
111558
L
U X E M B O U R G
1. One hundred eleven thousand two hundred and fifty (111,250) shares have been subscribed by Baupost LP A-1
aforementioned, for the price of one thousand one hundred twelve euro and fifty cents (EUR 1,112.50), wholly allocated
to the share capital of the Company.
2. Forty-three thousand eight hundred seventy-five (43,875) shares have been subscribed by Baupost LP B-1 afore-
mentioned, for the price of four hundred thirty-eight euro and seventy-five cents (EUR 438.75), wholly allocated to the
share capital of the Company.
3. Two hundred forty-five thousand two hundred fifty (245,250) shares have been subscribed by Baupost LP C-1 afo-
rementioned, for the price of two thousand four hundred fifty-two euro and fifty cents (EUR 2,452.50), wholly allocated
to the share capital of the Company.
4. Seventy thousand (70,000) shares have been subscribed by BVP-I aforementioned, for the price of seven hundred
euro (EUR 700), wholly allocated to the share capital of the Company.
5. Ninety thousand seven hundred fifty (90,750) shares have been subscribed by BVP-II aforementioned, for the price
of nine hundred seven euro and fifty cents (EUR 907.50), wholly allocated to the share capital of the Company.
6. Thirty-five thousand (35,000) shares have been subscribed by BVP-III aforementioned, for the price of three hundred
fifty euro (EUR 350), wholly allocated to the share capital of the Company.
7. Five hundred fourteen thousand one hundred twenty-five (514,125) shares have been subscribed by BVP- IV afore-
mentioned, for the price of five thousand one hundred forty-one euro and twenty-five cents (EUR 5,141.25), wholly
allocated to the share capital of the Company.
8. Seventy-three thousand six hundred twenty-five (73,625) shares have been subscribed by HBILP aforementioned,
for the price of seven hundred thirty-six euro and twenty-five cents (EUR 736.25), wholly allocated to the share capital of
the Company.
9. Thirty-nine thousand one hundred twenty-five (39,125) shares have been subscribed by PBILP aforementioned, for
the price of three hundred ninety-one euro and twenty-five cents (EUR 391.25), wholly allocated to the share capital of the
Company.
10. Twenty-seven thousand (27,000) shares have been subscribed by YBILP aforementioned, for the price of two
hundred seventy euro (EUR 270), wholly allocated to the share capital of the Company.
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been evidenced to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
<i>Class A Manager:i>
(i) Mr. Collin J. Beecroft, born in San Diego, California, United States of America, on 22 August 1961, having his
professional address at The Baupost Group, L.L.C., 10 Saint James Avenue, Suite 1700, Boston, Massachusetts 02116,
United States of America; and
<i>Class B Managers:i>
(i) Ms. Sonia Baldan, born in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 27 January 1960, having her professional
address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; and
(ii) Ms. Antonella Graziano, born in Orvieto (Italy) on 20 January 1966, having her professional address at 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
111559
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le trente juin.
Pardevant le soussigné notaire Carlo WERSANDT, de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1. Baupost Limited Partnership 1983 A-1, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son
siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583745, («Baupost
LP A-1»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, demeurant professionnellement
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
2. Baupost Limited Partnership 1983 B-1, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son
siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3 3583749, («Baupost
LP B-1»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
3. Baupost Limited Partnership 1983 C-1, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son
siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583752, («Baupost
LP C-1»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
4. Baupost Value Partners, L.P. - I, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège
social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3186829, («BVP-I»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
5. Baupost Value Partners, L.P. - II, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège
social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3191682, («BVP-II»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
6. Baupost Value Partners, L.P. - III, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège
social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3289794, («BVP-III»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
7. Baupost Value Partners, L.P. - IV, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège
social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 4520054, («BVP-IV»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
8. HB Institutional Limited Partnership, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège
social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583754, («HBILP»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
9. PB Institutional Limited Partnership, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège
social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583757, («PBILP»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
10. YB Institutional Limited Partnership, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son
siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583760, («YBILP»);
dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
111560
L
U X E M B O U R G
Les procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire instrumentant resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution
d'une société à responsabilité limitée qu'elles souhaitent constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «BPI 16 S.à r.l.» (ci-après
la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit, ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par un million deux
cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
111561
L
U X E M B O U R G
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous
réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil
de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A (le(s) «Gérant(s) de Catégorie A») et d'un ou plusieurs
gérant(s) de catégorie B (le(s) «Gérant(s) de Catégorie B»).
13.2 Toute référence faite aux «gérants» ci-après devra être entendue comme une référence au(x) Gérant(s) de Catégorie
A et/ou au(x) Gérant(s) de Catégorie B, selon le contexte et le cas échéant. Lorsque la Société est gérée par un gérant
unique, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme une référence au gérant unique.
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
13.4 Le conseil de gérance doit respecter toutes conditions posées pour l'approbation par les associés majoritaires de
tous points prévus dans toute convention entre les associés, telle que modifiée ou remplacée de temps à autre.
111562
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur rémunération et la durée de leur
mandat.
14.2 Les gérants sont nommés et peuvent être librement révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision
des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société et conformément aux dispositions de toute
convention entre les associés telle que modifiée ou remplacée de temps à autre.
Art. 15. Vacance d'un poste de gérant. Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à
l'incapacité juridique, la faillite, la démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire
et pour une période ne pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé, conformément aux disposition de toute
convention entre les associés, modifiées ou remplacées de temps à autre, par les gérants restants jusqu'à la prochaine
assemblée des associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures à
l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle
urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites, approuvées
et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres
du conseil de gérance.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un
(1) Gérant de Catégorie B sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance.
17.6 Les décisions sont prises par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion comprenant au
moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B présents ou représentés sous réserve de toute convention
entre les associés, telle que modifiée ou remplacée de temps à autre.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de
gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire et le secrétaire (le cas
échéant), ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés
par le président, ou par un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B.
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature conjointe d'un (1) Gérant de Classe A et d'un (1) Gérant de Classe B, ou (ii) par la signature conjointe de toutes
111563
L
U X E M B O U R G
personnes auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette
délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente et un décembre de la même année.
Art. 22. Comptes annuels et distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
111564
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et paiementi>
Les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales émises ont été souscrites comme suit:
1. cent onze mille deux cent cinquante (111.250) parts sociales ont été souscrites par Baupost LP A-1, susmentionnée,
pour un prix de mille cent douze euro et cinquante centimes (EUR 1.112,50), entièrement affecté au capital social.
2. quarante-trois mille huit cent soixante-quinze (43.875) parts sociales ont été souscrites par Baupost LP B-1, susmen-
tionnée, pour un prix de quatre cent trente-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 438,75), entièrement affecté au
capital social.
3. deux cent quarante-cinq mille deux cent cinquante (245.250) parts sociales ont été souscrites par Baupost LP C-1,
susmentionnée, pour un prix de deux mille quatre cent cinquante-deux euros et cinquante centimes (EUR 2.452,50), en-
tièrement affecté au capital social.
4. soixante-dix mille (70.000) parts sociales ont été souscrites par BVP-I, susmentionnée, pour un prix de sept cents
euros (EUR 700), entièrement affecté au capital social.
5. quatre-vingt-dix mille sept cent cinquante (90.750) parts sociales ont été souscrites par BVP-II, susmentionnée, pour
un prix de neuf cent sept euros et cinquante centimes (EUR 907,50), entièrement affecté au capital social.
6. trente-cinq mille (35.000) parts sociales ont été souscrites par BVP-III, susmentionnée, pour un prix de trois cent
cinquante euros (EUR 350), entièrement affecté au capital social.
7. cinq cent quatorze mille cent vingt-cinq (514.125) parts sociales ont été souscrites par BVP-IV, susmentionnée, pour
un prix de cinq mille cent quarante et un euros et vingt-cinq centimes (EUR 5.141,25), entièrement affecté au capital social.
8. soixante-treize mille six cent vingt-cinq (73.625) parts sociales ont été souscrites par HBILP, susmentionnée, pour
un prix de sept cent trente-six euros et vingt-cinq centimes (EUR 736,25), entièrement affecté au capital social.
9. trente-neuf mille cent vingt-cinq (39.125) parts sociales ont été souscrites par PBILP, susmentionnée, pour un prix
de trois cent quatre-vingt-onze euros et vingt-cinq centimes (EUR 391,25), entièrement affecté au capital social.
10. vingt-sept mille (27.000) parts sociales ont été souscrites par YBILP, susmentionnée, pour un prix de deux cent
soixante-dix euros (EUR 270), entièrement affecté au capital social.
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Résolutions des associési>
Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de
convocation, ont adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de Catégorie A:i>
(i) Monsieur Collin J. Beecroft, né à San Diego, California, Etats-Unis d'Amérique, le 22 août 1961, résidant profes-
sionnellement auprès de The Baupost Group, LLC, 10 Saint James Avenue, Suite 1700, Boston, Massachusetts 02116,
Etats-Unis d'Amérique; et
<i>Gérants de Catégorie B:i>
(i) Madame Sonia Baldan, née à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 janvier 1960, résidant profession-
nellement au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, et
(ii) Madame Antonella Graziano, née à Orvieto (Italie), le 20 janvier à 1966, résidant professionnellement au 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande des comparantes que le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. A. AGUERRE ENRIQUEZ, C. WERSANDT.
111565
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 juillet 2015. 2LAC/2015/14747. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 13 juillet 2015.
Référence de publication: 2015115264/659.
(150124967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Europe Air Service S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 105.302.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le trente juin.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Gaël DESPREAUX, pilote d'avions, demeurant au 68, rue de l'Espéranto, F-85540 Moutiers-les-Mauxfaits,
«le mandant»
ici représenté par Monsieur Philippe PONSARD, employé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg,
«la mandataire»
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Le mandant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses décla-
rations et constatations:
1. Que la société Europe Air Service S.A., R.C.S. Luxembourg B 105302, ayant son siège social au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été constituée en date du 23 décembre 2004 suivant acte reçu par Maître Joseph EL-
VINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°364 du
22 avril 2005.
2. Que le capital social de la société s'élève actuellement à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310
(trois cent dix) actions de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées.
3. Que le mandant est devenu propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital souscrit de la société
anonyme Europe Air Service S.A.
4. Que le mandant, en tant qu'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la société Europe Air Service S.A., déclare que l'activité de la société
Europe Air Service S.A a cessé, qu'en tant qu'actionnaire unique, il est investi de tout l'actif et qu'en sa qualité de liquidateur
il s'engage à régler tout le passif, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
6. Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes
de la société.
7. Que le mandataire ou le notaire peut procéder à l'annulation du registre des actions de la société.
8. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de CF Corporate Services.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à
raison de cet acte, est dès lors évalué à EUR 1,000.-
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par ses nom, prénom,
état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Philippe PONSARD, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 juillet 2015. Relation GAC/2015/5577. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2015115406/46.
(150123955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
111566
L
U X E M B O U R G
FINN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20A, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 152.171.
<i>Auszug aus dem Protokoll der aussergewöhnlichen Aktionnärvollversammlung vom 26. Juni 2015i>
Das Aktionnariat hat folgendes beschlossen:
<i>1. Beschlußi>
Die Aktionnäre nehmen die Niederlegung des Mandats vom alleinigen Verwaltungsrat H. Stefan SELIGSON an.
<i>2. Beschlußi>
Neue Verwaltungsratmitglieder werden:
i) H. Stephan SCHMIT, Unternehmer, geboren am 4. Mai 1978 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-8079 Bertrange
117a, rue de Leudelange
ii) H. Christophe SCHMIT, Unternehmer, geboren am 31. Mai 1979 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-8079
Bertrange 117a, rue de Leudelange
iii) H. Marc PELLER, Unternehmer, geboren am 31. August 1954 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1630 Lu-
xembourg 46, rue Glesener
iv) Fr. Laura Anne PELLER, Studentin, geboren am 11. Januar 1991 in Luxemburg, wohnhaft in L-8356 Garnich 4, rue
am Brill.
Alle Mandate sind gültig bis zur Generalvollversammlung die im Jahre 2021 stattfinden wird.
<i>3. Beschlußi>
Herr Stephan SCHMIT und Herr Marc PELLER werden beide zu Bevollmächtigten des Aufsichtrates zur Ausführung
der täglichen Geschäftsführung bestimmt und können somit die Gesellschaft durch ihre jeweils alleinige Unterschrift unter
allen Umständen verpflichten.
<i>4. Beschlußi>
Die Aktionnäre nehmen die Niederlegung des Mandats des Kommissars Lux-Fiduciaire Consulting SARL an
<i>5. Beschlußi>
Die Gesellschaft COMSERV SARL, RCS B 195.591, mit Sitz in L-2210 Luxembourg 54, Boulevard Napoléon 1
er
wird zum neuen Kommissar ernannt bis zur Generalvollversammlung die im Jahre 2021 stattfinden wird.
<i>6. Beschlußi>
Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach L-2210 Luxembourg 54, Boulevard Napoléon 1
er
Pour extrait conforme
Fidcoserv SARL
Unterschrift
Référence de publication: 2015115499/36.
(150124006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Erable Rouge Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 170.154.
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015115435/11.
(150123856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
111567
L
U X E M B O U R G
Euro Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 76.618.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115445/10.
(150124206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
European Public Infrastructure Managers - EPIM, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 115.604.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115446/10.
(150124086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
European Robot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue Louis Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 103.690.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115447/10.
(150124094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Every-1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.
R.C.S. Luxembourg B 175.778.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115449/9.
(150124361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
SOEREC, Société d'Etudes et de Réalisations Commerciales, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 70.637.
L'an deux mil quinze, le deux juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISA-
TIONS COMMERCIALES, en abrégé SOEREC S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 70.637, constituée suivant acte
reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 18 juin 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 719 du 28 septembre 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant assemblée
générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 7 mai 2002, dont un extrait a été publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 1574 du 2 novembre 2002.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.
111568
L
U X E M B O U R G
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Arlette Siebenaler, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification des articles 6 et 9 des statuts.
2. Constat des mandats expirés des administrateurs, administrateur-délégué et du commissaire aux comptes.
3. Nomination de Monsieur Jean Naveaux comme administrateur unique.
4. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier les articles 6 et 9 des statuts comme suit:
« Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant
au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société
n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-
més ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.»
« Art. 9. La société sera engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de toute personne à qui de pareils pouvoirs auront été délégués par le Conseil d'administration. Au cas où le Conseil
d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur
unique.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate que le mandat de tous les administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes
sont expirés.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide nommer comme administrateur unique:
Monsieur Jean NAVEAUX, né à Villers-la-Loue (Belgique), le 30 avril 1943, demeurant professionnellement à L-2163
Luxembourg, 29, avenue Monterey.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes:
MONTEREY AUDIT S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, RCS Luxembourg
B 78967.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
111569
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/20938. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Référence de publication: 2015115945/74.
(150125161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Fair Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 135.181.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115453/10.
(150123980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Finexeo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54-56, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 118.255.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115466/10.
(150124100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Five Arrows Credit Solutions, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-
sement Spécialisé.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 176.608.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115468/10.
(150124478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Five Arrows Credit Solutions General Partner, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 175.983.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115469/9.
(150124477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
FACS C General Partner, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 182.764.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115480/9.
(150124476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
111570
L
U X E M B O U R G
Ocalux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 137.839.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of June.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
DOGWOOD LIMITED, a company organized and incorporated under the laws of Jersey, having its registered office
at 37 Esplanade, 3
rd
Floor, JE23QA St Helier, JERSEY, registered with the Jersey Financial Services Commission under
number 98695 (the “Sole Shareholder”),
duly represented by Emmanuel REVEILLAUD, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse by
virtue of a proxy dated June 10
th
, 2015.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that the Sole Shareholder is the sole shareholder of OCALUX Sàrl, a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), having its registered office at L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, registered with the
Luxembourg trade and companies register under number B 137.839, incorporated by a deed received by Maître Joseph
Elvinger, notary then residing in Luxembourg, on March 31, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 1150 on May 9, 2008 (the “Company”),
II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Company, according to the agenda
below:
<i>Agendai>
1. Amendment of article 9.1 of the articles of incorporation of the Company;
2. Amendment of article 12 of the articles of incorporation of the Company;
3. Insertion of article 12bis in the articles of incorporation of the Company;
4. Any other business.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 9.1 of the articles of association of the Company which shall be read as
follows:
“ 9.1. The Corporation shall be managed by a board of managers composed, at least, of two managers, who do not need
to be members and who will be appointed pursuant to a resolution of the general meeting of members. The board of managers
shall be composed of two classes of managers (A and B).”
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 12 of the articles of association of the Company which shall be read as
follows:
“ Art. 12. Representation. Except as provided in article 12bis below and up to the limit allowed or essentials therein,
the Corporation shall be bound by the joint signature of one manager class A and one manager class B in any case and for
any amount or by the sole or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been
delegated by the board of managers.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to insert article 12bis. Bank powers to the articles of association which shall be read as
follows:
“ Art. 12bis. Bank powers.
12bis. 1 The general meeting of members shall determine the relevant applicable banking powers of the Corporation as
well as the restrictions thereof.
The general meeting of members is the competent body to appoint one or more duly authorized signatory agent(s)
(hereinafter the "Officer(s) C") in respect of one or more bank accounts (hereinafter the "Bank Account") of the Corporation
of any type (including but not limited to cash account, custodian account, brokerage account) in any jurisdiction.
12bis. 2 The bank powers (including the appointment and removal of Officer(s) C) as defined according to article 12bis.
1 first sentence, above may only be revoked and/or amended by a general meeting of members exclusively (excluding any
decision passed by the board of managers).
111571
L
U X E M B O U R G
12bis. 3 The operation of any of the Bank Accounts of the Corporation (including but not limited to execution, delivery,
of any documents, instructions) (whether in Luxembourg or elsewhere) as well as funds and/or securities transfers, ins-
tructed by the Corporation in excess of USD 10,000.- (ten thousand US dollars) (or its equivalent in another currency) will
be made validly and duly only upon the joint signature of any of the managers (regardless of the class to which such manager
belongs) and any Officer C, with the exception that the board of managers may authorize, for specific investment determined
by the board of managers only, any Officer C to execute alone funds and/or securities transfer instructions.
12bis. 4 The prior approval of the general meeting of the members of the Corporation is required for the opening and/
or closing of Bank Account, as well as the related powers, of the subsidiary(ies) of the Corporation.”
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed have been estimated at about EUR 900.- (nine hundred euro).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is
closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by
his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte que précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf juin.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
DOGWOOD LIMITED, une société constituée et établie sous le droit de l'Etat de Jersey ayant son siège social situé à
37 Esplanade, 3
rd
Floor, JE23QA St Helier, JERSEY, inscrite auprès de Jersey Financial Services Commission sous le
numéro 98695 (l'«Associé Unique»),
dûment représentée par Emmanuel REVEILLAUD, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thé-
rèse, en vertu d'une procuration du 10 juin 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la comparante et
par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès-qualité, déclare et demande au notaire:
I. d'acter que l'Associé Unique est l'associé unique de OCALUX Sàrl, une société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, enregistrée auprès du registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.839, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors
de résidence à Luxembourg le 31 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
1150 le 9 mai 2008 (la «Société»),
II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'article 9.1 des statuts de la Société;
2. Modification de l'article 12 des statuts de la Société;
3. Insertion de l'article 12bis dans les statuts de la Société;
4. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 9.1 des statuts de la Société qui doit être lu comme suit:
« 9.1. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé, au moins, de deux gérants, qui n'ont pas besoin d'être
des associés et qui seront nommés par résolution de l'assemblée générale des associés. Le conseil de gérance devra se
composer de deux catégories de gérants (A et B).»
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société qui doit être lu comme suit:
« Art. 12. Représentation. Exception faite des dispositions de l'article 12bis ci-dessous et jusqu'à la limite permise ou
nécessaire, la Société est engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B dans tout les
111572
L
U X E M B O U R G
cas et pour tout montant ou la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été
délégué par le conseil de gérance.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'insérer l'article 12bis. Pouvoirs bancaires dans les statuts de la Société qui doit être lu comme
suit:
« Art. 12bis. Pouvoirs bancaires.
12bis.1 L'assemblée générale déterminera les pouvoirs bancaires applicables appropriés de la Société aussi bien que les
restrictions ci-dessous.
L'assemblée générale est l'organe compétent pour nommer un ou plusieurs agent(s) signataires autorisés (ci-après le/les
«Agent(s) C») en ce qui concerne un ou plusieurs comptes bancaires (ci-après le "Compte Bancaire") de la Société de
chaque type (incluant mais pas limité aux compte de caisse, compte dépositaire, compte de courtage) de chaque juridiction.
12bis.2 Les pouvoirs bancaires (y compris la nomination et révocation de/des Agent(s) C) comme défini à l'article 12bis.
1 première phrase, ci-dessus peuvent seulement être retirés et/ou modifiés par toute décision passée exclusivement par
l'assemblée générale (excluant toute décision passée par le conseil de gérance).
12bis.3 L'opération de tout Compte Bancaire de la Société (y compris mais pas limité à l'exécution de tous documents,
instructions) (au Luxembourg ou ailleurs) ainsi que tous transferts de fonds ou valeurs, instruit par la Société de plus de
USD 10.000,- (dix mille Dollars américains) seront effectués valablement et dûment par la signature conjointe de tout
gérant (peut importe la classe auquel il appartient) et de tout Agent C, par exception, le conseil de gérance peut autoriser,
pour un investissement spécifique déterminé par le conseil de gérance, tout Agent C à exécuter seul des instructions de
transferts de fonds ou valeurs.
12bis.4 L'approbation préalable de l'assemblée générale de la Société est exigée pour l'ouverture et/ou la fermeture de
Compte Bancaire, ainsi que tout pouvoirs y relatifs, de(s) filiale(s) de la Société.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ EUR 900,- (neuf cents euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la
séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état
civil et domicile, ladite comparante a signée avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: REVEILLAUD, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 juillet 2015. Relation: 1LAC / 2015 /20748. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 13 juillet 2015.
Référence de publication: 2015115821/146.
(150125022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Fourteen Willow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 189.556.
Les comptes annuels pour la période du 31 juillet 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2014 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Référence de publication: 2015115475/11.
(150124819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
111573
L
U X E M B O U R G
Selenium Retail Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CGM Lux 1 S.à r.l.).
Capital social: EUR 30.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 125.046.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of the month of June.
Before Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Selenium Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 193.717 (the “Sole Shareholder”),
represented by Maître Vianney de Bagneaux, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated
30 June 2015, which proxy shall be registered with together with the present deed,
The Sole Shareholder is the sole shareholder of CGM Lux 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited
liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, having a share capital of thirty thousand five hundred Euros (EUR 30,500) and
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 125.046 (the "Company"),
incorporated on 9 February 2007 pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 2 May
2007, number 751.
The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the last time on 1 October 2010
pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary then residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,
published in the Mémorial on 18 November 2010, number 2500.
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all the three hundred five (305) shares in issue in the Company so that the total share
capital is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.
2. The items on which resolutions are to be taken are as follows:
(a) Change of the name of the Company into “Selenium Retail Midco S.à r.l.”;
(b) Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety so that they shall read as
set forth in the second resolution below;
(c) Acceptance of the resignation of the managers of the Company and appointment of the new manager of the Company;
(d) Discharge for the resigning managers;
(e) Change of the registered office of the Company.
Thereafter the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company into “Selenium Retail Midco S.à r.l.”.
<i>Second resolutioni>
The Meeting unanimously decided to fully amend and re-state the Company’s articles of association so that they shall
read as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Selenium Retail
Midco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests,
grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.
111574
L
U X E M B O U R G
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at thirty thousand five hundred Euros (EUR 30,500)
represented by three hundred five (305) shares with a nominal value of hundred Euros (EUR 100) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
111575
L
U X E M B O U R G
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability”
and “expenses” shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corpor¬ate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract
or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
111576
L
U X E M B O U R G
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to accept the resignation by Dr. Bernhard Weber and Mr. Detlef Koppenhagen from their
office as managers of the Company with effect as from the date hereof and resolved to appoint with effect as from the date
hereof as manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company
with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company BRE/Management 7 S.A., a société
anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.304.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to grant discharge to Dr. Bernhard Weber and Mr Detlef Koppenhagen as managers of
the Company until 30 June 2015 with respect to the performance of their duties until 30 June 2015.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the registered office of the Company and to fix it at 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at EUR 1,500.-.
111577
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above
appearing party the present deed is worded in English followed by and German translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN,
AM DREIßIGSTEN TAG DES MONATS JUNI.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Selenium Investment S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxembur-
gischen Rechts mit Sitz in 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 193.717 (der „Alleinige Gesellschafter“),
hier vertreten durch Maître Vianney de Bagneaux, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 30. Juni 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei
der Registrierungsbehörde eingericht zu werden,
der Alleinige Gesellschafter ist der alleinige Gesellschafter der CGM Lux 1 S.à r.l., eine société à responsabilité limitée
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg,
deren Gesellschaftskapital dreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 30.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Com-
merce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 125.046 (die «Gesellschaft»), gegründet am 9. Februar 2007
gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, veröffentlich am 2. Mai 2007 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial»), Nummer
751.
Die Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde zuletzt abgeändert am 1. Oktober 2010 gemäß Urkunde aufge-
nommen durch Maître Edouard DELOSCH, Notar mit damaligem Amtsitz in Rambrouch, veröffentlicht am 18. November
2010 im Mémorial, Nummer 2500.
Der Erschienene gibt, in Ausübung seines obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle dreihundertfünf (305) von der Gesellschaft ausgegebenen
Gesellschaftsanteile, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der Tagesordnung
entschieden werden kann.
2. Die Punkte, über die ein Beschluss getroffen werden soll, sind die folgenden:
a) Änderung des Namens der Gesellschaft in „Selenium Retail Midco S.à r.l.“;
b) Änderung und Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamheit, sodass diese wie im zweiten Be-
schluss beschrieben lautet;
c) Annahme des Rücktritts der Geschäftsführer und Ernennung des neuen Geschäftsführers;
d) Entlassung für die zurücktretenden Geschäftsführer;
e) Änderung des Gesellschaftssitzes.
Danach wurden folgende Beschlüsse vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, den Namen der Gesellschaft in „Selenium Retail Midco S.à r.l.“ abzuän-
dern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung hat einstimmig beschlossen die komplette Satzung der Gesellschaft zu ändern und umzuformulieren,
sodass diese wie folgt lautet:
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
“Selenium Retail Midco S.à r.l.” (die “Gesellschaft”) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
111578
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream als auch side-stream Bürgschaften), Sicherheiten
leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf dreißigtausend-
fünfhundert Euro (EUR 30.500), eingeteilt in dreihundertfünf (305) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert
Euro (EUR 100).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
111579
L
U X E M B O U R G
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage”, „Streitsache”, „Prozess” oder
„Verfahren” finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit”
und „Ausgaben” beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
111580
L
U X E M B O U R G
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
111581
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, den Rücktritt von Dr. Bernhard Weber sowie Herrn Detlef Koppenhagen
vom Amt des Geschäftsführers des Unternehmens mit Wirkung ab heutigem Datum zu akzeptieren. Des Weiteren hat der
Alleinige Gesellschafter mit Wirkung ab heutigem Datum beschlossen, BRE/Management 7 S.A., eine société anonyme
luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 180.304, vorbehaltlich der Satzung der Gesellschaft auf unbestimmte
Zeit, mit wie in der Satzung festgehaltenen Unterschriftsbefugnissen, als neuen Geschäftsführer zu ernennen.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Dr. Bernhard Weber sowie Herrn Detlef Koppenhagen in ihrer Funktion
als Geschäftsführer bis zum 30. Juni 2015, in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bis zum 30. Juni 2015 Entlastung
zu gewähren.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen den Sitz der Gesellschaft zu ändern, und ihn auf 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburg festzulegen.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte
entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 1.500,-.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage
der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung
maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei der dem
amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe zusammen mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: V. DE BAGNEAUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/20620. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 13. Juli 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015115320/490.
(150124489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Facs Investments Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 188.179.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115481/9.
(150124480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
111582
L
U X E M B O U R G
Facs SV, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, Place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 179.027.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115482/9.
(150124479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Lincoln Investment Fund-SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 184.068.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement commercial VI no 830/2015 du 9 juillet 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième
section, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société en commandite
par actions LINCOLN INVESTMENT FUNDSICAV-SIF, société d'investissement à capital variable, fonds d'investisse-
ment spécialisé, en vertu de l'article 47 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés.
Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Anita LECUIT, juge au tribunal d'arrondissement de et à Lu-
xembourg, et désigné comme liquidateur Maître Laurent BIZZOTTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les créanciers sont invités à déposer leurs déclarations de créances au greffe du tribunal de commerce de ce siège avant
le 30 juillet 2015.
Luxembourg, le 13 juillet 2015.
Pour extrait conforme
Laurent BIZZOTTO
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015115683/21.
(150125132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Faraway S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 180.700.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115484/10.
(150123815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
WOW SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9638 Pommerloch, Centre commercial "Knauf Center".
R.C.S. Luxembourg B 198.385.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le huitième jour de juillet.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Distrifashion, une société anonyme, régie selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-9638 Pommerloch,
Centre Commercial «KNAUF CENTER», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 159.790,
ici représentée par Madame Mélanie FRANCOIS, né à Bastogne (Belgique) le 04/08/1980, demeurant professionnel-
lement au L-9638 Pommerloch, Centre Commercial «Knauf Center», en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing
privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
111583
L
U X E M B O U R G
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée
qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La société a pour objet le commerce de vêtements et prêt-à-porter hommes, femmes, enfants et le commerce de
tous les articles de la branche, y inclus accessoires, maroquinerie, chaussures et bijoux fantaisie ainsi que toutes opérations
qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
La société a encore pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets.
Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés,
marques commerciales et marques de fabrique, dessins, modèles, logiciels informatiques, noms de domaines et en exploiter,
en céder et en concéder toutes les licences.
La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait faire
partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature
à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception
la plus large.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entre-
prises, associations ou sociétés.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.
De manière générale, la société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation de
son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.
Elle pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifi-
cations des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «WOW SARL».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Winseler.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par
assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et
entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé
unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
111584
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature individuelle d'un gérant technique, soit par la signature de deux gérants dont celle d'un gérant technique.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par
le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration.
Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou
communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de com-
munication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou
par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment,
sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les
questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution
sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circons-
tances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
111585
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois de
mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année, sauf exceptionnellement le premier exercice social qui se termine en décembre 2016.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de
gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libération:i>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante pré-qualifiée, déclare souscrire cent (100) parts sociales
comme suit:
- Distrifashion, une société anonyme, pré-qualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné,
qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante pré-qualifiée, présente ou représentée comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, se considérant comme dûment convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2.- Est nommé gérant technique de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur François HARDY, indépendant, né à Libramont (B), le 10 juin 1981, demeurant à B-6660 HOUFFALIZE,
avenue de la Gare, 19
3.- Est nommé gérante administrative de la Société pour une durée indéterminée:
Madame Leslie OTTO, indépendante, née à Bastogne (B), le 24 juin 1982, demeurant à B-6660 HOUFFALIZE, avenue
de la Gare, 19.
4.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant technique, soit
par la signature de deux gérants dont celle d'un gérant technique.
5.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9638 Pommerloch, Centre Commercial «Knauf Center».
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la partie comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société,
celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social tel que
modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par la partie comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
111586
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. FRANCOIS, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 09 juillet 2015. Relation: DAC/2015/11521. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 10 juillet 2015.
Référence de publication: 2015116083/187.
(150124740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Finexim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 181.243.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115497/9.
(150123937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Five Financials Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 97.469.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115502/10.
(150124350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Flexfinance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 153.015.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115505/9.
(150123803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
FR Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3328 Crauthem, 49, rue de Weiler.
R.C.S. Luxembourg B 151.975.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115509/10.
(150124264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
FR Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3328 Crauthem, 49, rue de Weiler.
R.C.S. Luxembourg B 151.975.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115510/10.
(150124265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
111587
L
U X E M B O U R G
FR Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3328 Crauthem, 49, rue de Weiler.
R.C.S. Luxembourg B 151.975.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115511/10.
(150124266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 192.503.
L'an deux mille quinze, le trois juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, résidant au Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du Conseil d'Administration de la société «Générale Alimentaire Franco-
Luxembourgeoise Holding», une société anonyme existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 192.503, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul MEYERS en date du 21 novembre 2014,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3795 le 27 décembre 2014, la «Société Absorbante»),
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes d'une résolution dudit Conseil d'Administration, prise lors de sa
réunion du 8 mai 2015;
une copie desdites résolutions du Conseil d'Administration est restée annexée au projet de fusion reçu par Maître Jean-
Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 12 mai 2015.
Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et consta-
tations suivantes:
- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée en date du 12 mai 2015, publié au Mémorial C, numéro
1386 du 1
er
juin 2015, la Société, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et la société «WAVECREST
INTERNATIONAL LIMITED», une société anonyme existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 193.395, constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques en date du 8 septembre 1995, et dont le
siège social a été transféré à Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2014, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 le 9 février 2015, en tant que société absorbée (la «Société
Absorbée»), ont projeté de fusionner;
- qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au
Mémorial du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, appelée à
se prononcer sur l'approbation de la fusion;
- qu'en conséquence la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle tant entre les
sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société
Absorbante. De plus, la Société Absorbante exécutera à partir de ce jour tous les contrats et obligations, de quelle que nature
qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à cette date et exécutera en particulier tous
les contrats existant avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant
de ces contrats;
- que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée a cessé d'exister, décharge pleine et entière est accordée aux
administrateurs de la Société;
- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée
seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège
de la Société Absorbante actuellement établi au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- que dès lors les conditions prévues à l'article 281 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée sont remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. GAUTIER, J.J. WAGNER.
111588
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 juillet 2015. Relation: EAC/2015/15838. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015115519/52.
(150125105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
F9 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 185.018.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115513/9.
(150124779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Frin Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5762 Hassel, 2B, Killebierg.
R.C.S. Luxembourg B 145.875.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015115512/10.
(150124095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Swiss Life German CRE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 198.378.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Swiss Life German CRE Holding S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4a rue Albert Borschette, L -
1246 Luxembourg, and to be registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register,
here represented by Mrs. Simone Baier, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-
bourg, on 6 July 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
“Swiss Life German CRE S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
111589
L
U X E M B O U R G
2.5 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
111590
L
U X E M B O U R G
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
111591
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, or
(ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of October of each year and shall end
on the thirtieth of September of the next year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
111592
L
U X E M B O U R G
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 30 September 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Swiss Life German CRE Holding
S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Resolutions of the incorporating shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company, has passed the following resolu-
tions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Vincent Charuel, born on 28 January 1978 in Saint-Quentin, France, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(ii) Jasmin Heitz, born on 28 March 1982 in Saarbrücken, Germany, with professional address at 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
(iii) Matthias Kath-Burdack, born on 29 September 1970 in Jena, Germany, 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
111593
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendundfünfzehn, am sechsten Juli.
Vor uns, Notar Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Swiss Life German CRE Holding S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée) mit Sitz in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, deren
Eintragung im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht;
hier vertreten durch Frau Simone Baier, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6. Juli 2015,
ausgestellt in Luxembourg.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde,
wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche die folgende Satzung haben soll:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen Swiss Life German CRE S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.
2.5 Ein weiterer Gesellschaftszweck ist der Erwerb und Verkauf von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,
deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, Förderung, Verkauf oder Verwaltung von Immobilien ist.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
111594
L
U X E M B O U R G
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus
zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der
überlebenden Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von Ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden.
Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehe-
partner/in oder einem sonstigen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich ge-
fasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt
sein Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesell-
schafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesell-
schafterversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten
werden, wie in der Einberufung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden
an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesell-
schafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben,
kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
111595
L
U X E M B O U R G
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche
Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Ein-
klang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum
zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dring-
lichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer
schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben,
wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen
des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäfts-
führungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
111596
L
U X E M B O U R G
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden, hat
im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls
vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
führer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungs-
rates (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige
Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift
des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige
Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden
ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend
das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen in seiner ge-
änderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschlussgewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober eines jeden Jahres und endet am
dreißigsten September des darauffolgenden Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz
von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.
111597
L
U X E M B O U R G
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage
zugeführt werden müssen, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September
2016.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden sämtlich durch Swiss Life German CRE Holding
S.à r.l., vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) gezeichnet.
Der Preis für die so gezeichneten Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wurde dem Stammkapital zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.800.-geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gründungsgesellschafterini>
Die Gründungsgesellschafterin, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert, hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
(i) Vincent Charuel, geboren am 28. Januar 1978 in Saint-Quentin, Frankreich, geschäftsansässig in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
(ii) Jasmin Heitz, geboren am 28. März 1982 in Saarbrücken, Deutschland, geschäftsansässig in 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
(iii) Matthias Kath-Burdack, geboren am 29. September 1970 in Jena, Deutschland, 4a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei,
dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
111598
L
U X E M B O U R G
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche dem Notar mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: S. BAIER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 7 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/21066. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 13. Juli 2015.
Référence de publication: 2015115963/530.
(150124473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Goodman Aventurine Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 136.616.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115523/9.
(150124816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Goodman Celestite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 158.804.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115525/9.
(150124814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Goodman Chrome Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 179.091.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115526/9.
(150124813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Goodman Coriander Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 164.560.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115527/9.
(150124812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
KFK Group S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 141.964.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu le 18/6/2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale
a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10/8/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation
de la société KFK GROUP S.A. dont le siège social à L-2522 Luxembourg, 6 rue Guillaume Schneider a été dénoncé le
27/10/2011.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg et désigné liquidateur Maître Philippe BARBIER, avocat, demeurant à Luxembourg.
111599
L
U X E M B O U R G
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 10/7/2015 au greffe de la 6
ème
chambre de
ce tribunal.
Pour extrait conforme
Maître Philippe BARBIER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015115657/18.
(150124058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Jardin de Portugal II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 33, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 97.722.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ainsi que les informations et documents annexés ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015115630/10.
(150124752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
JR Partnership GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 152.919.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015115637/10.
(150124687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
JR Partnership S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 2.000,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 152.947.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015115638/10.
(150124195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Pathway Finance USD, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 19.375,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 166.259.
Il est porté à la connaissance de tous que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015115839/11.
(150124381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
111600
BPI 16 S.à r.l.
CGM Lux 1 S.à r.l.
Erable Rouge Holding S.A.
Europe Air Service S.A.
European Public Infrastructure Managers - EPIM
European Robot S.à r.l.
Euro Properties S.à r.l.
Every-1
F9 Holding S.à r.l.
FACS C General Partner
Facs Investments Holdings I S.à r.l.
Facs SV
Fair Partners S.à r.l.
Faraway S.A.
Finexeo S.A.
Finexim S.à r.l.
FINN S.A.
Five Arrows Credit Solutions
Five Arrows Credit Solutions General Partner
Five Financials Holding S.A.
Flexfinance S.A.
Fourteen Willow S.à r.l.
Frin Participations S.A.
FR Transport S.à r.l.
FR Transport S.à r.l.
FR Transport S.à r.l.
Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise Holding
Goodman Aventurine Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Celestite Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Chrome Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Coriander Logistics (Lux) S.à r.l.
Jardin de Portugal II S.à r.l.
JR Partnership GP S.à r.l.
JR Partnership S.C.S.
KFK Group S.A.
Lincoln Investment Fund-SICAV-SIF
Ocalux Sàrl
Pathway Finance USD
Selenium Retail Midco S.à r.l.
Société d'Etudes et de Réalisations Commerciales
Swiss Life German CRE S.à r.l.
WOW SARL