This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2267
26 août 2015
SOMMAIRE
Advice Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108816
AGRE Debt I - Chiswick Holdings S.à r.l. . . .
108816
Blue Car Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108815
Bulco S.àr.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108777
Calumnia Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108772
CEP II Co-Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
108772
Cereplast International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
108771
CEREP Strategic Land S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
108777
Ceria S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108771
Chiron B1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108815
CLdN Bulk S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108772
CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108778
Commex International S.A.-SPF . . . . . . . . . . .
108777
Compagnie de Financements et d'Investisse-
ments Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108777
C.RO Ports S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108816
Duferco International Trading Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108797
Encore Plus Properties III S.à r.l. . . . . . . . . . .
108770
Entourage Commodity Management & Invest-
ment Company S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108816
False Moustache S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108773
GS Lux Management Services S.à r.l. . . . . . . .
108777
Haras de Martelinville Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
108774
H&M Incentive Program S.à r.l. . . . . . . . . . . .
108770
Ikano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108770
Immobilière Marina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
108774
Inbaso S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108772
Inbaso S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108773
Kedi 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108773
Manziana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108775
McCain Finance Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
108773
Midway Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108775
Multi Strategy SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108775
New Old Brewery S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108774
NGP IX Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
108776
NOS Communications S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
108776
NREP NSF 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108776
OCM Luxembourg Beluga Shipco S.àr.l. . . . .
108771
Oresc 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108782
P.E.A.C.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108770
Pentachem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108776
Permira SCF Feeder S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .
108770
Permira SCF IV S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108775
Pinecreek Capital S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
108771
PRESTO Consulting & Consultants S.A. . . . .
108771
Satisco International Holding . . . . . . . . . . . . . .
108789
Select Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108774
Shine France Logistics S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
108802
Sun European Investment III S.à r.l. . . . . . . . .
108780
108769
L
U X E M B O U R G
H&M Incentive Program S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.720.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015108708/9.
(150118457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Encore Plus Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 123.420.
Le bilan au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015109300/10.
(150118792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Ikano S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R.C.S. Luxembourg B 87.842.
Les comptes Consolidés annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015108762/10.
(150118121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Permira SCF Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 156.616.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cédric Pedoni
<i>Gérant de Permira SCF S.à r.l. / Géranti>
Référence de publication: 2015112505/11.
(150120590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 387.650,00.
Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 64.220.
La société PEACE SA, établie et ayant son siège social 14, rue Lentz L-3509 DUDELANGE, immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64 220.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 26/06/2015.
Lionel LAURENT / Steve LAURENT / William LAURENT / Mathias LAURENT
<i>LES ADMINISTRATEURSi>
Référence de publication: 2015112497/14.
(150120350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
108770
L
U X E M B O U R G
PRESTO Consulting & Consultants S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 10, rue Diks.
R.C.S. Luxembourg B 98.769.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015112538/9.
(150120269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Cereplast International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 115.422.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015109195/10.
(150119328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
OCM Luxembourg Beluga Shipco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.518.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112486/10.
(150119712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Pinecreek Capital S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.780,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 140.807.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015112511/12.
(150120068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Ceria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 176.483.
La résolution suivante a été adoptée par les associées en date du 13 mai 2014:
Le mandat de Commissaire de M. Luc Resslen, né le 16 novembre 1958 à Compiègne, France, résidant au 4, rue Van
Der Meulen, Dommeldange, L-2152 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée
appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 28 février 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112977/13.
(150122087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
108771
L
U X E M B O U R G
Inbaso S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 84.640.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109436/10.
(150119481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
CLdN Bulk S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 55.583.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2015i>
Messieurs Paul Traen, Vivek Pathak et Michel Jadot sont renommés administrateurs.
La société BDO AUDIT S.A., réviseur d'entreprises agréé, est renommée réviseur aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
Vivek Pathak / Michel Jadot
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015112992/13.
(150122025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
CEP II Co-Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en
Capital à Risque.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 114.414.
Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 30 juin 2015 que:
1. Erica Kathleen Herberg a démissionné de sa fonction de membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 1
er
juillet 2015:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 juillet 2015.
CEP II Co-Investment S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015112963/15.
(150121561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Calumnia Corporation, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 188.138.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 juin 2015 que la société suivante a été révoquée avec
effet immédiat de ses fonctions de réviseur d'entreprises de la Société:
- Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippman, Parc
d'Activité Syrdall 2, L-5365 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 88019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 2 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112922/16.
(150122233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
108772
L
U X E M B O U R G
Inbaso S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 84.640.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109437/10.
(150119482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Kedi 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.614.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015109470/10.
(150119265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
False Moustache S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 101.247.
<i>Extrait des décisions du liquidateuri>
Le liquidateur décide de transférer le siège social endéans la commune valeur 09/07/2015.
Nouvelle adresse: 11, avenue de la Gare L-1611 LUXEMBOURG
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COPROCESS S.A.
Jean-Paul FELIX
<i>Administrateur-délégué / Liquidateuri>
Référence de publication: 2015113099/14.
(150121572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
McCain Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 89.001,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.651.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 28 mai 2015 que:
1. La démission de Monsieur Michael Crouse, gérant de la Société, a été acceptée avec effet au 28 mai 2015;
2. Monsieur Alain Duranleau né le 9 janvier 1978 à Lausanne, Suisse, résidant professionnellement au Parc Scientifique
de la Haute Borne, 10 rue Hergé, 59650 Villeneuve-d'Ascq, France a été nommé gérant de la Société avec effet au 28 mai
2015 et ce pour une durée indéterminée.
3. Madame Saeeda Amin, née le 13 février 1969 à Whalley, Royaume-Uni, résidant professionnellement au Havers Hill,
Scarborough, North Yorkshire Y011 3BS, Royaume-Uni, a été nommée gérant de la Société avec effet au 28 mai 2015 et
ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109536/20.
(150120040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
108773
L
U X E M B O U R G
Haras de Martelinville Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8814 Bigonville, Ferme de Martelinville.
R.C.S. Luxembourg B 102.722.
Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015108725/9.
(150118301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Immobilière Marina S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 84.394.
Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015108771/10.
(150117903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.
New Old Brewery S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.424.
En date du 8 Juin 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Démission de Martin Paul Galliver, du poste d'administrateur de classe B avec effet au 22 mai 2015;
- Nomination de Angeliki Alafi, née le 1
er
septembre 1979 à Athènes, Grèce et ayant pour adresse professionnelle le
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste d'administrateur de classe B avec effet au 23 mai 2015 et pour
une durée déterminée de 6 ans et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes annuels de la Société
au 31 décembre 2020, qui se tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
New Old Brewery S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015112457/17.
(150120336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Select Global, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 186.547.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 27 avril 2015i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Philippe DENEF, Gérald SERVAIS, Jean-Marc TURIN et Madame Anne-Marie GOFFINET.,
en qualité d'administrateurs, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016,
2. de réélire KPMG Luxembourg, Société Coopérative, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B-149133 et étant
située au 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an,
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.
Luxembourg, le 26 mai 2015.
<i>Pour SELECT GLOBAL
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015108258/18.
(150119013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.
108774
L
U X E M B O U R G
Midway Investment, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 183.496.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2015.
Référence de publication: 2015112405/10.
(150120665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Multi Strategy SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 156.462.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015112415/10.
(150119573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Permira SCF IV S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 171.137.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cédric Pedoni
<i>Gérant de Permira SCF S.à r.l. / Géranti>
Référence de publication: 2015112507/12.
(150120588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Manziana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 53, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 147.285.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2015, statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2014 que:
Sont réélus pour une période de 4 ans, les mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale prévue en 2019:
- Monsieur Philip George BISSON, en qualité d’Administrateur, résidant professionnellement au 6, Hilgrove Street, JE
- JE4 9ZH — Jersey, Channel Islands
- Monsieur Paul YOUNG, en qualité d’Administrateur, résidant professionnellement au 53, me de Merl, L — 2146
Luxembourg
- Monsieur Jean Claude SCHAEFFER, en qualité d’Administrateur, résidant à 40, me des Anémones, L — 1129 Lu-
xembourg
- H.R.T. REVISION S.A., en qualité de commissaire aux comptes, ayant son siège social au 163, me du Kiem, L —
8030 Strassen
Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Pour extrait conforme
Manziana S.A.
Référence de publication: 2015112423/22.
(150120495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
108775
L
U X E M B O U R G
NOS Communications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 2, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 187.949.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112471/10.
(150120375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Pentachem, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 187.495.
Par résolutions prises en date du 8 juin 2015, l’associé unique a décidé de renouveler le mandat de commissaire aux
comptes d’Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une
période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant
au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Référence de publication: 2015113511/13.
(150121265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
NREP NSF 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 186.446.
EXTRAIT
En date du 19 juin 2015, le conseil de gérance de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Gulcin Tekes en tant que gérant B de la société avec effet au 30 juin 2015;
- Nomination de Barbara Neuerburg, née le 18 mai 1979 à Krumbach, Allemagne, demeurant professionnellement au
15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, comme nouveau gérant B de la société avec effet au 30 juin 2015 et ce
pour une durée illimitée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112474/15.
(150120555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
NGP IX Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 1.144.584,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 138.794.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'associé unique comme suit:
NGP IX Canadian Holdings, L.P., 5221 N. O'Connor Boulevard, Suite 1100, 75039 Irving, Texas (Etats-Unis d'Amé-
rique).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2015.
<i>Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
i>Joanna Casoli Compe
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015112468/16.
(150120220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
108776
L
U X E M B O U R G
Commex International S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 59.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015111263/9.
(150120413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Bulco S.àr.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.
R.C.S. Luxembourg B 74.202.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015109177/9.
(150119213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
CEREP Strategic Land S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 156.531.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 juillet 2015.
Référence de publication: 2015111249/10.
(150119857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Compagnie de Financements et d'Investissements Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 78.521.
EXTRAIT
Le Conseil d'administration réuni en date du 8 juin 2015 a pris à l'unanimité acte de la démission d'un administrateur,
Monsieur Sébastien Gravière, suivant lettre adressé par ce dernier à la Société en date du 6 mai 2015.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015113000/11.
(150121022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
GS Lux Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 88.045.
Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2002, acte publié au
Mémorial C no 1363
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GS Lux Management Services S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015112221/14.
(150120043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
108777
L
U X E M B O U R G
CMI Asset Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 29.384.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day day of June.
Before Us Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Henri Hel-
linckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of CMI Asset Management (Luxembourg) S.A., a
société anonyme having its registered office at 36, rue Rangwee, L-2412 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 29.384 (the "Company"),
incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg dated 22
December 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 41 of 15
February 1989.
The articles of association of the Company have been amended for the last time on 9 June 2010 by deed of the undersigned
notary, published in the Mémorial number 1873 of 11 September 2010.
The Meeting was opened at 5 a.m. with Mrs Mireille Jammaers, professionally residing in Luxembourg, as chairman
of the Meeting (the "Chairman").
The Chairman appointed as secretary Mrs Mathilde Rousseau, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Sandrine Puccilli, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus being constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decision to put the Company into liquidation and to dissolve it;
2. Appointment of KPMG Luxembourg, a société coopérative, incorporated and existing under the laws of Grand Duchy
of Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 149.133, having
its registered office at 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, duly represented by
Mr Zianddin Ahmad Hossen as liquidator of the Company, determination of the powers of the liquidator and granting the
largest powers and especially those determined by articles 144 and 145 and following of the Law of 10
th
August 1915 on
commercial companies (as amended) to the liquidator.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the bureau of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
III. As appears from the said attendance list, all the shares issued by the Company are present or represented at the
Meeting.
IV. That as a result of the foregoing, the Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the
agenda.
Then the Meeting, after deliberation, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to put the Company into liquidation and to dissolve it (the Company subsisting for
the sole purpose of the liquidation).
<i>Second resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to appoint as liquidator KPMG Luxembourg, a société coopérative, incorporated
and existing under the laws of Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
number B 149.133, having its registered office at 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, duly represented by Mr Zianddin Ahmad Hossen and to grant it the largest powers and particularly those set
forth in articles 144 and following of the Law of 10
th
August 1915 on commercial companies (as amended).
The Meeting resolved to authorise the liquidator in advance to execute the acts and enter into the operations set forth in
article 145 of the same law without any special authorisation, if such authorisation is required by law.
The liquidator is discharged by the Meeting to make an inventory and can simply refer to the documents of the Company.
It may, under its responsibility, for specific operations of contracts, delegate to one or more proxies part of its powers
to determine.
108778
L
U X E M B O U R G
The liquidator is authorised, with respect to the limits permitted by law, to proceed to the payment of any interim
liquidation proceeds that it would consider appropriate.
The liquidator is authorised to effect payment of the liquidation proceeds in cash.
The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered by
chartered accountants.
All the items of the agenda have been resolved upon.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed
by a French translation; at the request of the appearing persons, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.
This document having been read to the appearing persons, known to the notary by their respective names, first names,
civil status and residences, the said persons signed this original deed with us, the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-cinq juin.
Par-devant Nous, Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
S'est réunie
une assemblée générale des actionnaires (l'"Assemblée") de CMI Asset Management (Luxembourg) S.A., une société
anonyme dont le siège social est situé au 36, rue Rangwee, L-2412 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 29.384 (la "Société"), constituée
par acte de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg en date du 22
décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 41 du 15 février 1989.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 9 juin 2010 par acte du notaire soussigné, publié au
Mémorial numéro 1873 du 11 septembre 2010.
L'Assemblée a été ouverte à 17h sous la présidence de Madame Mireille Jammaers, résidant professionnellement à
Luxembourg (le "Président").
Le Président a désigné comme secrétaire Madame Mathilde Rousseau, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Madame Sandrine Puccilli, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire de constater:
I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de mettre la Société en liquidation et de la dissoudre;
2. Nomination de KPMG Luxembourg, une société coopérative de droit luxembourgeois et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 149.133, dont le siège social est situé au 39, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dûment représentée par Mr Zianddin Ahmad Hossen
en tant que liquidateur de la Société, détermination des pouvoirs du liquidateur et octroi des pouvoirs les plus larges et
notamment de ceux énoncés dans les articles 144 et 145 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (telle que modifiée) au liquidateur.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
III. Qu'il appert de ladite liste de présence que l'ensemble des actions émises par la Société sont présentes ou représentées
à l'Assemblée.
IV. Qu'il résulte de ce qui précède que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement décider sur les points
à l'ordre du jour.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a unanimement décidé de mettre la Société en liquidation et de la dissoudre (la Société subsistant unique-
ment aux fins de la liquidation).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée a unanimement décidé de nommer en tant que liquidateur KPMG Luxembourg, une société coopérative
de droit luxembourgeois et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
149.133, dont le siège social est situé au 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
108779
L
U X E M B O U R G
dûment représentée par Monsieur Zianddin Ahmad Hossen et de lui octroyer les pouvoirs les plus larges et notamment
ceux énoncés dans les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que
modifiée).
L'Assemblée a décidé d'autoriser le liquidateur à signer à l'avance les actes et de conclure les opérations énoncées à
l'article 145 de ladite loi sans autorisation spéciale, si la loi requiert cette autorisation.
Le liquidateur est dispensé par l'Assemblée de dresser un inventaire et peut simplement se référer aux documents de la
Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spécifiques de contrats, déléguer à un ou plusieurs mandataires une
partie de ses pouvoirs à déterminer.
Le liquidateur est autorisé, dans les limites prescrites par la loi, à procéder au paiement de tout produit de liquidation
intérimaire qu'il considérerait opportun.
Le liquidateur est autorisé à procéder au paiement du boni de liquidation en espèces.
Le liquidateur aura le droit à une rémunération conformément à la pratique du marché applicable aux services rendus
par les experts-comptables.
Tous les points portés à l'ordre du jour ont fait l'objet d'une résolution.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent document.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une
traduction en langue française; à la demande des comparants, le texte anglais fera foi en cas de divergences entre les versions
anglaise et française.
Après lecture faite du présent document aux comparants, qui sont connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civils
et résidences, lesdits comparants ont signé le présent acte original avec Nous, le notaire.
Signé: M. JAMMAERS, M. ROUSSEAU, S. PUCCILLI et D. KOLBACH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/20561. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Référence de publication: 2015111254/136.
(150120120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Sun European Investment III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 197.192.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of June.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED
1.- Ensign European Investment Co. I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 187.623, and having its registered office at L-2633 Senningerberg, 6D, route
de Trèves,
2.- Commodore European Investment Co. I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 187.627, and having its registered office at L-2633 Senningerberg, 6D, route
de Trèves, and
3.- Plenium Partners. S.L., a company incorporated under Spanish law, having its registered office at calle Velázquez,
47-7° planta, Madrid, Spain,, registered with the Registro Mercantil de Madrid, under number B85-116671
all three (3) here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of three
(3) proxies given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing are the shareholders representing the whole corporate capital of Sun European Investment III S.à r.l.,
a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of commerce and companies under number B.197.192 and having its registered office at 1,
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (the "Company").
108780
L
U X E M B O U R G
II. The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 18 May 2015, in process of being
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The Articles of incorporation have not been amended
since then.
III. The Company's share capital is currently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares, each with a par value of one euro (EUR 1.-) per share, all fully subscribed
and entirely paid up.
The shareholders, representing the whole corporate capital then passed, in the extraordinary general meeting by unani-
mous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to transfer the address of the registered office to L-2633 Senningerberg, 6D, route de
Trèves, and subsequently to amend the first sentence of article 4 of the articles of incorporation in order to give it the
following wording:
« Art. 4. (1
st
sentence). The Company has its registered office in the municipality of Niederanven.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting acknowledges that the shareholders Ensign European Investment Co. I S.à r.l. and Commodore
European Investment Co. I S.à r.l. have transferred the address of its registered office to L-2633 Senningerberg, 6D, route
de Trèves.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand and fifty Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing, acting as said before, known to the notary by name,
first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre juin.
Par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),
ONT COMPARU
1.- Ensign European Investment Co. I S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 187.623 et ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves,
2.- Commodore European Investment Co. I S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 187.623 et ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, et
3.- Plenium Partners S.L., société ayant son siège social à calle Velázquez, 47-7° planta, Madrid, Espagne, enregistrée
auprès du Registro Mercantil de Madrid, Espagne, sous le numéro B85-116671,
tous trois (3) ici représentée par Mr. Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, en vertu de
trois (3) procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumen-
taire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les comparantes sont les associés représentant l'intégralité du capital social de Sun European Investment III S.à
r.l., société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 197.192 et ayant son siège social au 1, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg (la «Société»).
II. Que la Société a été constituée suivant un acte notarié du notaire instrumentant en date du 18 mai 2015, en voie de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
III. Que le capital de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes intégralement souscrites
et entièrement libérées.
108781
L
U X E M B O U R G
Les associés représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont ensuite pris en assemblée générale extraordinaire
à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer l'adresse du siège social vers L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, et
en conséquence de modifier la première phrase de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. (1
ère
phrase). Le siège social est établi dans la Commune de Niederanven.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale constate que les associés Ensign European Investment Co. I S.à r.l., et Commodore European
Investment Co. I S.à r.l. ont transféré l'adresse de leur siège social vers L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte sont
estimés à environ mille cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare, à la demande de la comparante, que le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante, et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparantes, agissant comme indiqué ci-avant, connu du notaire par ses noms,
prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 juin 2015. Relation GAC/2015/5354. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015109723/105.
(150120149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Oresc 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 198.193.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of the month of June;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Orpea Real Estate Luxembourg S.à r.l.”, having its registered office in L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain,,
registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 196576,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; which proxy, after having been signed “ne
varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.
Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of a
private limited liability company, (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung”), to establish as follows:
Chapter A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) under the
name of “OESC 8 S.à r.l.”, (the “Company”), which will be governed by the present articles of association (the “Articles”)
as well as by the respective laws and particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the
“Law of 1915”).
Art. 2. The Company may proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer
in real estate.
108782
L
U X E M B O U R G
The Company’s purpose is furthermore the participation in businesses and companies of any kind and the establishment,
development, administration and supervision of businesses and companies. The Company may acquire its participations
by subscription, contribution in kind, exercise of option rights and in any other way, manage and exploit them and dispose
of them by sale, assignment, exchange or in any other way.
The Company may use its means to create, administer, develop and exploit a portfolio consisting of securities and patents
of any kind and origin. For this it may acquire all kinds of securities by purchase, subscription or in any other way and
alienate them by sale, assignment, exchange or in any other way.
The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same group
of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and without
carrying on a bank business or of the financial sector. Moreover, it may borrow in any form with or without guaranty and
mortgage, issue debt securities, loan notes or other debt instruments, pledge or otherwise hypothecate for the benefit of its
own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned kind.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security
for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.
The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are
in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The Company’s registered office is established in the municipality of Bertrange (Grand Duchy of Luxembourg).
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or the board
of managers.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective
decision of the corporate unit holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as abroad by a simple decision of the board of managers.
Chapter B. Corporate capital - Corporate units
Art. 5. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) corporate units with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.
Each corporate unit is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the Law of 1915.
Art. 6. The Company will recognize only one holder per corporate unit.
The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
Art. 7. The Company's corporate units are freely transferable among corporate unit holders. Inter vivos, they may only
be transferred to new corporate unit holders subject to the approval of such transfer given by the other corporate unit holders
in a general meeting, at a majority of three quarters of the corporate capital.
In the event of death, the corporate units of the deceased corporate unit holder may only be transferred to new corporate
unit holders subject to the approval of such transfer given by the other corporate unit holders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the remaining corporate capital. Such approval is, however, not required in case the corporate
units are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 8. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the corporate unit holders will not cause
the dissolution of the Company.
Art. 9. The creditors, the assignees and the heirs of the corporate unit holders may not for whatever reason affix seals
to the property and the documents of the Company nor may they interfere in any manner in the management of the Company.
They have to refer to the Company’s inventories.
Chapter C. Management - Representation
Art. 10. The Company is managed by one or several managers, appointed by a resolution of the sole partner or the
general meeting of partners, which sets the term of their office.
The manager(s) need not to be partner(s). If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers.
The managers may be dismissed “ad nutum”.
Art. 11. All powers not expressly reserved by the Law of 1915 or the present Articles to the general meeting of partners
fall within the competence of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
108783
L
U X E M B O U R G
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by
the sole manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 12. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of the chairman
or any two managers at the place indicated in the convening notice.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy.
The board of managers can only deliberate and act legally, if the majority of the managers are present or represented.
The resolutions of the board of managers are valid with the majority of the votes of the present or represented managers.
Minutes of meetings of the board of managers will be signed by all managers present or represented at the meeting.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 13. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law of 1915.
Chapter D. Decisions of the sole corporate unit holder - Collective decisions of the corporate unit holders
Art. 14. Each corporate unit holder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of corporate
units which he owns. Each corporate unit holder is entitled to as many votes as he holds or represents corporate units.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by corporate unit holders owning more
than half of the corporate capital.
The amendment of these Articles requires the approval of a majority of corporate unit holders representing at least three
quarters of the corporate capital.
Art. 16. The sole corporate unit holder exercises the powers granted to the general meeting of corporate unit holders
under the provisions of section XII of the Law of 1915 concerning commercial companies, as amended.
Chapter E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 17. The Company's accounting year begins on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 18. Each year, with reference to December 31, the Company's accounts are established and the Managers prepare
an annual account in the form of a financial statement including profits and losses.
Each corporate unit holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortizations,
expenses and other burdens is allocated as follows:
- five percent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten
per cent (10%) of the Company's nominal corporate capital;
- the remaining amount is at the disposal of the corporate unit holders.
Art. 19. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the
managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
Articles.
Chapter F. Dissolution - Liquidation
Art. 20. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be corporate unit holders, and which are appointed by the general meeting of corporate unit holders which
108784
L
U X E M B O U R G
will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
corporate unit holders proportionally to the corporate units of the Company held by them.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the corporate unit holders
themselves or between the manager(s) and the Company, will be settled insofar as the Company’s business is concerned
by arbitration in compliance with the civil procedure.
Art. 22. For all points not regulated by these bylaws, reference is made to the provisions of the modified Law of 1915
on commercial companies.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year starts with the present day and ends on the 31
st
December 2015.
<i>Subscription and payment of the corporate unitsi>
The Articles having thus been established, the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units have been sub-
scribed by the sole corporate unit holder, the company “Orpea Real Estate Luxembourg S.à r.l.”, pre-designated and
represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve
thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has
been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Decisions taken by the sole corporate unit holderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the
subscribed corporate capital, has adopted the following resolutions as sole corporate unit holder:
1. The registered office of the Company is established in L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.
2. The following persons are appointed, for an undetermined period, as the managers of the Company:
- Mr. Marc VERBRUGGEN, company director, born in Schaerbeek (Belgium) on June 24, 1955, residing professionally
in B-1620 Drogenbos, Langestraat 366 (Belgium);
- Mr. Sébastien MESNARD, directeur financier & administratif, born in Versailles (France) on April 13, 1970, residing
professionally in F-92806 Puteaux, 1-3, rue Bellini (France);
- Mr. Tom FABER, economist, born in Munich (Federal Republic of Germany), on November 5, 1979, residing pro-
fessionally in L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain (Grand Duchy of Luxembourg).
3. The Company is validly bound in any circumstances and without restrictions by the sole signature of any manager.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning.
The deed having been read to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
first and last name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunzehnten Tag des Monats Juni;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung
„Orpea Real Estate Luxembourg S.à r.l.“, mit Sitz in L-8070 Bartringen, 37, rue du Puits Romain, eingetragen im Handels-
und Firmenregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 196576,
hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean
Engling, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom
Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen,
um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründ-
enden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
108785
L
U X E M B O U R G
Kapitel A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „ORESC 8 S.à r.l.“ (die
„Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen (die „Statuten“), sowie durch die anwendbaren Gesetze
und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“)
geregelt wird.
Art. 2. Die Gesellschaft kann möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen
oder diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jeglicher Art tätigen mit der Aus-
nahme derer welche den Immobilienhändlern vorbehalten sind.
Der Gesellschaftszweck ist weiterhin die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Grün-
dung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteili-
gungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben
und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,
welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung
oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Unter-
nehmen, die zu der gleichen Gruppe gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung
gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des
Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unterstützen.
Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicher-
heiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten
Art bestellen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit
oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Bartringen (Großherzogtum Luxemburg).
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann Innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrates verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen,
die für eine Änderungen der Statuten maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Lu-
xemburg verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen, Büros oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großher-
zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Kapitel B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR).
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesetzes von 1915
festgelegt ist.
Art. 6. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an.
Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 7. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des restlichen
Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendenten, Deszendenten
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 8. Der Tod, der Verlust der Bürgerrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters wird
nicht die Auflösung der Gesellschaft herbeiführen.
Art. 9. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente
der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen
einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.
108786
L
U X E M B O U R G
Kapitel C. Verwaltung - Vertretung
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, ernannt durch einen Beschluss des
Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, welche die Dauer ihrer Mandate festlegt.
Der (die) Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Im Fall der Ernennung mehrerer Geschäftsführer bilden
diese die Geschäftsführung.
Die Geschäftsführer sind „ad nutum“ abrufbar.
Art. 11. Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die vorliegenden Statuten der Gesellschafter-
versammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäfts-
führern in die Zuständigkeit der Geschäftsführung, der/die mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet ist, um alle mit dem
Gesellschaftszweck zu vereinbarenden Handlungen und Geschäfte vorzunehmen und zu genehmigen.
Jeder Geschäftsführer kann beschränkte Sondervollmachten für besondere Aufgaben an einen oder mehrere Bevoll-
mächtigte erteilen, der/die kein(e) Gesellschafter zu sein braucht/brauchen.
Art. 12. Die Geschäftsführung versammelt sich so oft, wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern sowie auf Ein-
berufung eines der Geschäftsführer an dem in der Einberufung angegebenen Versammlungsort.
Jeder Geschäftsführer erhält für jede Versammlung der Geschäftsführung mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor
dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine mündliche oder schriftliche Mitteilung, außer im Falle einer
Dringlichkeit; in einem solchen Fall wird die Art dieser Dringlichkeit (und ihre Gründe) in der Einberufung der Versamm-
lung der Geschäftsführung kurz angegeben.
Die Versammlung kann ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer der
Gesellschaft bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Ver-
sammlung und ihre Tagesordnung informiert worden sind. Auf die Einberufung kann auch verzichtet werden, wenn das
schriftliche Einverständnis jedes Geschäftsführers der Gesellschaft entweder in Urschrift oder als Telegramm, Fax, Telex
oder E-Mail vorliegt.
Jeder Geschäftsführer kann sich durch schriftliche Ernennung eines anderen Geschäftsführers zu seinem Vertreter bei
den Versammlungen der Geschäftsführung vertreten lassen.
Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend
oder vertreten ist. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden rechtsgültig mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Die Protokolle der Versammlungen der Geschäftsführung werden von allen bei
der Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.
Jeder Geschäftsführer kann an der Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon-oder Videokonferenz oder ähn-
licher Kommunikationsmittel teilnehmen, bei denen sämtliche Versammlungsteilnehmer sich hören und miteinander
sprechen können. Die Teilnahme an der Versammlung durch eines dieser Mittel gilt als der persönlichen Teilnahme an der
Versammlung gleichwertig.
Die von allen Geschäftsführern unterzeichneten Umlaufbeschlüsse gelten als rechtsgültig gefasst, als wären sie in einer
ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst worden. Die Unterschriften
der Geschäftsführer können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder Telefax verschickten Kopien
eines identischen Beschlusses angebracht werden.
Art. 13. Die Geschäftsführer übernehmen auf der Grundlage ihres Amtes keine persönliche Haftung für Verpflichtungen,
die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, soweit diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den Statuten
und den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 eingegangen wurden.
Kapitel D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 15. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Statuten benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 16. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes von 1915 zustehen.
Kapitel E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 18. Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahres-
abschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinnund Verlustrechnung.
108787
L
U X E M B O U R G
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und sonstigen Lasten verbleibende Nettogewinn wird
wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,
bis diese 10% des gezeichneten Kapitals erreicht;
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 19. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines
von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur Ver-
fügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Statuten vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.
Kapitel F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern
selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in den Statuten festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes
von 1915 über die Handelsgesellschaften, verwiesen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung und Zahlung der Anteilei>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile durch die
alleinige Gesellschafterin, die Gesellschaft „Orpea Real Estate Luxembourg S.à r.l.“, vorgenannt und vertreten wie hiervor
erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-
EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies
ausdrücklich bestätigt.
<i>Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterini>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienene Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8070 Bartringen, 37, rue du Puits Romain.
2. Folgende Personen werden, für eine unbestimmte Dauer, zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
- Herr Marc VERBRUGGEN, Geschäftsführer, geboren in Schaerbeek (Belgien), am 24. Juni 1955, beruflich wohnhaft
in B-1620 Drogenbos, Langestraat 366 (Belgien);
- Herr Sébastien MESNARD, directeur financier & administratif, geboren in Versailles (Frankreich), am 13. April 1970,
beruflich wohnhaft in F-92806 Puteaux, 1-3, rue Bellini (Frankreich);
- Herr Tom FABER, Economist, geboren in München (Bundesrepublik Deutschland), am 5. November 1979, beruflich
wohnhaft in L-8070 Bartringen, 37, rue du Puits Romain (Großherzogtum Luxemburg).
3. Die Gesellschaft wird rechtmäßig vertreten in allen Umständen und ohne Einschränkungen durch die Einzelunter-
schrift eines Geschäftsführers.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, wird auf ungefähr tausend Euro abgeschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die
englische Fassung maßgeblich sein.
108788
L
U X E M B O U R G
WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, handelnd wie hiervor er-
wähnt, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagter
Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 juin 2015 2LAC/2015/14270. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 3 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109614/357.
(150119438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Satisco International Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 198.186.
STATUTS
L’an deux mille quinze, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Alain KUNNEN, informaticien, né à Etterbeek (Belgique), le 10 mai 1964, demeurant professionnellement
au 1, rue Emile Francqui, à 1435 Mont Saint Guibert, Belgique;
Et
2. Alan Allman Associates International, une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois ayant son siège
social au 22 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg sous le numéro B 174432,
Tous deux ici représentés par Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, selon
les termes de deux (2) procurations sous seing privé délivrées à Luxembourg, le 25 juin 2015;
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant
resteront annexées au présent acte aux fins d’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d’une
société anonyme sous le nom SATISCO INTERNATIONAL HOLDING qui est constituée comme suit:
I. Forme et nom, durée, siège social
Art. 1
er
. Forme et nom. Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-
après créées, une société anonyme sous la dénomination SATISCO INTERNATIONAL HOLDING (ci-après la «Société»)
qui sera régie par la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi sur les Sociétés») ainsi que par les
présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Siège social.
3.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
3.2. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration ou
par décision de l’administrateur unique (le cas échéant). Il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de
Luxembourg par décision de l’assemblée générale des actionnaires ou de l’actionnaire unique (le cas échéant), statuant
comme en matière de modification des Statuts
3.3. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration ou par décision de l’administrateur unique (le cas
échéant), des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
II. Objet Social de la Société
Art. 4. Objet Social.
4.1. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange
ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, d’instruments de dettes et de valeurs mobilières de toute nature et la
détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des
participations dans des sociétés en commandite ou partenariats.
4.2. La Société peut en particulier:
108789
L
U X E M B O U R G
(i) conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres de dette, conver-
tibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
(ii) conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats de
swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contrepartie ou bénéficiera d'une protection de cette
dernière;
(iii) en faveur de ses filiales ou à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou toute
autre société contrôlée directement ou indirectement par l’associé de la Société (ci-après «Société(s) Affiliée(s)»): (i)
avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à, ou de souscrire à, ou acquérir tous instruments de dette, émis par une
Société Affiliée luxembourgeoise ou étrangère, (ii) accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes
de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou
futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés
Affiliées dans les limites autorisées par toute disposition légale applicable; et
(iv) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats de
garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres
contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/ou de cours, et autres contrats financiers
dérivés en relation en relation avec son objet;
étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui pourrait l’engager dans une activité qui constituerait
une activité réglementée du secteur financier.
4.3. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de son objet.
III. Capital social et actions
Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à un million cinq cent mille Euro (EUR 1.500.000,-) divisé en 300.000
(trois cent mille) actions rachetables de catégorie A et 1.200.000 (un million deux cent mille) actions rachetables de catégorie
B sans désignation de valeur nominale (ci-après dénommée chacune comme une «Action», «Action(s) A»), «Action(s) B»
ou ensemble les «Actions»). Les détenteurs des Actions A et des Actions B sont respectivement désignés les «Actionnaire
(s) A» ou «Actionnaire(s) B» ou ensemble les «Actionnaires»
5.2. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment par décision de l'assemblée générale
des Actionnaires ou de l'Actionnaire unique statuant comme en matière de modification des Statuts.
5.3. La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions sous les conditions prévues par la Loi sur les Sociétés.
Les conditions et modalités de rachat telles qu'exigées par l’article 49-8 de la Loi sur Les Sociétés seront fixées par le
conseil d’administration ou l’administrateur unique (le cas échéant).
5.4 En cas d’opération d’augmentation de capital par apport en nature ou résultant d’une opération de fusion ou toute
opération similaire, chaque Actionnaire pourra souscrire à une augmentation de capital en numéraire et qui lui sera réservée,
de telle sorte qu'il conserve le même pourcentage de capital social qu'il possédait avant l’opération d’augmentation de
capital. Ce droit ne s’exercera toutefois pas dans le cadre d’augmentation de capital réservée aux salariés et dirigeants de
la Société dans le cadre d’un programme d’option sur actions.
Art. 6. Actions.
6.1. Toutes les Actions de la Société seront émises sous forme nominative ou au porteur, au choix de l’Actionnaire.
6.2. Si les Actions sont au porteur, le conseil d’administration ou l’administrateur unique, le cas échéant, sera tenu, en
vertu de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, de nommer un agent dépositaire
qui maintiendra un registre des Actions au porteur de la Société. Le registre contiendra toutes les informations requises par
la loi sur les sociétés.
6.3. Dans l’hypothèse où les Actions sont nominatives, un registre des Actionnaires sera tenu au siège social de la Société
et y pourra être consulté par tout Actionnaire de la Société. Ce registre contiendra toutes les informations requises par la
loi.
6.4. Le droit de propriété de l'Actionnaire sur les Actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre concerné.
Un certificat, qui devra être signé par deux membres du conseil d'administration ou par l’administrateur unique (le cas
échéant), constatera cette inscription et sera délivré sur demande à l'Actionnaire.
6.5. La Société peut avoir un ou plusieurs Actionnaires. Le décès ou la dissolution de l'Actionnaire unique (ou de tout
autre Actionnaire) n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.6. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une Action est détenue par plus d'une personne, les
personnes invoquant un droit sur l'Action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'Action à l'égard de la
Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle Action avant qu'une personne
soit désignée comme étant propriétaire unique à l'égard de la Société.
Art. 7. Cessions des Actions. Principes et définitions.
108790
L
U X E M B O U R G
7.1. Pour le besoin des dispositions de l’article 7 des Statuts, (i) les termes «transfert» et «cession» signifient tout transfert,
vente, cession, nantissement, mise en garantie ou en sûreté, apport en capital ou, de toute autre manière, en ce compris par
voie de fusion, toute aliénation, directe ou indirecte, à titre onéreux ou gratuit, volontaire ou non, démembrement en nue-
propriété ou en usufruit, d’une Action, et (ii) le terme «Actions» signifie les Actions de toutes catégories, les droits de
souscription, les droits de préférence, les obligations convertibles ou remboursables en Actions émis ou à émettre par la
Société, de même que toute valeur mobilière émise ou à émettre par la Société représentative du capital social ou garantissant
un droit actuel ou futur à une partie du capital social de la Société.
7.2 Les Actionnaires s’interdisent formellement de céder leurs Actions à un tiers, en ce compris dans le cadre des cessions
libres visées à l'article 7.6 des statuts, sans que celui-ci ne se soit préalablement engagé à adhérer sans réserve à toute
convention d'actionnaires en vigueur lors de la cession (la "Convention d'Actionnaires") et se soit porté fort de ce que tout
tiers auquel il céderait à son tour ses Actions adhère également sans réserve à la Convention d'Actionnaires. Les Actionnaires
se portent fort de ce que tout tiers auquel ils céderaient des Actions adhère à la Convention d'Actionnaires, sans la moindre
réserve, préalablement ou au plus tard concomitamment à la cession. Toute cession effectuée en violation de cette obligation
ne sera pas opposable à la Société.
7.3. Ni la Société ni aucun de ses administrateurs ou agents ne pourra inscrire dans le registre des Actionnaires de la
Société une cession des Actions qui n’est pas effectuée conformément aux Statuts.
7.4 Pour être valablement réalisée dans le cadre du présent article, toute notification doit être effectuée par lettre re-
commandée avec accusé de réception.
Pour les besoins des Statuts, tout délai qui consiste en un nombre de jours commencera à courir le jour qui suit celui où
l'événement déclencheur du délai s'est produit. La date d'expiration du délai est incluse dans la période. Si la date d'expiration
du délai n'est pas un Jour Ouvrable, la date d'expiration est reportée au premier Jour Ouvrable qui suit.
Pour les besoins des Statuts, le terme "Jour Ouvrable" désigne un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour
férié officiel en Luxembourg ou en Belgique.
Inaliénabilité
7.5 Sans préjudice des cessions libres visées à l'article 7.6 et de l'exercice des différentes options prévues dans la
Convention d'Actionnaires, les Actionnaires A s'engagent, dans l'intérêt de la Société, à ne pas céder tout ou partie de leurs
Actions avant le 30 juin 2020.
Nonobstant ce qui est prévu au paragraphe ci-dessus et sans préjudice de l'application des articles 7.6 et 7.7 des Statuts,
en cas de décès ou d'incapacité physique ou mentale de plus de quarante pour cent (40%) d'un Actionnaire A, les Actions
détenues par celui-ci pourront être cédées avant le 30 juin 2020.
Cessions libres
7.6 Les Actions A sont librement cessibles:
(i) aux Ayants Droit du cédant pour autant que la cession ne porte que sur la nue-propriété des Actions A concernées
ou que celle-ci prévoit un mécanisme permettant à l'Actionnaire A fondateur de la Société de continuer exercer les droits
de vote attachés aux Actions cédées; les Actions A ainsi cédées demeureront des Actions A et ne seront pas converties en
Actions ordinaires de la Société;
(ii) à une Personne Liée au cédant pour autant que la cession prévoie un mécanisme obligatoire de rétrocession des
Actions A cédées au cédant dans l'hypothèse où le cessionnaire viendrait à ne plus être une Personne Liée au cédant et ce,
pour quelque raison que ce soit; les Actions A ainsi cédées demeureront des Actions A et ne seront pas converties en Actions
ordinaires de la Société.
Les Actions B sont librement cessibles à une Personne Liée au cédant pour autant que la cession prévoie un mécanisme
obligatoire de rétrocession des Actions B cédées au cédant dans l'hypothèse où le cessionnaire viendrait à ne plus être une
Personne Liée au cédant et ce, pour quelque raison que ce soit; les Actions B ainsi cédées demeureront des Actions B et
ne seront pas converties en actions ordinaires de la Société.
Sans préjudice ce qui est prévu aux paragraphes ci-dessus, les Actions cédées à un tiers seront automatiquement con-
verties en actions ordinaires de la Société et ne bénéficieront pas des droits attachés aux Actions A ou aux Actions B au
titre des présents statuts ou de la Convention d'Actionnaires.
Pour les besoins du présent article, le terme "Ayant Droit" désigne toute personne physique pouvant acquérir la propriété,
l'usufruit ou la nue-propriété d'Actions suite au décès d'un actionnaire personne physique et le terme "Personne Liée"
désigne, par rapport à une personne morale:
- les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement;
- les personnes physiques ou morales qui la contrôlent directement ou indirectement;
- les sociétés avec lesquelles elle forme consortium;
- les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les personnes susvisées.
Pour autant que l'ensemble des conditions prévues au présent article 7.6 soient remplies, le droit de préemption et le
droit de suite prévus aux articles 7.7 et 7.8 des Statuts ne s'appliqueront pas.
Droit de préemption
108791
L
U X E M B O U R G
7.7 Sans préjudice de l'article 7.6 (cessions libres), chaque Actionnaire s'engage à ne pas céder tout ou partie de ses
Actions sans les avoir préalablement offertes aux autres Actionnaires.
L'Actionnaire (le "Cédant") qui souhaite céder tout ou partie de ses Actions à un tiers de bonne foi (le "Candidat
Cessionnaire") en informera le conseil d'administration par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre
comprendra une copie de la lettre d'offre du Candidat Cessionnaire précisant: (i) le nom, l’adresse, ou la dénomination et
le siège social, ainsi que la nationalité, du Candidat Cessionnaire; (ii) l'indication que le Candidat Cessionnaire agit en son
nom et pour son propre compte et non pour le compte d'un tiers non identifié; (iii) le nombre et les numéros des Actions
dont la cession est envisagée; (iv) le prix offert par le Candidat Cessionnaire ainsi que les modalités et conditions de la
cession envisagée; (v) le moment envisagé du transfert de propriété des Actions; et (vi), pour autant qu'ils existent déjà,
une copie de tous les projets de documents contractuels relatifs à la cession envisagée.
Dans les dix (10) jours suivant la réception de la lettre du Cédant, le conseil d'administration notifiera une copie de la
lettre d'offre du Candidat Cessionnaires aux autres Actionnaires (la "Notification").
Les autres Actionnaires disposeront d'un délai de vingt (20) Jours Ouvrables suivant la réception de la Notification pour
faire savoir au conseil d'administration s'ils exercent ou non leur droit de préemption.
Le droit de préemption est indivisible de sorte que son exercice doit porter sur l'ensemble des Actions offertes.
Si les autres Actionnaires n'exercent pas leur droit de préemption dans le délai de vingt (20) Jours Ouvrables dont
question ci-avant, ils seront réputés y avoir définitivement renoncé.
Le conseil d'administration informera tous les Actionnaires, dans les dix (10) jours de l'expiration du délai susmentionné,
du résultat de l'exercice du droit de préemption.
Si le nombre d'Actions préemptées est supérieur au nombre d'Actions offertes, les Actions offertes seront réparties entre
les Actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption proportionnellement à leur participation dans la société, compte
non tenu des Actions du Cédant et des Actionnaires n'ayant pas exercé leur droit de préemption.
Si le nombre d'Actions préemptée est inférieur au nombre d'Actions offertes, le Cédant pourra librement céder l'ensemble
des Actions offertes au Candidat Cessionnaire pour autant que la cession ne soit pas effectuée à des conditions et modalités
plus favorables au Candidat Cessionnaire que celles indiquées dans la Notification.
Le prix d'acquisition sera égal au prix offert par le Candidat Cessionnaire.
Le prix d'acquisition des Actions préemptées devra être payé au Cédant dans un délai de trente (30) jours à compter de
la date de cession des Actions préemptées. Si ladite cession n'intervient pas endéans les trente (30) Jours Ouvrables de la
notification par laquelle le conseil d'administration informe les actionnaires du résultat de l'exercice du droit de préemption,
le Cédant pourra librement céder l'ensemble des Actions offertes au Candidat Cessionnaire pour autant que la cession ne
soit pas effectuée à des conditions et modalités plus favorables au Candidat Cessionnaire que celles indiquées dans la
Notification.
La propriété des Actions préemptées, ainsi que l'ensemble des droits qui y sont attachés, sera transférée aux Actionnaires
ayant exercé leur droit de préemption lors du paiement du prix d'acquisition des Actions préemptées.
Droit de suite
7.8 Dans l'hypothèse où, après l'application de, ou la renonciation unanime par les autres Actionnaires à l'application
de, l'article 7.7 (droit de préemption), un Actionnaire (le "Cédant") envisagerait de céder tout ou partie de ses Actions
conférant plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote attachés à l'ensemble des Actions de la Société à un tiers
de bonne foi (le "Cessionnaire"), il en informera les autres Actionnaires dans les dix (10) jours suivant l'application de, ou
la renonciation unanime par les autres Actionnaires à l'application de, l'article 7.7 (droit de préemption), par lettre recom-
mandée avec accusé de réception (la "Notification"). La Notification comprendra une copie de la lettre d'offre du
Cessionnaire précisant: (i) le nom, l’adresse, ou la dénomination et le siège social, ainsi que la nationalité, du Cessionnaire;
(ii) l'indication que le Cessionnaires agit en son nom et pour son propre compte et non pour le compte d'un tiers non identifié;
(iii) le nombre et les numéros des Actions dont la cession est envisagée (les "Actions Offertes"); (iv) le prix offert par le
Cessionnaire ainsi que les modalités et conditions de la cession envisagée; (v) le moment envisagé du transfert de propriété
des Actions et (vi), pour autant qu'ils existent déjà, une copie de tous les projets de documents contractuels relatifs à la
cession envisagée.
Les autres Actionnaires bénéficieront du droit d'exiger du Cédant et du Cessionnaire, lesquels seront solidairement tenus
entre eux et à l'égard des autres Actionnaires, à leur choix:
(i) que le Cessionnaire acquiert les Actions Offertes, parmi leurs Actions en lieu et place des actions du Cédant, selon
des modalités et conditions, notamment le prix, identiques à celles convenues dans le cadre de la cession entre le Cédant
et le Cessionnaire; dans ce cas, si le nombre d'Actions que le Cédant et les autres Actionnaires qui ont exercé leur droit de
suite, conformément à l'alinéa précédent, souhaitent céder au Cessionnaire est supérieur au nombre d'Actions Offertes (que
le Cessionnaire souhaite acquérir), le nombre d'Actions que le Cédant et les autres Actionnaires qui ont exercé leur droit
de suite pourront céder au Cessionnaire sera réduit à concurrence de la différence entre le nombre d'Actions Offertes et le
nombre d'Actions détenues par le Cédant et les Actionnaires ayant exercé leur droit de suite répartie entre eux proportion-
nellement à leur participation dans la Société compte non tenu des Actions qui ne font pas l'objet d'un droit de suite;
(ii) que le Cessionnaire acquiert, outre les Actions Offertes, l'ensemble des Actions détenues par les autres Actionnaires,
selon des conditions et modalités, notamment le prix, identiques à celles convenues dans le cadre de la cession entre le
108792
L
U X E M B O U R G
Cédant et le Cessionnaire. A défaut pour le Cessionnaire d'acquérir, dans ce cas, les Actions détenues par les autres Ac-
tionnaires, le Cédant devra renoncer au projet de céder tout ou partie de ses Actions au Cessionnaire.
Les autres Actionnaires disposeront d'un délai de vingt (20) Jours Ouvrables suivant la Notification pour faire savoir au
Cédant et au Cessionnaire s'ils exercent ou non leur droit de suite et, s'ils l'exercent, leur choix d'exercice entre les deux
options prévues ci-dessus. Tout Actionnaire n'ayant pas exercé son droit de suite dans les vingt (20) Jours Ouvrables suivant
la Notification sera réputé y avoir définitivement renoncé.
Le prix offert par le Cessionnaire sera réparti entre le Cédant et les autres Actionnaires proportionnellement au nombre
d'Actions cédées par chacun d'eux.
La propriété des Actions cédées, ainsi que l'ensemble des droits qui y sont attachés, sera transférée au Cessionnaire
conformément aux conditions et modalités prévues dans les documents contractuels relatifs à l'opération dans le cadre de
laquelle les Actions sont transférées.
Le droit de suite sera toujours présumé exercé sous la condition suspensive de la réalisation de la cession faisant l'objet
de la Notification. Si celle-ci n'est pas lieu, l'exercice du droit de suite sera réputé nul et non avenu.
Mentions
7.9 A titre de garantie de la bonne et entière exécution des droits et obligations stipulés à la Convention d’Actionnaires,
les parties s’engagent à contresigner le registre des Actionnaires ou au verso des certificats nominatifs des Actions dont
chacune des parties sera propriétaire, la mention que ces “Actions sont grevées des droits et obligations stipulés à la
Convention d’Actionnaires» complétée par la date de la Convention d’Actionnaires.
IV. Administration
Art. 8. Administration.
8.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres. Toutefois, s'il est constaté
lors d'une assemblée des Actionnaires que toutes les Actions émises par la Société sont détenues par un seul Actionnaire,
la Société pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des Actionnaires faisant
suite au moment de la constatation par la Société que ses Actions sont à nouveau détenues par plus d'un Actionnaire.
8.2. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des Actionnaires qui déterminera leurs émoluments, la
durée de leur mandat et leur classe, le cas échéant. La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six années et
les administrateurs exerceront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sortant
peuvent être réélus.
8.3. Les administrateurs sont choisis par l’assemblée générale sur des listes composées par les Actionnaires comme suit:
- L’Actionnaire ou les Actionnaires, agissant de concert, qui détiennent les Actions A ont le droit de proposer à l’as-
semblée générale des Actionnaires une liste de candidat(s) sur laquelle l’assemblée choisira un (1) administrateur.
- L’Actionnaire ou les Actionnaires, agissant de concert, qui détiennent les Actions B ont en outre le droit de proposer
à l’assemblée générale des Actionnaires une liste de candidat(s) sur laquelle l’assemblée choisira deux (2) administrateurs.
L’Actionnaire ou les Actionnaires ayant le droit de désigner un administrateur sur la liste communiqueront au conseil
d’administration le ou les noms des administrateurs qu'ils désignent au moins quinze jours avant la date de l’assemblée
générale appelée à se prononcer sur leur nomination. Ce délai ne sera pas applicable au cas où l’ensemble des Actions sont
présentes ou représentées à l’assemblée des Actionnaires et qu'il aura été fait abstraction des convocations d’usage.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des Actionnaires à la majorité simple des voix valablement
émises. Tout administrateur peut être démis de ses fonctions à tout moment avec ou sans justification par l'assemblée
générale des Actionnaires à la majorité simple des voix valablement émises.
8.4. Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner
un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale
susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.
8.5. Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une démission ou autrement,
un administrateur peut être provisoirement désigné jusqu'à la prochaine assemblée générale, en suivant les dispositions
légales qui s'appliquent. Dans le cas où tous les postes d’administrateur deviennent vacants, le commissaire au compte
devra convoquer sans délai une assemblée générale des Actionnaires qui nommera de nouveaux administrateurs.
Art. 9. Décision du conseil d'administration.
8.1. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un vice-président. Il
peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera chargé de dresser les procès-
verbaux des réunions des Actionnaires et du conseil d'administration.
8.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
8.3. Le président préside le conseil d'administration, mais en son absence, le conseil d'administration peut, par majorité
des votes des personnes présentes, provisoirement élire un autre administrateur comme président de ce conseil d'adminis-
tration.
108793
L
U X E M B O U R G
8.4. Un avis par écrit, télécopie ou e-mail (sans signature électronique) contenant l'ordre du jour sera donné à tous les
administrateurs au moins trois (3) Jours Ouvrables avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas
l'avis de convocation devra mentionner la nature et les motifs de cette urgence.
8.5. Aucune convocation n’est nécessaire si tous les membres du conseil d’administration sont présents ou représentés
à la réunion et qu'ils déclarent avoir été dûment informés de l’agenda de la réunion. Il peut être passé outre à la nécessité
de pareille convocation en cas d'assentiment de chaque administrateur par écrit, télécopie ou tout autre moyen de commu-
nication, une copie étant suffisante. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du conseil d'administration
se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
8.6. Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit, par télécopie, par e-mail ou par un autre moyen
de communication un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de
ses collègues.
8.7. Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration au moyen d'une conférence télé-
phonique ou d'une vidéoconférence ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre l'une l'autre sans discontinuité et permettant à chacune des personnes participant
à cette réunion d'y participer pleinement et activement. La participation à une réunion se tenant par les moyens de com-
munication susvisés vaut présence personnelle à cette réunion. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication
susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.
8.8. Sans préjudice de toute disposition plus restrictive prévue dans la Convention d'Actionnaires, le conseil d'adminis-
tration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présent ou représenté à une réunion
du conseil d'administration. Sans préjudice de toute disposition plus restrictive prévue dans la Convention d'Actionnaires,
les décisions sont uniquement prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.
Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.
8.9. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence, par le
vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure
judiciaire ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
8.10. Le conseil d'administration peut également prendre par voie circulaire des décisions à l'unanimité de ses membres,
par écrit, fax ou par tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante. L'intégralité sera considérée comme
procès-verbal faisant preuve que les décisions ont été adoptées.
Art. 9. Pouvoir du conseil d’administration.
9.1. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique (le cas échéant) est investi des pouvoirs les plus larges pour
pouvoir adopter les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi sur les
Sociétés ou les Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'adminis-
tration ou de l’administrateur unique (le cas échéant).
9.2. Le conseil d'administration, à l’unanimité, ou l’administrateur unique (le cas échéant) peut déléguer la gestion
journalière de la Société à un directeur, agent, gérant ou autre mandataire, Actionnaire ou non susceptibles d'agir seuls ou
conjointement.
9.3. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques et pour une durée limitée peuvent être délégués à une
ou plusieurs personnes, administrateur ou non, par l’administrateur unique ou par le conseil d’administration selon le cas.
Art. 10. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l’administrateur
unique ou la signature de deux administrateurs conjointement ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration conformé-
ment aux articles 9.2 et 9.3.
V. Actionnariat
Art. 11. Pouvoirs.
11.1. L'assemblée générale des Actionnaires dûment constituée représente l'ensemble des Actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
11.2. Dans l’hypothèse d’un seul Actionnaire, cet Actionnaire exercera les pouvoirs attribués par la Loi sur les Sociétés
ou les Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires.
Art. 12. Droits de Vote.
12.1. Chaque Action donne droit à son détenteur à une voix.
12.2. Chaque Actionnaire peut participer à l’assemblée générale des Actionnaires quel que soit le nombre d’Actions
qu'il détient.
Art. 13. Décisions de l’Actionnaire unique. Les décisions de l’Actionnaire unique seront prises par écrit.
Art. 14. Décisions de l’assemblée générale des Actionnaires.
14.1. L'assemblée générale des Actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou par l’administrateur unique,
le cas échéant. Elle doit être obligatoirement convoquée lorsqu'un groupe d'Actionnaires représentant au moins dix pour
108794
L
U X E M B O U R G
cent (10%) du capital social de la Société en fait la demande auprès du conseil d'administration de la Société. Un groupe
d'Actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peut requérir le conseil d'admi-
nistration d'ajouter un ou plusieurs points à l'agenda de toute assemblée générale des Actionnaires. Ces demandes devront
être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée.
14.2. Chaque fois que tous les Actionnaires sont présents ou représentés et considèrent avoir été dûment convoqués et
informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut lever les formalités de convocation.
14.3. Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour pouvoir
prendre part aux assemblées générales.
14.4. Les Actionnaires qui prennent part à l'assemblée par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication
permettant leur identification sont censés être présents pour la prise en compte des quorums de présence et de vote. Les
moyens de communication susvisés doivent permettre aux personnes participant à l'assemblée de s'entendre l'une et l'autre
sans discontinuité et de participer pleinement et activement à l'assemblée.
14.5. Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des Actionnaires par procuration écrite, par
télécopie ou par tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante.
14.6. Tout Actionnaire peut voter à l'aide des bulletins de vote envoyés par courrier, courrier électronique ou par télécopie
au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les Actionnaires ne peuvent utiliser que les
bulletins de vote qui lui auront été envoyés par la Société et qui devront indiquer au moins l'endroit, la date et l'heure de
l'assemblée, l’agenda de l’assemblée, la proposition soumise au vote de l'assemblée, et pour chaque proposition, trois cases
à cocher permettant à l'Actionnaire de voter en faveur ou contre la proposition ou d'exprimer une abstention par rapport à
chacune des propositions soumise au vote, en cochant la case appropriée. Les bulletins de vote n'indiquant ni vote en faveur,
ni vote contre, ni abstention, sont nuls. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de
l'assemblée générale à laquelle ils se réfèrent.
14.7. Les décisions de toute assemblée générale des Actionnaires valablement convoquée seront adoptées à la majorité
simple des voix valablement exprimées, sauf disposition contraire dans la Loi sur les Sociétés ou disposition plus restrictive
prévue dans la Convention d'Actionnaires.
Art. 15. Assemblée générale annuelle des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la
Société ou à tout autre endroit au Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 30 du mois d’avril de chaque année
à 14 heures. Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour
ouvrable luxembourgeois suivant. D'autres assemblées générales d'Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés
dans les avis de convocation respectifs. Le quorum et le délai de convocation prévus par la Loi sur les Sociétés régissent
les avis de convocation et la tenue des assemblées, sauf disposition contraire dans ceux-ci.
VI. Surveillance de la société
Art. 16. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
L'assemblée générale des Actionnaires, qui nomme le(s) commissaire(s) aux comptes, déterminera leur nombre, leur ré-
munération et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent être réélus
pour un nouveau mandat.
VII. Exercice social, comptes annuels, répartition des bénéfices
Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31
décembre de la même année.
Art. 18. Comptes Annuels. Chaque année, référence faite à la fin de l’exercice social de la Société, les comptes sociaux
de la Société seront dressés et le conseil d’administration ou l’administrateur unique (le cas échéant) préparera un inventaire
qui indique la valeur de l’actif et du passif de la Société. L’inventaire et les comptes sociaux seront disponibles au siège
social de la Société pour inspection par chaque Actionnaire.
Art. 19. Répartition des bénéfices.
19.1. Sur les bénéfices annuels nets de la société, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation
cessera d'être obligatoire dès et aussi longtemps que le montant atteindra dix pour cent (10%) du capital souscrit de la
société tel qu'il résulte des présents statuts ou du capital social le cas échéant augmenté ou réduit suivants les conditions
énoncées dans les présents Statuts.
19.2. L'assemblée générale des Actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration ou de l’administrateur
unique (le cas échéant), décidera la manière dont le restant des bénéfices annuels nets sera affecté.
19.3. Des avances sur dividendes pourront être distribuées par le conseil d'administration ou par l’administrateur unique
(le cas échéant) en observant les dispositions légales.
VIII. Dissolution et liquidation
Art. 20. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs
liquidateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Ils sont nommés par l'assemblée générale qui déterminera
les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur.
108795
L
U X E M B O U R G
IX. Modifications des statuts
Art. 21. Modification. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des Actionnaires statuant aux
conditions requises par la Loi sur les Sociétés.
X. Dispositions générales
Art. 22. Loi applicable. Tous les points non spécifiés dans les Statuts relèvent des dispositions de la Loi sur les Sociétés.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 Décembre 2015.
2) La première assemblée générale annuelle des Actionnaires aura lieu en 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Le capital a été souscrit comme suit:
Souscripteurs
Nombre
d’Actions
souscrites
Pourcentage
du capital
social
Total du
prix de
souscription
(EUR)
Pourcentage
d’Actions
libérées
Montant
libéré
(EUR)
Alain Kunnen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000 Actions A
20%
300.000,-
100%
300.000,-
Alan Alman
Associates International . . . . . . . . . . 1.200.000 Actions B
80%
1.200.000,-
100% 1.200.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
100%
1.500.000,-
100% 1.500.000,-
Preuve du paiement du total du montant libéré a été donné au notaire instrumentant, de sorte que la somme d'un million
cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille six cents Euros (EUR 2.600,-).
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre d’administrateurs a été fixé à trois (3) et le nombre de commissaires aux comptes à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans:
- Monsieur Alain KUNNEN, proposé sur une liste établie par les Actionnaires A, né le 10 mai 1964 à Etterbeek (Bel-
gique), demeurant professionnellement au 1, Rue Emile Francqui, à 1435 Mont Saint Guibert, Belgique;
- Monsieur Jean-Marie THUAL, proposé sur une liste établie par les Actionnaires B, né le 18 septembre 1974 à Redon
(France), demeurant au 15 rue du Docteur Vuillième, à 92130 Issy les Moulineaux, France; et
- Monsieur Loup VOLPILIERE, proposé sur une liste établie par les Actionnaires B, né le 16 mai 1984 à Montpellier
(France), demeurant au 20 rue Notre Dame de Nazareth, à 75003 Paris, France;
3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes, pour une durée de six (6) ans:
Madame Karine Arnold, née le 27 avril 1974 à La Celle-Saint -Cloud (France), demeurant au 1 allée de Bretagne, à
95130 Le Plessis bouchard (France)
4. Le siège social de la Société est fixé au 22 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par nom,
prénom, et résidence, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/20199. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109731/435.
(150119284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
108796
L
U X E M B O U R G
Duferco International Trading Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 51.469.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of June.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING S.A. a public company limited by shares (société anonyme), duly or-
ganized and existing under the laws of Luxembourg with its registered office (siège social) at 6, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
(Trade Register) under the number B 49308 ( “DPH”),
hereby represented by Mr. Julien Guillaume, manager, residing professionally in Luxembourg, by virtue of the power
of attorney granted to him on 24 April 2015;
2. STEELHOLD LIMITED, a legal entity, duly organized and existing under the laws of Cyprus, having its registered
office at Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. CY-1066, Nicosia, Cyprus, registered with the Ministry of Commerce,
Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver of Nicosia under number HE 152463
( “STEELHOLD”),
here represented by Mr. Julien Guillaume, manager, residing professionally in Luxembourg, by virtue of the power of
attorney granted to him on 24 April 2015; and
3. HEBSTEEL GLOBAL HOLDING PTE. LTD, a legal entity, duly organized and existing under the laws of Singapore,
having its registered office at 20 Collyer Quay, #11-02, Singapore 049319, registered with the Accounting and Corporate
Regulatory Authority of Singapore under number 2015066010W (“HEBSTEEL”),
hereby represented by Mr. Zhao Shougang, having his professional address at No.385 Tiyu South Avenue, Shijiazhuang,
Habei, China, by virtue of the power of attorney granted to him on 19 June 2015,
All appearing parties are referred to as the “Shareholders”.
Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent the
entire share capital of "DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.", a société anonyme, duly organized
and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider,
L -2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Lu-
xembourg (Trade Register) under number B51469 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Marc
ELTER, then notary residing in Luxembourg dated on June 16
th
, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, N°456 dated on September 14
th
, 1995.
The articles of association of the Company have last been lastly amended pursuant to a deed of the undersigned Maître
Martine SCHAEFFER, dated 20 June 2013, published in the Mémorial C, N° 1577 on 3 July 2013. Pursuant to a meeting
of the board of directors held on December 23
rd
2013 the registered office of the Company was moved, which resolution
was published in the Mémorial C, number 319 of February 5
th
2014.
The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may
validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company up to the amount of USD 7,371,780 by cash contribution in order to
raise it from its current amount of USD 38,333,370 to an amount up to USD 45,705,150 by the issuance of up to 737,178
new ordinary shares of USD 10 each, with a global share premium of an amount of up to USD 142,629,199.44;
2. Subscription and full payment of the share capital increase and above mentioned share premium;
3. Subsequent amendment of the article 6 of the articles of association of the Company;
4. Subsequent appointment of new directors in connection with the proposed increase of capital of the Company;
5. Any other business
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decide to increase the share capital of the Company by an amount of seven million three hundred seventy-
one thousand seven hundred eighty US Dollars (USD 7,371,780.-) by a cash contribution, so as to raise it from its current
amount of thirty-eight million three hundred thirty-three thousand three hundred seventy US Dollars (USD 38,333,370.-)
to an amount of forty-five million seven hundred and five thousand one hundred fifty US Dollars (USD 45,705,150.-) with
issuance of seven hundred thirty-seven thousand one hundred seventy-eight (737,178) new shares with a nominal value of
108797
L
U X E M B O U R G
ten US Dollars (USD 10.-) each, having the same rights and obligations as the existing ones, with a global share premium
of one hundred forty-two million six hundred twenty-nine thousand one hundred ninety-nine US Dollars and forty-four
cents (USD 142,629,199.44).
<i>Second resolutioni>
The meeting note that DPH waives its pre-emptive right to subscribe to new shares in the share capital of the Company.
The meeting further note that:
- STEELHOLD, pre-named agrees to subscribe to five (5) new ordinary shares of ten US Dollars (USD 10.-) each for
the total cash subscription price of one thousand and seventeen US Dollars and forty cents (USD 1,017.40); and
- HEBSTEEL, pre-named agrees to subscribe to seven hundred thirty-seven thousand one hundred seventy-three
(737,173) new ordinary shares of ten US Dollars (USD 10.-) each for the total cash subscription price of one hundred forty-
nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred sixty-two US Dollars and four cents (USD 149,999,962.04).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
There appeared:
1. STEELHOLD, pre-named, here represented by Mr Julien GUILLAUME pursuant to the aforesaid proxy, declared
to fully subscribe to five (5) new shares in the Company and pay the corresponding subscription price by cash subscription.
2. HEBSTEEL, pre-named, here represented by Mr. Zhao Shougang, pursuant to the aforesaid proxy, declared to fully
subscribe to seven hundred thirty-seven thousand one hundred seventy-three (737,173) new shares in the Company and
pay the corresponding subscription price by cash subscription.
The meeting note that the difference between the value of the contribution in cash of one hundred fifty million nine
hundred seventy-nine US Dollars and forty-four cents (USD 150,000,979.44) and the capital increase of seven million
three hundred seventy-one thousand seven hundred eighty US Dollars (USD 7,371,780) equal to one hundred forty-two
million six hundred twenty-nine thousand one hundred ninety-nine US Dollars forty-four cents (USD 142,629,199.44) is
to be allocated to the share premium.
The total amount of the contribution in cash of one hundred fifty million nine hundred seventy-nine US Dollars and
forty-four cents (USD 150,000,979.44) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decide to amend article 6 of the Articles of Association of
the Company to read as follows:
“ Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is set at forty-five million seven hundred five thousand and one
hundred fifty US Dollars (USD 45,705,150) consisting of four million five hundred seventy thousand five hundred and
fifteen (4,570,515) shares in registered form with a par value of ten US Dollars (USD 10) each, all subscribed and fully
paid-up.
The share capital may be increased or reduced from time to time by means of a resolution of the extraordinary general
meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments to the Articles.
The company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law
All the shares are in registered form. A register of the registered shares shall be maintained by the Company and shall
specify the name and address of each shareholder, the number of shares or fractional shares held by him, the payment made
on the shares, transfers and dates thereof or conversion of the shares into shares in bearer form.”
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above increase of share capital of the Company, the meeting decide to remove all current
directors from the Board of Directors of the Company as of the date of the present meeting and appoint new directors of
the Company so that the new Board of Directors of the Company will be composed only by the following individuals,
namely:
Mr. Bruno Bolfo, born in Lavagna (GE), Italy, on 11 August 1941, residing in Piazza Bernardino Luini, 4, 6900 Lugano,
Switzerland, as A Director and President, until the annual general meeting of the shareholders to approve the annual accounts
for the financial year ending on September 30, 2020.
Mr. Benedict John Sciortino, born in New York, United States of America, on 29 June 1950, residing in Via Motta 34,
6900 Lugano, Switzerland, as A Director, until the annual general meeting of the shareholders to approve the annual
accounts for the financial year ending on September 30, 2020
Mr. Julien Guillaume, born in Messancy, Belgium, 3 July 1984, professionally residing in 6, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg as B Director until the annual general meeting of the shareholders to approve the annual accounts for
the financial year ending on September 30, 2020
108798
L
U X E M B O U R G
Mr. Bruno Beernaerts, born in Ixelles, Belgium, on 4 November 1963, residing in 28, rue du Cimetière, L-8824 Perlé,
as B Director, until the annual general meeting of the shareholders to approve the annual accounts for the financial year
ending on September 30, 2020
Mr. Matthew De Morgan, born in Guildford, United Kingdom, on 15 May 1970, residing in Via Sassa 10, 6900 Mas-
sagno, Switzerland, as A Director and Chief Executive Officer until the annual general meeting of the shareholders to
approve the annual accounts for the financial year ending on September 30, 2020
Mr. YU, Yong, born in Jilin, China, on 15 October 1963, residing in No. 8-2-602, Lijing Garden Community, Yuhua
District, Shijiazhuang, Hebei Province, China, as A Director and Vice-President until the annual general meeting of the
shareholders to approve the annual accounts for the financial year ending on September 30, 2020
Mr. LI, Yidong, born in Hebei, China, on 26 September 1963, residing in 1104, 1/F, Diaoyutai Gangfeng Tower, Lubei
District, Tangshan City, Hebei Province, China as A Director until the annual general meeting of the shareholders to approve
the annual accounts for the financial year ending on September 30, 2020
Mr. YAN, Xiujun born in Hebei, China, on 8 December 1965, residing in Room 701, Unite 1, Building No. 3, Xingye
Garden Community, Shuangqiao District, Chengde City, Hebei Province, China, as A Director until the annual general
meeting of the shareholders to approve the annual accounts for the financial year ending on September 30, 2020.
Mrs. YANG, Guiqing, born in Hebei, China, on 30 October 1968, residing in No. 2-1-201, Lijing Garden Community,
Yuhua District, Shijiazhuang, Hebei Province, China as A Director until the annual general meeting of the shareholders to
approve the annual accounts for the financial year ending on September 30, 2020.
Mr. Patrick Moinet, born in Bastogne, Belgium, on 6 June 1975, residing in 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg,
as B Director until the annual general meeting of the shareholders to approve the annual accounts for the financial year
ending on September 30, 2020.
Mr. Dirk Dewitte, born in Aalst, Belgium, on 10 April 1956, professionally residing in 31, Grand-Rue, L-1661 Luxem-
bourg, as B Director until the annual general meeting of the shareholders to approve the annual accounts for the financial
year ending on September 30, 2020
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed, are estimated at approximately seven thousand one hundred Euro (EUR 7,100.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-cinq jour du mois de Juin.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING S.A., une société anonyme valablement constituée et existante selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 49308 («DPH»),
ici représentée par M. Julien Guillaume, gréant, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procu-
ration sous seing privé qui lui a été donnée le 24 avril 2015;
2. STEELHOLD LIMITED, une société valablement constituée et existante selon les lois de Chypre, ayant son siège
social au Themistokli Dervi, 3, Julia House, CY-1066, Nicosia, Cyprus, immatriculée auprès du Ministry of Commerce,
Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver of Nicosia sous le numéro HE 152463
(«STEELHOLD»),
ici représentée par M. Julien Guillaume, gérant, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé qui lui a été donnée le 24 avril 2015;
3. HEBSTEEL GLOBAL HOLDING PTE. LTD, une société valablement constituée et existante selon les lois de
Singapour, ayant son siège social au 20 Collyer Quay, #11-02, Singapore 049319, immatriculée auprès du Accounting and
Corporate Regulatory Authority of Singapore sous le numéro 2015066010W («HEBSTEEL»),
ici représentée par M. Zhao Shougang, ayant son adresse professionnelle au No.385 Tiyu South Avenue, Shijiazhuang,
Habei, China en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été donnée le 19 juin 2015,
Tous ensemble nommés ci-après les «Actionnaires».
108799
L
U X E M B O U R G
Lesdites procurations, après signature «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les Actionnaires, aux termes de la capacité en laquelle ils agissent, ont demandé au notaire instrumentaire de prendre
acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social de la «DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING
S.A.», une société anonyme valablement constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B51469 (la «Société»), constituée selon acte du
notaire Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg le 16 juin 1995, , publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N° 456 du 14 septembre 1995.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Me Martine SCHAEFFER, notaire de
résidence à Luxembourg du 20 juin 2013 publié au Mémorial C numéro 1577 du 3 juillet 2013. En date du 23 décembre
2013, le conseil d'administration a changé le siège de la Société qui a été publié au Mémorial C, numéro 319 du 5 février
2014.
Les Actionnaires reconnaissent que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
son ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société jusqu'à concurrence d'un montant de 7.371.780 USD par apport en
numéraire, en vue de le porter de son montant actuel de 38.333.370 USD à un montant maximum de 45.705.150 USD par
l'émission d'au maximum 737.178 nouvelles actions ordinaires ayant une valeur nominale de 10 USD chacune, avec une
prime d'émission globale d'un montant maximum de 142.629.199,44 USD;
2. Souscription et paiement intégral de l'augmentation du capital et de la prime d'émission susmentionnée;
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société;
4. Nomination subséquente de nouveaux administrateurs dans le cadre de l'augmentation de capital proposée de la
Société;
5. Divers
Après que l'agenda ait été approuvé par l'assemblé générale, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de sept millions trois cent
soixante-et-onze mille sept cent quatre-vingt US Dollars (USD 7.371.780,-) par apport en numéraire afin de le porter de
son montant actuel de trente-huit millions trois cent trente-trois mille trois cent soixante-dix US Dollars (USD 38.333.370,-)
à un montant de quarante-cinq millions sept cent cinq mille cent cinquante US Dollars (USD 45.705.150,-) par l'émission
de sept cent trente-sept mille cent soixante-dix-huit (737.178) nouvelles actions ayant une valeur nominale de dix US
Dollars (10 USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes, avec une prime d'émission globale
de cent quarante-deux millions six cent vingt-neuf mille cent quatre-vingt-dix-neuf US Dollars et quarante-quatre cents
(USD 142.629.199,44).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée prend acte que DPH renonce à son droit préférentiel de souscription aux nouvelles actions dans le capital
social de la Société.
L'assemblée prend également acte que:
- STEELHOLD, prénommé, consent à souscrire à cinq (5) nouvelles actions ordinaires ayant une valeur nominale de
dix US Dollars (USD 10,-) chacune pour un prix de souscription total de mille dix-sept US Dollars et quarante cents (USD
1.017,40); et
- HEBSTEEL, prénommé, consent à souscrire à sept cent trente-sept mille cent soixante-treize (737.173) nouvelles
actions ordinaires ayant une valeur nominale de dix US Dollars (USD 10,-) chacune pour un prix de souscription total de
cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-deux US Dollars et quatre cents (USD
149.999.962,04)
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Ont comparu:
1.- STEELHOLD, prénommée, ici représentée par M. Julien Guillaume en vertu de la procuration susmentionnée, a
déclaré souscrire à cinq (5) nouvelles actions de la Société et payer le prix de souscription correspondant en numéraire.
2.- HEBSTEEL, prénommée, ici représentée par M. Zhao Shougang en vertu de la procuration susmentionnée, a déclaré
souscrire à sept cent trente-sept mille cent soixante-treize (737.173) nouvelles actions de la Société et payer le prix de
souscription correspondant en numéraire.
L'assemblée prend acte que la différence entre la valeur de la souscription en numéraire de cent cinquante millions neuf
cent soixante-dix-neuf US Dollars et quarante-quatre cents (150.000.979,44 USD) et l'augmentation du capital de la Société
108800
L
U X E M B O U R G
de sept millions trois cent soixante et onze mille sept cent quatre-vingt US Dollars (7.371.780 USD) est égale à cent
quarante-deux millions six cent vingt-neuf mille cent quatre-vingt-dix-neuf US Dollars et quarante-quatre cents
(142.629.199,44 USD) est à verser au compte prime d'émission.
Le montant total de l'apport en numéraire de cent cinquante millions neuf cent soixante-dix-neuf US Dollars et quarante-
quatre cents (150.000.979,44 USD) est à la disposition de la Société, comme il l'a été prouvé au notaire soussigné, qui le
reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société
afin de le lire comme suit:
« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à quarante-cinq millions sept cent cinq mille cent cinquante US Dollars (USD
45.705.150), divisé en quatre millions cinq cent soixante-dix mille cinq cent quinze (4.570.515) actions nominatives ayant
chacune une valeur nominale de dix US Dollars (USD 10), toutes entièrement souscrites et libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Toutes les actions sont nominatives. Un registre des actionnaires est tenu par la Société et mentionne le nom et l'adresse
de chaque actionnaire, le nombre d'actions ou de fractions d'actions qu'il détient, les paiements relatifs à ces actions, les
transferts d'actions, le cas échéant, la date de chaque transfert ou la conversion des actions en actions au porteur.»
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société mentionnée ci-avant, l'assemblée décide de révoquer
les administrateurs courants avec effet immédiat et de nommer de nouveaux administrateurs de la Société de sorte que le
nouveau conseil d'administration de la Société soit composé seulement par les personnes suivantes, à savoir:
M. Bruno Bolfo, né à Lavagna (GE), Italie, le 11 Août 1941, résidant à Pizza Bernardino Luini, 4, 6900 Lugano, Suisse,
comme Administrateur A et Président, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes
annuels pour l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
M. Benedict John Sciortino, né à New York, USA, le 29 Juin 1950, résidant à Via Motta, 34, 6900 Lugano, Suisse,
comme Administrateur A, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels pour
l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
M. Julien Guillaume, né à Messancy, Belgique, le 3 Juillet 1984, résidant professionnellement à 6, rue Guillaume
Schneider, L-2522 Luxembourg comme Administrateur B, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approu-
vant les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
M. Bruno Beernaerts, né à Ixelles, Belgique, le 4 Novembre 1963, résidant à 28, rue du Cimetière, L-8824 Perlé, comme
Administrateur B, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels pour l'exercice
se terminant le 30 Septembre 2020.
M. Matthew De Morgan, né à Guildford, Royaume-Unis, le 15 Mai 1970, résidant à Via Sassa, 10, 6900 Massagno,
Suisse, comme Administrateur A et Délégué à la gestion journalière (Chief Executive Officer), jusqu'à l'assemblée générale
annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
M. YU, Yong, né à Jilin, Chine, le 15 octobre 1963, résidant à No. 8-2-602, Lijing Garden Community, Yuhua District,
Shijiazhuang, Hebei Province, China comme Administrateur A and Vice-Président , jusqu'à l'assemblée générale annuelle
des actionnaires approuvant les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
M. LI, Yidong, né à Hebei, Chine, le 26 septembre 1963, résidant à 1104, 1/F, Diaoyutai Gangfeng Tower, Lubei District,
Tangshan City, Hebei Province, Chine, comme Administrateur A, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires
approuvant les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
M. YAN, Xiujun, né à Hebei, Chine, le 8 décembre 1965, résidant à Room 701, Unite 1, Building No. 3, Xingye Garden
Community, Shuangqiao District, Chengde City, Hebei Province, China comme Administrateur A, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
Mme YANG, Guiqing, né à Hebei, Chine, le 30 octobre 1968, résidant à No. 2-1-201, Lijing Garden Community, Yuhua
District, Shijiazhuang, Hebei Province, China comme Administrateur A jusqu'à l'assemblée générael annuelle des action-
naires approuvant les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
M. Patrick Moinet, né à Bastogne, Belgique on 6 juin 1975, résidant à in 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg,
comme Administrateur B, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels pour
l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
M. Dirk Dewitte, né à Aalst, Belgique, le 10 avril 1956 résidant professionnellement à 31, Grand-Rue, L-1661 Luxem-
bourg, comme Administrateur B, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels
pour l'exercice se terminant le 30 Septembre 2020.
108801
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit et qui incomberont à la Société en raison
du présent acte, sont estimés à environ sept mille cent euros (EUR 7.100,-).
L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance a alors été levée.
Passé à Luxembourg, le jour, qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux parties comparantes, elles ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des parties comparantes
susmentionnées, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de ces mêmes parties
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Signé: J. Guillaume et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 juin 2015. Relation: 2LAC/2015/14365. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Référence de publication: 2015111300/292.
(150120920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Shine France Logistics S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 196.957.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty second day of the month of June.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the
depositary of the present deed,
there appeared:
Shine France Pledgeco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés of Luxembourg under number B 196.933 (the “Sole Shareholder”),
represented by Maître Elsa Idir, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 18 June 2015
which proxy shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the
undersigned notary,
being the Sole Shareholder of Shine France Logistics S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability
company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 196.957 (the "Company"), incorporated
on 4 May 2015 pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”).
The articles of association of the Company have never been amended.
The appearing party, represented as above stated declared and requested the notary to record as follows:
A. The Sole Shareholder holds all the five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital
is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.
B. The items on which resolutions are to be taken are as follows:
1) creation of two classes of shares in the Company, namely class A shares and class B shares, and determination of the
rights and obligations thereof by amending and restating the articles of association of the Company as set forth further to
item 4) of the agenda.
2) reclassification of all the five hundred (500) issued shares in the Company as five hundred (500) class A shares.
3) increase of the issued share capital by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) from its current
amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) by the issue of
five hundred (500) new class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) (the “New Shares”) and
a total subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) (the “Subscription Price”); subscription to
the New Shares by the Sole Shareholder and payment of the Subscription Price in cash.
108802
L
U X E M B O U R G
4) consequential amendment and restatement of the articles of association of the Company to reflect the resolutions on
the items above.
Thereafter the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to create two classes of shares in the Company, namely class A shares and class B shares,
and determination of the rights and obligations thereof by amending and restating the articles of association of the Company
as set forth further to item 4) of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to reclassify all the five hundred (500) issued shares in the Company as five hundred
(500) class A shares.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital by an amount of twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500) from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to twenty-five thousand Euro
(EUR 25,000) by the issue of five hundred (500) new class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25) (the “New Shares”) and a total subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) (the “Subscription
Price”).
The New Shares have been subscribed and fully paid in by way of a contribution in cash of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500) by the Sole Shareholder pursuant to proxy and subscription forms (copies of which shall remain attached
to the present deed to be registered therewith).
Proof of the existence and the amount of the Subscription Price, blocked in an account of the Company, has been given
to the notary.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend and restate of the articles of
association of the Company to reflect the resolutions on the items above.
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Shine France Lo-
gistics S.à r.l.” (the “Company”) between the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
108803
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twenty five thousand Euros (EUR 25,000)
represented by (i) five hundred (500) shares of class A of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each divided,
and (ii) five hundred (500) shares of class B of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.
Each class of shares shall be issued in connection with the acquisition or making by the Company of a specific investment
or investment portfolio directly or indirectly (each a "Specific Investment"), except as otherwise specified herein. The
subscription price paid to the Company upon the issuance of shares of a particular class (including for the avoidance of
doubt any share premium) (the "Subscription Price"), net of all costs payable by the Company in connection with such
issuance including, but not limited to, capital duty, notarial fees and publication costs ("Issuance Costs"), shall be invested
directly or indirectly in one and the same Specific Investment.
The Specific Investment for Class A is the Class A Portfolio.
The Specific Investment for Class B is the Class B Portfolio.
In relation to each Specific Investment, the sole manager, or as the case may be, the board of managers will, in the
internal accounts of the Company, establish a separate compartment of assets and liabilities of the Company in the following
manner:
- the Subscription Price of the relevant class of shares, the payment to share premium account, and the proceeds of any
loans, preferred equity certificates, debt or other instruments convertible or not which may from time to time be granted
to, or issued by, the Company by or to its shareholder(s) in connection with the relevant Specific Investment, as well as
assets acquired with such funds contributed to or borrowed by the Company, in each case shall be applied in the internal
books of the Company to the compartment established for such Specific Investment;
- any income or proceeds earned by the Company on, or any asset derived from, the assets allocated to a compartment
shall be allocated to that compartment;
- any liability, costs and expenses (including provisions) relating to assets allocated to a compartment or to any action
taken in connection with a compartment or an asset of a particular compartment or in connection with the issuance of shares
or other instruments of the particular class (such as Issuance Costs) as well as all administration expenses, tax liabilities
and other costs and expenses of the Company attributable to the relevant Specific Investment or the operation or adminis-
tration of that compartment shall be allocated to that compartment;
- in the case where any liability or expense of the Company cannot be considered as being attributable solely to a
particular compartment, such liability or expense shall be allocated between all the existing compartments pro rata to the
Net Assets (as defined below) of each compartment or pro rata to the relevant compartments to which the liability or expense
relates;
- any distributions or payments (including payments of the price payable by the Company for shares of the relevant class
repurchased by it) made to shareholders in respect of a compartment shall reduce the Net Assets (as defined below) of that
compartment;
- the net assets of each compartment (the "Net Assets") will be equal to the sum of the value of the Specific Investment
of that compartment and all other assets attributable to that compartment in accordance with these articles of association
less all the liabilities, costs and expenses allocated to that compartment in accordance with these articles of association.
For the avoidance of doubt, any reference to the Net Assets in these articles of association may be construed as a reference
to the Net Assets as calculated for any Specific Investment allocated to a specific class of shares in the compartment created
to that purpose in the internal accounts of the Company.
Any share premium paid in respect of a specific class (or sub-class) of shares upon their issuance shall be allocated to
a share premium account corresponding to that specific class (or sub-class) of shares of the Company. Any payment or
contribution of any kind to any share premium account established in accordance with Luxembourg law or accounting
108804
L
U X E M B O U R G
regulations shall be specified as to which class (or sub-class) of shares it relates, the sole manager or, as the case may be,
the board of managers, having the power to confirm any allocation to a specific class (or sub-class) of shares if this has not
been specified otherwise. Any available share premium shall be distributable. In addition, the economic rights of share-
holders may be governed by an agreement between the shareholders. To the extent there are any inconsistencies between
the provisions of such agreement and these articles of association, the principle set out in the agreement between the
shareholders in relation to the economic rights shall prevail.
Art. 6. Cancellation of an entire class of shares and reduction of share capital. The share capital of the Company may
be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire class of shares through
the repurchase and cancellation of all the shares in issue in the relevant class by approval at the general meeting of share-
holders resolving at the quorum and majorities provided for the amendment of the articles of association.
In case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more class of shares, the
holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the
Cancellation Value per Share (as defined below) for each share of the relevant class held by them and cancelled.
The board of managers shall, in case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a
class of shares, calculate the Class Available Amount for the repurchased class (always subject to the amount of available
profits, premium and reserves of the Company) on the basis of the interim accounts of the Company and interim internal
accounts relating to the relevant class which shall be prepared on the basis set out in Article 5, each time not older than
eight (8) days (together, the “Interim Accounts”).
“Class Available Amount” means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company
(including carried forward profits) relating to the Specific Investment to which the relevant class of shares belongs (i) plus
the amount of the share capital reduction relating to the class of shares repurchased (and if any the amount equal to the
decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such class) but (ii) less any Investment
Losses of that class (including carried forward losses) and (iii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the articles of association.
“Class A Portfolio”, means the investment by way of shares, share premium account, loans, preferred equity certificates,
or other instruments, convertible or not, or otherwise in Shine France Holdco BV, a Dutch limited liability company,
incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at Suikersilo-Oost 32, 1165MS Halfweg, Netherlands
(and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to
finance directly or indirectly the project Clover, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to
finance any other projects and especially project Shine.
“Class B Portfolio” means the investment by way of shares, share premium account, loans, preferred equity certificates,
or other instruments, convertible or not, in Shine France Holdco BV, a Dutch limited liability company, incorporated under
the laws of the Netherlands, with registered office at Suikersilo-Oost 32, 1165MS Halfweg, Netherlands (and the underlying
assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or
indirectly the French portfolio of project Shine, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance
any other projects and especially project Clover.
“Investment Losses” means any losses (including carry forward losses relating to the relevant Specific Investment) and
any costs, charges or expenses related to the relevant Specific Investment (including repayment by the Company of any
debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion (calculated
of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the board of managers) and the Company's non-
recoverable losses. The “Cancellation Value per Share” shall be calculated by dividing the Class Cancellation Amount by
the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.
The “Class Cancellation Amount” shall be an amount determined by the sole manager or, as the case may be, the board
of managers and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the Interim Accounts. Subject always to
the amount of available net profits, reserves and premium of the Company, the Class Cancellation Amount for the class of
shares to be repurchased and cancelled shall be the Class Available Amount unless otherwise resolved by the general
meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the articles of association provided however that the
Class Cancellation Amount shall never be higher than the Class Available Amount and provided further that the Class
Cancellation Amount shall never be greater than the total amount of available net profits, reserves and premium of the
Company.
Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class, the Cancellation Value per Share will become
due and payable by the Company.
Art. 7. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent (75%)
of the Company's share capital.
Art. 8. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
108805
L
U X E M B O U R G
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers, including specific powers given
in specific provisions of these articles of association.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 9. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability”
and “expenses” shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
108806
L
U X E M B O U R G
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
Art. 10. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns (regardless of class) and may validly act at any meeting of shareholders through a
special proxy.
Art. 11. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than forty (40) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 12. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2015.
Art. 13. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the sole
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 14. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on one or several classes of shares on the basis of statements of
accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the
last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law (regardless of the Investment Net Income of
a class of shares). Distribution to a class shall only be made out of the Investment Net Income related to that class (subject
to the above).
“Investment Net Income” means any income last accounting year increased by profits carried forward and distribute
return of any total or partial disposal of the relevant Specific Investment (disposal meaning through transfers and contri-
butions of any kind) as well as any dividends or other distributions, interest, yield, repayment of principal or other income
or return deriving from the relevant Specific Investment and assets and reserve funds received by or attributable to the
Company in respect of the issue of the relevant class of shares such as the share premium or any amounts of profit (related
to the relevant Specific Investment(s)) carried forward after deducting any costs, charges or expenses related to the relevant
Specific Investment (including repayment by the Company of any debt incurred to manage the respective Specific Invest-
ment), and an amount corresponding to the pro rata portion calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly
but irrevocably by the board of managers or the sole manager as the case may be) and the Company's non-recoverable
losses.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders,
but only to the shareholders of the class to which this share premium relates to. The general meeting of shareholders may
decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.
108807
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds of each class shall be the amount to which the class is entitled
as per the relevant Specific Investment if applicable, or, for the classes of non-tracking shares, as per the nominal value of
the shares as may be determined through the separate compartment of assets and liabilities that the board of managers has
established for them in the internal accounts of the Company. Each class of shares shall be entitled to proceeds of liquidation
determined as follows in relation to the relevant Specific Investment to which the class relates or as follows from the
nominal value of the shares for the classes of non-tracking shares:
First all debts and liabilities of the Company (regardless of Specific Investment) shall be paid. Such debts or liabilities
shall be attributed to the class of shares to which they specifically belong (i.e. because they relate to the relevant Specific
Investment for that class) or, if that is not possible, distributed rateably among all classes of shares in proportion of the
issued share capital of the Company which they represent.
Thereafter the relevant amount of liabilities for each class of shares shown in the separate category for the Specific
Investment to which they relate shall be set against the assets attributable to the relevant class including in particular the
Specific Investment of that class and any reserve funds attributable to such class. Assets not attributable to a specific class
shall be divided pro rata to all classes of shares.
To the extent that the amount so calculated for any class shall be negative, such class shall not be entitled to any liquidation
proceeds. The relevant negative amount shall be allocated rateably among all classes of shares which have a positive amount
up such positive amount. Any surplus remaining within a specific class of shares (the "Class Surplus") shall be distributed
to the relevant holders of such class of shares.
Art. 16. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies,
as amended; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 17. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at EUR 1,550.-
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above
appearing persons the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing persons signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Englischen Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zweiundzwanzigsten Tag des Monats Juni.
Vor Uns, Maître Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welch Letzterer in
Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.
Ist erschienen:
Shine France Pledgeco S.à r.l., société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer
B 196.933 (der «Alleinige Gesellschafter»),
hier vertreten durch Maître Elsa Idir, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht aus-
gestellt am 18. Juni 2015, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt wird nachdem sie ne varietur durch den Vollmacht-
nehmer und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde,
als Alleiniger Gesellschafter der Shine France Logistics S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesell-
schaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des
Sociétés in Luxemburg unter Nummer B 196.957 (die «Gesellschaft»), gegründet am 4. May 2015 gemäß Urkunde auf-
genommen durch Maître Cosita Delvaux, Notar mit Amtsitz in Luxemburg, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (das «Mémorial») veröffentlicht.
Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nie abgeändert.
Der Erschienene gibt, in Ausübung seines obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
108808
L
U X E M B O U R G
A. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Ge-
sellschaftsanteile, sodass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der Tagesordnung
entschieden werden kann.
B. Die Punkte, über die Beschlüsse getroffen werden, sollen sind die Folgenden:
1) Gründung von zwei Anteilsklassen der Gesellschaft, nämlich Klasse A Anteilen und Klasse B Anteilen, und Be-
stimmung denen Rechten und Pflichten durch die Abänderung und Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft, wie in
Punkt 4 der Agenda vorgesehen.
2) Umnennung allen fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile in fünfhundert (500)
Klasse A Anteilen.
3) Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapital in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) von dem
aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) auf fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25,000) durch
Ausgabe von fünfhundert (500) neue Anteile der Klasse B mit einem Nominalwert in Höhe von fünfundzwanzig Euro
(EUR 25) (die „Neuen Anteile“) und für einen Gesamtzeichnungspreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500)
(der „Zeichnungspreis“); Zeichnung der Neuen Anteile durch den Alleinigen Gesellschafter und Zahlung des Zeichnungs-
preises in Bar.
4) Die daraus folgende Abänderung und Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft um die Beschlüsse über die
obengenannten Punkte wiederzuspiegeln.
Danach wurden die folgenden Beschlüsse vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen zwei Anteilsklassen der Gesellschaft, nämlich Klasse A Anteilen und
Klasse B Anteilen zu gründen, und die daraus Rechten und Pflichten durch die Abänderung und Neuformulierung der
Satzung der Gesellschaft zu bestimmen, wie in Punkt 4 der Agenda vorgesehen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschafts-
anteile in fünfhundert (500) Klasse A Anteilen umzunennen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen das Gesellschaftskapital in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12,500) von dem aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) auf fünfundzwanzigtausend Euro
(EUR 25,000) zu erhöhen, durch die Ausgabe von insgesamt fünfhundert (500) neuen Anteilen der Klasse B mit einem
Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) (die „Neuen Anteile“) und einem Zeichnungspreis in Höhe von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) (der „Zeichnungspreis“). Die Neue Anteile sind in Bar in Höhe von dem
aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) gezeichnet und völlig bezahlt worden durch den Al-
leinigen Gesellschafter laut Bevollmächtigungen und Zeichnungsformular (denen Kopien mit dieser Urkunde eingetragen
werden soll).
Ein Beweis über die Existenz und den Betrag des Zeichnungspreises, in einem Sperrkonto der Gesellschaft beinhaltet,
wurde vor dem Notar gezeigt.
<i>Vierten Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat folglich beschlossen die Satzung der Gesellschaft abzuändern und neuzuformulieren,
um die obgenannten Beschlüsse wiederzuspiegeln.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Shine France Logistics S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise sowie die Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direktem oder indirektem Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann garantieren, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder
indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder
anderen Form unterstützen.
108809
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzen oder Regulierungsmaßnahmen, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfundzwanzig-
tausend Euro (EUR 25.000), eingeteilt in (i) fünfhundert Klasse A (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig Euro (EUR 25) und (ii) fünfhundert Klasse B (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig Euro (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Jede Anteilsklasse wird in Verbindung mit dem Erwerb oder der Durchführung eines spezifischen direkten oder indi-
rekten Investments ausgegeben (jedes ein „Spezifisches Investment“), soweit hiernach nicht anders angegeben. Der, der
Gesellschaft gezahlte Zeichnungspreis bei der Ausgabe der Anteile (um Zweifel zu vermeiden einschließlich jedes An-
teilsprämie) (der „Zeichnungspreis“), abzüglich aller durch die Gesellschaft, bezüglich der Anteilsausgabe, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf, Gesellschaftssteuer, Notargebühren und Veröffentlichungskosten („Emissionskosten“) zu zah-
lenden Kosten, soll direkt oder indirekt in ein und demselben Spezifischen Investment investiert werden.
Das Spezifische Investment bezüglich Klasse A bezieht sich auf Klasse A Portfolio.
Das Spezifische Investment bezüglich Klasse B bezieht sich auf Klasse B Portfolio.
In Bezug auf jedes Spezifische Investment wird der alleinige Geschäftsführer, beziehungsweise die Geschäftsführung,
in der Buchführung der Gesellschaft wie folgt eine separate Abteilung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf-
stellen:
- Der Zeichnungspreis der relevanten Anteilsklasse, die Zahlung ins Anteilsprämienkonto, Erlöse aus Gesellschafter-
darlehen, Preferred Equity Shares, Schulden oder andere Instrumente, wandelbar oder nicht, welche von Zeit zu Zeit der
Gesellschaft gewährt, oder durch die Gesellschaft gewährt werden, von oder an ihre(n) Anteilsinhabe(r), in Verbindung
mit dem relevanten Spezifischen Investment, sowie Vermögenswerte welche mit solchen Mitteln der Gesellschaft beige-
108810
L
U X E M B O U R G
tragen oder von ihr geliehen wurden, sollen in der Buchhaltung der Gesellschaft der, des spezifischen Investments
zugeteilten separaten Abteilung, angewendet werden;
- Alle Einkommen oder Einlöse welche die Gesellschaft verdient, oder irgendwelche Vermögenswerte, abgeleitet von
den Vermögenswerten die einer separaten Abteilung der Buchführung zugeteilt sind, werden dieser separaten Abteilung
zugeteilt;
- Jegliche Verbindlichkeit, Kosten und Ausgaben (einschließlich Provisionen) bezüglich der Vermögenswerte die einer
separaten Abteilung zugerechnet werden, oder jeglicher in Verbindung mit einer separaten Abteilung oder einem Vermö-
genswertes einer separaten Abteilung, oder in Verbindung mit der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen oder anderer
Instrumente der betroffenen Klasse (z.B. Emissionskosten), getroffenen Handlung, sowie alle administrativen Kosten,
Steuerverpflichtungen und andere Kosten und Ausgaben der Gesellschaft welche dem relevanten Spezifischen Investment
zugerechnet werden können, oder die Durchführung und Verwaltung dieser Abteilung, sollen dieser separaten Abteilung
zugerechnet werden;
- Im Falle von Verbindlichkeit oder Aufwendung der Gesellschaft welche nicht einer separaten Abteilung zugerechnet
werden können, wird diese Verbindlichkeit oder Aufwendung pro rata zu den Nettovermögenswerten (wie hierfolgt defi-
niert) jeder separaten Abteilung zwischen den existierenden Abteilungen oder pro rata zwischen den relevanten Abteilungen
auf welche diese Verbindlichkeit oder Aufwendung fällt aufgeteilt;
- Jedwede Ausschüttungen oder Auszahlungen (einschließlich Zahlungen welche im Falle eines Anteilsrückkaufs durch
die Gesellschaft fällig werden würden) an die Gesellschafter bezüglich einer Abteilung sollen die Nettovermögenswerte
(wie hierfolgt definiert) dieser Abteilung mindern;
- Die Nettovermögenswerte jeder Abteilung („Nettovermögenswerte“) entsprechen der Summe des Wertes des spezi-
fischen Investments dieser Abteilung und aller weiteren Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, Kosten und
Ausgaben welche gemäß dieser Satzung dieser Abteilung zugerechnet werden können
Zur Vermeidung jeglicher Zweifel, soll jeder Bezug auf die Nettovermögenswerte in dieser Satzung so verstanden
werden, dass er die berechneten Nettovermögenswerte der Spezifischen Investments die auf eine spezifische Anteilsklasse
zugeteilt sind in der eigens dafür geschaffenen Abteilung der Geschäftsbücher der Gesellschaft zusammengefasst werden,
umfasst.
Irgendeine Anteilsprämie welche in Bezug auf die Ausgabe einer spezifischen Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse)
eingezahlt wurde, wird auf das Anteilsprämienkonto eingezahlt welches der spezifischen Anteilsklasse (oder Anteilsun-
terklasse) der Gesellschaft entspricht. Bezüglich jeglicher Zahlung oder Einzahlung in eines der Anteilsprämienkonten,
welche in Übereinstimmung mit luxemburgischem Gesetz sowie Rechnungslegungsvorschriften getätigt wird, soll festlegt
werden, auf welche Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse) sie sich bezieht. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise
die Geschäftsführung, haben die Befugnis jede Einzahlung an eine Spezifische Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse) zu
bestätigen falls nicht anders angegeben. Jede verfügbare Anteilsprämie können verteilt werden. Außerdem können die
Vermögensrechte der Gesellschafter durch einen privatschriftlichen Vertrag zwischen den Gesellschafter geregelt werden.
Insofern es Unstimmigkeiten zwischen den Bestimmungen dieses Vertrags und der Satzung der Gesellschaft gibt, so sind
die in einem solchen Vertrag dargelegten Grundsätze bezüglich der Vermögenswerte, maßgebend.
Art. 6. Annullierung einer gesamten Anteilsklasse und Herabsetzung des Stammkapitals. Das Gesellschaftskapital der
Gesellschaft kann durch die Annullierung von Anteilen herabgesetzt werden, einschließlich der Annullierung einer oder
mehrerer Anteilsklassen durch den Rückkauf und die Annullierung aller ausgegebenen Anteile bezüglich der relevanten
Anteilsklasse, durch Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit dem Quorum und der Mehrheit welche für eine
Änderung der Satzung nötig wären.
Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapital durch den Rückkauf und die Annullierung einer oder mehrerer
Anteilsklassen sollen die Anteilsinhaber der rückgekauften und annullierten Anteile entsprechend des Annullierungswert
pro Anteil (wie hierfolgt definiert) pro Anteil der relevanten Anteilsklasse welchen sie hielten und welcher annulliert wurde.
Die Geschäftsführung soll im Falle einer Herabsetzung des Grundkapitals durch den Rückkauf und die Annullierung
einer Anteilsklasse, den Klassenausschüttfähige Betrag für die rückgekaufte Klasse berechnen (immer abhängig von der
Summe der verfügbaren Gewinne, Agio und Reserven der Gesellschaft) anhand des Zwischenabschlusses der Gesellschaft
sowie des internen Zwischenabschlusses bezüglich der relevanten Klasse welcher gemäß Artikel 5 angefertigt werden soll,
jeweils nicht älter als acht (8) Tage (zusammen die „Zwischenabschlüsse“).
„Klassenausschüttfähige Betrag“ bedeutet die Gesamtsumme der Nettogewinne, verfügbaren Reserven sowie Anteils-
prämie der Gesellschaft (einschließlich Gewinnvortrag) betreffend das Spezifische Investment zu welcher die relevante
Anteilsklasse gehört (i) zuzüglich des Betrages der Herabsetzung des Stammkapitals betreffend der zurückgekauften An-
teilsklasse (und etwaiger Verringerung der gesetzlichen Reserven betreffend die Reduzierung des Stammkapitals bezüglich
der betroffenen Anteilsklasse) aber (ii) abzüglich etwaiger Anlageverluste betreffend diese Klasse (zuzüglich Verlustvor-
trägen) und (iii) abzüglich etwaiger Summen welche gemäß Gesetz oder Satzung in Reserve(n) eingebracht werden müssen.
„Klasse A Portfolio“ bedeutet das Investment durch Anteilen, Anteilsprämienkonto, Darlehens, Preferred Equity Shares
oder andere Instrumente, wandelbar oder nicht, oder auf anderem Wege in Shine France Holdco BV, eine niederländische
Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts mit Sitz in Suikersilo-Oost 32, 1165MS Halfweg, Nie-
derlande (und die Basiswerte, Filialen und juristische Personen), aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instru-
108811
L
U X E M B O U R G
menten bezüglich direkte oder indirekte Finanzierung des Projects Clover, mit Ausnahme von Instrumente gezeichnet oder
erworben bezüglich anderen Projekten und besonders Project Shine.
„Klasse B Portfolio“ bedeutet das Investment durch Anteilen, Anteilsprämienkonto, Darlehens, Preferred Equity Shares
oder andere Instrumente, wandelbar oder nicht, oder auf anderem Wege in Shine France Holdco BV, eine niederländische
Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts mit Sitz in Suikersilo-Oost 32, 1165MS Halfweg, Nie-
derlande (und die Basiswerte, Filialen und juristische Personen), aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instru-
menten bezüglich direkte oder indirekte Finanzierung des Projects Shine, mit Ausnahme von Instrumente gezeichnet oder
erworben bezüglich anderen Projekten und besonders Project Clover.
„Anlageverluste“ bezeichnet etwaige Verluste (einschließlich Verlustvorträge des relevanten Spezifische Investment)
sowie etwaige Kosten, Gebühren und Ausgaben betreffend das Spezifische Investment (einschließlich der Rückzahlung
durch der Gesellschaft jedweder Schulden welche in Folge der Verwaltung des relevanten Spezifischen Investments auf-
getreten sind), und einen Betrag in Höhe des pro rata Teils (berechnet an den allgemeinen Geschäftskosten (fair aber
unwiderruflich festgesetzt von der Geschäftsführung) und nicht erstattungsfähiger Verluste der Gesellschaft. Um den „An-
teilsannullierungswert pro Anteil“ zu berechnen wird der Annullierungsbetrag der Anteilsklasse durch die Anzahl der
ausgegebenen Anteile der betroffenen Anteilklasse welche zurückgekauft und annulliert werden, geteilt.
Der „Annullierungsbetrag der Anteilsklasse“ wird vom alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsfüh-
rung bestimmt und von der Gesellschafterversammlung auf Basis des Zwischenberichts genehmigt. Immer vorbehaltlich
der Summe der verfügbaren Nettogewinne, Reserven oder Anteilsprämie der Gesellschaft, wird der Annullierungsbetrag
der Anteilsklasse für die zurückzukaufende und annullierende Anteilsklasse, der Klassenausschüttfähige Betrag sein, sofern
nicht anderweitig durch die Gesellschafterversammlung in der Art und Weise bestimmt wie für eine Änderung der Satzung
vorgesehen, vorausgesetzt dass der Annullierungsbetrag der Anteilsklasse nie höher sein soll als der Klassenausschüttfähige
Betrag und ferner, dass der Annullierungsbetrag der Anteilsklasse nie höher sein soll als die Gesamtsumme der verfügbaren
Nettogewinne, Reserven und Anteilsprämie der Gesellschaft. Bei Rückkauf und Annullierung der Anteile einer relevanten
Klasse, wird der Anteilsannullierungswert durch die Gesellschaft fällig und zahlbar.
Art. 7. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 8. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichensten Befugnissen aus-
gestattet, die Geschäfte der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung, einschließlich spezifische Befugnissen
welche gemäß spezifischen Auflagen der Satzung eingebracht würden.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichensten Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
108812
L
U X E M B O U R G
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig Eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 10. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 11. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
108813
L
U X E M B O U R G
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als vierzig (40) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 12. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres mit
Aufnahme vom ersten Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31.December 2015
endet.
Art. 13. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 14. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf (trotz
des Investment Überschusses einer Anteilsklasse). Gewinnausschüttung in einer Klasse soll nur durch Investment Über-
schuss bezüglich dieser Klasse erlaubt werden (mit Vorbehalt des Obenerwähnten).
„Investment Überschuss“ umfasst jegliches Einkommen des letzten Geschäftsjahres zuzüglich Gewinnvorträge und
ausgeschüttet Rückgabe jeglicher teilweisen oder kompletten Veräußerung bezüglich relevante Spezifische Investment
(Veräußerung bedeutet Transfers sowie Einlagen jeder Art) sowie jegliche Dividenden und andere Ausschüttungen, Zinsen,
Renditen, Tilgungszahlungen, oder anderes Einkommen und Erträge welche vom relevanten Spezifischen Investment,
sowie Vermögenswerten und Reserven welche die Gesellschaft bekommen hat beziehungsweise ihr zugerechnet werden
können hinsichtlich der Ausgabe der relevanten Anteilsklassen wie beispielsweise das Agio oder jedwede Gewinne (be-
treffend das relevante Investment(s)), vorgetragen, ableiten lassen; abzüglich jeder Kosten, Gebühren und Ausgaben im
Zusammenhang mit dem relevanten Spezifischen Investment (einschließlich Rückzahlungen der Gesellschaft jedweder im
Zusammenhang mit der Verwaltung der relevanten Spezifischen Investments), und einen Betrag in Höhe des pro rata Teils
berechnet an den allgemeinen Geschäftskosten (fair aber unwiderruflich festgesetzt vom alleinigen Geschäftsführer be-
ziehungsweise der Geschäftsführung) und nicht erstattungsfähiger Verluste der Gesellschaft.
Der Kontostand kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, das Anteilsprämienkonto den Anteilsinhaber auszuschütten, aber
nur zu dessen Anteilsinhaber der angehörigen Klasse des Anteilsprämienkontos. Die Gesellschafterversammlung kann
beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche Rücklage zu übertragen.
Art. 15. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
Bei Auflösung der Gesellschaft umfasst der Liquidationserlös jeder Klasse, die Summe welche dieser Klasse bezüglich
des relevanten Spezifischen Investments gegebenenfalls zusteht, oder, bezüglich der „nontracking“ Anteile, den Nomi-
nalwert der Anteile wie anhand der separaten Klasse von Vermögenswerten und Schulden durch die Geschäftsführung
anhand der internen Buchführung der Gesellschaft bestimmt. Jede Anteilsklasse ist am Liquidationserlös berechtigt, fest-
gelegt anhand des relevanten Spezifischen Investments auf welches sich die Klasse bezieht oder anhand des Nominalwertes
der Anteile betreffend die Klassen von „nontracking“ Anteilen.
Erstens werden alle Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft (unabhängig eines Spezifischen Investments) ge-
zahlt. Solche Schulden und Verpflichtungen werden der Anteilsklasse zugerechnet welcher sie angehören (z.B. weil sie in
108814
L
U X E M B O U R G
Zusammenhang mit dem relevanten Spezifischen Investment dieser Klasse stehen) oder, sollte dies nicht umsetzbar sein,
proportional zwischen allen Anteilsklassen, zum Anteil des Gesellschaftskapital welches sie vertreten.
Anschließend werden alle relevanten Verpflichtungen bezüglich jeder Anteilsklasse, welche in separaten Kategorien
der Spezifischen Investments angezeigt werden, den Vermögensanlagen welche der spezifischen Klasse insbesondere dem
Spezifischen Investment dieser Klasse sowie jeglicher Reserven die dieser Klasse angerechnet werden können, entgegen-
gesetzt. Vermögenswerte welche keiner spezifischen Klasse zugerechnet werden können, werden pro rata zwischen allen
Anteilsklassen aufgeteilt.
In dem Maß, dass die so bestimmte Summe für eine Klasse negativ sein sollte, wird diese Klasse kein Anspruch auf
jeglichen Liquidationserlös haben. Die relevante Negativsumme, wird unter allen Anteilsklassen welche eine positive
Summe aufweisen können anteilig aufgeteilt bis zu dieser positiven Summe. Jeder innerhalb einer Klasse von Anteilen
verbleibende Überschuss (der „Klassenüberschuss“) wird unter den Anteilsinhabern dieser relevanten Anteilsklasse aus-
geschüttet.
Art. 16. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 17. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass
dieser Akte entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 1.550,- geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der deutschen und englischen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage
der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung
maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei hat dieser mit dem
amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: E. IDIR, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/19803. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 07. Juli 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015109712/757.
(150119541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Blue Car Lux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3961 Ehlange, 35B, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 156.774.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015109166/9.
(150119314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Chiron B1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 422.762.460,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 164.304.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109197/10.
(150119476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
108815
L
U X E M B O U R G
Entourage Commodity Management & Investment Company S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 156.689.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015111311/9.
(150120439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
AGRE Debt I - Chiswick Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 176.846.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109926/10.
(150118883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
C.RO Ports S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 149.469.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2015i>
Messieurs Michel Jadot, Jozef Adriaens, Paul Traen et Franciscus J.A. Las sont renommés administrateurs.
BDO Audit S.A. est renommée réviseur aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2016.
CERTIFIE CONFORME
Michel Jadot / Jozef Adriaens
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015112919/14.
(150122023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Advice Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 112.689.
Société constituée le 7 décembre 2005 par devant Me A. Schwachtgen. Les statuts ont été publiés au Mémorial C n°
560 du 17 mars 2006.
EXTRAIT
Il résulte d'une Assemblée générale ordinaire tenue le 24 juin 2016 que:
Le mandat de chacun des trois Administrateurs Mme Alejandra Fontanals Jauma, Monsieur Jean Wagener et Monsieur
Gilbert Muller ainsi que le mandat du Commissaire aux comptes, la société Compagnie Européenne de Révision Sàrl, sont
reconduits pour une nouvelle période d’une année, soit jusqu'à l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice
2015.
Le mandat de Présidente du Conseil d’Administration de Mme Alejandra Fontanals Jauma, est reconduit également
pour une nouvelle période de une année, soit jusqu'à l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait
Signature
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2015111989/21.
(150120424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
108816
Advice Invest S.A.
AGRE Debt I - Chiswick Holdings S.à r.l.
Blue Car Lux
Bulco S.àr.l
Calumnia Corporation
CEP II Co-Investment S.à r.l.
Cereplast International S.A.
CEREP Strategic Land S.à r.l.
Ceria S.A.
Chiron B1 S.à r.l.
CLdN Bulk S.A.
CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.
Commex International S.A.-SPF
Compagnie de Financements et d'Investissements Holding S.A.
C.RO Ports S.A.
Duferco International Trading Holding S.A.
Encore Plus Properties III S.à r.l.
Entourage Commodity Management & Investment Company S.à r.l
False Moustache S.A.
GS Lux Management Services S.à r.l.
Haras de Martelinville Sàrl
H&M Incentive Program S.à r.l.
Ikano S.A.
Immobilière Marina S.A.
Inbaso S.A.
Inbaso S.A.
Kedi 2 S.à r.l.
Manziana S.A.
McCain Finance Luxembourg S.à r.l.
Midway Investment
Multi Strategy SICAV
New Old Brewery S.A.
NGP IX Holdings I S.à r.l.
NOS Communications S.à r.l.
NREP NSF 1 S.à r.l.
OCM Luxembourg Beluga Shipco S.àr.l.
Oresc 8 S.à r.l.
P.E.A.C.E. S.A.
Pentachem
Permira SCF Feeder S.C.A.
Permira SCF IV S.C.A.
Pinecreek Capital S. à r.l.
PRESTO Consulting & Consultants S.A.
Satisco International Holding
Select Global
Shine France Logistics S.à.r.l.
Sun European Investment III S.à r.l.