This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2213
24 août 2015
SOMMAIRE
A.C.I. Aconcagua S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106196
A.C.I. Aeronautical S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
106196
A.C.I. Armenia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106200
A.C.I. Cargo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106200
A.C.I. City Country S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
106201
A.C.I. City Country S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
106201
A.C.I. Construction S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
106202
A.C.I. Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106211
A.C.I. Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106211
A.C.I. Fuelling S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106212
A.C.I. Mining S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106212
A.C.I. Mining S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106212
A.C.I. Morocco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106213
A.C.I. Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
106214
A.C.I. Technology S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
106214
A.C.I. VIP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106215
A.C.I. Wines S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106215
Actelion Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106216
Adara Venture Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
106216
Agilis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106224
Albatros S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106219
Alcuilux Desox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106219
Aleph Holdings Limited, II S.à r.l. . . . . . . . . . .
106220
Christom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106185
Contractors Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . .
106216
Eurasian Resources Group . . . . . . . . . . . . . . . .
106201
General Electric Services Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106211
Georgia-Pacific Andes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
106219
Just-eat.lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106215
Lac Invest Co. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106186
LSF 9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106197
LSREF4 Bologna REO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
106197
Lufkin Industries Holdings Luxembourg . . . .
106213
Presco Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
106220
Romafi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106178
Rothesay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106183
Société Luxembourgeoise d'Entreprises et de
Constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106178
Spie BondCo 3 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106186
Star Consult s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106186
Stena Drillmax Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
106186
Stena Drillmax Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
106186
Stena Forth Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
106186
UBS Luxembourg Financial Group Asset Ma-
nagement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106180
W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l. . . . . .
106201
W2007/W2008 Ourse Holding B S.à r.l. . . . . .
106213
W2007/W2008 Ourse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
106214
Weena Rotterdam Real Estate S.à r.l. . . . . . . .
106202
106177
L
U X E M B O U R G
Société Luxembourgeoise d'Entreprises et de Constructions, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 4.473.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015102630/10.
(150111306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Romafi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J-F Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 118.507.
L'an deux mille quinze, le neuf juin,
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ROMAFI S.A.», ayant son siège social à
L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 118507, constituée suivant acte notarié en date du 27 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1832 du 30 septembre 2006 (la Société).
Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés.
L'assemblée est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Madame Caroline WOLFF, employée privée, L-1855
Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy,
qui désigne comme secrétaire Madame Carole SABINOT, employée privée, L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F.
Kennedy.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie ARPEA, employée privée, L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F.
Kennedy.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social de la Société qui aura la teneur suivante: «La Société a pour objet social la souscription,
la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de
participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises luxembourgeois ou étrangers ainsi que la gestion des fonds
mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.
La Société a également pour objet la création, l’acquisition, la vente, le développement, l’exploitation, l’usage ou la
concession de l’usage, par toute voie, d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique
ou de commerce, de dessins ou de modèles, la prestation de conseils, l’assistance et plus généralement toutes prestations
de services, sous toutes ses formes, à toutes personnes morales, en matière de recherche et développement, de stratégie
commerciale.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations
de nature commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts de la Société.
3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre vingt dix mille euros (EUR 90.000) pour le
porter de son montant actuel de onze millions cent trente mille cent euros (EUR 11.130.100) à un montant de onze millions
deux cent vingt mille cent euros (EUR 11.220.100) par la création de neuf cent (900) actions d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100) chacune,
4. Souscription et libération des actions nouvelles par versement en numéraire
5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts de la Société,
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
106178
L
U X E M B O U R G
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la Société et par conséquent de modifier l’article 2 des statuts
de la Société, afin de lui donner désormais la teneur suivante:
«La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous quelque
forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises luxembour-
geois ou étrangers ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses
participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.
La Société a également pour objet la création, l’acquisition, la vente, le développement, l’exploitation, l’usage ou la
concession de l’usage, par toute voie, d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique
ou de commerce, de dessins ou de modèles, la prestation de conseils, l’assistance et plus généralement toutes prestations
de services, sous toutes ses formes, à toutes personnes morales, en matière de recherche et développement, de stratégie
commerciale.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations
de nature commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation.»
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-dix mille euros
(EUR 90.000,-) pour le porter de son montant actuel de onze millions cent trente mille cent euros (EUR 11.130.100,-),
représenté par cent onze mille trois cent et une (111.301) action ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune, à un montant de onze millions deux cent vingt mille cent euros (EUR 11.220.100,-) par la création de neuf cents
(900) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les neuf cents (900) actions nouvelles sont souscrites par l’actionnaire unique de la Société Monsieur Roger-
Marc NICOUD, directeur de sociétés, demeurant au 3, rue A. Patton, F-54690 Lay Saint Christophe (France).
Toutes les actions sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt-dix
mille euros (EUR 90.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société, afin de lui
donner désormais la teneur suivante:
« Art. 3. Le capital social est fixé à onze millions deux cent vingt mille cent euros (EUR 11.220.100,-) représenté par
cent douze mille deux cent et une (112.201) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ deux mille euros (EUR 2.000.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. WOLFF, C. SABINOT, S. ARPEA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 12 juin 2015. 1LAC/2015/18308. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
106179
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 29 juin 2015.
Référence de publication: 2015102610/102.
(150111979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
UBS Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.851.
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of June,
before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of UBS Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., a public
limited liability company (société anonyme) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 33 A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 125.851 (the Company). The Company was incorporated on
21 March 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published on 30 April 2007 in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 745 page 35750. The articles of association of the Company have been amended
for the last time on 29 December 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published on 20 March
2015 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 777 page 37287.
The Meeting was chaired by José Ignacio Pascual Gutiérrez, with professional address in Luxembourg (the Chairman),
who appointed Annick Braquet, with professional address in Luxembourg as secretary of the Meeting (the Secretary).
The Meeting appointed Thomas Ségal, with professional address in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the
Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the bureau of the Meeting (the Bureau).
The shareholder represented at the Meeting and the number of shares it holds are indicated on an attendance list which
will remain attached to the present deed after having been signed by the proxyholder of the shareholder represented at the
Meeting, the members of the Bureau and the notary.
The proxy from the shareholder represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by all appearing
parties, will also remain attached to the present deed to be filed with it.
The Bureau having thus been validly constituted, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. It appears from an attendance list established and executed by the members of the Bureau that thirty-two thousand
three hundred fifty-four (32,354) ordinary shares in registered form, fully paid in, with a nominal value of one hundred
euros (EUR 100) each, representing the entirety of the subscribed share capital of the Company in the amount of three
million two hundred thirty five thousand four hundred euros (EUR 3,235,400), are duly represented at the Meeting which
is consequently regularly constituted and may validly deliberate upon all the items on the agenda.
II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million five hundred thousand euros (EUR
1,500,000), in order to bring the share capital from its present amount of three million two hundred thirty-five thousand
four hundred euros (EUR 3,235,400) consisting of thirty-two thousand three hundred fifty-four (32,354) ordinary shares
in registered form, fully paid in, with a nominal value of one hundred euros (EUR 100) each to four million seven hundred
thirty-five thousand four hundred euros (EUR 4,735,400) by way of the issuance of fifteen thousand (15,000) new ordinary
shares in registered form with a nominal value of one hundred euros (EUR 100) each, with such shares having the same
rights and obligations as the existing shares.
3. Subscription to and payment in full of the new shares by way of a contribution in cash.
4. Subsequent amendment to the first paragraph of article five (5) of the articles of incorporation of the Company (the
Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 2. above.
5. Miscellaneous.
III. After due and careful consideration of the above, the Meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waived the
convening notices, the shareholder represented considering itself duly convened and declaring to have perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one million five hundred thousand
euros (EUR 1,500,000), in order to bring the share capital from its present amount of three million two hundred thirty-five
thousand four hundred euros (EUR 3,235,400) consisting of thirty-two thousand three hundred fifty-four (32,354) ordinary
106180
L
U X E M B O U R G
shares in registered form, fully paid in, with a nominal value of one hundred euros (EUR 100) each to four million seven
hundred thirty-five thousand four hundred euros (EUR 4,735,400) by way of the issuance of fifteen thousand (15,000) new
ordinary shares in registered form with a nominal value of one hundred euros (EUR 100) each, with such shares having
the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The shareholder represented at the Meeting declared to subscribe to the fifteen thousand (15,000) new shares and to
fully pay them up by a contribution in cash in an amount of one million five hundred thousand euros (EUR 1,500,000) to
be allocated entirely to the share capital account of the Company.
The amount of one million five hundred thousand euros (EUR 1,500,000) was at the disposal of the Company, evidence
of which has been given to the notary by means of a blocking certificate (certificat de blocage).
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolved to amend the first paragraph of article five (5) of
the Articles in order to reflect the increase of the share capital of the Company adopted under the second resolution above,
which shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at EUR 4,735,400 (four million seven hundred and thirty-five
thousand four hundred euros) consisting of 47,354 (forty-seven thousand three hundred and fifty-four) ordinary shares in
registered form, fully paid in, with a nominal value of EUR 100 each.”
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 3,000.-.
The notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the appearing parties, the present
deed is worded in English followed by a French version. At the request of said parties and in case of discrepancy between
the English and the French versions, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing parties, who are known to the undersigned notary by their surnames, first
names, civil status and residences, said parties, together with the notary, signed the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de juin,
par-devant nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) d’UBS Luxembourg Financial Group Asset Management S.A.,
une société anonyme régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 125.851 (la Société). La Société a été constituée le 21 mars 2007 suivant
un acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié le 30 avril 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 745 page 35750. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 29 mars 2014 suivant un acte de Maître
Henri Hellinckx, prénommé, publié le 20 mars 2015 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 777 page
37287.
L’Assemblée a été présidée par José Ignacio Pascual Gutiérrez, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (le
Président), qui a nommé Annick Braquet, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg en tant que secrétaire de l’As-
semblée (le Secrétaire).
L’Assemblée a nommé Thomas Ségal, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en tant que scrutateur de
l’Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent le bureau de l’Assemblée (le Bureau).
L’actionnaire représenté à l’Assemblée et le nombre d’actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence qui
restera annexée au présent acte après avoir été signée par le mandataire de l’actionnaire représenté à l'Assemblée, les
membres du Bureau et le notaire.
La procuration de l’actionnaire représenté à la présente Assemblée, après avoir été signée ne varietur par toutes les
personnes comparantes, restera également annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Le Bureau ayant été ainsi valablement constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d’acter que:
I. Il ressort d’une liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que trente-deux mille trois cent cinquante-
quatre actions (32.354) ordinaires nominatives, entièrement libérées ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
106181
L
U X E M B O U R G
chacune, représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société d’un montant de trois millions deux cent trente-
cinq mille quatre cents euros (EUR 3.235.400) sont dûment représentées à l’Assemblée qui est par conséquent régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000), dans
le but de porter le capital social de son montant actuel de trois millions deux cent trente-cinq mille quatre cents euros (EUR
3.235.400) représenté par trente-deux mille trois cent cinquante-quatre (32.354) actions ordinaires nominatives, entièrement
libérées, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune à quatre millions sept cent trente-cinq mille quatre
cents euros (EUR 4.735.400) par l’émission de quinze mille (15.000) nouvelles actions ordinaires nominatives ayant une
valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, lesquelles ayant les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux
actions existantes.
3. Souscription à et libération des nouvelles actions par un apport en numéraire.
4. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article cinq (5) des statuts de la Société (les Statuts) afin de
refléter l’augmentation du capital social adoptée au point 2. ci-dessus.
5. Divers.
III. Après un examen attentif de ce qui précède, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’entièreté du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée a renoncé aux formalités
de convocation, l’actionnaire représenté se considérant dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant d’un million cinq cent mille euros (EUR
1.500.000), dans le but de porter le capital social de son montant actuel de trois millions deux cent trente-cinq mille quatre
cents euros (EUR 3.235.400) représenté par trente-deux mille trois cent cinquante-quatre (32.354) actions ordinaires no-
minatives, entièrement libérées, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune à quatre millions sept cent
trente-cinq mille quatre cents euros (EUR 4.735.400) par l’émission de quinze mille (15.000) nouvelles actions ordinaires
nominatives ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, lesquelles ayant les mêmes droits et obligations
que ceux attachés aux actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée a décidé d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l’augmen-
tation du capital comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
L’actionnaire représenté à l’Assemblée a déclaré souscrire aux quinze mille (15.000) nouvelles actions et les libérer
intégralement par un apport en numéraire d’un montant d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000) qui sera alloué
entièrement au compte capital social de la Société.
Le montant d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000) était à la disposition de la Société, preuve en ayant été
donnée au notaire sous la forme d’un certificat de blocage.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l’article cinq
(5) des Statuts afin de refléter l’augmentation du capital social de la Société adopté à la deuxième résolution ci-dessus, qui
aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital. Le capital souscrit de la Société est établi à EUR 4.735.400 (quatre millions sept cent trente-cinq mille
quatre cents euros), représenté par 47.354 (quarante-sept mille trois cent cinquante-quatre) actions ordinaires nominatives,
entièrement libérées, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.»
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont estimés approximativement à EUR 3.000.-.
Le notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes personnes et en cas de divergence entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
106182
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite aux personnes comparantes, connues du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, état
civil et demeure, lesdites personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. GUTIÉRREZ, A. BRAQUET, T. SÉGAL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 24 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/19616. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 juillet 2015.
Référence de publication: 2015106289/168.
(150115790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.
Rothesay, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 102.948.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the ninth of June,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
Is Appeared:
Pattison S.à.r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F.
Kennedy, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 114.264,
here represented by Mrs Delphine GUILLOU, private employee, having its professional address in L-1855 Luxembourg,
44, avenue J.F. Kennedy,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg on 29
th
May 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as aforementioned and representing the whole corporate capital, requires the notary
to act the following:
1° The appearing party is the sole shareholder of “ROTHESAY”, a société à responsabilité limitée, having its registered
office at L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 102.948, incorporated pursuant to a notarial deed dated 3
rd
September 2004, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1173 of 18
th
November 2004 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 10
th
February 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 847 of 30
th
March 2012.
2° The share capital of the Company is set at one hundred thousand nine hundred Pound Sterling (100,900.- GBP),
represented by one thousand and nine (1,009) parts with a nominal value of one hundred Pound Sterling (100.- GBP) each.
3° Pattison S.à r.l., prenamed, acting in its capacity as sole shareholder, hereby resolves to dissolve the Company with
effect from today and to put the Company into liquidation. It assumes the function of liquidator of the Company.
4° In such capacity, it declares that the activity of the Company has ceased, that the Company has no more liabilities,
that the sole shareholder is vested with all assets and hereby declares that it will take over and assume liability for any
known but unpaid and any yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation
of the Company is deemed to have been carried out and completed.
5° All assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company shall be deemed transferred at book
value to the sole shareholder as of the date hereof. The transfer of all assets and liabilities of the Company will be undertaken
against the cancellation of the shares held by the sole shareholder in the Company.
6° All rights and obligations of the Company vis-à-vis third parties shall be taken over by the sole shareholder.
7° The liquidator and sole shareholder has full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of
the Company.
8° The accounts of the Company with respect to all past financial years are approved at the date of the present meeting
and the liquidator and sole shareholder takes note of the liquidation accounts of the Company and hereby approves such
accounts. The liquidator and sole shareholder waives the review of the liquidation accounts and the preparation of a report
by an auditor to the liquidation.
9° Discharge is granted to the managers of the Company and to the internal auditor for the execution of their mandates.
10° The books and corporate documents of the Company will be maintained during the period of five (5) years at the
registered office of the Company.
106183
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English
followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English and the
French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le neuf juin,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu
Pattison S.à r.l., une société anonyme, ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.264,
ici représentée par Madame Delphine GUILLOU, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1855 Lu-
xembourg, 44, avenue J.F. Kennedy,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 mai 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, annexée aux
présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus et représentant l’intégralité du capital souscrit, a requis le
notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1° La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée «ROTHESAY», ayant son siège social à
L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 102.948, constituée suivant acte notarié en date du 3 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1173 du 18 novembre 2004 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 10 février
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 847 du 30 mars 2012.
2° Le capital social de la société est fixé à cent mille neuf cents Livres Sterling (100.900,- GBP), représenté par mille
neuf (1.009) parts sociales d’une valeur nominale de cent Livres Sterling (100,- GBP) chacune.
3° Par la présente, Pattison S.à r.l., prénommée, en sa qualité d'associé unique prononce la dissolution anticipée de la
Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle assume la fonction de liquidateur.
4° En cette qualité, l’associé unique déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été
payé ou provisionné, que l’associé unique est investi de tout l’actif et qu'il s’engage expressément à prendre à sa charge
tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement
à sa personne; par conséquent la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
5° L’universalité des éléments actifs et passifs, sans aucune restriction ni limitation, du patrimoine de la Société sont
considérés transférés à leur valeur comptable à l’associé unique à la date d’aujourd'hui. Le transfert de l’universalité des
éléments actifs et passifs de la Société sera réalisé en contrepartie de l’annulation des parts sociales détenues par l’associé
unique dans la Société.
6° Tous droits et obligations de la Société vis-à-vis des tiers seront pris en charge par l’associé unique.
7° Le liquidateur et associé unique a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
8° Les comptes de la Société relatifs aux exercices sociaux passés sont approuvés à la date de la présente assemblée et
le liquidateur et associé unique prend note des comptes de liquidation de la Société et par la présente approuve ces comptes.
Le liquidateur et associé unique renonce à l’examen des comptes de liquidation et à l’établissement d’un rapport par un
commissaire à la liquidation.
9° Décharge pleine et entière est accordée aux gérants et au commissaire pour l’exécution de leurs mandats.
10° Les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au siège social de la Société
dissoute.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d’une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: D. GUILLOU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 12 juin 2015. 1LAC/2015/18306. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
106184
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 29 juin 2015.
Référence de publication: 2015102612/105.
(150111981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Christom S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3334 Hellange, 22, rue de Crauthen.
R.C.S. Luxembourg B 164.247.
L'an deux mil quinze, le trois juin.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Christophe THOMAS, gérant de société, né le 6 avril 1979 à Metz (France), demeurant à L-3334 Hellange,
22, rue de Crauthem,
ci-après dénommé l’«Associé unique»,
Ledit comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est l’associé unique de la société CHRISTOM S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée par acte du
notaire soussigné en date du 18 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2962
du 2 décembre 2011 et ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 52, rue Goethe. Les statuts n’ont pas été modifiés
depuis cette date.
- Qu'il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide de transférer le siège social de la société actuellement sise à «L-1637 Luxembourg, 52, rue
Goethe» à l’adresse «L-3334 Hellange, 22, rue de Crauthem».
L’Associé unique décide en outre de procéder à la modification corrélative du premier alinéa de l’article 4 des statuts
et lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège est établi à Hellange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg
sur simple décision des associés.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé unique décide de révoquer Madame Conceiçao DE CASTRO de sa fonction de gérant technique et lui donner
pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat, jusqu'au 28 février 2015.
En conséquence de ladite révocation, l’Associé unique décide de nommer Monsieur Christophe THOMAS, précité, à
la fonction de gérant technique.
Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison des présentes est évalué à environ huit cent trente euros (830,- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. THOMAS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17677. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Référence de publication: 2015104695/47.
(150115126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2015.
106185
L
U X E M B O U R G
Spie BondCo 3 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 161.836.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2015.
Référence de publication: 2015102632/10.
(150111449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Star Consult s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2166 Luxembourg, 3, rue Mozart.
R.C.S. Luxembourg B 164.973.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 Juin 2015.
Référence de publication: 2015102635/10.
(150112053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Stena Drillmax Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 176.683.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015102638/9.
(150112215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Stena Drillmax Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 176.686.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015102639/9.
(150112214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Stena Forth Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.626.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015102640/9.
(150111561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Lac Invest Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 198.039.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of June,
before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
106186
L
U X E M B O U R G
LAC Prop Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, which registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is currently pending
and a share capital of thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-),
LAC Prop Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, which registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is currently pending
and a share capital of thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-),
LAC Prop Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, which registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is currently pending
and a share capital of thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-),
here all represented by José María Ortiz, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a powers of attorney all dated 24 June 2015.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name . The name of the company is “LAC Invest Co. S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Contern, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances.
Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer
of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition, directly or indirectly, of real estate property in Luxembourg or
abroad, in particular shopping centres, and the holding and managing of the assets required for the management of the real
estate property.
3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is set at thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-), represented by
thirteen thousand seven hundred fifty (13,750) shares; each in registered form fully paid-up with a nominal value of one
euro (EUR 1) each.
106187
L
U X E M B O U R G
5.2 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid on
the shares of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium account may
be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any
net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal
reserve.
5.3. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a
resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution adopted in the manner required for
amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than thirteen thousand
seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-).
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives). The shares are indivisible and the
Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for that
purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the General
Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution, which sets the term of their office. The managers need not be
shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting or by
way of Shareholders Circular Resolution.
Art. 8. Board of managers. The Company will be managed by a board of managers (the Board). The Board shall be
composed of at least two (2) managers who will be A managers (hereafter each a Manager A) or B managers (hereafter
each a Manager B).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board that has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if (a) a majority of its members is present or represented, and (b) at
least one Manager A is present or represented at the meetings. Resolutions of the Board are validly taken by a simple
majority of the managers present or represented provided that at least one Manager A votes in favour of the decision(s) to
be adopted. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman
has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers, including at least
the signature of one Manager A.
106188
L
U X E M B O U R G
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been
delegated.
Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.
IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders of the Company (the General
Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
10.3. Subject-Matters of Resolutions
The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.
Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by
the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions
is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders
Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
106189
L
U X E M B O U R G
13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to
the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the
interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one (1)
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and
remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets
and pay the liabilities of the Company.
14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in
proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders
Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.
15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original
or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.
15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject
to any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
LAC Prop Co. A S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for four thousand forty-one
(4,041) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution
in cash in the amount of four thousand forty-one euro (EUR 4,041.-).
LAC Prop Co. B S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for four thousand eighty-eight
(4,088) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution
in cash in the amount of four thousand eighty-eight euro (EUR 4,088.-).
LAC Prop Co. C S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for five thousand six hundred
twenty-one (5,621) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full
by a contribution in cash in the amount of five thousand six hundred twenty-one euro (EUR 5,621.-).
The amount of thirteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 13,750) is at the disposal of the Company, evidence
of which has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed
are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed
capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed for an indefinite period:
106190
L
U X E M B O U R G
<i>a. as Manager A of the Companyi>
- Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond
Reuter, L-5326 Contern
<i>b. as Manager B of the Companyi>
- Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19,
rue des Lilas, L-8035 Strassen
2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this deed
are drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German
text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Contern, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.
Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes
Am vierundzwanzigsten Tag des Monats Juni im Jahre zweitausendfünfzehn,
ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
ERSCHIENEN:
Die LAC Prop Co. A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, deren Eintragung beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister derzeit noch aussteht und ein Ge-
sellschaftskapital von dreizehntausendsiebenhunderfünfzig Euro (EUR 13.750,-) hat,
Die LAC Prop Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, deren Eintragung beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister derzeit noch aussteht und ein Ge-
sellschaftskapital von dreizehntausendsiebenhunderfünfzig Euro (EUR 13.750,-) hat,
Die LAC Prop Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, deren Eintragung beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister derzeit noch aussteht und ein Ge-
sellschaftskapital von dreizehntausendsiebenhunderfünfzig Euro (EUR 13.750,-) hat,
hier alle vertreten durch Herrn José María Ortiz, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Großherzogtum Luxemburg, aufgrund von Vollmachten, welche jeweils am 24. Juni 2015 erteilt wurden.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird der
vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen.
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „LAC Invest Co. S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann
durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die
Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
106191
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland, insbesondere von Einkaufszentren, und der Erwerb und die Verwaltung von zur Bewirtschaftung von Immo-
bilien erforderlichen Gegenständen.
3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen
anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen
Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche
Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf dreizehntausendsiebenhunderfünfzig Euro (EUR 13.750,-), aufgeteilt in
dreizehntausendsiebenhunderfünfzig (13.750) Anteile, jede jeweils ausgegeben in voll liberierten Namensanteile mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
5.2. Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital kann ein Rücklagenkonto für das Emmissionsagio eingerichtet
werden, auf welchem das auf die Anteile über deren Nominalwert eingezahlte Emissionsagio als Kapitalrücklage verbucht
werden kann. Der Betrag des Rücklagenkontos kann für Zahlungen der Gesellschaft an ihre(n) Gesellschafter im Rahmen
des Rückerwerbs von Anteilen, zum Ausgleich des realisierten Nettoverlusts, für Ausschüttungen an den/die Gesellschafter
in Form von Dividenden verwendet werden oder der gesetzlichen Kapitalrücklage zugeführt zu werden.
5.3. Durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den für eine
Satzungsänderung erforderlichen Bestimmungen zu fassen ist, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die Aus-
gabe von Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag von
dreizehntausendsiebenhunderfünfzig Euro (EUR 13.750,-) fallen.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile (parts sociales nominatives). Die Geschäftsanteile sind unteilbar
und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690
des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichend ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch
einen Beschluss der Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses bestellt, welcher auch ihre Amtszeit
festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung oder im Wege
eines Umlaufbeschlusses abberufen werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführungsrat (der Rat) verwaltet. Der Rat soll
aus mindestens zwei (2) Geschäftsführern bestehen, die entweder A Geschäftsführer (Geschäftsführer A) oder B Ge-
schäftsführer (Geschäftsführer B) sein sollen.
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.
106192
L
U X E M B O U R G
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vier-
undzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann
in der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn (a) die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind
und (b) wenigstens ein Geschäftsführer A bei der Versammlung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates
sind wirksam, wenn sie mit einer einfachen Mehrheit der von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst
werden, wobei mindestens ein Geschäftsführer A für den Beschluss oder die Beschlüsse gestimmt haben muss. Die Be-
schlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn
kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet
werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommuni-
kationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind und im Umlaufverfahren gefasst
worden sind (die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in
einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt
hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei
(2) Geschäftsführern gebunden, wobei stets mindestens ein Geschäftsführer A unterzeichnet haben muss.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.
(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Ver-
bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.“
IV. Gesellschafter
Art. 10. Hauptversammlung und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Hauptversammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder
durch Beschlüsse im Umlaufverfahren (die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage
im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.
106193
L
U X E M B O U R G
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter
per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die
Beschlüsse oder die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
10.3. Gegenstände von Beschlüssen
Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.
Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Umlaufbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage
zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des
Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive des Emissionsagio) zur
Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende
des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten
ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter,
welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen
106194
L
U X E M B O U R G
(1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der
Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die
Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaf-
tern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Umlaufbe-
schlüsse der Geschäftsführer und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-
Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden
alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Umlaufbe-
schlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst
werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche
zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
LAC Prop Co. A S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet viertausendundeinundvierzig (4.041) Ge-
schäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäfts-
anteile in Höhe von viertausendundeinundvierzig Euro (EUR 4.041.-).
LAC Prop Co. B S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet viertausendundachtundachtzig (4.088)
Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäfts-
anteile in Höhe von viertausendundachtundachzig Euro (EUR 4.088,-).
LAC Prop Co. C S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet fünftausendsechshunderteinundzwanzig
(5.621) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser
Geschäftsanteile in Höhe von fünftausendsechshunderteinundzwanzig Euro (EUR 5.621,-).
Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von dreizehntausendsiebenhundertfünfzig
Euro (EUR 13.750) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend einhundert Euro (EUR 1.100.-) betragen.
<i>Beschlüsse der Ersten Hauptversammlung Gesellschafteri>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die Hauptversammlung der Gesellschafter, welche die Gesamt-
heit der gezeichneten Geschäftsanteile vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum ernannt:
<i>a. als Geschäftsführer A der Gesellschafti>
- José María Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern
<i>b. als Geschäftsführer B der Gesellschafti>
- Ulrich Binninger, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30 August, 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in
19, rue des Lilas, L-8035 Strassen
2. Sitz der Gesellschaft sind in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
106195
L
U X E M B O U R G
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichneten
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: J.M. ORTIZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 29 juin 2015. Relation: DAC/2015/10687. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 01 juillet 2015.
Référence de publication: 2015104085/513.
(150114764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
A.C.I. Aconcagua S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.068.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Aconcagua S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102653/20.
(150112762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
A.C.I. Aeronautical S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.187.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Aeronautical S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102655/20.
(150113010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
106196
L
U X E M B O U R G
LSREF4 Bologna REO S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LSF 9 S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 197.705.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of June,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
LSREF4 Falcon Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the “RCS”) under number B 196199 being the sole
shareholder (the Sole Shareholder), following a share transfer agreement signed and dated as of the date hereof,
hereby represented by Isabel DIAS, employee, professionally residing at L- 1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, on 24
June 2015,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary
to act that it represents the entire share capital of LSF 9 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société
à responsabilité limitée) registered with the RCS under number B 197705, with a share capital of EUR 12,500.-, having its
registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg
and incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg dated 10 June 2015 (the “Articles”), not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the “Mémorial”). The articles of incorporation have not been amended since.
The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
1. The entire issued share capital represented by 100 (one hundred) shares is held by the Sole Shareholder.
2. The Sole Shareholder is represented by a proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this
extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below
agenda.
3. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
a) Change of the name of the Company to "LSREF4 Bologna REO S.à r.l." (the “Name Change”);
b) Subsequent amendment of article 4 (Name) of the Articles to reflect such Name Change;
c) Amendment of article 2 (Object) of the Articles so as to read as follows:
“ Art. 2. Object. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the creation, acquisition,
holding and/or disposal, in any form and by any means, of participations, rights and interests in, and obligations of, any
form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, and the administration, management, control and/or deve-
lopment of those participations, rights, interests and obligations.
In addition, the Company may acquire, hold, administrate, manage, enhance and dispose of real estate (in particular land
and buildings as well as rights related to real property such as leasehold and part-ownership rights) located in Luxembourg
or abroad and may hold, administrate, manage and dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign entities
the object of which is, according to their articles, (i) to acquire, hold, administrate, manage and dispose of the real estate
and/or (ii) to acquire, hold, administrate, manage and dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign real
estate companies.
In a general fashion, the Company may, by any means whatsoever, use its funds to establish, manage, develop and/or
dispose of all of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and/or dispose of any kinds of
property, tangible and intangible, movable and immovable, to participate in the creation, acquisition, development and/or
control of any form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, to acquire by any means, establish, own,
manage, develop and/or dispose of any portfolio of securities, real estate and intellectual property rights of whatever origin
and to realise them by way of sale, transfer, assignment, exchange or otherwise.
The Company may give guarantees and/or grant security in favour of third parties to secure its obligations and/or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies and any other company, pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over some or all of its assets and grant loans, advances and/or assistance, in any form whatsoever, to its subsidiaries,
affiliated companies and third parties.
106197
L
U X E M B O U R G
The Company may take any measure and carry out any operation, including but not limited to commercial, industrial
and financial operations, which are directly or indirectly connected with, or may favour the development of, its corporate
purpose."
d) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and
authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l., to proceed, under
his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Name Change in the share register of the
Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record their resolutions as
follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the Company’s name into “LSREF4 Bologna REO S.à r.l.”.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to subsequently amend article 4 (Name) of the Articles so as to read it as follows in the
English version of the Articles:
" Art. 4. Name. The corporate name of the Company is "LSREF4 Bologna REO S.à r.l.".
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 4 (Object) of the Articles so as to read it as set forth in item c) of the
agenda.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the changes resolved above
and hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments
S.à r.l., to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Name Change in
the share register of the Company and (ii) to any formalities in connection therewith.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the proxyholder of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder appearing signed,
together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre juin,
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
LSREF4 Falcon Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à l’Atrium Business Park- Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 196199, étant l’associé
unique (l’Associé Unique), suivant un contrat de transfert de parts signé et daté à la date du présent acte,
ici représentée par Isabel DIAS, employée, ayant son adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor
Hugo, Grand- Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le
24 juin 2015.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l’Associé Unique de LSF 9 S.à r.l., société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 197705, ayant un capital
social de EUR 12.500,-, ayant son siège social à l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand- Duché de Luxembourg, et constituée suivant un acte Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg daté du 10 juin 2015 (les “Statuts”) non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial»). Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis.
La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. La totalité du capital social, représentée par 100 (cent) parts sociales, est détenu par l’Associé Unique.
106198
L
U X E M B O U R G
2. L’Associé Unique est représenté en vertu d’une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société
sont représentées à cette décision extraordinaire de l’Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises
sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.
3. L’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
a) Changement de nom de la Société en «LSREF4 Bologna REO S.à r.l.» (le «Changement de Dénomination»);
b) Par conséquent, modification de l'article 4 (Dénomination) des Statuts afin d’y refléter ce Changement de Dénomi-
nation;
c) Modification de l'article 2 (Objet) des Statuts de sorte qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
constitution, l'acquisition, la détention et/ou la cession, sous quelque forme que ce soit et selon tous les moyens, de parti-
cipations, droits et intérêts et obligations, dans toute société et entreprise luxembourgeoise et étrangère, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, droits, intérêts et obligations.
De plus, la Société peut acquérir, détenir, administrer, gérer, mettre en valeur et transférer des biens immobiliers (en
particulier des terrains et bâtiments, de même que des droits liés à la propriété immobilière tels que les baux et les dé-
membrements du droit de propriété) situés à Luxembourg ou à l'étranger et peut détenir, administrer, gérer et transférer
des intérêts et des participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet est, selon leurs statuts, (i)
d'acquérir, détenir, administrer, gérer et transférer des biens immobiliers et/ou (ii) d'acquérir, détenir, administrer, gérer et
transférer des intérêts et participations dans des entités immobilières luxembourgeoises ou étrangères.
De manière générale, la Société peut utiliser ses fonds par tous les moyens pour constituer, administrer, développer et
vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, pour acquérir, investir dans et/ou vendre toute
sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, pour participer à la création, l'acquisition, le
développement et/ou le contrôle de toute forme de sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères, pour acquérir
par tout moyen, établir, détenir, gérer, développer et/ou vendre tout portefeuille de valeurs mobilières, biens immobiliers
et de brevets de n'importe quelle origine, et pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement.
La Société peut également consentir des garanties et/ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations et/ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société, nantir, céder, grever de charges
ou créer des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs et accorder des prêts, avances et/ou assistance, sous n’importe
quelle forme, à ses filiales, sociétés affiliées et tierces parties.
La Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant mais n’étant pas limité à des opérations
commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement.»
d) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l., afin
d’effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription du Changement de Dénomination dans le
registre de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de changer le nom de la Société en «LSREF4 Bologna REO S.à r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide en conséquence de modifier l'article 4 (Dénomination) des Statuts, de sorte qu'il ait la teneur
suivante dans la version française des Statuts:
« Art. 4. Dénomination. La société est dénommée «LSREF4 Bologna REO S.à r.l.».
<i>Troisième résolutioni>
L'Associe Unique décide de modifier en conséquence de l'article 2 (Objet) des Statuts de façon à le lire tel qu'établi au
point c) de l'ordre du jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de Lone Star Capital Investments
S.à r.l., afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription du Changement de Dénomination
dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
106199
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante ci-
dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction en langue française. A la requête de ce même mandataire
et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au bureau du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du document faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire comparant et le notaire ont
signé le présent acte original.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 25 juin 2015. 2LAC/2015/14104. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Yvette Thill.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2015.
Référence de publication: 2015103168/176.
(150113324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
A.C.I. Armenia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.152.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Armenia S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102659/20.
(150113083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
A.C.I. Cargo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.147.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Cargo S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102661/20.
(150112337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
106200
L
U X E M B O U R G
W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.894.
Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai 2008, acte publié au
Mémorial C no 1520
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015104488/14.
(150113984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
A.C.I. City Country S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.146.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. City Country S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102663/20.
(150112341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
A.C.I. City Country S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.146.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Référence de publication: 2015102664/11.
(150113411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Eurasian Resources Group, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 77.500,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 177.275.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de gérance en date du 25 avril 2015i>
Lors de la réunion du 25 avril 2015, le Conseil de gérance a décidé de relever Monsieur Paul Waller de ses fonctions
de délégué à la gestion journalière, avec effet au 1
er
juin 2015.
106201
L
U X E M B O U R G
Monsieur Paul Aggleton, nouveau Directeur Financier, a été nommé en qualité de délégué à la gestion journalière, et
ce à compter du 1
er
juin 2015 et pour une durée indéterminée. Il a comme adresse professionnelle 9 rue Saint-Zithe, L-2763
Luxembourg.
Le Conseil de gérance prend note du changement d'adresse professionnelle de Monsieur Benedikt Sobotka, du 22 avenue
Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg au 9 rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg.
Pour tous les actes de gestion journalière, le Conseil de gérance a décidé que la Société sera valablement engagée par
la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2015.
<i>Pour la Société
i>Franz DUCLOS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015102926/23.
(150113071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
A.C.I. Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.145.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Référence de publication: 2015102666/11.
(150113423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Weena Rotterdam Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 198.083.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen,
on the twenty second day of June.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), which is governed by Luxembourg Law, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under company number
R.C.S. B 185.605,
here represented by Mr Alexander WAGNER, Rechtsanwalt,, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated 15 June 2015.
Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
Articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration.
Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of "Weena Rotterdam Real Estate S.à r.l." a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by Luxembourg Law (hereafter the
"Company"), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the
"Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board of
managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
106202
L
U X E M B O U R G
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Lu-
xembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 3. Corporate Objectives. The company's object is
- buying or holding shares or units in one or more Investment Companies;
- granting financing to Investment Companies provided they are, directly or indirectly via one or more Investment
Companies, controlled by the company; and/or
- buying Real Estate and developing, administering, operating, renting and selling
Real Estate held by it.
For the purpose of this clause, "Real Estate" shall comprise direct title to property (consisting of land and buildings),
property related long-term interests (such as surface ownership, master-lease, fee simple ownership, concession and lease-
hold), purchase options and forward commitments to purchase upon completion in relation to such property and property-
related long term interests and other assets that are necessary to operate such property and property-related long term
interests. For the purpose of this clause, "Investment Company" means any company or other investment vehicle whose
object is (according to its articles of incorporation or other constituent documents) buying Real Estate and developing,
administering, operating, renting and selling Real Estate held by it, (directly or indirectly via one or more investment
vehicles with a similar object clause) buying or holding shares or units in one or more of investment vehicles with a similar
object clause and/ or granting financing to such investment vehicles provided that the financed investment vehicle is
ultimately controlled by the company.
The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates, loan notes and debentures,
convertible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or
guarantee to or in favour of the companies, trustees or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest,
or to companies being part of the same group of companies as the Company (the "Connected Companies"). The Company
may grant any guarantee in favour of a third party to secure the obligations of the Connected Companies. The Company
is also authorised to pledge, mortgage or otherwise create security interests in or over its assets to secure its own obligations
or those of the Connected Companies.
The company can perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfil its object as well as all
operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object, including transactions to hedge
interest and/ or currency exchange risks.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Units.
Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by
one hundred and twenty-five (125) units with no reference to nominal value.
Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there
is only one unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits
of the Company in direct proportion to the number of units in existence.
Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted
per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely
transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the requi-
rements of article 189 of the Law.
Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of the
majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company’s unit capital.
Chapter III. - Management.
Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The managers
need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of unitholders
holding a majority of votes.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for
106203
L
U X E M B O U R G
keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The board of managers shall meet upon call by the chairman,
or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of unitholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or another
manager appointed by the Board of managers shall preside as chairman pro-tempore or in their absence or inability to act,
the unitholders may appoint another manager, an officer of the Company or such other individual as they may determine
as chairman pro-tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting.
The board of managers from time to time may appoint the officers of the Company, including general managers, any
assistant general manager, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and
management of the Company, who need not be managers or unitholders of the Company. The officers appointed, unless
otherwise stipulated in these articles, shall have the powers and duties given to them by the board of managers. The board
of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to such officers of the Company. Any such appointment may
be revoked at any time by the board of managers.
Notice of any meeting of the Board of managers shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by
other electronic means of transmission to all manager at least twenty four hours in advance of the day set for the meeting.
The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business other
than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board not
referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telex or
telefax or by other electronic means of transmission of each manager and shall be deemed to be waived by any manager
who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable or telegram, telex
or telefax another manager as his proxy. Any manager may attend a meeting of the board of managers using teleconference,
video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of board of
managers by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.
A meeting of the board of managers held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of
communication, in which a quorum of managers participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Managers who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or by
cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have
a casting vote.
Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and
held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced
by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as mentioned therein.
In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which the last signature
of a board member is affixed.
Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be
formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Company via electronic means of communication. Such approvals received from
all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the decisions
formerly approved by electronic means of communication.
Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of managers.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.
Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the
competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agreements
and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.
Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound by the joint signature of any two managers, officers
or of any other persons to whom authority has been delegated by the board of managers.
Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate his powers
for specific tasks to one or more ad hoc agents.
106204
L
U X E M B O U R G
Any members of the board of managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later
date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 15. Liabilities of the manager. In the exercise of their mandate, the members of the board of managers are not to
be personally held liable for the indebtedness of the Company. As agent of the Company they are responsible for the correct
performance of their duties.
Chapter IV. - General meeting of Unitholders
Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred to the
general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.
A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal
representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit
capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least
three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.
Chapter V. - Financial year - Balance sheet.
Art. 17. Financial Year. The Company’s financial year starts on the 1
st
January and ends on the 31
st
December of each
year.
At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.
The operations of the Company, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or
other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor («réviseur d’entreprises»).
The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of unitholders for a period ending at the date of the
next annual general meeting of unitholders and until his successor is elected.
The independent auditor in office may be removed at any time by the unitholders in accordance with the provisions of
article 256 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies.
Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%)
of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the
Company’s unit capital.
The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the Company.
Chapter VI. - Dissolution - Liquidation.
Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.
Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.
A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Applicable law.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
st
December 2015.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
106205
L
U X E M B O U R G
Shares:
CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Units
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Units
All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR
12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now available to
the Company, as evidenced before the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l., re-
presenting the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the general meeting of Unitholders,
passed the following resolutions:
1) The number of Managers is three (3).
2) The following are appointed as Managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Rudolf Kömen, born on January 01, 1967 in Trier, Germany, having his professional address at 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg;
- Mr Fernand Schaus, born on April 26, 1967 in Sandweiler, Luxembourg having his professional address at 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg;
- Mr Rainer Scherwey, born on December 20, 1972 in Fribourg, (Switzerland), having his professional address at
Kalanderplatz 5, CH-8045 Zurich (Switzerland).
3) The Company shall have its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
4) PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg (RCS Luxembourg
section B number 64 577) is appointed as independent auditor of the Company until the end of the next annual general
meeting of unitholders which will deliberate on the annual accounts of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, notary the present deed.
Follows the GERMAN translation of the preceding text
Im Jahre zweitausendfünfzehn,
am zweiundzwanzigsten Tag des Monats Juni.
Vor Uns dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER mit Amtssitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Luxem-
burg,
ist erschienen:
die „CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l.“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), mit Sitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister
unter der Nummer R.C.S. B 185.605,
hier vertreten durch Herrn Alexander Wagner, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 15. Juni 2015.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar der
gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Die Erschienene, vertreten wie oben angezeigt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
Kapitel I. Form, Name, Gesellschaftssitz, Geschäftszweck, Dauer
Art. 1. Form, Name. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht unter der Firma
"Weena Rotterdam Real Estate S.à r.l." (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet, die dem Luxemburger Recht, insbe-
sondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung
(nachstehend das "Gesetz"), sowie dieser Satzung (nachstehend die "Satzung") unterliegt.
106206
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Sitz. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Die Geschäftsführung ist befugt die Adresse der Gesellschaft
innerhalb des Gemeindegebietes des satzungsmäßig festgelegten Gesellschaftssitzes zu verlegen.
Der Sitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung gemäß dem für Satzungsänderungen
geltenden Verfahren an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Sofern außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur eintreten oder vor-
hersehbar sind, die die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindern, kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden; eine solche vorübergehende
Maßnahme berührt die Nationalität der Gesellschaft nicht, die ungeachtet der einstweiligen Verlegung des Gesellschafts-
sitzes luxemburgisch bleibt. Die Entscheidung den Gesellschaftssitz ins Ausland zu verlegen wird von der Geschäftsfüh-
rung getroffen.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Geschäftsstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.
Art. 3. Zweck. Das Ziel der Gesellschaft ist
- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Investmentgesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierungen an Investmentgesellschaften, vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt durch
eine oder mehrere Investmentgesellschaften von der Gesellschaft kontrolliert werden; und/oder
- das Kaufen von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf von ihr
gehaltener Immobilien.
Für diese Klausel gilt, dass "Immobilien" das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus Land und Gebäuden), lang-
fristige Immobilien-bezogene Anlagen (solche wie Oberflächeneigentum (surface ownership), Hauptleasing (master-
lease), Volleigentum (fee simple ownership), exklusive Nutzungsrechte (concession) und Nießbrauch (leasehold),
Erwerbsoptionen und zukünftige Verpflichtungen, die nach Fertigstellung in Bezug auf solche Grundstücke und grund-
stückbezogene Langzeitinteressen und andere Vermögensgegenstände erworben werden, die notwendig sind, um solche
Grundstück und grundstückbezogene Langzeitinteressen zu betreiben, beinhaltet. Für die Zwecke dieser Klausel meint
"Investmentgesellschaft" jede Gesellschaft oder anderes Investitionsvehikel, deren Ziel (gemäß ihrer Satzung oder anderen
Gründungsunterlagen) der Kauf von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der
Verkauf von ihr gehaltener Immobilien, (direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Investitionsvehikel mit einer ähnli-
chen Zielsetzung), der Kauf oder das Halten von Anteilen an einem oder mehreren Investitionsvehikeln mit einer ähnlichen
Zielsetzung und/oder Gewährung von Finanzierungen an solche Investitionsvehikel ist, vorausgesetzt, dass das finanzierte
Investitionsvehikel letztendlich von der Gesellschaft kontrolliert wird.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Schuldscheine und Pfandbrie-
fe, wandelbar oder nicht wandelbar im Rahmen des Gesetzes ausgeben. Die Gesellschaft kann jegliche Unterstützung,
Darlehen, Vorschüsse oder Garantien an oder zugunsten von Gesellschaften, Treunehmern oder Unternehmen geben, an
welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die dem gleichen Konzern wie die Gesellschaft angehören
(die "Verbundenen Unternehmen"). Die Gesellschaft kann jegliche Garantie zugunsten einer dritten Partei gewähren, um
die Verpflichtungen von Verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft ist zudem dazu berechtigt, sich zu
verbürgen, zu verpfänden oder in anderer Weise Sicherheiten an oder über ihre Vermögenswerte zu bestellen, um die
eigenen Verpflichtungen oder diejenigen eines Verbundenen Unternehmens zu sichern.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten und Transaktionen durchführen, die sie für notwendig erachtet, um ihre Ziele zu
erfüllen, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Förderung der Erreichung ihrer Ziele verbunden sind,
einschließlich Transaktionen zur Absicherung von Interessen und/oder Wechselkursrisiken.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.
Kapitel II. Kapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt
in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile ohne Bezug zu einem Nennwert.
Art. 6. Kapitaländerungen. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Anteilsinhabers (so-
weit es nur einen Anteilsinhaber gibt) oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 16 dieser
Satzung geändert werden.
Art. 7. Ausschüttungsrechte der Anteile. Jeder Anteil gibt seinem jeweiligen Besitzer das Recht auf einen Anteil der
Aktiva und der erzielten Gewinne der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar insofern nur ein
Besitzer pro Anteil zugelassen ist. Die gemeinschaftlichen Miteigentümer sind verpflichtet eine einzige Person als ihren
Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.
Art. 9. Übertragung der Anteile. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilinhaber hat, sind die Gesellschaftsanteile frei
auf Dritte übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehrere Anteilinhaber, können die Gesellschaftsanteile unter den im Artikel 189 des Gesetzes
vorgeschriebenen Bedingungen übertragen werden.
106207
L
U X E M B O U R G
Jeder Anteilinhaber ist damit einverstanden seine Gesellschaftsanteile nicht ohne das vorherige Einverständnis der
Mehrheit der Anteilinhaber, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, zu verpfänden oder als Garantie
zu verwenden.
Kapitel III. Geschäftsführung
Art. 10. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung, die aus mindestens drei Geschäftsführern besteht, verwaltet die Ge-
sellschaft. Die Geschäftsführer müssen nicht Anteilinhaber sein. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit durch einen
Beschluss der Anteilinhaber, die eine Mehrheit der Stimmen besitzen, mit oder ohne Grund abberufen werden.
Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer ge-
fasst.
Die Geschäftsführer wählen einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vize-Vorsitzenden sowie, falls
erforderlich, einen Sekretär, der nicht Geschäftsführer sein muss, und der die Protokolle der Geschäftsführersitzungen
aufsetzt. Die Geschäftsführerversammlung wird vom Vorsitzenden bzw. von zwei Geschäftsführern eingeladen und an
dem in der Einladung angegebenen Ort abgehalten.
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen der Gesellschafter vor. Für den Fall seiner Abwesenheit oder Handlungs-
unfähigkeit wird er vom Vize-Vorsitzenden oder einem anderen durch die Geschäftsführung bestimmten Geschäftsführer
als Vertreter auf Zeit vertreten. Für den Falle der Abwesenheit oder Handlungsfähigkeit auch dieser Personen können die
Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer, einen leitenden Angestellten oder eine sonstige Person zum Vorsitzenden
auf Zeit durch Beschluss mit Mehrheit der teilnehmenden oder vertretenen Gesellschaftsanteile wählen.
Die Geschäftsführung hat die Befugnis zur Anstellung von leitenden Angestellten, insbesondere Prokuristen, Assisten-
zen von Prokuristen, Sekretären, Assistenzsekretären oder anderen Angestellten, die als erforderlich für die Geschäftstä-
tigkeit der Gesellschaft angesehen werden können, wobei diese Personen keine Geschäftsführer oder Gesellschafter sein
müssen. Die Angestellten haben, solange nichts anderes in dieser Satzung geregelt ist, die ihnen von der Geschäftsführung
übertragene Handlungsbefugnis. Die Geschäftsführung kann die laufende Geschäftsführung sowie die Abwicklung von
Gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten im Einklang mit der Gesellschaftspolitik und dem Gesellschaftszweck an diese
Angestellten delegieren. Eine solche Delegation kann jederzeit von der Geschäftsführung widerrufen werden.
Die Einladung zu einer Versammlung der Geschäftsführung erfolgt schriftlich bzw. per Kabel, Telegramm, Telex, Fax
oder auf elektronischem Wege und soll mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung zugestellt werden. Die
Einladung beinhaltet die Tagesordnung der Versammlung. Ein nicht in der Tagesordnung enthaltener Agenda-Punkt kann
nicht rechtsgültig in der Versammlung beraten werden. Auf die Einberufung zur Versammlung der Geschäftsführer kann
verzichtet werden mittels schriftlicher Einwilligung bzw. mittels einer Zustellung der Mitteilung per Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischer Mittel. Das Erfordernis der Einberufung gilt als verzichtet für alle in der Versammlung
anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Geschäftsführer. Für die Versammlungen, die gemäß einem durch Beschluss
der Geschäftsführer festgesetzten Zeitplan abgehalten werden, ist keine zusätzliche Einladung zur Versammlung erfor-
derlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich in der Versammlung der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer vertreten
lassen, in dem er schriftlich bzw. per Kabel, Telefax, Telegramm, Telex, einen anderen Geschäftsführer als seinen Be-
vollmächtigten ernennt. Die Teilnahme der Geschäftsführer an der Geschäftsführungssitzung kann per Telefon, Video-
Konferenzschaltung oder anderen ähnlichen Kommunikationsmittel, die es allen an der Geschäftsführungssitzung
teilnehmenden Personen erlaubt, sich gegenseitig zu hören, erfolgen. Ein Geschäftsführer, der durch die Kommunikati-
onsmittel an einer Geschäftsführungssitzung teilnimmt, gilt als persönlich Anwesender dieser Sitzung.
Eine Versammlung der Geschäftsführer per Telefon oder Video-Konferenzschaltung oder jeder anderen Art von Audio-
oder Videokommunikation, an der ein Quorum von Geschäftsführern teilnimmt, ist genauso bindend als ob alle Geschäfts-
führer persönlich anwesend gewesen wären, vorausgesetzt, ein Protokoll wurde erstellt und vom Vorsitzenden der
Geschäftsführungssitzung unterzeichnet.
Die Geschäftsführung kann rechtsgültig Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Geschäftsführer gefasst, welche
bei der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Nicht persönlich anwesende oder nicht vertretene Geschäftsführer können
schriftlich bzw. durch Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder durch Einsatz anderer elektronischer Mittel an der Abstimmung
teilnehmen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurden, sind genauso rechtswirksam und bindend, als
ob die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Die Unterschrift der Geschäftsführer kann auf
einer einzelnen Ausfertigung bzw. auf mehreren Ausfertigungen eines jeden Beschlusses vermerkt sein, und auch per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des im Umlaufbeschluss vermerkten Datums.
Sollte dort kein spezielles Datum vermerkt sein, wird der Umlaufbeschluss gültig an dem Tag, an dem die letzte Unterschrift
getätigt wird.
Beschlüsse, die durch elektronische Mittel wie z.B. per E-Mail, ein Telegramm oder ein Telex gefasst werden, müssen
anschließend durch einen Zirkularbeschluss formalisiert werden. Das Inkrafttreten des Zirkularbeschlusses erfolgt am Tage
der letzten Zustimmungserklärung, welche die Gesellschaft in elektronischer Form erhielt. Die Zustimmungen von allen
106208
L
U X E M B O U R G
Mitgliedern der Geschäftsführung werden dem Umlaufbeschluss beigefügt und bilden dabei einen integralen Bestandteil
derselben, wobei der Umlaufbeschluss die zuvor in elektronischer Form gefassten Beschlüsse bestätigt.
Umlaufbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Geschäftsführer gefasst werden.
Die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung müssen durch den Vorsitzenden der Sitzung unterzeichnet werden.
Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, welche für die Zwecke von juristischen Verfahren oder andersweitig erstellt
werden, sind vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder seinem zeitweisen Vertreter in dieser Sitzung oder von zwei
Geschäftsführern zu unterzeichnen.
Art. 11. Befugnisse der Geschäftsführer. Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer die Befugnis unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte und Handlungen, die dem Geschäftszweck der
Gesellschaft entsprechen, auszuführen und zu genehmigen, vorausgesetzt, dass die Bestimmungen dieses Artikels beachtet
wurden.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann insbesondere
Vermögensberatungsverträge und Verwaltungsverträge, wie z.B. Grundstücksmakler-oder Grundstücksverwaltungsver-
träge abschließen.
Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer
oder anderer Personen, welche hierzu von der Geschäftsführung wirksam bevollmächtigt wurden, rechtsgültig verpflichtet.
Art. 13. Befugnisübertragung und Vertretung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für
bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere ad hoc Vertreter abtreten.
Die Geschäftsführung wird die Verantwortung und (gegebenenfalls) Entlohnung, die Dauer der Vertretung und alle
anderen erheblichen Bedingungen dieser Vertretung festlegen.
Art. 14. Entlohnung der Geschäftsführer. Die Befugnisse und die Entlohnung eines möglicherweise zu einem späteren
Zeitpunkt zusätzlich oder zu Ersatzzwecken ernannten Geschäftsführern werden im jeweiligen Ernennungsschreiben fest-
gelegt.
Art. 15. Haftung der Geschäftsführer. In Ausübung ihres Mandates sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar
für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte
Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.
Kapitel IV. Gesellschafterversammlung
Art. 16. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Der alleinige Anteilinhaber übernimmt alle der Gesellschafter-
versammlung zuerkannten Befugnisse.
Falls es mehrere Anteilinhaber geben sollte, kann jeder Anteilinhaber an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen,
unabhängig der ihm gehörenden Anzahl an Anteilen. Jeder Anteilinhaber verfügt über Stimmrechte, entsprechend der ihm
gehörenden Anteile.
Ein Anteilinhaber kann in jeder Gesellschafterversammlung handeln, indem er eine andere Person, die selbst nicht
Anteilinhaber sein muss (oder wenn der Anteilinhaber eine juristische Einheit ist, ihre(n) gesetzliche(n) Vertreter), schrift-
lich oder per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, E-Mail als seinen Bevollmächtigten ernennt.
Gemeinsame Beschlüsse sind nur gültig gefasst, wenn sie von Anteilinhabern die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals besitzen, gefasst wurden. Jedoch können Beschlüsse zur Abänderung der vorliegenden Satzung nur von einer
Mehrheit der Anteilinhaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften gefasst werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erstellt und die Geschäftsführung wird
ein Inventar, einschließlich einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft vorbereiten.
Jeder Anteilinhaber hat das Recht die Bücher und Niederschriften der Gesellschaft, das oben genannte Inventar und die
Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einzusehen.
Die Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich insbesondere ihrer Bücher und Steuerangelegenheiten oder anderer Be-
richte, welche nach Luxemburger Gesetz erforderlich sind, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer
(«réviseur d’entreprises»). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur
nächsten jährlichen Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.
Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 256 des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften abberufen werden.
Art. 18. Zuweisung und Ausschüttung von Gewinnen. Der Bruttogewinn der Gesellschaft wie in der Jahresbilanz auf-
geführt ergibt nach Abzug der allgemeinen Kosten, Tilgungskosten und Ausgaben jeglicher Art den Reingewinn. Vom
106209
L
U X E M B O U R G
Nettogewinn wird die Summe von fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, solange bis diese Rücklage
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Überschuss des Nettogewinns kann an die/den Anteilinhaber im Verhältnis zu ihren/seinen Anteilsbeteiligungen in
der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
Kapitel VI. Auflösung - Liquidation
Art. 19. Auflösungsgründe. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nicht im Falle des Todes, der Außerkraftsetzung der
Bürgerrechte, bei Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs des alleinigen Anteilinhabers oder von einem der Anteilinhaber.
Art. 20. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere durch die
Anteilinhaber ernannten Liquidatoren durchgeführt, die nicht unbedingt selbst Anteilinhaber sein müssen; die Anteilinhaber
legen die Aufgaben und Vergütung der Liquidatoren fest.
Ein alleiniger Anteilinhaber kann die Auflösung der Gesellschaft und die Durchführung der Liquidation beschließen,
wobei er persönlich die Zahlung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden übernimmt, welche der Gesellschaft
bekannt oder unbekannt sind.
Kapitel VII. Geltendes Recht
Art. 21. Ergänzend zu der vorliegenden Satzung gelten für alle weiteren Angelegenheiten die Bestimmungen des Ge-
setzes.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Das Kapital wurde wie folgt gezeichnet:
Anteile:
CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
Diese Anteile wurden voll in bar einbezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
entsprechend einem Anteilkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) nunmehr der Gesellschaft zur Ver-
fügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Geschätzte Kosteni>
Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgrün-
dung zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausend Euro geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fasst CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l., die die
Gesamtheit des gezeichneten Kapitals repräsentiert und die Befugnisse der Versammlung der Anteilsinhaber ausübt, fol-
gende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt.
2) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für einen unbegrenzten Zeitraum ernannt:
- Herr Rudolf Kömen, geboren am 01. Januar 1967 in Trier, Deutschland, mit Geschäftsanschrift 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg;
- Herr Fernand Schaus, geboren am 26. April 1967 in Sandweiler, Luxemburg, mit Geschäftsanschrift 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxemburg;
- Herr Rainer Scherwey, geboren am 20. Dezember 1972 in Fribourg (Schweiz),, mit Geschäftsanschrift Kalanderplatz
5, CH-8045 Zürich (Schweiz).
3) Zum Gesellschaftssitz wird 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg bestimmt.
4) Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Lu-
xembourg (RCS Luxembourg Sektion B Nummer 64 577) bis zum Ende der nächsten jährlichen Generalversammlung
ernannt, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft befindet.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch
der oben genannten erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst wurde und ihr eine deutsche Version beigefügt ist.
Auf Wunsch derselben erschienenen Partei soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschem Text die
englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER, die vorliegende Urkunde in Luxemburg am eingangs des vorliegenden Dokuments angegebenen Datum
aufgesetzt wurde.
106210
L
U X E M B O U R G
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer
mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. WAGNER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. Juni 2015. Relation: EAC/2015/14799. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-
EUR).
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015106311/475.
(150116447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.
A.C.I. Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.144.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Energy S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102667/20.
(150112376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
A.C.I. Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.144.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Référence de publication: 2015102668/11.
(150113432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
General Electric Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 400.025,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 62.661.
Suite aux résolutions prises par l'actionnaire unique de General Electric Services Luxembourg S.à r.l. (la «Société») il
a été décidé de renouveler les mandats de tous les membres du conseil de gérance de la Société, et ce avec effet du 17 juin
2015 jusqu'à l'assemblée générale de la Société concernant l'approbation des comptes annuels de la Société qui se tiendra
en l'année 2016.
Par conséquence, le conseil de gérance de la Société, à partir du 17 juin 2015, se compose comme suit:
- Monsieur Teunis Chr. AKKERMAN, membre du conseil de gérance de classe «A»;
- Monsieur Arjan Cornelis VAN DER LINDE, membre du conseil de gérance de classe «A»;
- Madame Roisin Alice O'HAGAN, membre du conseil de gérance de classe «A»;
- Monsieur Stephen M. PARKS, membre du conseil de gérance de classe «A»;
- Monsieur Philippe REIBEL, membre du conseil de gérance de classe «B»;
- Madame Michelle Ryann RIEGER, membre du conseil de gérance de classe «B»;
106211
L
U X E M B O U R G
- Madame Egle SABALYTE, membre du conseil de gérance de classe «B».
<i>Pour General Electric Services Luxembourg S.à.r.l.
i>S.Th. Kortekaas
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015103947/23.
(150114678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
A.C.I. Fuelling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.212.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Fuelling S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102669/20.
(150112399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
A.C.I. Mining S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.150.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Mining S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102672/20.
(150112479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
A.C.I. Mining S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.150.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
106212
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Référence de publication: 2015102673/11.
(150113451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
W2007/W2008 Ourse Holding B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.892.
Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai 2008, acte publié au
Mémorial C no 1506
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
W2007/W2008 Ourse Holding B S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015104489/14.
(150113983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
A.C.I. Morocco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.151.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Morocco S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102674/20.
(150112500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Lufkin Industries Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.165.944,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 167.922.
Suite aux résolutions prises par l'associé unique de Lufkin Industries Holdings Luxembourg (la «Société») il a été décidé
de renouveler les mandats de tous les membres du conseil de gérance de la Société, et ce avec effet du 17 juin 2015 jusqu'à
l'assemblée générale de la Société concernant l'approbation des comptes annuels de la Société qui se tiendra en l'année
2016.
Par conséquence, le conseil de gérance de la Société, à partir du 17 juin 2015, se compose comme suit:
- Monsieur Teunis Christiaan AKKERMAN, membre du conseil de gérance de classe «A»;
- Monsieur Arjan Cornelis VAN DER LINDE, membre du conseil de gérance de classe «A»;
- Monsieur Stephen M. PARKS, membre du conseil de gérance de classe «A»;
- Madame Roisin Alice O'HAGAN, membre du conseil de gérance de classe «A»;
- Madame Michelle Ryann RIEGER, membre du conseil de gérance de classe «B»;
106213
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Philippe REIBEL, membre du conseil de gérance de classe «B»;
- Madame Egle SABALYTE, membre du conseil de gérance de classe «B».
<i>Pour Lufkin Industries Holdings Luxembourg
i>S.Th. Kortekaas
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015105963/23.
(150115995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.
A.C.I. Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.148.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Bárbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Real Estate S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102678/20.
(150112593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
W2007/W2008 Ourse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 57.396,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.954.
Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 avril 2008, acte publié au
Mémorial C no 1525
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
W2007/W2008 Ourse S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015104490/14.
(150113982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
A.C.I. Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2353 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.157.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
106214
L
U X E M B O U R G
4. Madame Mariana Barbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Technology S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102682/20.
(150112663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
A.C.I. VIP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.156.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
4. Madame Mariana Barbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. VIP S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102683/20.
(150112680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Just-eat.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DKK 95.001,00.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 176.212.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 23 avril 2015 que le siège social de la société a été
transféré, avec effet au 1
er
juillet 2015, de son adresse actuelle au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au 20, rue des
Peupliers, L-2328 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Référence de publication: 2015104977/14.
(150115505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2015.
A.C.I. Wines S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.154.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juin 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 4 mai 2015.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
3. Monsieur Joel CÁRDENAS SAN MARTÍN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B
avec effet au 4 mai 2015 et pour une durée indéterminée.
106215
L
U X E M B O U R G
4. Madame Mariana Barbara DE SA MORAIS CARNEIRO VERÍSSIMO DA CUNHA, née à Lisbonne (Portugal), le
25 février 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme
gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour A.C.I. Wines S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015102684/20.
(150112709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Actelion Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 149.511.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015102688/10.
(150112713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Adara Venture Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 108.805.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2015.
Référence de publication: 2015102690/10.
(150112602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Contractors Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 253, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 191.606.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of June.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch.
There appeared:
Builders Insurance Holdings S.A., a public company limited by shares (société anonyme) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-8422 Steinfort, 69 rue de Hobscheid,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B180.477,
here represented by
- Mrs Ellina Henner, Executive Assistant, residing professionally in 69 rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort and
- Mr Bertrand Gilson, Chief Investment Officer, residing professionally in 69 rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort.
by virtue of a proxy under private seal.
Such proxy, after been signed "ne varietur" by the proxyholders of the appearing party and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as aforementioned, requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of Contractors Reinsurance S.A., a public company limited by shares
(société anonyme), having its registered office at L-1221 Luxembourg, 253, rue de Beggen, registered with the Luxembourg
register of commerce and companies under the number B 191606, incorporated by deed of the undersigned notary, dated
October 28
th
, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3389 of November 14
th
, 2014 (the “Company”).
The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the last time by a deed of the
undersigned notary dated December 11
th
, 2014, published with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under number 78, dated January 12
th
, 2015.
The shares are in registered form.
106216
L
U X E M B O U R G
II. The appearing party, duly represented, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis
of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of USD 1,100,000 so as to raise it from its
current amount of USD 9,900,000 to USD 11,000,000 by the issue of 1,100 new shares with a par value of USD 1,000
each, subject to the payment of a global share premium in the amount of USD 9,900,000;
2. Subscription and payment;
3. Subsequent amendment of the 1
st
sentence of article 5 of the Company's articles of association in order to reflect the
new corporate capital of the Company pursuant to the above resolutions;
III. The appearing party has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million one hundred
thousand US Dollar (USD 1,100,000) so as to raise it from its current amount of nine million nine hundred thousand US
Dollar (USD 9,900,000) to eleven million US Dollar (USD 11,000,000) by the issue of 1,100 new shares with a par value
of one thousand US Dollar (USD 1,000) each, subject to the payment of a global share premium in the amount of nine
million nine hundred thousand US Dollar (USD 9,900,000), the whole to be fully paid up through a contribution in cash
of eleven million US Dollar (USD 11,000,000).
<i>Second resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes “Builders Insurance Holdings S.A.”, represented as stated above.
“Builders Insurance Holdings S.A.” declares to subscribe the new shares as indicated above, subject to the payment of
the Share Premium as indicated above.
The cash amount of USD 11,000,000 has been blocked on the bank account of the Company and a proof of the contri-
bution's existence has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, and the contribution having been fully carried out, the sole shareholder
resolves to amend the 1
st
sentence of article 5 of the Company's articles of association, which shall then be read as follows:
“ Art. 5. Corporate capital. The subscribed capital is set at eleven million US Dollar (USD 11,000,000) represented by
eleven thousand (11,000) shares with a nominal value of one thousand US Dollar (USD 1,000.-) each.”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately five thousand euro (USD 5,000.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Beringen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representatives of the appearing party, known to the notary by their surnames,
given names, civil status and residences, the said representatives signed together with the notary the present deed.
Follows the French Version:
L'an deux mille quinze, le trente juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Builders Insurance Holdings S.A., une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, avec son siège social à L-8422 Steinfort, 69 rue de Hobscheid, enregistrée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 180.477,
Ici représentée par
- Mrs Ellina Henner, Executive Assistant, demeurant professionnellement à 69 rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort et
- Mr Bertrand Gilson, Chief Investment Officer, demeurant professionnellement à 69 rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les mandataires de la comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme susmentionné, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
106217
L
U X E M B O U R G
La partie comparante est l'actionnaire unique de Contractors Reinsurance S.A., une société anonyme, ayant son siège
social à L-1221 Luxembourg, 253, rue de Beggen, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 191606, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 28 octobre 2014, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3389 du 14 novembre 2014 (la «Société») et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 décembre 2014 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 78 du 12 janvier 2015.
Les actions sont nominatives.
I. La partie comparante, dûment représentée, a reconnu être pleinement informée des résolutions à prendre sur base de
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 1.100.000 pour le porter de son montant actuel
de USD 9.900.000 à USD 11.000.000 par l'émission de 1.100 nouvelles actions d'une valeur nominale de USD 1.000
chacune, sujet au paiement d'une prime d'émission d'un montant de USD 9.900.000;
2. Souscription et libération;
3. Modification subséquente de la 1ère phrase de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital
social de la Société conformément aux résolutions ci-dessus;
III. La partie comparante a demandé au notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million cent mille Dollars US
(USD 1.100.000) afin de le porter de son montant actuel de neuf millions neuf cent mille Dollars US (USD 9.900.000) à
onze millions de Dollars US (USD 11.000.000) par l'émission de 1.100 nouvelles actions d'une valeur nominale de mille
Dollars US (USD 1.000) chacune, sujet au paiement d'une prime d'émission d'un montant de neuf millions neuf cent mille
Dollars US (USD 9.900.000), la totalité devant être libérée par un apport en numéraire de onze millions de Dollars US
(USD 11.000.000).
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Souscription - Libérationi>
Est intervenue aux présentes «Builders Insurance Holdings S.A.», représentée comme indiqué ci-dessus.
«Builders Insurance Holdings S.A.» déclare souscrire les actions nouvelles comme indiqué ci-dessus, sujet au paiement
d'une prime d'émission comme indiqué ci-dessus.
Le montant en espèces de onze millions de Dollar US (USD 11.000.000) a été bloqué sur le compte bancaire de la
Société et une preuve de l'existence de la contribution a été donnée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent et l'apport ayant été entièrement réalisées, il est décidé de modifier la 1
ère
phrase de l'article 5 des statuts de la Société, qui doit alors être lu comme suit:
« Art. 5. Capital social. Le capital souscrit est fixé à onze millions de Dollars US (USD 11.000.000) représenté par onze
mille (11.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- USD) chacune.».
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés
approximativement à cinq mille euros (5.000 EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi par une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants de la partie comparante, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms,
états et demeures, lesdits mandataires ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. HENNER, B GILSON, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 juin 2015. Relation: 2LAC/2015/14491. Reçu soixante quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR COPIE CONFORME
Beringen, le 7 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109204/132.
(150119547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
106218
L
U X E M B O U R G
Albatros S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 181.418.
Le bilan pour la période du 29 octobre 2013 au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015102700/11.
(150112423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Georgia-Pacific Andes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 146.968.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 juin 2015 que la personne suivante a démissionné,
avec effet au 1
er
juillet 2015, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société;
- Monsieur Romuald Minatchy, né le 6 octobre 1982 à Colombes, France, ayant son adresse professionnelle au 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 1
er
juillet 2015, et pour
une durée indéterminée, en qualité gérant de catégorie B de la Société:
- Monsieur David Aderhold, né le 5 décembre 1980 à Forbach, France, ayant son adresse professionnelle au 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
<i>Gérant de catégorie Ai>
- Monsieur Timothy J. Berryman, né le 7 janvier 1972 à Christchurch, Nouvelle Zélande, ayant son adresse profession-
nelle au 133 Peachtree Street NE, 30303 Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique.
<i>Gérants de catégorie Bi>
- Monsieur Olivier Lequeue, né le 31 octobre 1978 à Schaerbeek, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2-4,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur David Aderhold, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 juillet 2015.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2015106671/33.
(150117374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Alcuilux Desox S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R.C.S. Luxembourg B 143.064.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 30 juin 2015.
Référence de publication: 2015102701/10.
(150113437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
106219
L
U X E M B O U R G
Aleph Holdings Limited, II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.484.380,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 186.124.
<i>Extrait de la résolution des associési>
En date du 23 juin 2015, les associés ont décidés comme suit:
- D’accepter la démission d’Elizabeth TIMMER en tant que gérant de catégorie B et ce avec effet au 29 mai 2015;
- De nommer François-Xavier GOOSSENS, né le 8 mai 1976 à Bruxelles, Belgique, demeurant professionnellement au
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet au 29 mai
2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2015.
Carsten SÖNS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015102702/18.
(150113039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Presco Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 124.417.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth of June.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), the undersigned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the sole partner of “PRESCO INVESTMENTS S.à r.l.” a private limited liability
company (Societe responsabilite limitee), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
incorporated by a notarial deed of December 29, 2006, registered with the Trade and Companies` Register of Luxembourg
section B number 124417, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations dated April 21, 2007, under
number C 676. The articles of incorporation have been modified for the last time by a notarial deed of January 9, 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated March 4, 2015, under number 602.
The meeting is presided by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally in Junglinster.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Henri DA CRUZ, private employee, residing
professionally in Junglinster.
The Chairman requests the notary to act that:
i. The sole partner present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list and
proxy, signed by the appearing party and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
ii. As appears from the attendance list, the four hundred and forty thousand and fifty (440.050) shares, divided into three
hundred and eighty three thousand (383.000) class A shares and fifty-seven thousand and fifty (57.050) class B shares of
one hundred polish zloty (100 PLN) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the
meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand informed.
iii. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Decrease of the Company's subscribed share capital by an amount of PLN 5.000.000 (five million polish zloty), in
order to decrease it from its current amount of PLN 44.005.000 (forty-four million and five thousand polish zloty) to PLN
39.005.000 (thirty-nine million five thousand polish zloty) through the redemption of 50.000 (fifty thousand) Class A shares
held by the sole shareholder, with a par value of 100 PLN (one hundred polish zloty) each by a repayment to the sole
shareholder.
2. The remaining 333.000 (three hundred and thirty three thousand) Class A shares will remain in the PLN Compartment.
3. Amendment of Article 6 of the Articles of Association further to the above resolutions.
4. Decrease of the legal reserve by an amount of PLN 500.000 (five hundred thousand polish zloty) to decrease it from
PLN 4.400.500 (four million four hundred thousand five hundred polish zloty) to PLN 3.900.500 (three million nine hundred
thousand five hundred polish zloty) by a repayment to the sole shareholder.
5. Amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation.
106220
L
U X E M B O U R G
6. Miscellaneous.
That, based on the aforementioned agenda, the general meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to decrease the corporate capital by an amount of PLN 5.000.000 (five million polish zloty), in
order to decrease it from its current amount of PLN 44.005.000 (forty-four million and five thousand polish zloty) to PLN
39.005.000 (thirty-nine million five thousand polish zloty) through the redemption of 50.000 (fifty thousand) Class A shares
(the Class A shares) held by the sole shareholder, with a par value of 100 PLN (one hundred polish zloty) each by a
repayment to the sole shareholder.
The remaining 333.000 (three hundred and thirty three thousand) Class A shares will remain in the PLN Compartment.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend Article 6 of the articles of incorporation, in order to reflect such action, and to give it the
following wording:
“ Art. 6. The Company`s share capital is set at 39.005.000 (thirty-nine million five thousand polish zloty) represented
by 390.050 (three hundred ninety thousand and fifty) shares, divided into 333.000 (three hundred and thirty-three thousand)
Class A shares and 57.050 (fifty-seven thousand and fifty) Class B shares of 100 PLN (one hundred polish zloty) each.”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to decrease the legal reserve by an amount of PLN 500.000 (five hundred thousand polish zloty)
to decrease it from PLN 4.400.500 (four million four hundred thousand five hundred polish zloty) to PLN 3.900.500 (three
million nine hundred thousand five hundred polish zloty) by a repayment to the sole shareholder.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to amend Article 2 of the articles of incorporation by substitution of the current object by the
following:
3.1. The corporate object of the Company is to enter into, perform and serve as a vehicle for, any securitisation trans-
actions as permitted under the Securitisation Law.
3.2. The Company may acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding
or ownership of claims, receivables and/or other goods, either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks
relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third
parties, by issuing securities (valeurs mobilières) of any kind whose value or return is linked to these risks. The Company
may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, structured deposits, receivables and/or other goods,
structured products relating to commodities or assets, by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by
binding itself m any other way. The method that will be used to determine the value of the securitised assets will be set out
in the relevant issue documents entered into by the Company.
3.3. The Company may, within the limits of the Securitisation Law, proceed, insofar as they relate to securitisation
transactions, to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of
participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by pur-
chase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds,
debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by
Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and exchangeable or convertible securities), structured pro-
ducts relating to commodities or assets (including debt or equity securities of any kind), receivables, claims or loans or
other credit facilities (and the agreements relating thereto) as well as all other types of assets, and (iii) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above) in accordance with the provisions of the relevant issue documentation, gives the Company the
possibility to be part of synthetic securitization operations.
3.4. The Company may, within the limits of the Securitisation Law and for as long as it is necessary to facilitate the
performance of its corporate object, borrow in any form and enter into any type of loan agreement. It may issue notes and
bonds (including exchangeable or convertible securities and securities linked to an index or a basket of indices or shares).
The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities, within the limits of the
Securitisation Law and provided such lending or such borrowing relates to securitisation transactions, to its subsidiaries or
affiliated companies or to any other company.
3.5. The Company may, within the limits of the Securitisation Law, give guarantees and grant security over its assets
in order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of those assets or for the benefit of investors (including
their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity participating in a securitisation transaction of the Company.
The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets or transfer its
assets for guarantee purposes, unless permitted by the Securitisation Law.
106221
L
U X E M B O U R G
3.6. The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to facilitate
the performance of the Company's corporate object. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instru-
ments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.7. The Board is entitled to create one or more compartments (referencing the assets of the Company relating to an
issue by the Company of securities), in each case, corresponding to a separate part of the Company's estate. The Company
may appoint one or more fiduciary representatives as described in articles 67 to 84 of the Securitisation Law.
3.8. The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limited. The
corporate object of the Company shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided
that it is not inconsistent with the foregoing enumerated object.
3.9. In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or trans-
action which it considers necessary or useful for the accomplishment and development of its corporate object to the largest
extent permitted under the Securitisation Law.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
present deed, are estimated to one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
The total amount of the Capital Decrease is valued at EUR 1,199,430.-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-cinq juin,
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), le soussigné;
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la Société à responsabilité limitée «PRESCO INVEST-
MENTS S.à r.l.» ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 124.417, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KES-
SELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, daté du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations en date du 21 avril 2007 sous le numéro 676. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 9 janvier 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
602 du 4 mars 2015.
L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, employé
privé, demeurant professionnellement à Junglinster.
Le président prie le notaire d'acter que:
i. L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l'acte.
ii. Il ressort de la liste de présence que les quatre cent quarante mille cinquante (440.050) parts sociales divisées en trois
cent quatre-vingt trois mille (383.000) parts sociales de catégorie A et cinquante-sept mille cinquante (57.050) parts sociales
de catégorie B de cent zloty polonais (PLN 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à
la présente assemblée extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.
iii. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Diminution du capital social à concurrence de cinq millions de zloty polonais (PLN 5.000.000,-) pour le ramener de
son montant actuel de quarante-quatre millions cinq mille de zloty polonais (PLN 44.005.000,-) à trente-neuf millions cinq
mille de zloty polonais (PLN 39.005.000,-) par le rachat de cinquante mille (50.000) parts sociales de catégorie A détenues
106222
L
U X E M B O U R G
par l'actionnaire unique, d’une valeur nominale de cent zloty polonais (PLN 100,-) chacune par un remboursement à
l'actionnaire unique.
2. Les trois cent trente trois mille (333.000) parts sociales de categorie A demeureront au Compartiment PLN.
3. Modification afférente de l’article 6 des statuts.
4. Diminution de la réserve légale à concurrence de cinq cent mille zloty polonais (PLN 500.000,-) pour la ramener de
son montant actuel de quatre millions quatre cent mille cinq cents zloty polonais (PLN 4.400.500,-) à trois millions neuf
cent mille cinq cents zloty polonais (PLN 3.900.500,-) par un remboursement à l'actionnaire unique.
5. Modification afférente de l’article 2 des statuts
6. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinq millions zloty polonais (PLN 5.000.000,-) pour
le ramener de son montant actuel de quarante-quatre millions cinq mille zloty polonais (PLN 44.005.000,-) à trente-neuf
millions cinq mille zloty polonais (PLN 39.005.000,-) par le rachat de cinquante mille (50.000) parts sociales de catégorie
A détenues par l'actionnaire unique, d’une valeur nominale de cent zloty polonais (PLN 100,-) chacune par un rembour-
sement à l'actionnaire unique. Les trois cent trente trois mille (333.000) parts sociales de catégorie A demeureront sur au
Compartiment PLN.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article six (6) des statuts afin de lui donner la teneur
suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à trente-neuf millions cinq mille zloty polonais (PLN 39.005.000,-), représenté par
trois cent quatre-vingt-dix mille cinquante (390.050) parts sociales de cent zloty polonais (PLN 100,-) chacune, divisées
en trois cent trente trois mille (333.000) parts sociales de catégorie A et de cinquante-sept mille cinquante (57.050) parts
sociales de catégorie B d’une valeur nominale de cent zloty polonais (PLN 100,-) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire la réserve légale à concurrence de cinq cent mille zloty polonais (PLN 500.000,-) pour
la ramener de son montant actuel de quatre millions quatre cent mille cinq cents zloty polonais (PLN 4.400.500,-) à trois
millions neuf cent mille cinq cents zloty polonais (PLN 3.900.500,-), par un remboursement à l'actionnaire unique.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article deux (2) des statuts en remplaçant l’objet actuel par le texte suivant:
3.1. La Société a pour objet social de s'engager, de fonctionner et de servir comme véhicule pour toute transaction de
titrisation permise par la Loi sur la Titrisation.
3.2. La Société peut acquérir ou supporter, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou d'un autre organisme,
les risques liés à la propriété ou la détention de titres, de créances et/ou d'autres biens, mobiliers ou immobiliers, corporels
ou incorporels, et/ou risques liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par
des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépend de ces risques. La Société peut supporter
ces risques en acquérant, par tout moyen, les titres, dépôts structurés, créances et/ou autres biens, produits structurés sur
matières premières ou actifs, en garantissant les dettes ou les engagements de tiers ou en s'engageant de toute autre manière.
La méthode utilisée pour le calcul de la valeur des actifs titrisés sera décrite dans les documents relatifs aux conditions
particulières de l'émission acceptées par la Société.
3.3. La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation, procéder, à condition que ces opérations aient
trait à des opérations de titrisation, à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous
moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces
(notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout
autre organisme similaire et des titres échangeables ou convertibles), de produits structurés sur matières premières ou actifs
(incluant des titres d'emprunt ou de capitaux propres de toute sorte), créances, prêts ou toute autre facilité de crédit (ainsi
que les conventions y relatives) ainsi que tout autre type d'actifs et (iii) la possession, l'administration, le développement
et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus)
conformément aux dispositions de la documentation d'émission des titres en question, donnant à la Société la possibilité
de participer à des transactions de titrisation «Synthétique».
3.4. La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation et aussi longtemps que cela s'avère nécessaire
en vue de l'accomplissement de son objet social, emprunter sous quelque forme que ce soit et conclure tout type de contrat
de prêt. Elle peut procéder à l'émission de titres de créances, d'obligations (notamment des titres échangeables ou conver-
tibles ainsi que des titres liés à un indice ou à un panier d'indices ou d'actions. Dans les limites fixées par la Loi sur la
106223
L
U X E M B O U R G
Titrisation, la Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales,
à des sociétés affiliées et à toute autre société à condition que ces emprunts ou ces prêts aient trait à une ou plusieurs
opérations de titrisation.
3.5. La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation, consentir des garanties ou des sûretés sur ses
avoirs afin d'assurer le respect des obligations qu'elle assume dans le cadre de la titrisation de ses actifs ou dans l'intérêt
des investisseurs (y compris leur "trustee" ou mandataire, le cas échéant) et/ou de toute entité émettrice participant à une
opération de titrisation de la Société. La Société ne peut pas nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs ou donner ses avoirs à titre de garantie, à
moins que la Loi sur la Titrisation ne le permette.
3.6. La Société peut conclure, exécuter, fournir ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires, aussi longtemps que ces contrats et transactions s'avèrent nécessaires en vue de l'accomplissement
de l'objet de la Société. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et utiliser les instruments liés à
des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris sans s'y limiter, des techniques et instruments destinés à la
protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.
3.7. Le Conseil peut créer un ou plusieurs compartiments (représentant les actifs de la Société relatifs à une émission
par la Société de titres) correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société. La Société peut nommer
un ou plusieurs représentants-fiduciaires, tels que décrit aux articles 67 à 84 de la Loi sur la Titrisation.
3.8. Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non exhaustive.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats conclus par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.
3.9. D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toutes
opérations ou transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles en vue de l'accomplissement et du développement de son
objet social de la manière la plus large autorisée par la Loi sur la Titrisation.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
Le montant total de la reduction de capital est évalué à EUR 1.199.430,-.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, les présents
statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergence entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 juin 2015. Relation GAC/2015/5411. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015109632/242.
(150120025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Agilis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4876 Lamadelaine, 14, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 143.379.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AGILIS S. à r.l.i>
Référence de publication: 2015102745/10.
(150112369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
106224
A.C.I. Aconcagua S.à r.l.
A.C.I. Aeronautical S.à r.l.
A.C.I. Armenia S.à r.l.
A.C.I. Cargo S.à r.l.
A.C.I. City Country S.à r.l.
A.C.I. City Country S.à r.l.
A.C.I. Construction S.à r.l.
A.C.I. Energy S.à r.l.
A.C.I. Energy S.à r.l.
A.C.I. Fuelling S.à r.l.
A.C.I. Mining S.à r.l.
A.C.I. Mining S.à r.l.
A.C.I. Morocco S.à r.l.
A.C.I. Real Estate S.à r.l.
A.C.I. Technology S.à r.l.
A.C.I. VIP S.à r.l.
A.C.I. Wines S.à r.l.
Actelion Re S.A.
Adara Venture Partners S.à r.l.
Agilis S.à r.l.
Albatros S.à r.l.
Alcuilux Desox S.A.
Aleph Holdings Limited, II S.à r.l.
Christom S.à r.l.
Contractors Reinsurance S.A.
Eurasian Resources Group
General Electric Services Luxembourg S.à r.l.
Georgia-Pacific Andes S.à r.l.
Just-eat.lu S.à r.l.
Lac Invest Co. S.à r.l.
LSF 9 S.à r.l.
LSREF4 Bologna REO S.à r.l.
Lufkin Industries Holdings Luxembourg
Presco Investments S.à r.l.
Romafi S.A.
Rothesay
Société Luxembourgeoise d'Entreprises et de Constructions
Spie BondCo 3 S.C.A.
Star Consult s.à r.l.
Stena Drillmax Lux 1 S.à r.l.
Stena Drillmax Lux 2 S.à r.l.
Stena Forth Lux 1 S.à r.l.
UBS Luxembourg Financial Group Asset Management S.A.
W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l.
W2007/W2008 Ourse Holding B S.à r.l.
W2007/W2008 Ourse S.à r.l.
Weena Rotterdam Real Estate S.à r.l.