This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1284
18 mai 2015
SOMMAIRE
26 United Corpo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61632
3 PH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61632
Abertas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61631
Black Tie Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61631
Bonativo Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61586
Colex Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61630
Digital Services Holding XXIII S.à r.l. . . . .
61586
IC Latin America Opportunity Fund I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61607
NETASEC, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61631
PET International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
61614
Petronilla Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
61614
Piaf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61615
Pilamaye S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61615
Porlux Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61615
Portman S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61616
Proformlux Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
61616
ProLogis European Holdings X S.à r.l. . . .
61616
Protexion Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61616
Putman Lux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61616
PVC Compound Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
61617
Quetzacoatl Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61618
Quetzacoatl Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61618
Red Rock S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61618
Redstone Securities Holdings S.à r.l. . . . . .
61619
R Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61618
Sagittarius Investissements S.A. . . . . . . . . .
61623
Sangre Pura SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61625
Saproman Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61625
S.E.C. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61619
S.E.C. Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
61619
Shield Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
61620
Sieberath International Consulting . . . . . .
61622
S.I.E. - Stratégie Informatique Européenne
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61620
Sopage S. à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61625
SPS International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
61626
SSP Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61626
Stonebridge Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
61622
Stonebridge Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
61622
Stonebridge Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61622
Stonebridge Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61623
STRIKE Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
61626
Sukhoï S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61626
Sun (Lille) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61623
Sunstream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61627
Tele2 Finance Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
61630
Tilon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61632
61585
L
U X E M B O U R G
Bonativo Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Digital Services Holding XXIII S.à r.l.).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.606.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of February,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) under the laws of Germany with its statutory seat in
Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amts-
gericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany (hereinafter "Rocket"),
being the holder of twelve thousand five hundred (12,500) common shares and being the holder of six hundred twenty-
five (625) series A1 shares,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Berlin, Germany, on 11 February 2015;
2. TEC Global Invest XII GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of
Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local
court of Duisburg (Amtsgericht Duisburg), Germany, under no. HRB 24728, having its business address at Wissollstraße
5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany,
being the holder of two thousand eighty-three (2,083) series A1 shares, here represented by Julien De Mayer, private
employee, professionally
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Mülheim an der Ruhr, Germany, on 11 February 2015.
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 191.426
(hereinafter "Holtzbrinck"),
becoming the holder of one thousand forty-two (1,042) series A2 shares,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Luxembourg, on 11 February 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties under 1. and 2 (the "Existing Shareholders") are the shareholders of Digital Services Holding XXIII S.à r.l.
(the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.606 and incorporated pursuant
to a deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on 1 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2575 dated 23 September 2014. The articles of association have been amended
pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux dated 9 January 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The meeting of
the Existing Shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Holtzbrinck
participates and votes for the purpose of Agenda points 5 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Amendment of the name of the Company from "Digital Services Holding XXIII S.à r.l." to "Bonativo Global S.à r.l."
and subsequent amendment of article one (1) of the articles of association of the Company which shall now read as
follows:
" Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Bonativo
Global S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association."
2. Decision to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have three (3) classes of shares,
divided into common shares (hereinafter "Common Shares"), series A1 shares (hereinafter "Series A1 Shares") and series
A2 shares (hereinafter "Series A2 Shares").
3. Acceptance of HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel,
61586
L
U X E M B O U R G
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number
B 191.426, as new shareholder of the Company.
4. Increase of the Company's share capital by an amount of one thousand forty-two euros (EUR 1,042) so as to raise
it from its current amount of fifteen thousand two hundred eight euros (EUR 15,208.00) up to sixteen thousand two
hundred fifty euros (EUR 16,250.00) by issuing one thousand forty-two (1,042) Series A2 Shares with a nominal value of
one euro (EUR 1.00) each.
5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at sixteen thousand two hundred fifty euros (EUR 16,250.00), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 two thousand seven hundred eight (2,708) series A1 shares (hereinafter "Series A1 Shares"), with a nominal value
of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.3 one thousand forty-two (1,042) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter
"Series A2 Shares"; the Series A1 Shares and the Series A2 Shares jointly also the "Series A Shares").
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association."
6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
"A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Bonativo Global
S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
61587
L
U X E M B O U R G
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at sixteen thousand two hundred fifty euros (EUR 16,250.00), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 two thousand seven hundred eight (2,708) series A1 shares (hereinafter "Series A1 Shares"), with a nominal value
of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.3 one thousand forty-two (1,042) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter
"Series A2 Shares"; the Series A1 Shares and the Series A2 Shares jointly also the "Series A Shares").
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a "Super Majority") and subject to the provisions
of any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet AG
("Rocket"), the shareholder TEC Global Invest XII GmbH ("TEC") and the shareholder HV Holtzbrinck Ventures Fund
VI SCS ("Holtzbrinck", jointly with Rocket and TEC the "Investors" and each also an "Investor") to a company affiliated
to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is
directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a "Controlled Company"), whereas "Control" or "Con-
trolled" or "Controlling" shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by
means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the ma-
nagement and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the
respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified
employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;
7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation
procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than 50% in any surviving legal entity after such transformation
procedure.
7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights
of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
61588
L
U X E M B O U R G
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.
8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
61589
L
U X E M B O U R G
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
12.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.
Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-
holders (ii) who also constitute a Super Majority:
16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company; and
16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
61590
L
U X E M B O U R G
16.2.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG));
16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of
any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;
16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases; and
16.2.4 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and
transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.
16.3. Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".
17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by
the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
61591
L
U X E M B O U R G
21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
21.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board (as defined below) for the legal transactions and
measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and
have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board (as defined below):
21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros
(EUR 200,000.00) in aggregate;
21.8.2 future transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;
21.8.6 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party, excluding,
however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;
21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct
or indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly -hold, directly or indirectly, a majority interest. The
consent requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of
business of the Company and is at arm's length;
21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)
outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agree-
ment, if any.
21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board (as defined below). The Advisory Board (as defined
below) may give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
61592
L
U X E M B O U R G
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board ("Advisory Board"). It shall consist of four (4) voting members. The
shareholders may by way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of
the Advisory Board.
24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders' consent.
24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-
pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
24.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, each having two (2) votes, shall be nominated by Rocket in its
sole discretion;
24.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by TEC in its sole
discretion; and
24.3.3 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Holtzbrinck in its sole
discretion.
24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other
representative of the respective party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Rocket, TEC and Holtzbrinck are entitled to appoint one substitute member for each Advisory
Board member.
24.5 The Advisory Board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
24.6 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall
be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide for further
provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with
the simple majority of votes cast. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar
quarter.
24.7 In addition to any consent or approvals otherwise required under these articles of association and/or any share-
holders' agreement with respect to the Company, if any, the Advisory Board has a consultative function and will not
interfere in the management of the Company.
24.8 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and supervision
Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
61593
L
U X E M B O U R G
Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.
30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail."
7. Decision to appoint Mr Julien De Mayer as new class B manager of the Company for an unlimited duration.
8. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, as well as Mr Rüdiger Trox, regardless of his
category, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders' register of the
Company.
9. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned
notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Existing Shareholders decide to amend the name of the Company from "Digital Services Holding XXIII S.à r.l." to
"Bonativo Global S.à r.l." and subsequently amend article one (1) of the articles of association of the Company which shall
now read as follows:
" Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Bonativo
Global S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association."
<i>Second resolutioni>
The Existing Shareholders decide to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have
two (3) classes of shares, divided into Common Shares, Series A1 Shares and Series A2 Shares.
61594
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Existing Shareholders accept HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748
Findel, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under
number B 191.426, as new shareholder of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Existing Shareholders decide to increase the Company's share capital by an amount of one thousand forty-two
euros (EUR 1,042) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand two hundred eight euros (EUR 15,208.00)
up to sixteen thousand two hundred fifty euros (EUR 16,250.00) by issuing one thousand forty-two (1,042) Series A2
Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
<i>Subscriptioni>
The one thousand forty-two (1,042) Series A2 Shares have been duly subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, for
the price of one thousand forty-two euros (EUR 1,042).
<i>Paymenti>
The one thousand forty-two (1,042) Series A2 Shares subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, have been entirely
paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand forty-two euros (EUR 1,042).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand forty-two euros (EUR 1,042) is entirely allocated to the share capital.
<i>Fifth resolutioni>
The Existing Shareholders acknowledge that Holtzbrinck has now become the holder of one thousand forty-two
(1,042) Series A2 Shares.
As a consequence Holtzbrinck, aforementioned, entitled to vote and here represented by Julien De Mayer, private
employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxies, joins the meeting, which is
henceforth referred to as "the general meeting of shareholders", for the purpose of the following resolutions.
The general meeting of shareholders resolves to amend article five (5) of the articles of association of the Company
so that it shall now henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at sixteen thousand two hundred fifty euros (EUR 16,250.00), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 two thousand seven hundred eight (2,708) series A1 shares (hereinafter "Series A1 Shares"), with a nominal value
of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.3 one thousand forty-two (1,042) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter
"Series A2 Shares"; the Series A1 Shares and the Series A2 Shares jointly also the "Series A Shares").
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association."
<i>Sixth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders decides to fully restate the articles of
association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Seventh Resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to appoint, with immediate effect, Mr Julien De Mayer, private employee,
born on 9 April 1982, in Etterbeek, Belgium, residing professionally at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy
of Luxembourg, as new class B manager of the Company for unlimited duration.
<i>Eighth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well
as Mr Rüdiger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders register
of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 1,800.-.
61595
L
U X E M B O U R G
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehn Februar,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit
Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),
Inhaberin von zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen und von sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteilen
der Serie A1,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 11 Februar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
2. TEC Global Invest XII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmä-
ßigem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB
24728, mit Sitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland,
Inhaberin von zweitausenddreiundachtzig (2.083) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 11 Februar 2015, ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland;
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés)
unter der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),
zukünftige Inhaberin von eintausendzweiundvierzig (1.042) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 11 Februar 2015, ausgestellt in Luxembourg.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur pa-
raphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien unter 1. und 2. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind die Gesellschafter der Digital Services Holding
XXIII S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, ein-
getragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188.606, gegründet am 1. Juli 2014
gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 23. September 2014 im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2575, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde
am 9. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet. Die Gesellschafterversammlung der Bestehenden Gesellschafter ist ordnungsgemäß zusammengekommen und
kann wirksam über die folgende Tagesordnung verhandeln, wobei Holtzbrinck ausschließlich für die Punkte 5 ff. der
Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Digital Services Holding XXIII S.à r.l.“ in „Bonativo Global S.à r.l.“ und
dementsprechende Änderung des Artikels eins (1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Bonativo Global S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“
2. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, sodass die Gesellschaft nunmehr drei (3) An-
teilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) und
Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“).
3. Aufnahme von HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, einer Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Groß-
61596
L
U X E M B O U R G
herzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausendzweihun-
dertacht Euro (EUR 15.208,00) um einen Betrag von eintausendzweiundvierzig Euro (EUR 1.042) auf einen Betrag von
sechzehntausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 16.250,00) durch die Ausgabe von eintausendzweiundvierzig (1.042) An-
teilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
5. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt sechzehntausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 16.250,00), be-
stehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 zweitausendsiebenhundertacht (2.708) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.3 eintausendzweiundvierzig (1.042) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(die „Anteile der Serie A2“; die Anteile der Serie A1 und die Anteile der Serie A2 gemeinsam auch die „Anteile der Serie
A“).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Bonativo Global S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
61597
L
U X E M B O U R G
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt sechzehntausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 16.250,00), be-
stehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 zweitausendsiebenhundertacht (2.708) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.3 eintausendzweiundvierzig (1.042) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(die „Anteile der Serie A2“; die Anteile der Serie A1 und die Anteile der Serie A2 gemeinsam auch die „Anteile der Serie
A“).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung
von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter
Rocket Internet AG („Rocket“), den Gesellschafter TEC Global Invest XII GmbH („TEC“) und den Gesellschafter HV
Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“, gemeinschaftlich mit Rocket und TEC die „Investoren“ und jeweils
einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile
61598
L
U X E M B O U R G
oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige
Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das
Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor
oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten,
welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;
7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-
wandlungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in Artikeln 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen
werden, wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
61599
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.
10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichs-
zahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft
als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der
Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter
den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in
der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
61600
L
U X E M B O U R G
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 12.2
eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist
dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einbe-
rufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 15. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit
der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:
16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft; und
16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-
teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;
16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen; und
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.
16.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.
17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
61601
L
U X E M B O U R G
19.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) für die unten genannten Rechts-
geschäfte und Maßnahmen im Einklang mit Artikel 24.5. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsge-
schäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) genehmigt wurden:
21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-
hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;
21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-
aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-
wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;
61602
L
U X E M B O U R G
21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft
an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.
Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt
15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehr-
heitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Anteils-oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.
21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-
lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats (wie unten definiert) erfordern. Der Beirat (wie unten definiert) kann seine Zustimmung für bestimmte
Gruppen und Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat („Beirat“). Dieser besteht aus vier (4) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-
sellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.
24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-
schafter festlegen und/oder verändern.
24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
24.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit je zwei (2) Stimmen werden von Rocket nach eigenem
Ermessen ernannt;
24.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von TEC nach eigenem Ermessen
ernannt; und
61603
L
U X E M B O U R G
24.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Holtzbrinck nach eigenem Ermessen
ernannt.
24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von jedem anderen Mitglieds des Beirats oder einem Vertreter der jeweiligen
Partei vertreten werden. In diesem Fall muss bei der jeweiligen Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht vorgelegt
werden. Zu diesem Zweck sind Rocket, TEC und Holtzbrinck berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes Beiratsmitglied zu
ernennen.
24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-
berechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der
Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.
24.7 Vorbehaltlich anderer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesell-
schaftervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird
nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
24.8 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
27.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.
27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
61604
L
U X E M B O U R G
28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Andwendbares recht
Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
7. Beschluss bezüglich der Ernennung von Herrn Julien De Mayer als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft
für unbegrenzte Dauer.
8. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
9. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter beschließen, den Namen der Gesellschaft von „Digital Services Holding XXIII S.à r.l.“
in „Bonativo Global S.à r.l.“ und dementsprechend Artikel eins (1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher
nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Bonativo Global S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter beschließen, eine (1) weitere Anteilsklasse zu schaffen, sodass die Gesellschaft nun-
mehr drei (3) Anteilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A1 und Anteile der Serie A2.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter akzeptieren HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en
commandite simple) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou
Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
(Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter beschließen, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von fünfzehntausendzweihundertacht Euro (EUR 15.208,00) um einen Betrag von eintausendzweiundvierzig Euro (EUR
1.042) auf einen Betrag von sechzehntausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 16.250,00) durch die Ausgabe von eintau-
sendzweiundvierzig (1.042) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die eintausendzweiundvierzig (1.042) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck, vorbenannt, zum
Preis von eintausendzweiundvierzig Euro (EUR 1.042) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Holtzbrinck, vorbenannt, gezeichneten eintausendzweiundvierzig (1.042) Anteile der Serie A2 wurden voll-
ständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendzweiundvierzig Euro (EUR 1.042).
61605
L
U X E M B O U R G
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin
erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendzweiundvierzig Euro (EUR 1.042) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zuge-
führt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Bestehenden Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, dass Holtzbrinck nun die Inhaberin von eintausendzweiund-
vierzig (1.042) Anteilen der Serie A2 geworden ist.
Demzufolge schließt sich Holtzbrinck, vorbenannt, stimmberechtigt und hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer,
private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß der vorbenannten Vollmachten der Versammlung, welche im
Folgenden als „Gesellschafterversammlung“ bezeichnet wird, für die folgenden Beschlüsse an.
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt sechzehntausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 16.250,00), be-
stehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 zweitausendsiebenhundertacht (2.708) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.3 eintausendzweiundvierzig (1.042) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(die „Anteile der Serie A2“; die Anteile der Serie A1 und die Anteile der Serie A2 gemeinsam auch die „Anteile der Serie
A“).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Herrn Julien De Mayer, private employee, geboren am 9. April 1982 in
Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, mit sofortiger
Wirkung und für unbegrenzte Dauer als neuen Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft zu ernennen.
<i>Achter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 1.800,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unter-
zeichnet worden.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2015. Relation: 1LAC/2015/5065. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
61606
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 31. März 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015049094/1165.
(150056508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
IC Latin America Opportunity Fund I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 195.768.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-third day of the month of March.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
IC Latin America Opportunity Fund I L.P., an exempted limited partnership, established under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at c/o Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket
Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman, KY1-1112, Cayman Islands,
here represented by Mrs. Annick Braquet, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed «ne varietur» by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10
th
, 1915, on commercial companies,
as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of incorporation (hereafter the "Articles"), which specify in
the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. Corporate name. The Company will have the name "IC Latin America Opportunity Fund I S.à r.l. (hereafter
the "Company").
Art. 3. Corporate objects. The Company may acquire participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever, and manage those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of
any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect
itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real
estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of its share-
holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) repre-
sented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and
fully paid-up.
61607
L
U X E M B O U R G
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by unanimous vote of the shareholders representing one
hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share
capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Changes on capital. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by
a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these
Articles.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder,
the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions of the sole shareholder or of the
shareholders, as the case may be.
The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever
reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is
admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are
freely transferable.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. Events affecting the company. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Managers. The Company is managed by a sole manager or by a board of managers, composed of at least one
(1) manager A and at least (1) one manager B, who need not be shareholders, appointed by decision of the sole shareholder
or the shareholders, as the case may be, for an undetermined period of time.
Managers are eligible for re-election. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the
sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.
While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, without prejudice to
the first sentence of this article 12, the duration of their tenure and the powers and competence of the manager(s).
The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
Art. 13. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to
attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need
not be members of the board of managers.
Art. 14. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two
members of the board.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members, including at least one manager A
and at least one manager B, are present or represented.
Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to
vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or e-mail.
Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting.
A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board
shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.
In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall
be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
61608
L
U X E M B O U R G
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
Art. 15. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by
at least one manager. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.
The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.
Art. 16. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the
broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.
Art. 17. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general
meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.
The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.
Art. 18. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, or,
in case of plurality of managers, by the joint signature of one manager A and one manager B of the Company, or the joint
signatures or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 17 of these Articles.
Art. 19. Liability of the managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.
Art. 21. Decisions of the shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder
meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall vote in writing.
Art. 22. Financial year. The Company's year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of the
same year.
Art. 23. Financial statements. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts
are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 24. Allocation of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general
expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits
of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or in case of plurality of managers, the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 25. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one
or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remu-
neration.
61609
L
U X E M B O U R G
Art. 26. Matters not provided. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall start on the date of the incorporation and end on December 31
st
, 2015.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, IC Latin America
Opportunity Fund I L.P, has subscribed and entirely paid up twelve thousand five hundred (12,500) shares, each with a
nominal value of one Euro (EUR 1.-), for a total subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been given
to the undersigned notary, who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August, 10, 1915, on
commercial companies, as amended have been observed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,300.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers for an unlimited period of time:
<i>Managers A:i>
- Mr. Norman Villarina, born in Italy, on 2 November 1963, professionally address at One Sansome Street, 15
th
Floor,
San Francisco, California, 94104, United States of America;
- Mr. Douglas Wertheimer, born New York, United States, on 27 April 1964, with professional address at One Sansome
Street, 15
th
Floor, San Francisco, California, 94104.
<i>Managers B:i>
- Mrs. Virginia Strelen, born in Bergisch, Gladbach, Germany on 30 May 1977, with professional address at L-2540
Luxembourg, 15, rue Edward Steichen,
- Mr. Jean-Marc Mclean, born in Port of Spain, Trinidad and Tobago, on 13 March 1976, with professional address at
L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
2) The address of the Company is fixed at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
IC Latin America Opportunity Fund I, L.P.., un limited partnership exempté, établi en vertu du droit des îles Caïmans,
et ayant son siège social at c/o Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O.
Box 2804, Grand Cayman, KY1-1112 Île des Caïmans,
Ici représenté par Madame Annick Braquet, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité,
et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que
par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles excep-
tionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
61610
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination: "IC Latin America Opportunity Fund I S.à r.l." (ci-après "La
Société").
Art. 3. Objet. La Société peut prendre des participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et gérer ces participations. La Société peut notamment acquérir par sou-
scription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées, ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.
La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements
et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.
La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Modification du capital social. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout
moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité
avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l’associé unique ou
de la collectivité des associés, selon le cas.
Les créanciers et successeurs de l’associé unique ou de l’assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons
que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l’actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l’exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l’associé unique ou de l’assemblée des associés,
suivant le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-
priétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.
61611
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Cession de parts sociales. Dans l’hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-
ci sont librement transmissibles.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. Événements affectant la Société. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits
civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un gérant, ou un conseil de gérance, composé d’au moins
un (1) gérant A et d’au moins un (1) gérant B, associés ou non associés, nommés par une décision de l’associé unique ou
par l’assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l’assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, en
considération de la première phrase de l’article 12 des Statuts, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs
et attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 13. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
Art. 14. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux
membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l’endroit, au jour et à l’heure mentionnée dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres, incluant un gérant A et un gérant B, sont
présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et
voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l’approbation du conseil doit en informer
le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.
En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des
autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l’ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue.
Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 15. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des
procès-verbaux signés par, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l’alinéa qui précède. Les procurations
resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies et extraits de ces procès-verbaux seront signés par le président.
Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 16. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les
plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 17. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l’autorisation préalable de l’associé unique ou l’as-
semblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.
Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Art. 18. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de
pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant A et un gérant B dans tous les cas où la signature conjointe ou
la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné conformément à l’article 17
des Statuts.
61612
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Responsabilité de la gérance. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 20. Événements affectant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
Art. 21. Décisions de l’associé ou des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale
des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 23. Bilan. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 24. Répartition des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des
frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent
pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L'associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 25. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 26. Dispositions générales. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts,
il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la société commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante IC Latin America Opportunity Fund I L.P. a
souscrit et intégralement libéré les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR
1.-) chacune, pour un prix total de souscription de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-).
Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) a été donnée au notaire
instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.300.-
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
61613
L
U X E M B O U R G
<i>Gérants Ai>
- Monsieur Norman Villarina, né en Italie, le 02 Novembre 1963, résidant professionnellement à One Sansome Street,
15
eme
étage, San Francisco, Californie, 94104, Etats-Unis,
- Monsieur Douglas Wertheimer, né à New York, Etats-Unis, le 27 avril 1964, résidant professionnellement à One
Sansome Street, 15
eme
étage, San Francisco, Californie, 94104, Etats-Unis.
<i>Gérants Bi>
- Madame Virginia Strelen, née à Bergisch, Allemagne, le 30 mai 1977, résidant professionnellement à L-2540 Luxem-
bourg, 15, rue Edward Steichen,
- Monsieur Jean-Marc Mclean, né à Port of Spain, Trinité-et-Tobago, le 13 mars 1976, résidant professionnellement à
L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9674. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049245/397.
(150056939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
PET International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 99.137.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 19 mars 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes les opérations de liquidation de la société suivante:
- la société PET INTERNATIONAL s.à.r.l., dont le siège social à L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall a été
dénoncé en date du 29 mai 2009, inscrite au RCS sous le numéro B 99.137;
Le même jugement a mis les frais à charge de la masse.
Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015049441/16.
(150056905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Petronilla Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 116.255.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-
bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.
61614
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Signature
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015049442/13.
(150057024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Piaf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 183.163.
Par décision de l'administrateur unique du 24 mars 2015, Monsieur Alfred GUETTI, domicilié professionnellement au
8A, rue de Messancy, L-4962 CLEMENCY, a été coopté administrateur unique en remplacement de Monsieur Martin
RUTLEDGE, démissionnaire au 31 mars 2015.
Le mandat de l'administrateur unique s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2021.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour: PIAF S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015049444/16.
(150056442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Pilamaye S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 183.178.
Par décision de l'administrateur unique du 24 mars 2015, Monsieur Alfred GUETTI, domicilié professionnellement au
8A, rue de Messancy, L-4962 CLEMENCY, a été coopté administrateur unique en remplacement de Monsieur Martin
RUTLEDGE, démissionnaire au 31 mars 2015.
Le mandat de l'administrateur unique s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2021.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour: PILAMAYE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015049445/16.
(150056536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Porlux Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 113.847.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 19 mars 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:
la société anonyme PORLUX SOPARFI S.A (RCS B113847) avec siège social à L-3450 Dudelange, 28, rue du commerce,
de fait inconnue à cette adresse.
Les frais ont été mis à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Stéphanie STAROWICZ
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015049447/16.
(150056337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61615
L
U X E M B O U R G
Portman S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 114.979.
<i>Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 24 mars 2015i>
Suite à une lettre de démission datée du 11 mars 2015, le Conseil d'administration a pris note de la démission de
Monsieur Pierre Metzler de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 31 mars 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049448/11.
(150056676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Proformlux Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 115.671.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 19 mars 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:
la société anonyme PROFORMLUX SOPARFI S.A (RCS B115671) avec siège social à L-3450 Dudelange, 28, rue du
commerce, de fait inconnue à cette adresse.
Les frais ont été mis à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Stéphanie STAROWICZ
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015049449/16.
(150056336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
ProLogis European Holdings X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.591.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049450/9.
(150056409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Protexion Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5695 Emerange, 13, rue d'Elvange.
R.C.S. Luxembourg B 185.440.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 30 mars 2015.
Référence de publication: 2015049451/10.
(150056270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Putman Lux SA, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.
R.C.S. Luxembourg B 195.747.
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUEi>
<i>PUTMAN FRERES SA en date du 17 avril 2014i>
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité les points suivants:
1. L'établissement d'une succursale.
61616
L
U X E M B O U R G
2. De donner plein mandat à Monsieur Domenico Ranieri, dirigeant d'entreprises, né le 02 novembre 1954 à Elouges
demeurant à B-7382 Audregnies, Rue de l'Abbaye, 8, représentant permanent de la succursale luxembourgeoise, en vue
de l'accomplissement de toutes les démarches utiles et nécessaires liées à l'implantation d'une succursale.
3. Désigner Monsieur Ranieri, dirigeant d'entreprises, né le 02 novembre 1954 à Elouges demeurant à B-7382 Audre-
gnies, Rue de l'Abbaye, 8 en tant que représentant permanent de la succursale luxembourgeoise.
4. De donner, avec effet immédiat, à Monsieur Ranieri, dirigeant d'entreprises, né le 02 novembre 1954 à Elouges
demeurant à B-7382 Audregnies, Rue de l'Abbaye, 8 le pouvoir d'engager valablement et légalement, sans limite de
montant ou de durée, par sa seule signature, notamment:
a. Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées.
b. Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclaration de créance.
c. Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions.
d. Sur tout document de correspondance ou contractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les tiers et avec toute
autorité, administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en général.
5. Que la succursale exercera l'activité économique d'installateur électrique et électromécanique à savoir précisément
la fabrication, la vente et l'installation dans le pays de son siège social ou d'établissement et dans tous autres pays, de tous
appareils quelconques utilisant directement ou indirectement l'énergie sous toutes ses formes. Elle pourra notamment
fabriquer, installer et vendre tous les objets servant à utiliser directement ou indirectement l'électricité, la vapeur, l'eau,
les gaz, les huiles combustibles, l'énergie atomique et autres. Elle pourra également fabriquer, transformer ou préparer
les matières premières utilisées dans son industrie. Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, fi-
nancières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
6. De dénommer la succursale «PUTMAN LUX SA».
7. D'établir le siège de la succursale PUTMAN LUX SA à l'adresse suivante: 4, Rue de Kleinbettingen à L-8362 Grass
(Grand-Duché de Luxembourg).
8. Que l'exercice social de la succursale luxembourgeoise de la société commencera le 1
er
janvier et se terminera le
31 décembre de chaque année. En outre, le premier exercice social commencera le jour du dépôt du dossier au Registre
de Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2014.
La société-mère est la société ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES SA ayant son siège social
à 30, Rue Henri-Joseph Genesse à B-1070 Bruxelles enregistré sous le numéro d'entreprise BE437.709.827.
Les administrateurs de la société ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES SA sont:
- Madame Françoise Putman demeurant à 19, Grand Chemin à B-1380 Lasne.
- Monsieur Jacques Putman demeurant à 31, Avenue des Tilleuls à B-1180 Bruxelles.
- Monsieur Pierre Putman.demeurant à 16, Chemin Lazard à B-1420 Braine L'Alleud.
- Monsieur Domenico Ranieri demeurant à 8, Rue de l'Abbaye à B-7382 Audregnies.
Les administrateurs-délégués de la société précitée sont:
- Madame Françoise Putman demeurant à 19, Grand Chemin à B-1380 Lasne.
- Monsieur Domenico Ranieri demeurant à 8, Rue de l'Abbaye à B-7382 Audregnies.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049452/49.
(150056580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
PVC Compound Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 185.504.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales en date du 10 octobre 2014 entre OpenGate Capital Group Europe
S.à r.l. et Syntagma Capital Limited, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 130, Shaftesbury Avenue,
London W1D 5AR, Royaume-Uni, inscrite au Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 6979718,
que OpenGate Capital Group Europe S.à r.l. a cédé 563 parts sociales de la Société à Syntagma Capital Limited, avec effet
au 10 octobre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049453/17.
(150056725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61617
L
U X E M B O U R G
Quetzacoatl Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 128.395.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour QUETZACOATL INVESTi>
Référence de publication: 2015049455/10.
(150056233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Quetzacoatl Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 128.395.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour QUETZACOATL INVESTi>
Référence de publication: 2015049456/10.
(150056234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
R Port, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 126.465.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014i>
L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de la société KARSTE BVBA ayant comme représentant
permanent Monsieur Steven De Keyzer, en tant que délégué à la gestion journalière de la société.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2017, soit pour une durée de 3 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour R PORTi>
Référence de publication: 2015049457/13.
(150056330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Red Rock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 97.161.
EXTRAIT
En date du 30 mars 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Vishal Sookloll, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 6 mars 2015; et
- Madame Zuzanna Zielinska-Rousseau, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
est élue nouveau gérant de la Société avec effet au 6 mars 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049458/15.
(150056718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61618
L
U X E M B O U R G
Redstone Securities Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.978.
EXTRAIT
En date du 30 mars 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Vishal Sookloll, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 6 mars 2015; et
- Madame Zuzanna Zielinska-Rousseau, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
est élue nouveau gérant de la Société avec effet au 6 mars 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049459/15.
(150056704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
S.E.C. Finance S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Capital social: EUR 232.501.000,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 104.730.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue le 27 mars 2015i>
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 27 mars 2015, il a été résolu ce qui suit:
- De renouveler les mandats des administrateurs suivant jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se pro-
noncer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2015, soit en 2016:
* Monsieur Francesco D'Angelo, demeurant à 40, rue de Rollingergrund, L 2440 Luxembourg;
* Madame Allison Kirkby demeurant à Eastmansvagen 8b, 113 61 Stockholm, Suède;
* Madame Åsa Bladin demeurant à Östermalmsgatan 97, 114 59 Stockholm, Suède.
- De renouveler les mandats des AUXILIAIRE DES P.M.E. Société Anonyme, R.C.S. Luxembourg N° B 30718, 58, rue
Glesener, L - 1630 Luxembourg, en tant que Commissaire-aux-Comptes. Son mandat se terminera lors de l'assemblée
générale des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2015, soit en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
Francesco D'Angelo.
Référence de publication: 2015049478/20.
(150056426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
S.E.C. Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.134.495.200,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 84.649.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue le 27 mars 2015i>
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 27 mars 2015, il a été résolu ce qui suit:
- De renouveler les mandats des administrateurs suivant jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se pro-
noncer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2015, soit en 2016:
* Monsieur Francesco D'Angelo, demeurant à 40, rue de Rollingergrund, L 2440 Luxembourg;
* Madame Allison Kirkby demeurant à Eastmansvagen 8b, 113 61 Stockholm, Suède;
* Madame Åsa Bladin demeurant à Östermalmsgatan 97, 114 59 Stockholm, Suède.
- De renouveler les mandats des AUXILIAIRE DES P.M.E. Société Anonyme, R.C.S. Luxembourg N° B 30718, 58, rue
Glesener, L - 1630 Luxembourg, en tant que Commissaire-aux-Comptes. Son mandat se terminera lors de l'assemblée
générale des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2015, soit en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
Francesco D'Angelo.
Référence de publication: 2015049479/20.
(150056425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61619
L
U X E M B O U R G
S.I.E. - Stratégie Informatique Européenne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8720 Rippweiler, 14, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 63.173.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2015.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015049480/12.
(150056529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Shield Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 161.578.
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth of November,
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette,
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of Shield Luxembourg S.A., a public limited liability
company (société anonyme) organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
161.578, incorporated on 16 June 2011 by a deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette,
published in the Mémorial C number 2081 of 7 September 2011 (the “Company”). The articles of association of the
Company (the “Articles”) have been amended by a deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-
Alzette on 14 June 2011, published in the Mémorial C number 2293 of 27 September 2011.
The Meeting was presided by Eamonn MCDONALD, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing in Esch-sur-
Alzette.
The Meeting elected as scrutineer Aude NORMANT, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the shareholders and the number of shares held by them are shown on an attendance list, signed by the
chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said attendance list as well as the proxies will
be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. - That it appears from the attendance list, that all the sixty-seven million and fifty-nine thousand six hundred and
thirty-four (67,059,634) shares are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting may validly decide
on all the items of the agenda of which the shareholders have been duly informed ahead of the Meeting.
III. - That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Decision to change the accounting year of the Company so that it shall commence on the first day of January and
end on the last day of December of each year and that the current accounting year of the Company has exceptionally
started on 1 August 2014 and shall end on 31 December 2014.
2. Subsequent amendment of article 23 of the Articles.
IV. - After this had been set forth, the Meeting representing the whole corporate capital of the Company, has decided
to take the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to change the accounting year of the Company so that it shall commence on the first day of
January each year and shall end on the last day of December of each year. The Meeting further decides that the current
accounting year of the Company has exceptionally started on 1 August 2014 and shall end on 31 December 2014.
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides, subsequently, to amend article 23 of the Articles, which henceforth shall read as follows:
“ Art. 23. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
January and shall terminate on
the 31
st
December of the same year.” The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith
that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the
61620
L
U X E M B O U R G
request of the same appearing parties, in case of divergences between the English and the French text, the English version
will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status
and residences, the said persons appearing signed together with us the notary, the present original deed.
Follows the french version:
L'an deux mille quatorze, le dix-huit novembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
S'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de Shield Luxembourg S.A., une société anonyme
constituée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.578, constituée le 16 juin 2011
suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C numéro 2081
du 7 septembre 2011 (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés suivant acte de Maître
Blanche MOUTRIER, notaire résidant à Esch-sur-Alzette le 14 Juin 2011, publié dans le Mémorial C numéro 2293 du 27
Septembre 2011.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Eamonn MCDONALD, juriste, résidant à Luxembourg.
Le président désigne conne secrétaire Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant à Esch-sur-
Alzette.
L'Assemblée élit comme scrutateur Aude NORMANT, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires et le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée
par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations
resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il apparaît selon cette liste de présence que l'intégralité des soixante sept millions cinquante-neuf mille six cent
trente-quatre (67.059.634) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été
informés avant l'assemblée.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision de changer l'exercice social de la Société pour le faire commencer le premier jour de janvier et terminer
le dernier jour de décembre de chaque année et que l'exercice social en cours a exceptionnellement commencé le 1 août
2014 et se terminera le 31 décembre 2014.
2. Modification subséquente de l'article 23 des Statuts.
IV.- Ceci ayant été exposé, l'Assemblée représentant l'intégralité du capital social de la Société, a décidé de prendre
les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de changer l'exercice comptable de la Société pour le faire commencer le premier jour de janvier
de chaque année et terminer le dernier jour de décembre de chaque année. L'Assemblée décide ensuite que l'exercice
social en cours a exceptionnellement commencé le 1 août 2014 et se terminera le 31 décembre 2014.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide, en conséquence, de modifier l'article 23 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:
“ Art. 23. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera au 1 janvier et se terminera le 31 décembre de
la même année”
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande des mêmes personnes, en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite aux parties comparantes, connus du notaire par les noms, prénoms, état civil et résidence, lesdites
personnes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: McDonald, Conde, Normant, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15808. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
61621
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015049481/99.
(150056310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sieberath International Consulting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9749 Fischbach, 8, Z.I. Giaellewee.
R.C.S. Luxembourg B 153.314.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30.03.2015.
1. L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de 7, Z.I. Giällewee L-9749 FISCHBACH à 8, Z.I.
Giällewee L-9749 FISCHBACH
David SIEBERATH
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015049482/12.
(150056386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Stonebridge Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 109.399,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.307.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 31 mars 2015, l'associé unique a pris la décision suivante:
1. Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, réviseur d'entreprises agréé, avec
siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049490/15.
(150056547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Stonebridge Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 109.399,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.307.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049491/10.
(150056767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Stonebridge Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 61.605.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 31 mars 2015, l'actionnaire unique a pris la décision suivante:
1. Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, réviseur d'entreprises agréé, avec
siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049492/14.
(150056548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61622
L
U X E M B O U R G
Stonebridge Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 61.605.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049493/10.
(150056766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sun (Lille) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.361.
<i>1. Extrait des résolutions du conseil de gérance du 11 mars 2015:i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société est transféré du 28, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg
au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 23 mars 2015.
2. Il est à noter que:
- le siège social de BR Sun S.à r.l., associé unique de la Société, a été transféré au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg avec effet au 23 mars 2015.
- l'adresse professionnelle de Madame Joanne Fitzgerald a été transférée au 35a, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Lu-
xembourg avec effet au 23 mars 2015.
- l'adresse professionnelle de Madame Delloula Aouinti a été transférée au 35a, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxem-
bourg avec effet au 23 mars 2015.
- l'adresse professionnelle de Monsieur Alexis Gisselbrecht est 12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL, Roy-
aume Uni.
- La nouvelle adresse du réviseur d'entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, est 2, rue Ge-
rhard Mercator, L-1014 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 23 mars 2015.
<i>Pour la Société
i>Joel Davidson
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015049494/27.
(150056485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sagittarius Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R.C.S. Luxembourg B 69.113.
L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Terenzio Maria SERVETTI, entrepreneur, domicilié professionnellement à I-47014 Meldola, Via Roma 188
int. 4 (Italie) c/o CENTROPLAST HOLDING S.r.l.,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration (le “Conseil d'Administration”) de “SAGIT-
TARIUS INVESTISSEMENTS S.A.”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 69113, (la “Société”),
en vertu de pouvoirs lui conférés par décisions du Conseil d'Administration, en date du 16 février 2015,
une copie du procès-verbal de ladite décision, après avoir été signé “ne varietur” par le Mandataire et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel il sera formalisé.
61623
L
U X E M B O U R G
Le susdit Mandataire, agissant en vertu des prédit pouvoirs, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il
suit ses déclarations et constatations:
I.- La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 23 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 440 du 11 juin 1999,
et les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant actes reçus par:
- ledit notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, en date du 18 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 69 du 19 janvier 2004, et
- le notaire instrumentant, en date du 14 mai 2014 (2 actes), publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéros 1385 et 1386 du 30 mai 2014.
II.- Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,-EUR), représenté par CENT CINQUANTE
(150) action de catégorie A avec une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.
III.- Aux termes de l'article 3 des Statuts, le capital social peut être porté de son montant actuel à ONZE MILLIONS
DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE EUROS (11.288.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions de ca-
tégorie A ou de catégorie B supplémentaires d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000,- EUR) chacune, émises avec
une prime d'émission de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,- EUR) par action et le Conseil d'Administration
est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mai 2019, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être libérées en espèces, en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société, ou même par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.
Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le Conseil d'Administration est spécialement, dans le cadre de ce capital autorisé, à:
a) émettre de nouvelles actions, en une fois ou en tranches;
b) fixer le moment et le lieu de l'émission intégrale ou partielle de nouvelles actions;
c) fixer les conditions de souscription et de libération du capital;
d) proposer, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires la souscription de nouvelles actions;
e) mettre en place toutes modalités de réalisation jugées utiles ou nécessaires n'ayant pas été prévues expressément
par le présent acte;
f) faire constater, selon les modalités prévues, les souscriptions de nouvelles actions, la libération du capital ainsi que
son augmentation;
g) mettre à jour les statuts après toute modification résultant de l'augmentation du capital réalisée et dûment vérifiée,
conformément à la loi, pourvu que la présente autorisation sera renouvelée tous les cinq ans.
IV.- Par ses résolutions du 25 novembre 2014, dûment ratifiées par des résolutions prise le 16 février 2015, le Conseil
d'Administration, a, conformément à l'article 5 des Statuts, réalisé une augmentation du capital social dans les limites du
capital autorisé, d'un montant de cent trente-huit mille euros (138.000,- EUR), par la création de cent trente-huit (138)
actions de catégorie B avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, émises avec une prime d'émission
de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) par action, (les “Actions Nouvellement Emises”), à souscrire et à libérer
intégralement en numéraire et jouissant des droits et avantages tels que stipulés dans les Statuts.
V.- Les Actions Nouvellement Emises de la Société ont été souscrites et affectées, pour les besoins des autorités
fiscales italiennes, avec effet au 31 décembre 2014, aux souscripteurs apparaissant sur la liste en annexe.
Les formulaires justificatifs de souscription, après avoir été signés “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instru-
mentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les Actions Nouvellement Emises ont été libérées intégralement, ensemble avec la prime d'émission, par un apport
en numéraire. La preuve du paiement des quatre cent quatre-vingt-trois mille euros (483.000,- EUR), faisant cent trente-
huit mille euros (138.000,- EUR) pour l'augmentation de capital et trois cent quarante-cinq mille euros (345.000,- EUR)
pour le paiement de la prime d'émission, a été donnée au notaire soussigné qui le constate expressément.
VI.- Suite à la réalisation de cette augmentation, dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l'article 3 des
Statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
“ 3.1. Le capital social est fixé à DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE EUROS (288.000,- EUR), représenté par
CENT CINQUANTE (150) actions de catégorie A et CENT TRENTE-HUIT (138) actions de catégorie B avec une valeur
nominale de MILLE EUROS (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille neuf cents
euros.
61624
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par son nom, prénom,
état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. M. SERVETTI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 19 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/6018. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société;
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049496/85.
(150056818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sangre Pura SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 183.882.
Par décision de l'administrateur unique du 24 mars 2015, Monsieur Alfred GUETTI, domicilié professionnellement au
8A, rue de Messancy, L-4962 CLEMENCY, a été coopté administrateur unique en remplacement de Monsieur Martin
RUTLEDGE, démissionnaire au 31 mars 2015.
Le mandat de l'administrateur unique s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2021.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour: SANGRE PURA SPF S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015049497/16.
(150056534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Saproman Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel.
R.C.S. Luxembourg B 172.486.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Extraordinaire du 17 mars 2015i>
Monsieur Fabrice Caurla, expert-comptable, né le 04 février 1983 à Esch-sur-Alzette (L), demeurant au 3, rue Emile
Eischen à L-4107 Esch-sur-Alzette est nommé nouvel Administrateur de cat. B en remplacement de Monsieur Pascal De
Graeve. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour SAPROMAN INVESTi>
Référence de publication: 2015049498/13.
(150056453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sopage S. à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 40.805.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049519/9.
(150056335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61625
L
U X E M B O U R G
SPS International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 98.669.404,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.164.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 19 mars 2015i>
1. Monsieur Robert HESSING a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 29 janvier 2015.
2. Monsieur Davy TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Bastogne (Belgique), le 28 octobre 1986, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, gérant de catégorie B a été nommé comme gérant
de classe B pour une durée indéterminée avec effet au 29 janvier 2015.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SPS International S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015049523/17.
(150056643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
SSP Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.000.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 148.210.
Le bilan de la société au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
SSP Luxco S.à r.l.
Référence de publication: 2015049524/11.
(150056942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
STRIKE Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 89.784.
Le bilan de la société au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049525/12.
(150056352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sukhoï S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 187.600.
Par décision du conseil d'administration du 26 mars 2015: LANNAGE S.A., R.C.S. Luxembourg B-63130, 42 rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour son compte au conseil d'administration de la société SUKHOÏ S.A., Monsieur Anouar BELLI, 42 rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Raphaël EBER, démissionnaire au 12 février 2015.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019
61626
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 26 mars 2015.
<i>Pour: SUKHOÏ S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015049526/17.
(150056374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sunstream, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 176.737.
In the year two thousand and fifteen, on twenty-fourth of March.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing at Junglinster, Grand- Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED:
METHORIOS CAPITAL S.p.A., a company existing and validly incorporated under the law of Italia, with registered
office at Via Bocca di Leone 78, 00197, Rome (Italy),
here represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, having his professional residence at L-6130 Junglinster, 3, Route
de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxy, after being signed «ne varietur» by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to enact the following:
A) That the present public limited liability company “SUNSTREAM” having its registered office at L-8308 Capellen, 75,
Parc d'Activités, RCS Luxembourg B 176737, incorporated by deed dated April 4, 2013 and enacted by Maître Jean
SECKLER, then notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C number 1390 of June 12, 2013 (the “Company”);
B) That the share capital of the Company amounts to thirty one thousand euros (EUR 31.000) and partially paid up at
twenty-five percent (25%) of an amount of seven thousand seven hundred and fifty euros (EUR 7.750) represented by
thirty one thousand (31.000) shares with a par value of one euro (EUR 1).
C) That the appearing party is the current sole shareholder of the Company (the “Sole Shareholder”), representing
100% of the share capital and that he has taken, through its proxy-holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges that following the resolution taken by the sole director hold on December 18,
2014 and having noted the payment of the sum of twenty-three thousand two hundred fifty Euros (EUR 23,250 -) by the
Sole Shareholder, the share capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000 -) of the Company is now fully paid-up.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by a total amount of two hundred and one
thousand and two hundred and forty-six euros (EUR 201.246) in order to raise it from its current amount of thirty one
thousand Euros (EUR 31,000) to two hundred and thirty-two thousand two hundred and forty-six Euros (EUR 232.246)
through the issue of two hundred and one thousand and two hundred and forty-six (EUR 201.246) new shares having a
nominal value of one Euro (EUR 1) each.
The new shares are paid-up in full and subscribed as follows:
1) Ninety-six thousand seven hundred and fifty (96.750) shares have been subscribed by the Sole Shareholder and have
been fully paid up by payment in cash so that the amount of ninety-six thousand seven hundred and fifty Euros (EUR
96,750) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned
notary, who expressly attests thereto;
2) One hundred and four thousand four hundred and ninety-six (104.496) shares have been subscribed by the afore-
mentioned sole shareholder in exchange for a contribution in kind of sixty-three thousand three hundred thirty-one
(63.331) shares held in the company AZ Leasing S.p.A. with registered office at Via F. Carrara, n°24, IT 00196 Roma, and
listed on the Marché Libre de Paris (ISIN Code IT0004812258) (the “Contribution”).
The total value of the Contribution amounts to one hundred and four thousand four hundred and ninety-six euros
(EUR 104.496).
<i>Evaluationi>
The value of the Contribution results from report issued by VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO S.à r.l., dated
December 5, 2014 annexed hereto.
61627
L
U X E M B O U R G
The conclusion of the report is the following: “Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention
qui nous laisse à penser que la valeur globale de l’apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale
des nouvelles actions à émettre en contrepartie, c’est-à-dire 104.496 actions, représentant un capital de 104.496,00
euros.”
The above mentioned report, after having been initialled by the notary and the proxyholder of the appearing party,
will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
The appearing party declares that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there
subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without any restriction or limitation
and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Contribution to the Company.
The proof of the existence and of the value of the above Contribution has been produced to the undersigned notary,
together with evidence of the subscription of the above shares by the aforementioned sole shareholder.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the
articles of association in order to give it the following wording:
“ Art. 5. (first paragraph). The share capital is set at two hundred and thirty-two thousand two hundred and forty-six
Euros (EUR 232.246) represented by two hundred and thirty-two thousand two hundred and forty-six (232.246) shares
with a nominal value of one Euros (EUR 1) each.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the article 6 of the articles of association in order to give it the following
wording:
“ Art. 6. The Company may have one or several shareholders. The death, suspension of civil rights, dissolution, ban-
kruptcy or insolvency of any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
The shares of the Company are in registered form and are freely negotiable and freely transferrable.
The shares of the Company may be admitted to trading in a multilateral trading facility (MTF) within the European
Union. In such a case, the rules and any requirements and regulations of the MTF concerned will apply.
The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative who shall
represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.
The Company will only recognize a transferee of shares in the Company as the owner of such shares.”
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed is drawn up in Junglinster on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said proxyholder of the person
appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
METHORIOS CAPITAL S.p.A., une société existante et valablement constituée selon les lois d’Italie, ayant son siège
social à Via Bocca di Leone 78, 00197, Rome (Italie),
ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son adresse professionnelle à L-6130 Junglinster, 3,
Route de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme indiqué, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
A) Que la société anonyme «SUNSTREAM», ayant son siège social à L- 8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, RCS
Luxembourg B 176737, a été constituée le 4 avril 2013 suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER notaire de résidence
61628
L
U X E M B O U R G
à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg), tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date
du 12 juin 2013 sous le numéro 1390 (la «Société»);
B) Que le capital social de la Société s’élève à trente et un mille euros (EUR 31.000) et qu’il a été partiellement payé
à hauteur de vingt-cinq pour cent pour un montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750);
C) Que le comparant est l’actionnaire unique de la Société, représentant 100% du capital (l’"Actionnaire Unique») et
qu’il a pris, par l’intermédiaire de son mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Actionnaire Unique constate que suite à la résolution unique prise par l’administrateur unique en date du 18 décembre
2014 et ayant porté constat de libération de la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (EUR 23.250,-) par
les actionnaires, de sorte que le capital social de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) de la Société est désormais
entièrement libéré.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide d’augmenter le capital de la Société d’un montant de deux cent un mille deux cent qua-
rante-six euros (EUR 201.246,-) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à deux
cent trente-deux mille deux cent quarante-six euros (EUR 232.246,-) par l’émission de deux cent un mille deux cent
quarante-six (201.246) nouvelles actions ayant une valeur nominale d’un (1) euro chacune.
Les nouvelles actions sont entièrement libérées et souscrites de la façon suivante:
1) Quatre-vingt-seize mille sept cent cinquante (96.750) actions ont été souscrites par l’actionnaire unique et ont été
entièrement libérées moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de quatre-vingt-seize mille sept cent
cinquante euros (EUR 96,750) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément;
2) Cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-seize (104.496) actions ont été souscrites par l’actionnaire unique men-
tionné ci-dessus en échange d’un apport en nature de soixante-trois mille trois cent trente et une (63.331) actions
détenues dans la société AZ Leasing S.p.A. ayant son siège social à Via F. Carrara, n°24, IT 00196 Rome, cotée sur le
Marché Libre de Paris (ISIN Code IT0004812258) (la «Contribution»).
La valeur de la Contribution est d’un montant total de cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-seize euros (EUR
104.496).
<i>Evaluationi>
La valeur de la Contribution résulte d’un rapport spécial émis par VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO S.à r.l., en
date du 5 décembre 2014, annexé aux présentes.
La conclusion du rapport est la suivante: «Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui
nous laisse à penser que la valeur globale de l’apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des
nouvelles actions à émettre en contrepartie, c’est-à-dire 104.496 actions, représentant un capital de 104.496,00 euros.»
Le rapport susmentionné, après avoir été paraphé par le notaire et le mandataire de la partie comparante, restera annexé
au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie présente déclare que la Contribution est libre de tout gage, privilège ou charge, selon le cas, et qu’il n’y a pas
d’obstacle quant au libre transfert de la Contribution à la Société sans aucune restriction ou limitation et que des ins-
tructions valables ont été données pour que les notifications, enregistrements ou autres formalités nécessaires pour
rendre valable le transfert de la Contribution à la Société ont été entrepris.
La preuve de l’existence et de la valeur de la contribution ci-dessus a été rapportée au notaire soussigné, ensemble
avec la preuve de la souscription des actions ci-dessus par l’actionnaire unique.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Actionnaire Unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts
afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. (premier alinea). Le capital social est fixé à deux cent trente-deux mille deux cent quarante-six euros (EUR
232.246,-) représenté par deux cent trente-deux mille deux cent quarante-six euros (232.246) actions d’une valeur no-
minale de un euro (1) euro chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. La Société pourra avoir un ou plusieurs actionnaires. Le décès, l’interdiction, la dissolution, la faillite ou
l’insolvabilité de l’un des actionnaires ne saurait entraîner la dissolution de la Société.
Les actions de la Société sont nominatives, librement négociables et librement cessibles.
Les titres de la Société pourront être admis à la cotation sur un système multilatéral de négociation (SMN) au sein de
l’Union Européenne. Le cas échéant, les règles, les conditions et les règlements du SMN concerné seront applicables.
61629
L
U X E M B O U R G
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Les copropriétaires indivis d’actions devront désigner un man-
dataire unique pour les représenter à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les
droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire.
La Société reconnaîtra seulement le bénéficiaire d’un transfert d’actions de la Société comme propriétaire desdites
actions.»
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille six cents euros (EUR 1.600,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la comparante le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, passé à Junglinster, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 mars 2015. Relation GAC/2015/2591. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015049527/174.
(150056554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Tele2 Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 17.700.000,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 112.873.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue le 27 mars 2015i>
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 27 mars 2015, il a été résolu ce qui suit:
- De renouveler les mandats des gérantes suivant jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se prononcer
sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2015, soit en 2016:
* Monsieur Francesco D'Angelo, demeurant à 40, rue de Rollingergrund, L 2440 Luxembourg;
* Madame Olga Kotiranta, demeurant au 19 avenue du X Septembre, L 2551;
* Madame Åsa Bladin demeurant á Östermalmsgatan 97, 114 59 Stockholm, Suède.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
Francesco D'Angelo.
Référence de publication: 2015049529/17.
(150056603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Colex Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 61.235.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. s.a. / A.T.T.C. s.a.
<i>Gérant / Gérant
i>N. Patteet / K. Van Huynegem
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2015049083/15.
(150056623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61630
L
U X E M B O U R G
Abertas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 180.833.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 mars 2015i>
En date du 24 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de prendre note du décès de Monsieur Hiroyuki Rex SATO, gérant A de la Société, en date du 7 mars 2015;
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Anne Catherine GRAVE de son mandat de gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015;
- de nommer Madame Antonella GRAZIANO, née le 20 janvier 1966 à Orvieto, Italie, résidant à l'adresse profes-
sionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 31 mars
2015 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Madame Sonia BALDAN, née le 27 janvier 1960 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant
à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur John J. FOSINA, gérant A
- Monsieur Christian REYNT JENS, gérant A
- Monsieur Christophe AURAND, gérant A
- Madame Catherine KOCH, gérant B
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant B
- Madame Sonia BALDAN, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
ABERTAS S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015048955/30.
(150056501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Black Tie Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 200.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 157.838.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société en date du 30 mars 2015i>
- Il a été décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Diogo Alves en tant que gérant B de la Société avec effet au 4 mars 2015,
- de nommer Monsieur Vito Marinelli, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
en tant que gérant B avec effet immédiat pour une période illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015048991/14.
(150056522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
NETASEC, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 18, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 25.293.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait conforme
Référence de publication: 2015049390/10.
(150056697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61631
L
U X E M B O U R G
Tilon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 183.308.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 mars 2015i>
En date du 24 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de prendre note du décès de Monsieur Hiroyuki Rex SATO, gérant A de la Société, en date du 7 mars 2015;
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Anne Catherine GRAVE de son mandat de gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015;
- de nommer Madame Antonella GRAZIANO, née le 20 janvier 1966 à Orvieto, Italie, résidant à l'adresse profes-
sionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 31 mars
2015 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Madame Sonia BALDAN, née le 27 janvier 1960 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant
à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur John J. FOSINA, gérant A
- Monsieur Christian REYNT JENS, gérant A
- Monsieur Christophe AURAND, gérant A
- Madame Catherine KOCH, gérant B
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant B
- Madame Sonia BALDAN, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Tilon S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015049535/30.
(150056565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
26 United Corpo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 2, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 176.725.
Les statuts coordonnés au 26/02/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31/03/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015049594/12.
(150056835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
3 PH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 86.564.
Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
3 PH S.A.
Référence de publication: 2015049596/10.
(150056921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
61632
26 United Corpo SA
3 PH S.A.
Abertas S.à r.l.
Black Tie Luxco S.à r.l.
Bonativo Global S.à r.l.
Colex Investments S.A.
Digital Services Holding XXIII S.à r.l.
IC Latin America Opportunity Fund I S.à r.l.
NETASEC, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
PET International S.à r.l.
Petronilla Investments S.A.
Piaf S.A.
Pilamaye S.A.
Porlux Soparfi S.A.
Portman S.A.
Proformlux Soparfi S.A.
ProLogis European Holdings X S.à r.l.
Protexion Group S.A.
Putman Lux SA
PVC Compound Holding S.à r.l.
Quetzacoatl Invest
Quetzacoatl Invest
Red Rock S.à r.l.
Redstone Securities Holdings S.à r.l.
R Port
Sagittarius Investissements S.A.
Sangre Pura SPF S.A.
Saproman Invest
S.E.C. Finance S.A.
S.E.C. Luxembourg S.A.
Shield Luxembourg S.A.
Sieberath International Consulting
S.I.E. - Stratégie Informatique Européenne S.A.
Sopage S. à.r.l.
SPS International S.à r.l.
SSP Luxco S.à r.l.
Stonebridge Holding S.à r.l.
Stonebridge Holding S.à r.l.
Stonebridge Re S.A.
Stonebridge Re S.A.
STRIKE Participations S.A.
Sukhoï S.A.
Sun (Lille) S.à r.l.
Sunstream
Tele2 Finance Luxembourg S.à r.l.
Tilon S.à r.l.