This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1283
18 mai 2015
SOMMAIRE
Argan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61584
Carmudi Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61538
Castello (Lux) Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . .
61538
CNH Industrial Europe Holding S.A. . . . . .
61583
Green Consult Luxembourg S.A. . . . . . . . .
61583
Immo 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61563
LIC Telecommunications S.à. r.l. . . . . . . . .
61567
LIC Telecommunications S.à. r.l. . . . . . . . .
61568
Prominvest S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61584
Schnetzer & Holzmoler Atelier S.à r.l. . . .
61564
Scoubidou S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61565
SECURITEC Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61565
Sekmet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61565
Selecta Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61566
Sestrice SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61566
Shay Properties Bury S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
61566
Shay Property Investments S.à r.l. . . . . . . .
61566
SHCO 79 S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61567
SHRM Corporate Services S.à r.l. . . . . . . . .
61569
SHRM Corporate Services S.à r.l. . . . . . . . .
61569
Sigma Tau Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61569
Skans Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61570
Société Européenne de Banque . . . . . . . . .
61570
Société Intercontinentale de Négoce S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61570
Sogepar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61581
Solutio Premium Private Equity VI Master
SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61582
SOSTNT Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
61571
Soyuz Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61576
SPEP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61576
Tafelberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61576
TE Connectivity Holding International I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61577
Tele 2 Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61577
Themis Realty Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61578
THEOLIA Management Company S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61579
The Sixth Belfry Properties (UK) S.A. . . .
61578
Thiel AS Logistics A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61580
TLW Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61580
TVX Amalco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61580
TVX Mining Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . .
61581
TyCom Holdings II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61576
ULT (Union Luxembourgeoise du Touris-
me) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61581
UNA S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61581
61537
L
U X E M B O U R G
Castello (Lux) Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 104.838.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2015049043/11.
(150056172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Carmudi Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.487.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of February.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.038,
having its registered office at 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (he-
reinafter “AIH”),
being the holder of six thousand seventy-one (6,071) common shares, six thousand seventy-one (6,071) series A1
shares and five thousand four hundred sixty-eight (5,468) series B shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Berlin, Germany, on 9 February 2015, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 9 February 2015,
2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 139778 B, having
its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “MKC”),
being the holder of one thousand eight hundred seventy-five (1,875) common shares and one thousand eight hundred
seventy-five (1,875) series A2 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Berlin, Germany, on 9 February 2015,
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000) (hereinafter “Aismare”),
being the holder of one thousand five hundred eighteen (1,518) common shares and one thousand five hundred eighteen
(1,518) series A3 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
London, on 12 February 2015,
4. TEC Global Invest VIII GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg under number HRB 26060, having its registered office at
Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany (hereinafter “TEC”),
being the holder of one thousand five hundred eighteen (1,518) common shares, one thousand five hundred eighteen
(1,518) series A3 shares and one thousand two hundred fifty (1,250) series B shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Mülheim an der Ruhr, Germany, on 9 February 2015,
5. SHCO 57 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B183425, having its regis-
tered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “SHCO”),
being the holder of one thousand five hundred eighteen (1,518) common shares and one thousand five hundred eighteen
(1,518) series A3 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 9 February 2015,
61538
L
U X E M B O U R G
6. Leifina GmbH & Co. KG, a limited partnership under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany,
registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRA 80493, having its business
address at Maximilianstr. 21, 80539 Munich, Germany (hereinafter “Leifina”),
being the holder of one thousand (1,000) series B shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Munich, Germany, on 10 February 2015, and
7. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 191.426 (hereinafter “Holtzbrinck”),
becoming the holder of one thousand two hundred fifty (1,250) series B shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 February 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties under 1., 2., 3., 4., 5. and 6. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Carmudi Global S.à
r.l. (hereinafter the “Company”), formerly Digital Services XXVI S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number B 188487, incorporated pursuant to a deed of notary Carlo Wersandt on
18 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2516 on 17 September 2014. The
articles of association have been amended pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux dated 29 January 2014, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Existing Shareholders representing the entire share capital having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda whereby
Holtzbrinck participates and votes for the purpose of agenda point 3 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Acceptance of HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 191.426, as new shareholder of the Company.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250)
from its current amount of thirty-two thousand seven hundred eighteen euro (EUR 32,718) up to thirty-three thousand
nine hundred sixty-eight euro (EUR 33,968) through the issuance of one thousand two hundred fifty (1,250) series B
shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
3. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth
read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-three thousand nine hundred sixty-eight euro (EUR 33,968), repre-
sented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand seventy-one (6,071) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series A1 Shares”),
5.1.3 one thousand eight hundred seventy-five (1,875) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 four thousand five hundred fifty-four (4,554) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A3 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares collectively “Series A Shares”),
and
5.1.5 eight thousand nine hundred sixty-eight (8,968) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series B Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH (“TEC”), (v) SHCO 57 S.à r.l (“SHCO”), (vi) Leifina GmbH & Co
KG (“Leifina”) and (vii) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”; AIH, LIH, Aismare, TEC, SHCO, Leifina
61539
L
U X E M B O U R G
and Holtzbrinck jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further
Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a
shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corpo-
ration Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party
Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders -required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO,
(vi) Leifina and Holtzbrinck shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been
notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO, (vi)
Leifina and/or (vii) Holtzbrinck intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this
Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”
4. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Carmudi Global
S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-three thousand nine hundred sixty-eight euro (EUR 33,968), repre-
sented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand seventy-one (6,071) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series A1 Shares”),
61540
L
U X E M B O U R G
5.1.3 one thousand eight hundred seventy-five (1,875) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 four thousand five hundred fifty-four (4,554) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A3 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares collectively “Series A Shares”),
and
5.1.5 eight thousand nine hundred sixty-eight (8,968) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series B Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH (“TEC”), (v) SHCO 57 S.à r.l (“SHCO”), (vi) Leifina GmbH & Co
KG (“Leifina”) and (vii) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”; AIH, LIH, Aismare, TEC, SHCO, Leifina
and Holtzbrinck jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further
Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a
shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corpo-
ration Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party
Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders -required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO,
(vi) Leifina and Holtzbrinck shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been
notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO, (vi)
Leifina and/or (vii) Holtzbrinck intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this
Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing Shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated
to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”);
7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity
(x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by
one or more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Con-
trol” or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of
(a) managing the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority
of voting rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders
of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer of Shares from Leifina to a company affiliated to Leifina within the meaning of sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) and/or to any entity the ultimate owner of which is Dr. Kurt Schwarz,
61541
L
U X E M B O U R G
the spouse of Dr. Kurt Schwarz and/or all children of Dr. Kurt Schwarz, provided that (i) the acquiring entity assumes all
rights and obligations under the existing shareholders’ agreement in its most recent version among, inter alia, the sha-
reholders of the company and (ii) for the purpose of determining the Shareholders' or Investors majority all entities
succeeding Leifina jointly shall be deemed to be one (1) Investor;
7.4.4 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a shareholder to the Company and/or
any of the Investors pursuant to a call-option under a vesting scheme.
7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the
shareholders’ meeting pursuant to Article 7.4.1 through Article 7.4.3 above, neither duties to offer for sale, nor any rights
of first refusal, nor rights of pre-emption, nor tag-along rights, nor drag-along rights apply in favour of other Shareholders.
7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with Article
1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an
economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with Article 8.4 to the Shareholders pro rata to
their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series B Shares shall receive per Share an amount of EUR 2,000 being
subject to the Liquidity Event.
8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares shall
receive per Share of the respective Share class an amount stipulated next to the relevant share class being subject to the
Liquidity Event in the following table:
Share Class
Amount
per Share
in Euro
Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.06
Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553.25
Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,646.90
8.4 After the payments on the First Level and on the Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall
be allocated on a third level (“Third Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event.
Any amounts received by any Investor on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be allocated to
such Investor on this Third Level provided that no Investor shall be obliged to repay any amount received on the First
Level and/or the Second Level. Irrespective of whether or not the sale of Shares is made in one Liquidity Event or after
the Liquidity Event in one transaction or more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of its Shares
(and shall repay any exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the
total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the Shares sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated
to such shareholder on the First Level and/or Second Level and/or Third Level from a subsequent sale. All rights related
to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
8.5 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective Investor so
long as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according to
the First Level.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
61542
L
U X E M B O U R G
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with
the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the
Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register
the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
61543
L
U X E M B O U R G
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Shareholders’ Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders’ resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the
consent of the Advisory Board:
17.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
17.1.2 amendment of these articles of association including the resolution with respect to the merger, separation and
transformation of the Company;
17.1.3 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such
profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
17.1.4 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG));
17.1.5 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of existing
shares or issuance of new shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other con-
tractual party is granted a participation in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the
Company’s profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agree-
ments concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the consent of
the Investors.
17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company’s own Shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and
transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.
61544
L
U X E M B O U R G
17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of Shares the special rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders’ who hold
all the issued Shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
61545
L
U X E M B O U R G
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The managers shall require the consent of the advisory board (the “Advisory Board”) for the legal transactions
and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined
and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:
22.8.1 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of five hundred thousand Euros
(EUR 500,000.00) in aggregate;
22.8.3 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,
however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
22.8.4 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two
hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework, excluding,
however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
22.8.5 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
22.8.6 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.7 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
22.8.8 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than five hundred thousand Euros (EUR 500,000.00) in the individual case;
22.8.9 passing on of industrial property rights or know-how by the Company to a third party outside the ordinary
course of business;
22.8.10 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals as set
forth in any shareholders’ agreement between the shareholders;
22.8.11 amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections
291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)); and
22.8.12 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)
other than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the
Company in a shareholders' agreement, if any.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers) such minutes shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
61546
L
U X E M B O U R G
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an Advisory Board. It consists of six (6) voting members. The shareholders may by way
of unanimous shareholders’ consent increase or decrease the number of voting members of the Advisory Board.
25.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders’ consent.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-
pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.3.1 One (1) voting member of the Advisory Board, having seven (7) votes, shall be nominated by the shareholder
AIH in its sole discretion;
25.3.2 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder
LIH in its sole discretion;
25.3.3 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder
Aismare in its sole discretion;
25.3.4 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder
TEC in its sole discretion; and
25.3.5 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder
SHCO in its sole discretion.
25.3.6 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder
Holtzbrinck in its sole discretion.
25.4 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. The chairman shall be the member nominated
by the largest shareholder in terms of percentage participation that is entitled to nominate a member to the Advisory
Board. The rules of procedure of the Advisory Board may provide for further provisions in particular on the self-orga-
nization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast. In case
of a vote tie, the chairman shall have a casting vote if at the point in time of the respective decision the Shareholder having
nominated the chairman holds more than 50 % of all shares in the Company. For the avoidance of doubt the deputy
chairman shall not have a casting vote.
25.5 The objective and responsibility of the Advisory Board shall be the granting of consents to specific transactions
of the management of the Company which pursuant to (i) any shareholders’ agreement relating to the Company, (ii) these
articles of association, (iii) the rules of procedure for the managers, (iv) the rules of procedure for the Advisory Board
or (v) respective shareholders’ resolutions require the consent of the Advisory Board. Further powers and responsibilities
may be conferred on the Advisory Board by shareholders’ resolution. In addition to those consent requirements, the
Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the management of the Company.
25.6 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
61547
L
U X E M B O U R G
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
5. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr Ruediger
Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders’ register of
the Company.
6. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the undersigned notary to enact, the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to accept HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en com-
mandite simple incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 191.426, as new shareholder of the Company.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to increase the share capital of the Company by an amount of one
thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250) from its current amount of thirty-two thousand seven hundred eighteen
euro (EUR 32,718) up to thirty-three thousand nine hundred sixty-eight euro (EUR 33,968) through the issuance of one
thousand two hundred fifty (1,250) series B shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The new one thousand two hundred fifty (1,250) Series B Shares have been duly subscribed by Holtzbrinck, afore-
mentioned, for the subscription price of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250).
61548
L
U X E M B O U R G
<i>Paymenti>
The new one thousand two hundred fifty (1,250) Series B Shares subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, have
been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250).
The proof of the existence of the above contribution in cash has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250) is entirely allocated to the share
capital of the Company.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article five (5)
of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-three thousand nine hundred sixty-eight euro (EUR 33,968), repre-
sented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand seventy-one (6,071) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series A1 Shares”),
5.1.3 one thousand eight hundred seventy-five (1,875) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 four thousand five hundred fifty-four (4,554) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A3 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares collectively “Series A Shares”),
and
5.1.5 eight thousand nine hundred sixty-eight (8,968) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series B Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH (“TEC”), (v) SHCO 57 S.à r.l (“SHCO”), (vi) Leifina GmbH & Co
KG (“Leifina”) and (vii) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”; AIH, LIH, Aismare, TEC, SHCO, Leifina
and Holtzbrinck jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further
Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a
shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corpo-
ration Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party
Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders -required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO,
(vi) Leifina and Holtzbrinck shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been
notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO, (vi)
Leifina and/or (vii) Holtzbrinck intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this
Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”
<i>Fourth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the
articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Fifth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby grant power to any manager of the Company, regardless of his category,
as well as Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the
shareholders’ register of the Company.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 1,800.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
61549
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten Februar,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 177.038, mit Sitz in 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg („AIH“), Inhaberin von sechstausendeinundsiebzig (6.071) Stammanteilen, sechstausendeinundsiebzig
(6.071) Anteilen der Serie A1 und fünftausendvierhundertachtundsechzig (5.468) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht aus-
gestellt in Berlin, Deutschland, am 9 Februar 2015, und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 9 Februar 2015,
2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („MKC“),
Inhaberin von eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Stammanteilen und eintausendachthundertfünfundsiebzig
(1.875) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
9 Februar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland,
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000) („Aismare“),
Inhaberin von eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Stammanteilen und eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) An-
teilen der Serie A3,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
12 Februar 2015, ausgestellt in London,
4. TEC Global Invest VIII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 26060, mit Sitz in Wissoll-
straße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland („TEC“),
Inhaberin von eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Stammanteilen, eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteilen
der Serie A3 und eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
9 Februar 2015, ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland,
5. SHCO 57 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und be-
stehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsre-
gister unter der Nummer B183425, mit Sitz in 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg („SHCO“),
Inhaberin von eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Stammanteilen und eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) An-
teilen der Serie A3,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
9 Februar 2015, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
6. Leifina GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft bestehend unter deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz
in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer
HRA 80493, mit Geschäftssitz in Maximilianstr. 21, 80539 München, Deutschland („Leifina“),
Inhaberin von eintausend (1.000) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
10 Februar 2015, ausgestellt in München, Deutschland, und
7. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés)
unter der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),
zukünftige Inhaberin von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B,
61550
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
10 Februar 2015, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur pa-
raphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien unter 1., 2., 3., 4., 5. und 6. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Carmudi Global
S.à r.l. (die „Gesellschaft”), vormals Digital Services XXVI S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Lu-
xemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188487, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß einer
Urkunde des Notars Carlo Wersandt, welche am 17. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 2516 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde am 29. Januar 2015 gemäß einer Urkunde
der Notarin Cosita Delvaux geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffent-
licht wurde.
Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle
Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei Holtzbrinck ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung
teilnahme- und stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Aufnahme von HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, einer Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Groß-
herzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zweiunddreißigtausendsie-
benhundertachtzehn Euro (EUR 32.718) um einen Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) auf einen
Betrag von dreiunddreißigtausendneunhundertachtundsechzig Euro (EUR 33.968) durch die Ausgabe von eintausend-
zweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendneunhundertachtundsechzig Euro (EUR
33.968), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3
gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und
5.1.5 achttausendneunhundertachtundsechzig (8.968) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH („TEC“), (v) SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“),
(vi) Leifina GmbH & Co KG („Leifina“) und (vii) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“; AIH, LIH, Aismare,
TEC, SHCO, Leifina und Holtzbrinck gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer
Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Drit-
ten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat
zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem
oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft
vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines
Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO, (vi) Leifina und Holtzbrinck hat die
Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition eines
Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO, (vi) Leifina
61551
L
U X E M B O U R G
und/oder (vii) Holtzbrinck ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben
möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“
4. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Carmudi Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Artikel
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendneunhundertachtundsechzig Euro (EUR
33.968), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3
gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und
61552
L
U X E M B O U R G
5.1.5 achttausendneunhundertachtundsechzig (8.968) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH („TEC“), (v) SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“),
(vi) Leifina GmbH & Co KG („Leifina“) und (vii) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“; AIH, LIH, Aismare,
TEC, SHCO, Leifina und Holtzbrinck gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer
Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Drit-
ten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat
zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem
oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft
vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines
Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO, (vi) Leifina und Holtzbrinck hat die
Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition eines
Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO, (vi) Leifina
und/oder (vii) Holtzbrinck ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben
möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-
venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Über-
tragung von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Investor an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);
7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines
Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen
oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“)
Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder
des Unternehmens bezeichnen, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens als geschäftsführender
Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine
61553
L
U X E M B O U R G
vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Gesellschafter
dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung von Anteilen von Leifina an eine mit Leifina verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des Deutschen Aktiengesetzes und/oder an ein Unternehmen, deren letztendliche/r Eigentümer/in Dr. Kurt Schwarz,
die Ehefrau von Dr. Kurt Schwarz und/oder die Kinder von Dr. Kurt Schwarz sind, vorausgesetzt, dass (i) das erwerbende
Unternehmen alle Rechte und Pflichten aus der bestehenden Gesellschaftervereinbarung in ihrer letzten Fassung zwischen,
unter anderem, den Gesellschaftern der Gesellschaft, wahrnimmt und (ii) alle Rechtsnachfolger von Leifina zum Zwecke
der Bestimmung der Gesellschafter- oder Investorenmehrheit gemeinschaftlich als ein (1) Investor angesehen werden;
7.4.4 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang
mit einer Vesting-Regelung.
7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner weiteren
Zustimmung als der der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen
zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesell-
schafter.
7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis
gesetzt wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Ge-
sellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich,
wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen
Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer
Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeit-
licher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von
Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder
mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel 8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B pro Anteil einen Betrag von
EUR 2.000, vorausgesetzt, dass das Liquiditätsereignis eingetroffen ist.
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2
und Anteilen der Serie A3 pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse einen in der folgenden Tabelle neben der entsprechenden
vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteilsklasse vereinbarten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro Anteil
in Euro
Serie A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,06
Serie A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553,25
Serie A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.646.90
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen
Exiterlöse auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entspre-
chend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Investor auf der Ersten Ebene und/oder
Zweiten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Investor zu erhaltenden Betrag auf dieser Dritten Ebene,
mit der Maßgabe, dass kein Investor zur Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene und/oder Zweiten Ebene erhaltenen
Betrags verpflichtet ist. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach
in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen
Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein
Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen
und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten Ebene und/
oder Zweiten Ebene und/oder Dritten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin
festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
8.5 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Investors solange, wie
dieser den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß der Ersten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.
61554
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
61555
L
U X E M B O U R G
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche
in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.
Art. 17. Gesellschafterbeschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und
zudem die Zustimmung des Beirats:
17.1.1 Veräußerung des Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens, ein-
schließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
17.1.2 Änderung dieser Satzung, einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und
Umwandlung der Gesellschaft;
17.1.3 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-
cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;
17.1.4 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
61556
L
U X E M B O U R G
17.1.5 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung bestehender oder
die Ausgabe neuer Anteile) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die
andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag
der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, ein-
schließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abge-
schlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der
Gesellschaft und Werbepartnern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-
stimmung der Investoren:
17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
ihre Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
61557
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (der „Beirat“) für die untenstehenden Rechtsgeschäfte
und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert
und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:
22.8.1 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von fünfhun-
derttausend Euro (EUR 500.000,00) überschreiten;
22.8.3 Gewährung von Darlehen, die, im Einzelfall, einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00)
überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Toch-
tergesellschaften der Gesellschaft;
22.8.4 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,
einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, aller-
dings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der
Gesellschaft;
22.8.5 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-
aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.6 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
22.8.7 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
22.8.8 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-
wert von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00) im Einzelfall;
22.8.9 Weitergabe von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how von der Gesellschaft an Dritte außerhalb des
gewöhnlichen Geschäftsgangs;
22.8.10 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen,
wie in Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern dargelegt;
22.8.11 Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG)); und 22.8.12 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der
Gewährung jeglicher Anteilsoder Aktienoptionen) mit Ausnahme der Einführung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteili-
gung, die zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart
wurde.
61558
L
U X E M B O U R G
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-
lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet. Dieser besteht aus sechs (6) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-
sellschafter können die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats mit einstimmiger Zustimmung erhöhen oder
herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur mit einstimmiger Zustimmung festlegen und/
oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit sieben (7) Stimmen wird von dem Gesellschafter AIH nach
eigenem Ermessen ernannt;
25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter LIH nach
eigenem Ermessen ernannt;
25.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Aismare nach
eigenem Ermessen ernannt;
25.3.4 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter TEC nach
eigenem Ermessen ernannt; und 25.3.5 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem
Gesellschafter SHCO nach eigenem Ermessen ernannt.
25.3.6 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Holtzbrinck
nach eigenem Ermessen ernannt.
25.4 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Beirats ist das
Mitglied, welches von dem Gesellschafter ernannt wurde, welcher von der prozentualen Beteiligung her der größte der-
jenigen ist, welche zur Ernennung eines Beiratsmitglieds ermächtigt sind. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit
61559
L
U X E M B O U R G
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme, sofern
zu dem Zeitpunkt der jeweiligen Entscheidung derjenige Gesellschafter, der den Vorsitzenden ernannt hat, mehr als 50%
aller Anteile an der Gesellschaft hält. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass der stellvertretende Vorsitzende
nicht die entscheidende Stimme hat.
25.5 Ziel und Zuständigkeit des Beirats ist die Erteilung von Zustimmungen zu spezifischen Transaktionen der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft, welche gemäß (i) einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, (ii) dieser
Satzung, (iii) der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iv) der Geschäftsordnung für den Beirat oder (v) entsprech-
ender Gesellschafterbeschlüsse die Zustimmung des Beirats erfordern. Weitere Befugnisse und Zuständigkeiten können
dem Beirat durch einen Gesellschafterbeschluss übertragen werden. Neben diesen Zustimmungserfordernissen hat der
Beirat eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
25.6 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinnund Ver-
lustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
61560
L
U X E M B O U R G
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
5. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en com-
mandite simple) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou
Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
(Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft auf-
zunehmen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
zweiunddreißigtausendsiebenhundertachtzehn Euro (EUR 32.718) um einen Betrag von eintausendzweihundertfünfzig
Euro (EUR 1.250) auf einen Betrag von dreiunddreißigtausendneunhundertachtundsechzig Euro (EUR 33.968) durch die
Ausgabe von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die neuen eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Serie B wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck, vor-
benannt, zum Bezugspreis von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Holtzbrinck, vorbenannt, gezeichneten eintausendzweihundertfünfzig (1.250) neuen Anteile der Serie B wur-
den vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250).
Der Nachweis über die Existenz der oben bezeichneten Bareinlage wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel fünf (5) der Satzung der Ge-
sellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendneunhundertachtundsechzig Euro (EUR
33.968), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(die „Anteile der Serie A1“),
61561
L
U X E M B O U R G
5.1.3 eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3
gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und
5.1.5 achttausendneunhundertachtundsechzig (8.968) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH („TEC“), (v) SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“),
(vi) Leifina GmbH & Co KG („Leifina“) und (vii) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“; AIH, LIH, Aismare,
TEC, SHCO, Leifina und Holtzbrinck gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer
Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Drit-
ten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat
zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem
oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft
vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines
Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO, (vi) Leifina und Holtzbrinck hat die
Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition eines
Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO, (vi) Leifina
und/oder (vii) Holtzbrinck ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben
möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-
fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden
Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 1.800,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unter-
zeichnet worden.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2015. Relation: 1LAC/2015/5067. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 31. März 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015049042/1390.
(150056857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61562
L
U X E M B O U R G
Immo 7, Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 56.124.
L'an deux mille quinze, le vingt-cinq mars.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO 7, ayant son siège social à L-1510
Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 56124, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, le 9 septembre
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 589 du 13 novembre 1996, dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 20 mars 2002, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 970 du 26 juin 2002.
L'Assemblée est présidée par Madame Ivanka Dalmas de Polignac, demeurant à Paris.
Le président désigne comme secrétaire Madame Corinne Busciglio, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Treis, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que toutes les actions sont au porteur et sont inscrites dans un registre des actions auprès d'un dépositaire lu-
xembourgeois.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, et le notaire soussigné.
Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
III.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Conversion des titres au porteur en actions nominatives et modification afférente de l'article 3 des statuts.
2. Modification de l'article 4 des statuts.
3. Modification de l'article 6 des statuts.
4. Révocation de tous les membres du conseil d'administration et décharge.
5. Nomination d'un administrateur unique.
6. Divers.
Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de convertir les 800 (huit cents) titres au porteur sans valeur nominale, représentant la totalité du
capital social, en 800 (huit cents) actions nominatives sans valeur nominale de sorte que l'article 3 des statuts aura
désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-deux centimes
(198.314,82.- EUR) représenté par huit cents (800) actions sans désignation de valeur nominale.
Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au
cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société
n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.»
61563
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:
«Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs.
Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature indivi-
duelle de l'administrateur unique.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer tous les membres du conseil d'administration et de leur accorder pleine et entière
décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer un administrateur unique:
Madame Ivanka Dalmas de Polignac, administrateur de société, née à Belgrade, Serbie, le 18 mai 1932, demeurant à
F-75869 Paris Cedex 18, 8, rue des Cloys.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: I. DALMAS DE POLIGNAC, C. BUSCIGLIO, J. TREIS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 26 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9325. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049255/81.
(150056664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Schnetzer & Holzmoler Atelier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9154 Grosbous, 11, rue d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 175.491.
DISSOLUTION
L'an deux mil quinze, le treize mars.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
- Monsieur Carlo ETTELBRUCK, sculpteur, né à Luxembourg, le 29 avril 1956, demeurant à L-1324 Luxembourg, 18,
rue Jean Chalop,
Lequel comparant, a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter ce qui suit:
Que le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée «SCHNETZER & HOLZMOLER ATELIER
S.à r.l.» établie et ayant son siège social à L-9154 Grosbous, 11, rue d'Ettelbruck, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175.491 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître
Léon Thomas dit Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 février 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 948 du 20 avril 2013.
Que la Société a un capital social de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, entièrement libéré;
Que le comparant est le seul propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société en vertu des statuts tels que
publiés,
Ensuite le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a décidé de dissoudre la société «SCHNETZER &
HOLZMOLER ATELIER S.à r.l.», avec effet immédiat sans liquidation.
Qu'il déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et en connaître parfaitement la situation financière;
Que l'activité de la Société a cessé;
Que la Société ne possède pas d'immeuble ni de part(s) d'immeuble(s);
61564
L
U X E M B O U R G
En sa qualité de liquidateur de la Société, il déclare que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il
se trouve investi de tout l'actif et s'engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant éventuellement encore
exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société ou à tout autre
endroit à désigner par le comparant.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la Société.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état
et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ettelbruck, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8448. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049499/45.
(150056382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Scoubidou S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 183.162.
Par décision de l'administrateur unique du 24 mars 2015, Monsieur Alfred GUETTI, domicilié professionnellement au
8A, rue de Messancy, L-4962 CLEMENCY, a été coopté administrateur unique en remplacement de Monsieur Martin
RUTLEDGE, démissionnaire au 31 mars 2015.
Le mandat de l'administrateur unique s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2021.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour: SCOUBIDOU S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015049500/16.
(150056533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
SECURITEC Europe, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 127.124.
Les comptes annuels du 01/01/2014 au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049501/10.
(150056384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sekmet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 129.292.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mars 2015i>
- Monsieur Stéphane Cosco, employé privé, né le 5 juin 1976 à Villerupt (F) demeurant professionnellement au 3, Place
Dargent, L-1413 Luxembourg est nommé en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Pascal De Graeve,
démissionnaire,. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2019.
61565
L
U X E M B O U R G
Certifié sincère et conforme
SEKMET S.A.
Référence de publication: 2015049502/13.
(150056418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Selecta Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 77.466.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 septembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2015.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015049503/14.
(150056589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sestrice SA., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 76.753.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-
bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Signature
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015049505/13.
(150056752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Shay Properties Bury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 3.660.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 124.723.
EXTRAIT
La Société prends acte que le siège social de la société KPMG Luxembourg S.à r.l., Réviseur d'entreprises de la Société
est désormais au 39 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049506/13.
(150056651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Shay Property Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 63.704.600,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 122.773.
EXTRAIT
La Société prends acte que le siège social de la société KPMG Luxembourg S.à r.l., Réviseur d'entreprises de la Société
est désormais au 39 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
61566
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049507/13.
(150056650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
LIC Telecommunications S.à. r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SHCO 79 S.à. r.l.).
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 188.415.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of the month of March;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
The public limited company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “Louvrier
Investments Company 33 S.A.”, (formerly: “Luxembourg Investments Company 33 S.A.”), established and having its re-
gistered office in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, registered with the Trade and Companies Registry of
Luxembourg, section B, under number 193884,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne
varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.
Such appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:
- That the private limited liability company “SHCO 79 S.à r.l.”, established and having its registered office in L-1466
Luxembourg, 12, rue Jean Engling, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under
number 188415, (the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me Francis KESSELER, notary then
residing in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on July 3, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 2494 of September 16, 2014,
and that the articles of association (the “Articles”) have not been amended since;
- That the appearing party is the sole actual partner (the “Sole Partner”) of the Company and that it has taken, through
its Proxy-holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner resolves to change the corporate name into “LIC Telecommunications S.à r.l.” and to subsequently
amend article 4 of the Articles in order to give it the following wording:
“ Art. 4. The company will assume the name of “LIC Telecommunications S.à r.l.”, private limited liability company.”
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend at the Trade and Companies Registry of Luxembourg the corporate name and the address of
the Sole Partner as indicated here before.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred and fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with us the notary the present deed.
suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
61567
L
U X E M B O U R G
La société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “Louvrier Investments Com-
pany 33 S.A.”, (anciennement: “Luxembourg Investments Company 33 S.A.”), établie et ayant son siège social à L1466
Luxembourg, 12, rue Jean Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 193884,
ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-
xembourg, 12, rue Jean Engling, (le “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle
procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “SHCO 79 S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 12,
rue Jean Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 188412,
(la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire alors de résidence à Esch-sur-
Alzette (Grand-Duché de Luxembourg, le 3 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2494 du 16 septembre 2014,
et que les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors;
- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l’“Associé Unique”) de la Société et qu'elle a pris, par son
Mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société en “LIC Telecommunications S.à r.l.” et de modifier
subséquemment l'article 4 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 4. La société prend la dénomination de “LIC Telecommunications S.à r.l.”, société à responsabilité limitée.”
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de modifier auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg la dénomination sociale et
l'adresse du siège social de l'Associé Unique comme indiqué ci-avant.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 24 mars 2015. 2LAC/2015/6409. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
Référence de publication: 2015049508/90.
(150056213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
LIC Telecommunications S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 188.415.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
61568
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 27 mars 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015049509/14.
(150056236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
SHRM Corporate Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 78.100.
EXTRAIT
- Veuillez noter la démission avec effet au 12 mars 2015 de Bart Jan Willem d'Ancona, comme gérant de la société.
Le conseil de gérance se constitue donc avec effet au 12 mars 2015 de:
<i>Géranti>
- Michelle Marie Carvill
- Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Gentoo Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétési>
Référence de publication: 2015049510/17.
(150056901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
SHRM Corporate Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 78.100.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts du 12 février 2015, que M. Bart d'Ancona, ayant son adresse privée au 6
rue de Montagne, L-5234 Sandweiler, Luxembourg a cédé ses 60 parts sociales de la Société SHRM Corporate Services
S.à r.l. à M. Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, ayant son adresse professionnelle au 64 rue Principale, L-5367
Schuttrange, Luxembourg.
Suite à ce transfert, M. Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland détient les 100 parts sociales de la Société SHRM
Corporate Services S.à.r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Gentoo Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015049511/18.
(150056901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sigma Tau Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 52.948.
Par décision du Conseil d'Administration tenu le 23 mars 2015 au siège social de la société, il a été décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Dominique Audia de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat;
- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Benoît Dessy, résidant professionnellement 2-8 Ave-
nue Charles de Gaulle L-1015 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
61569
L
U X E M B O U R G
SIGMA TAU EUROPE S.A.
Société anonyme
Signatures
Référence de publication: 2015049512/15.
(150056609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Skans Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 144.628.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2015.
<i>Pour: SKANS HOLDING S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015049514/14.
(150056284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Société Européenne de Banque, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 13.859.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2015049515/12.
(150056619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Société Intercontinentale de Négoce S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 83.957.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 25 février 2015i>
<i>Première résolution:i>
Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Luc HANSEN en qualité d'administrateur de la société
et coopte à partir du 19 décembre 2014 Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, né le 23 septembre 1955 à Lu-
xembourg, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg. Son mandat prendra
fin lors de l'Assemblée Générale statutaire annuelle qui se tiendra en 2018
Cette décision sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société.
<i>Deuxième résolution:i>
Le Conseil d'Administration a décidé, à compter du 19 décembre 2014, de nommer Monsieur Gerdy ROOSE, conseiller
fiscal, né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée
Générale statutaire annuelle qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE INTERCONTINENTALE DE NEGOCE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015049516/22.
(150056411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61570
L
U X E M B O U R G
SOSTNT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.993.521,66.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 124.732.
In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of March, before Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of SOSTNT Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 124732 (the
Company). The Company was incorporated on 9 February 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No 769 of 3 May 2007. The
articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 30
December 2014 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
There appeared
1. SOS Holding, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at
89 Nexus Bay, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands (SOS Holding),
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch-
sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal; and
2. Thursday Holding, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office
at 89 Nexus Bay, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands (Thursday Holding),
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch-
sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.
Thursday Holding and SOS Holding are together referred to as the Shareholders.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Shareholders as well as by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration au-
thorities.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. The Shareholders hold all the 13,751,524 (thirteen million seven hundred and fifty-one thousand five hundred and
twenty-four shares of class A, 7,384,617 (seven million three hundred eighty-four thousand six hundred seventeen) shares
of class H, 374,829,847 (three hundred and seventy-four million eight hundred and twenty-nine thousand eight hundred
and forty-seven) shares of class α, 14,240,589 (fourteen million two hundred forty thousand five hundred and eighty-nine)
shares of class 1, 32,000,056 (thirty-two million fifty-six) shares of class 2, 57,661,932 (fifty-seven million six hundred
sixty-one thousand nine hundred thirty-two) shares of class 3, 90,208,209 (ninety million two hundred and eighth thousand
two hundred and nine) shares of class ASA, 50,000,000 (fifty million) shares of class RT and 30,011,000 (thirty million
eleven thousand) shares of class FTI, with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each in the share capital of the
Company.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. reduction of the share capital of the Company to bring the share capital from its current amount of EUR 6,700,876.74
(six million seven hundred thousand eight hundred and seventy-six Euro and seventy-four Cents) to EUR 5,993,521.66
(five million nine hundred ninety-three thousand five hundred twenty-one Euro and sixty-six Cents) by way of the re-
purchase from Thursday Holding of 47,800,067 (forty-seven million eight hundred thousand sixty-seven) shares of class
α2 (the Thursday Repurchased Shares) and the repurchase from SOS Holding of 22,935,441 (twenty-two million nine
hundred thirty-five thousand four hundred forty-one) shares of class α1 (the SOS Repurchased Shares, together with the
Thursday Repurchased Shares, the Repurchased Shares) in the share capital of the Company for an aggregate repurchase
price of EUR 707,355.08 (seven hundred seven thousand three hundred fifty-five Euro and eight Cents) and the subsequent
cancellation of all the Repurchased Shares;
3. subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital
reduction specified under item 2. above;
4. amendment of the share register of the Company in order to reflect the share capital reduction specified under
item 2. above, with power and authority given to any manager of the Company to proceed, under his/her sole signature,
on behalf of the Company with the registration of the repurchase and cancellation of the shares specified under item 2.
above; and
5. miscellaneous.
61571
L
U X E M B O U R G
The Meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notice, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting notes the terms of article 7 and 8 of the Articles. The Meeting acknowledges that the aggregate Intrinsic
Value (as defined in the Articles) of the Repurchased Shares is set at EUR 707,355.08 (seven hundred seven thousand
three hundred fifty-five Euro and eight Cents).
The Meeting resolves to reduce the subscribed capital by an amount of EUR 707,355.08 (seven hundred seven thousand
three hundred fifty-five Euro and eight Cents) and the subscribed capital shall therefore be brought from its present
amount of EUR 6,700,876.74 (six million seven hundred thousand eight hundred and seventy-six Euro and seventy-four
Cents) to EUR 5,993,521.66 (five million nine hundred ninety-three thousand five hundred twenty-one Euro and sixty-
six Cents) represented by 13,751,524 (thirteen million seven hundred and fifty-one thousand five hundred and twenty-
four shares of class A, with such Class A Shares being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of
3,620,280 (three million six hundred and twenty thousand two hundred and eighty) shares of sub-class 1 and 10,131,244
(ten million one hundred thirty-one thousand two hundred forty-four) shares of sub-class 2, 7,384,617 (seven million
three hundred eighty-four thousand six hundred seventeen) shares of class H, with such Class H Shares being further
sub-divided into two additional sub-classes consisting of 2,510,768 (two million five hundred ten thousand seven hundred
sixty-eight) shares of sub-class 1 and 4,873,849 (four million eight hundred seventy-three thousand eight hundred forty-
nine) shares of sub-class 2, 304,094,339 (three hundred four million ninety-four thousand three hundred thirty-nine)
shares of class α, with such Class α Shares being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 85,762,770
(eighty-five million seven hundred sixty-two thousand seven hundred seventy) shares of sub-class 1 and 218,331,569 (two
hundred eighteen million three hundred thirty-one thousand five hundred sixty-nine) shares of sub-class 2, 14,240,589
(fourteen million two hundred forty thousand five hundred eighty-nine) shares of class 1, 32,000,056 (thirty-two million
fifty-six) shares of class 2, 57,661,932 (fifty-seven million six hundred sixty-one thousand nine hundred thirty-two) shares
of class 3, 90,208,209 (ninety million two hundred and eighth thousand two hundred and nine) shares of class ASA being
further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 14,910,684 (fourteen million nine hundred and ten thou-
sand six hundred and eighty-four) shares of sub-class ASA1 and 75,297,525 (seventy-five million two hundred and ninety-
seven thousand five hundred and twenty-five) shares of sub-class ASA2, 50,000,000 (fifty million) shares of class RT, and
30,011,000 (thirty million eleven thousand) shares of class FTI, with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each
by way of the repurchase and the subsequent cancellation of all the Repurchased Shares held by Thursday Holding and
SOS Holding for an aggregate repurchase price of EUR 707,355.08 (seven hundred seven thousand three hundred fifty-
five Euro and eight Cent) (the Repurchase Price), which is equal to their aggregate Intrinsic Value.
SOS Holding, represented as stated above, (i) acknowledges, in connection with the repurchase of the Thursday
Repurchased Shares by the Company, that it has no repurchase right over the shares of class α1 held by it in connection
with the repurchase of the Thursday Repurchased Shares and (ii) declares, in connection with the repurchase of the SOS
Repurchased Shares by the Company, to accept the repurchase of the SOS Repurchased Shares for EUR 229,354.41 (two
hundred twenty-nine thousand three hundred fifty-four Euro and forty-one Cents) with immediate effect.
Thursday Holding, represented as stated above, (i) acknowledges, in connection with the repurchase of the SOS
Repurchased Shares by the Company, that it has no repurchase right over the shares of class α2 held by it in connection
with the repurchase of the SOS Repurchased Shares and (ii) declares, in connection with the repurchase of the Thursday
Repurchased Shares by the Company, to accept the repurchase of the Thursday Repurchased Shares for EUR 478,000.67
(four hundred seventy-eight thousand Euro and sixty-seven Cents) with immediate effect.
The Meeting resolves that the current article 4 of the Articles shall be amended, and will be amended accordingly in
order to reflect the above resolutions.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it shall
henceforth read as follows:
“ Art. 4. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 5,993,521.66 (five million nine hundred
ninety-three thousand five hundred twenty-one Euro and sixty-six Cent) represented by 13,751,524 (thirteen million
seven hundred and fifty-one thousand five hundred and twenty-four shares of class A (the Class A Shares), with such
Class A Shares being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 3,620,280 (three million six hundred
and twenty thousand two hundred and eighty) shares of sub-class 1 (Class A1 Shares) and 10,131,244 (ten million one
hundred thirty-one thousand two hundred forty-four) shares of subclass 2 (Class A2 Shares), 7,384,617 (seven million
three hundred eighty-four thousand six hundred seventeen) shares of class H (the Class H Shares), with such Class H
Shares being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 2,510,768 (two million five hundred ten
thousand seven hundred sixty-eight) shares of sub-class 1 (the Class H1 Shares) and 4,873,849 (four million eight hundred
61572
L
U X E M B O U R G
seventy-three thousand eight hundred forty-nine) shares of sub-class 2 (the Class H2 Shares), 304,094,339 (three hundred
four million ninety-four thousand three hundred thirty-nine) shares of class α (the Class α Shares), with such Class α Shares
being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 85,762,770 (eighty-five million seven hundred sixty-
two thousand seven hundred seventy) shares of sub-class 1 (the Class α1 Shares) and 218,331,569 (two hundred eighteen
million three hundred thirty-one thousand five hundred sixty-nine) shares of sub-class 2 (the Class α2 Shares), 14,240,589
(fourteen million two hundred forty thousand five hundred eighty-nine) shares of class 1 (the Class 1 Shares), 32,000,056
(thirty-two million fifty-six) shares of class 2 (the Class 2 Shares), 57,661,932 (fifty-seven million six hundred sixty-one
thousand nine hundred thirty-two) shares of class 3 (the Class 3 Shares), 90,208,209 (ninety million two hundred and
eighth thousand two hundred and nine) shares of class ASA (the Class ASA Shares) being further sub-divided into two
additional sub-classes consisting of 14,910,684 (fourteen million nine hundred and ten thousand six hundred and eighty-
four) shares of sub-class ASA1 (the Class ASA1 Shares) and 75,297,525 (seventy-five million two hundred and ninety-
seven thousand five hundred and twenty-five) shares of sub-class ASA2 (the Class ASA2 Shares), 50,000,000 (fifty million)
shares of class RT (the Class RT Shares), and 30,011,000 (thirty million eleven thousand) shares of class FTI (the Class
FTI Shares, and together with the Class A Shares, the Class H Shares, the Class α Shares, the Class 1 Shares, the Class 2
Shares, the Class 3 Shares, the Class ASA Shares, and the Class RT Shares, the Shares, and each individually a Share), each
Share having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent).”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to authorise and empower any manager of the Company to proceed on behalf of the Company
to the registration of the repurchase and cancellation of the Repurchased Shares, in the share register of the Company
and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication
of documents with the relevant Luxembourg authorities).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Esch/Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de mars, par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de SOSTNT Luxembourg S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124732 (la Société). La Société a été constituée
le 9 février 2007 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations - N. 769 du 3 mai 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés
plusieurs fois et pour la dernière fois en date du 30 décembre 2014 en vertu d'un acte du notaire instrumentaire, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Ont comparu
1. SOS Holding, une société de droit des Iles Caymans, ayant son siège social au 89, Nexus Bay, Camana Bay, Grand
Cayman KY1-9007, Iles Caymans (SOS Holding),
ci-après représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement
à Esch-Sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
2. Thursday Holding, une société de droit des Iles Caymans, ayant son siège social au 89, Nexus Bay, Camana Bay,
Grand Cayman KY1-9007, Iles Caymans (Thursday Holding),
ci-après représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement
à Esch-Sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Thursday Holding et SOS Holding sont collectivement désignés comme les Associés.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des Associés
ainsi que par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec ce dernier aux
formalités de l'enregistrement.
Les Associés ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent l'intégralité des 13.751.524 (treize millions sept cent cinquante-et-un mille cinq cent
vingt-quatre) parts sociales de classe A, 7.384.617 (sept millions trois cent quatre-vingt- quatre mille six cent dix-sept)
parts sociales de classe H, 374.829.847 (trois cent soixante-quatorze million huit cent vingt-neuf mille huit cent quarante-
sept) parts sociales de classe α 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-neuf) parts
sociales de classe 1, 32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) parts sociales de classe 2, 57.661.932 (cinquante-sept
61573
L
U X E M B O U R G
millions six cent soixante-et-un mille neuf cent trente-deux) parts sociales de classe 3, 90.208.209 (quatre-vingt-dix mil-
lions deux cent huit mille deux cent neuf) parts sociales de classe ASA et 50.000.000 (cinquante millions) parts sociales
de classe RT et 30.011.000 (trente million onze mille) part sociales de classe FTI, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR
(un centime d'euro) chacune dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Réduction du capital social de la Société afin de porter le capital social de son montant actuel de 6.700.876,74 EUR
(six millions sept cent mille huit cent soixante-seize euros et soixante-quatorze centimes d’euro) à un montant de
5.993.521,66 EUR (cinq millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt-et-un euros et soixante-six centimes
d’euro) au moyen du rachat par Thursday Holding de 47.800.067 (quarante-sept million huit cent mille soixante-sept)
parts sociales de classe α2 (les Parts Sociales Rachetées de Thursday) et du rachat par SOS Holding de 22.935.441 (vingt-
deux millions neuf cent trente-cinq mille quatre cent quarante-et-une) parts sociales de classe α1 (les Parts Sociales
Rachetées de SOS, collectivement désignées avec les Parts Sociales Rachetées de Thursday, les Parts Sociales Rachetées)
pour un prix total de rachat de 707.355,08 EUR (sept cent sept mille trois cent cinquante-cinq euros et huit centimes
d’euro) et annulation consécutive de l’ensemble des Parts Sociales Rachetées;
3. Modification consécutive de l'article 4 des statuts de la Société afin d'y refléter la réduction du capital social reprise
sous le point 2. ci-dessus;
4. Modification du registre de parts sociales de la Société afin de refléter la réduction du capital social reprise sous le
point 2. ci-dessus et pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société de procéder sous sa seule signature et pour
le compte de la Société à l'inscription et l’annulation des parts sociales reprises sous le point 2. ci-dessus; et
5. Divers.
L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l’Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les Associés représentés à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des dispositions des articles 7 et 8 des Statuts. L’Assemblée reconnaît que la Valeur Intrinsèque
totale (telle que définie dans les Statuts) des Parts Sociales Rachetées est établie à 707.355,08 EUR (sept cent sept mille
trois cent cinquante-cinq euros et huit centimes d’euro).
L’Assemblée décide de réduire le capital social souscrit de la Société d’un montant de 707.355,08 EUR (sept cent sept
mille trois cent cinquante-cinq euros et huit centimes d’euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de
6.700.876,74 EUR (six millions sept cent mille huit cent soixante-seize euros et soixante-quatorze centimes d’euro), à un
montant de 5.993.521,66 EUR (cinq millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt-et-un euros et soixante-
six centimes d’euro) représenté par 13.751.524 (treize millions sept cent cinquante-et-un mille cinq cent vingt-quatre)
parts sociales de classe A, lesdites Parts Sociales de Classe A étant elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes com-
posées de 3.620.280 (trois millions six cent vingt mille deux cent quatre-vingt) parts sociales de sous-classe 1 et 10.131.244
(dix millions cent trente-et-un mille deux cent quarante-quatre) parts sociales de sous-classe 2, 7.384.617 (sept millions
trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent dix-sept) parts sociales de classe H, lesdites Parts Sociales de Classe H étant
elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de 2.510.768 (deux millions cinq cent dix mille sept cent
soixante-huit) parts sociales de sous-classe 1 et 4.873.849 (quatre millions huit cent soixante-treize mille huit cent qua-
rante-neuf) parts sociales sous-classe 2, 304.094.339 (trois cent quatre millions quatre-vingt-quatorze mille trois cent
trente-neuf) parts sociales de classe α, elles-mêmes étant subdivisées en deux sous-classes composées de 85.762.770
(quatre-vingt-cinq millions sept cent soixante-deux mille sept cent soixante-dix) parts sociales de sous-classe 1 et en
218.331.569 (deux cent dix-huit millions trois cent trente et un mille cinq cent soixante-neuf) parts sociales de sous-classe
2, 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de classe 1,
32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) parts sociales de classe 2, 57.661.932 (cinquante-sept millions six cent
soixante-et-un mille neuf cent trente-deux) parts sociales de classe 3, et 90.208.209 (quatre-vingt-dix millions deux cent
huit mille deux cent neuf) parts sociales de classe ASA, elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de
14.910.684 (quatorze millions neuf cent dix mille six cent quatre-vingt-quatre) parts sociales de sous-classe ASA1, et
75.297.525 (soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-cinq) parts sociales de sous-
classe ASA2, 50.000.000 (cinquante millions) parts sociales RT et 30.011.000 (trente millions onze mille) parts sociales
FTI, ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) au moyen du rachat et de l’annulation consécutive
de toutes les Parts Sociales Rachetées détenues par Thursday Holding et SOS Holding, pour un prix de rachat total de
707.355,08 EUR (sept cent sept mille trois cent cinquante-cinq euros et huit centimes d’euro) (le Prix de Rachat), équi-
valant à la Valeur Intrinsèque totale.
SOS Holding, représenté comme indiqué ci-dessous, (i) reconnaît, concernant les Parts Sociales Rachetées de Thursday
par la Société, qu’elle n’a pas de droit de rachat sur les parts sociales de classe α1 détenues par elle en lien avec le rachat
61574
L
U X E M B O U R G
des Parts Sociales Rachetées de Thursday et (ii) déclare, concernant les Parts Sociales Rachetées de SOS par la Société,
accepter le rachat par la Société des Parts Sociales Rachetées de SOS pour un prix de EUR 229.354,41 (deux cent vingt-
neuf mille trois cent cinquante-quatre euros et quarante-et-un centimes d’euro) avec effet immédiat.
Thursday Holding, représenté comme indiqué ci-dessous, (i) reconnaît, concernant les Parts Sociales Rachetées de
SOS par la Société, qu’elle n’a pas de droit de rachat sur les parts sociales de classe α2 détenues par elle en lien avec le
rachat des Parts Sociales Rachetées de SOS et (ii) déclare, concernant les Parts Sociales Rachetées de Thursday par la
Société, accepter le rachat par la Société des Parts Sociales Rachetées de Thursday pour un prix de EUR 478.000,67
(quatre cent soixante-dix-huit mille euros et soixante-sept centimes d’euro) avec effet immédiat.
L’Assemblée décide que l’article 4 des Statuts dans sa version actuelle sera modifié de façon à refléter la résolution ci-
dessus.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts afin d'y refléter les résolutions ci-dessus, de sorte qu'il aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 4. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à 5.993.521,66 EUR (cinq millions neuf cent
quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt-et-un euros et soixante-six centimes d’euros) représenté par 13.751.524 (treize
millions sept cent cinquante-et-un mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A),
lesdites Parts Sociales de Classe A étant elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de 3.620.280 (trois
millions six cent vingt mille deux cent quatre-vingt) parts sociales de sous-classe 1 (les Parts Sociales de Classe A1) et
10.131.244 (dix millions cent trente-et-un mille deux cent quarante-quatre) parts sociales de sous-classe 2 (les Parts
Sociales de Classe A2), 7.384.617 (sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent dix-sept) parts sociales de
classe H (les Parts Sociales de Classe H), lesdites Parts Sociales de Classe H étant elles-mêmes subdivisées en deux sous-
classes composées de 2.510.768 (deux millions cinq cent dix mille sept cent soixante-huit) parts sociales de sous-classe
1 (les Parts Sociales de Classe H1) et 4.873.849 (quatre millions huit cent soixante-treize mille huit cent quarante-neuf)
parts sociales sous-classe 2 (les Parts Sociales de Classe H2), 304.094.339 (trois cent quatre millions quatre-vingt-quatorze
mille trois cent trente-neuf) parts sociales de classe α(les Parts Sociales de Classe α), elles-mêmes étant subdivisées en
deux sous-classes composées de 85.762.770 (quatre-vingt-cinq millions sept cent soixante-deux mille sept cent soixante-
dix) parts sociales de sous-classe 1 (les Parts Sociales de Classe α1) et en 218.331.569 (deux cent dix-huit millions trois
cent trente et un mille cinq cent soixante-neuf) parts sociales de sous-classe 2 (les Parts Sociales de Classe α2), 14.240.589
(quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de classe 1 (les Parts Sociales de
Classe 1), 32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) parts sociales de classe 2 (les Parts Sociales de Classe 2),
57.661.932 (cinquante-sept millions six cent soixante-et-un mille neuf cent trente-deux) parts sociales de classe 3 (les
Parts Sociales de Classe 3), et 90.208.209 (quatre-vingt-dix millions deux cent huit mille deux cent neuf) parts sociales
de classe ASA (les Parts Sociales de Classe ASA), elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de 14.910.684
(quatorze millions neuf cent dix mille six cent quatre-vingt-quatre) parts sociales de sous-classe ASA1 (les Parts Sociales
de Classe ASA1), et 75.297.525 (soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-cinq) parts
sociales de sous-classe ASA2 (les Parts Sociales de Classe ASA2) 50.000.000 (cinquante millions) parts sociales RT (les
Parts Sociales de Classe RT) et 30.011.000 (trente millions onze mille) parts sociales FTI (les Parts Sociales de Classe FTI,
et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales de Classe H, Parts Sociales de Classe α, Parts Sociales de
Classe 1, Parts Sociales de Classe 2, et les Parts Sociales de Classe 3, les Parts Sociales de Classe ASA et les Parts Sociales
de Classe RT les Parts Sociales, chacune individuellement une Part Sociale), ayant chacune une valeur nominale de 0,01
EUR (un centime d’euro).»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner pouvoir à et d’autoriser tout gérant de la Société à procéder pour le compte de la
Société, à l'inscription du rachat des Parts Sociales Rachetées dans le registre de parts sociales de la Société, et de pourvoir
à toutes les formalités y relatives (y compris, afin d'éviter tout doute, l'enregistrement et la publication des documents
auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus,
le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes,
en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé
ensemble avec le notaire instrumentaire l'original du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 mars 2015. Relation: EAC/2015/5935. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
61575
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015049520/291.
(150056659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Soyuz Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 116.702.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 31 mars 2015 que:
- La démission de M. Patrick MOINET, administrateur de classe B de la Société, avec effet au 13 février 2015 a été
acceptée.
- La personne suivante a été nommée administrateur de classe B de la Société, avec effet au 13 février 2015 et ce pour
une durée de six années:
* Mme Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049521/17.
(150056956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
SPEP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 174.474.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 25 février 2015i>
En date du 25 février 2015, l'Actionnaire Unique a décidé:
- de transférer le siège social de la Société SPEP S.àr.l. du 5 Rue de Kirchberg, 1858 Luxembourg au 41 Avenue de la
Liberté, 1931 Luxembourg avec effet au 25 février 2015.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour SPEP S.àr.l.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2015049522/14.
(150056876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
TyCom Holdings II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 75.098.
En date du 31 mars 2015, les mandats des administrateurs ainsi que le mandat de BDO Tax & Accounting ont été
renouvelés pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes clos au 25
septembre 2015.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TyCom Holdings II S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049537/14.
(150056858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Tafelberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 84.802.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
61576
L
U X E M B O U R G
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Nico Patteet/ K. Van Huynegem
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2015049538/13.
(150056625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
TE Connectivity Holding International I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 169.801.
Avec effet au 31 mars 2015, Mme Sarah Kouider Huot de Saint Albin, ayant comme adresse professionnelle le 17,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg a été nommée au conseil de gérance pour une durée
indéterminée.
Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Harold G. Barksdale,
- Juerg Frischknecht,
- Jürg Giraudi,
- Thomas Ernst,
- Fabienne Roger-Eck
- Sarah Kouider Huot de Saint Albin, et
- Magnus Svensson.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TE Connectivity Holding International I S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015049539/23.
(150056701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Tele 2 Europe S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Capital social: EUR 1.045.515.750,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 56.944.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue le 27 mars 2015i>
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 27 mars 2015, il a été résolu ce qui suit:
- De renouveler les mandats des administrateurs suivant jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se pro-
noncer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2015, soit en 2016:
* Monsieur Francesco D'Angelo, demeurant à 40, rue de Rollingergrund, L 2440 Luxembourg;
* Madame Allison Kirkby demeurant à Eastmansvagen 8b, 113 61 Stockholm, Suède;
* Madame Åsa Bladin demeurant à Östermalmsgatan 97, 114 59 Stockholm, Suède.
- De renouveler les mandats des AUXILIAIRE DES P.M.E. Société Anonyme, R.C.S. Luxembourg N° B 30718, 58, rue
Glesener, L - 1630 Luxembourg, en tant que Commissaire-aux-Comptes. Son mandat se terminera lors de l'assemblée
générale des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2015, soit en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
Francesco D'Angelo.
Référence de publication: 2015049540/20.
(150056424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61577
L
U X E M B O U R G
The Sixth Belfry Properties (UK) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 120.807.
RECTIFICATIF
B120.807 - L 140229092
Ce dépôt remplace la précédente version déposée en date du 22 décembre 2014
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2015.
Référence de publication: 2015049543/13.
(150056283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Themis Realty Italy, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 193.049.
L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE QUATRE MARS.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée "THEMIS REALTY ITALY",
ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 232 rue de Beggen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 27 novembre 2014, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 193.049, acte publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 177, page 8468 du 22 janvier 2015.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31.000 (trente et
un mille) actions d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, toutes entièrement libérées.
L'assemblée est présidée par Monsieur Antoine Delissnyder, employé privé, demeurant professionnellement au 232,
rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, employé, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Antoine Delissnyder Luxembourg prénommé.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital souscrit de EUR 2.000,- (deux mille euros) pour augmenter le capital souscrit de son
montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) par l’émission de
2.000 (deux mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, à libérer intégralement par un
apport en numéraire.
2. Approbation de la souscription des 2.000 (deux mille) actions nouvelles comme suit:
- THEMIS REALTY EUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 actions
3. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros), représenté par 33.000 (trente-trois mille) actions
d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.»
4. Divers
II) Le nom des actionnaires, le nombre d’actions détenues par chacun d’eux et le nom de leur mandataire sont ren-
seignés sur une liste de présence, laquelle, signée par le mandataire des actionnaires représentés, par les membres du
bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, resteront aussi annexées au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée
générale extraordinaire.
IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
tous les points de l’ordre du jour.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont toutes été prises
à l’unanimité des voix.
61578
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.000,- (deux mille euros)
pour augmenter le capital souscrit de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 33.000,-
(trente-trois mille euros) par l’émission de 2.000 (deux mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,- (un
euro) chacune bénéficiant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, tel que prévu par les Statuts, à
émettre contre payement en numéraire.
<i>Souscription - Libérationi>
L’assemblée approuve la souscription des 2.000 (deux mille) actions nouvelles par l’actionnaire actuel
THEMIS REALTY EUROPE, société anonyme de droit luxembourgeois, sise au 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 134.999, qui déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société
"THEMIS REALTY ITALY", et a déclaré souscrire à concurrence de 2.000 (deux mille) actions nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 1,- (un euro) par action, au moyen d’un apport en numéraire de EUR 2.000,- (deux mille euros).
L’Assemblée constate que le montant total de EUR 2.000,- (deux mille euros) se trouve à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires, suite à la résolution qui précède, décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des
statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros), représenté par 33.000 (trente-trois mille) actions
d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.»
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,
suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 1.300,-.
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en têtes des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de la notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: A. DELISSNYDER, B. TASSIGNY, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6826. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015049544/78.
(150056909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
THEOLIA Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 163.192.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 30 mars 2015 que:
- La démission de Monsieur Patrick MOINET, gérant de la Société, avec effet au 13 février 2015, a été acceptée; et
- Madame Katia CAMBON, née le 24 mai 1972 à Le Raincy, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg, a été nommée gérant de la Société avec effet au 13 février 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049545/16.
(150056593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61579
L
U X E M B O U R G
Thiel AS Logistics A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 75.394.
AUSZUG
Herr Dr. Karl-Heinz Kramer hat sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit Wirkung zum 31.
März 2015 niedergelegt.
Es geht aus dem schriftlichen Beschluss der alleinigen Aktionärin der Gesellschaft vom 19. März 2015 hervor, dass
Herr Sebastian Esser, geboren am 13. April 1974 in Köln, Deutschland, geschäftsansässig in Weicherstrasse 5, 63741
Aschaffenburg, Deutschland, mit Wirkung zum 1. April 2015, bis zur Generalversammlung die im Jahr 2015 stattfinden
wird als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, den 19. März 2015.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschriften
Référence de publication: 2015049546/18.
(150056530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
TLW Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 132.546.
EXTRAIT
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société TLW Investment S.A., qui s'est tenue
au siège social de la société le 30 mars 2015 que:
- La société transfert son siège social au 20, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour TLW Investment S.A
i>LPL Expert-Comptable Sàrl
Référence de publication: 2015049548/15.
(150056437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
TVX Amalco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 184.242.
EXTRAIT
La Société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Mauro Ostwald, gérant de la Société, comme suit:
Laan van Roos en Doorn 29B
2514BC Den Haag
Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049553/15.
(150056670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61580
L
U X E M B O U R G
TVX Mining Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 184.164.
EXTRAIT
La Société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Mauro Ostwald, gérant de la Société, comme suit:
Laan van Roos en Doorn 29B
2514BC Den Haag
Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049554/15.
(150056669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
ULT (Union Luxembourgeoise du Tourisme) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 3, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 145.806.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015049558/10.
(150056678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
UNA S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 166.810.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2015i>
1. L'Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes, de Monsieur Gerard Alexander VAN
HUNEN employé privé, avec adresse professionnelle au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
2. L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, Monsieur Peter VAN OPSTAL,
employé privé, avec adresse professionnelle au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.
3. L'Assemblée renouvelle les mandats des commissaires aux comptes de
- Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,
- Monsieur Pieter Adriaan Cornelis Simon VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle
40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,
Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui se tiendra en 2020.
Luxembourg, le 25 mars 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049559/20.
(150056732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Sogepar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 40.763.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049517/9.
(150056343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61581
L
U X E M B O U R G
Solutio Premium Private Equity VI Master SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 195.764.
STATUTES
<i>Extrait de l'acte constitutif conformément à l'article 6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiéei>
Name of the Partnership
SOLUTIO PREMIUM Private Equity VI Master SCSp
Form of the Partnership
Special Limited Partnership (société en commandite spéciale)
Registered office
47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Name of the shareholders with
joint and several liability
PREMIUM Private Equity VI General Partner S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), whose registered office is at 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of
EUR 12,500.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
(Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 195676.
Purpose of the Partnership
The corporate object and purpose of the Partnership is to carry on the business of
an investor and, in particular, of identifying, negotiating, making, monitoring and
realising investments and to carry out all connected functions and acts. The business
of the Partnership shall be carried on with a view to producing profits for distribution
in accordance with the limited partnership agreement. Subject to the terms of the
limited partnership agreement, the Partnership may execute, deliver and perform all
contracts and other undertakings and engage in all activities and transactions as may
in the opinion of the general partner be necessary or advisable in order to carry out
the foregoing purposes and objectives.
Name of the general partner
PREMIUM Private Equity VI General Partner S.à r.l.
Management power and
representative capacity of the
general partner
The General Partner shall have full power and authority to conduct the on going
administration of the Partnership as well to manage the Partnership pursuant to the
limited partnership agreement and the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended from time to time, to the extent that such responsibilities
have not been allocated to other Partners in accordance with this Agreement. In
particular, the General Partner is exclusively responsible for:
(a) the acceptance of applications to the Partnership from prospective investors and
to admit such persons as limited partners by accepting on behalf of the Partnership
a duly executed form of adherence;
(b) decisions on investment and divestment strategies;
(c) decisions on the proposed acquisition of an investment, including any and all
decisions on the amount of the investment or the type and financing of such
investment;
(d) decisions on any proposed disposal of an investment;
(e) decisions on any transfers of interests by limited partners pursuant to clause 6;
and
(f) investor relations.
Commencement date
20 March 2015
Terminate Date
The Partnership is established for an unlimited period of time.
The SOLUTIO PREMIUM Private Equity VI Master SCSp partnership agreement extract has been drawn up in English
and is followed by a French translation, in case of discrepancies between the English and French version, the English
version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
Dénomination sociale
SOLUTIO PREMIUM Private Equity VI Master SCS
Forme légale
société en commandite spéciale
Siège social
47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Nom des associés solidaires
(associé gérant commandité)
PREMIUM Private Equity VI General Partner S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, dont le siège social est au 49, Avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195676.
Objet social
L'objet social de la Société est d'exercer les activités d'un investisseur et,
particulièrement, d'identifier, négocier, effectuer, surveiller et réaliser des
61582
L
U X E M B O U R G
investissements et d'accomplir toute fonction et action connexe. Les activités de la
Société doivent être gérées dans le but de générer des profits qui pourront être
distribués en conformité avec les dispositions de l'acte constitutif. La Société pourra,
sous réserve des dispositions de l'acte constitutif, exécuter, produire et mettre en
oeuvre toute convention et tout autre engagement, et prendre part à toute activité
et opération que l'associé gérant commandité estime nécessaire ou recommandable
afin de mener à bien les buts et objectifs qui précèdent.
Nom du gérant
PREMIUM Private Equity VI General Partner S.à r.l.
Pouvoir de signature du gérant L'associé gérant commandité doit avoir les pleins pouvoirs et posséder l'autorité
compétente afin de mener à bien l'administration de la Société ainsi que la gestion
de la Société selon les dispositions de l'acte constitutif ainsi que de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, dans la mesure où de telles
responsabilités n'ont pas été allouées à d'autres associés selon les dispositions de
l'acte constitutif. L'associé gérant commandité sera exclusivement responsable, en
particulier:
(a) de l'acceptation de demandes de souscription d'investisseurs potentiels dans la
Société et l'admission de telles personnes en tant qu'associés commanditaires en
acceptant au nom de la Société un formulaire de souscription;
(b) des décisions concernant les investissements et la stratégie de désinvestissement;
(c) des décisions sur les acquisitions d'investissement potentielles, y compris toutes
décisions portant sur les montants de l'investissement, ou du type et le financement
de tel investissement;
(d) des décisions portant sur toute cession proposée d'un investissement;
(e) des décisions portant sur tout transfert d'intérêts par des associés
commanditaires conformément à la clause 6 de l'acte constitutif; et
(f) des relations avec les investisseurs.
Date de commencement
Le 20 mars 2015
Date de fin
La Société a été établie pour une durée indéterminée.
L'extrait de l'acte constitutif de SOLUTIO PREMIUM Private Equity VI Master SCSp a été rédigé en langue anglaise et
suivi d'une traduction en langue française, en cas de différence entre la version anglaise et la version française, la version
anglaise fera foi.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049518/92.
(150056828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Green Consult Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8821 Rambrouch, Zone Industrielle Riesenhaff.
R.C.S. Luxembourg B 75.470.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049202/9.
(150056229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
CNH Industrial Europe Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 71.335.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049082/9.
(150056634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61583
L
U X E M B O U R G
Argan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 185.662.
<i>Cession de parts socialesi>
Suite au contrat de cession de parts sociales signé en date du 24 mars 2015, 12.500 (douze mille cinq cent) parts
sociales d'une valeur nominal de EUR 1,- (un euro) de la société Argan S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B- 185662, ayant
son siège social au 412F, route d'Esch, L- 1471 Luxembourg, ont été cédées
de
ICG Recovery 2, 2008 S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B- 141383, ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L- 2633 Senningerberg.
à
ICG EF 2006 ELP 2 LP, société de droit anglais, enregistrée sous le numéro LP15797, ayant son siège social au Juxon
House, 100 St Paul's Churchyard, EC4M 8BU Londres, Royaume-Uni
ICG RF 2008 ELP 2 LP, société de droit anglais, enregistrée sous le numéro LP15799, ayant son siège social au Juxon
House, 100 St Paul's Churchyard, EC4M 8BU Londres, Royaume-Uni
Intermediate Capital Group PLC, société de droit anglais, enregistrée sous le numéro 2234775, ayant son siège social
au Juxon House, 100 St Paul's Churchyard, EC4M 8BU, Londres, Royaume-Uni
Intermediate Finance II PLC, société de droit anglais, enregistrée sous le numéro 6015791, ayant son siège social au
Juxon House, 100 St Paul's Churchyard, EC4M 8BU, Londres, Royaume-Uni
Dès lors, la répartition des parts sociales de la société Agan S.à r.l. se présente comme suit:
Associé
Parts
sociales
ICG EF 2006 ELP 2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 000
ICG RF 2008 ELP 2 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 000
Intermediate Capital Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 666
Intermediate Finance II PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
834
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 31 mars 2015.
Certifié sincère et conforme
Argan S.à r.l.
Référence de publication: 2015048950/36.
(150056839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Prominvest S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 183.187.
Par décision de l'administrateur unique du 24 mars 2015, Monsieur Alfred GUETTI, domicilié professionnellement au
8A, rue de Messancy, L-4962 CLEMENCY, a été coopté administrateur unique en remplacement de Monsieur Martin
RUTLEDGE, démissionnaire au 31 mars 2015.
Le mandat de l'administrateur unique s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2021.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour: PROMINVEST S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015049427/16.
(150056535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
61584
Argan S.à r.l.
Carmudi Global S.à r.l.
Castello (Lux) Holdings S.à.r.l.
CNH Industrial Europe Holding S.A.
Green Consult Luxembourg S.A.
Immo 7
LIC Telecommunications S.à. r.l.
LIC Telecommunications S.à. r.l.
Prominvest S.A. SPF
Schnetzer & Holzmoler Atelier S.à r.l.
Scoubidou S.A. SPF
SECURITEC Europe
Sekmet S.A.
Selecta Luxembourg
Sestrice SA.
Shay Properties Bury S.à r.l.
Shay Property Investments S.à r.l.
SHCO 79 S.à. r.l.
SHRM Corporate Services S.à r.l.
SHRM Corporate Services S.à r.l.
Sigma Tau Europe S.A.
Skans Holding S.à r.l.
Société Européenne de Banque
Société Intercontinentale de Négoce S.A.
Sogepar S.à r.l.
Solutio Premium Private Equity VI Master SCSp
SOSTNT Luxembourg S.à r.l.
Soyuz Holding S.A.
SPEP S.à r.l.
Tafelberg S.A.
TE Connectivity Holding International I S.à r.l.
Tele 2 Europe S.A.
Themis Realty Italy
THEOLIA Management Company S.à r.l.
The Sixth Belfry Properties (UK) S.A.
Thiel AS Logistics A.G.
TLW Investment S.A.
TVX Amalco S.à r.l.
TVX Mining Properties S.à r.l.
TyCom Holdings II S.A.
ULT (Union Luxembourgeoise du Tourisme) S.à r.l.
UNA S.C.A.