This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1220
11 mai 2015
SOMMAIRE
1000.lu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58545
Accenture International Capital SCA . . . .
58515
Advanced Capital Holdings (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58517
Alacer Gold Corp. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
58514
Alacer Gold Holdings Corp. S.à r.l. . . . . . .
58515
Ampere Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
58515
ANFA II S.C.Sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58560
Apex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58516
Arachy Private S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
58517
Atelier d'Architecture din @ 3 Muller & Si-
mon S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58522
Athena Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . .
58515
BEOOGO S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58525
Bib-Be in Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58526
Brand France S.A.S. succursale Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58521
Cavim S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58514
CID Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58522
Cloud Managed Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58522
COF III Holdings (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . .
58528
Croc'Time S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58521
Den Holzwuerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58515
Erste Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
58560
Gleinor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58520
Hairdreams by M.H. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
58559
Hansainvest Lux Umbrella . . . . . . . . . . . . . .
58526
HeritageWealth SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . .
58546
Heritam SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58546
ISOLA Développement . . . . . . . . . . . . . . . . .
58524
KBK Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58524
L.A. Productions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58516
LBPAM European Debt Funds . . . . . . . . . . .
58519
Lennox Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
58519
Mabel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58518
Metec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58528
Real Estate Development 2015 S.à r.l. . . .
58533
Rehoss S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58523
Starmaker S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58523
Suco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58514
The Next Big Thing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
58514
Triton Luxembourg II GP Anton S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58514
UniAbsoluterErtrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58525
UniAbsoluterErtrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58525
YG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58523
Zolpan-Selco SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58522
58513
L
U X E M B O U R G
Cavim S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 130.785.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015047654/9.
(150055175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
Alacer Gold Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 174.377.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
Référence de publication: 2015047543/10.
(150054943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
Suco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 19.755.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015047416/10.
(150054096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Triton Luxembourg II GP Anton S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 179.539.
Les statuts coordonnés au 6 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015047431/11.
(150053660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
The Next Big Thing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 174.851.
La société prend acte et accepte la démission des gérants suivants:
Marcia Dyann Kilgore, gérant de catégorie B, nommée pour une durée indéterminée depuis le 31 Décembre 2012.
Thierry Paul Maurice Boue, gérant de catégorie B, nommé pour une durée indéterminée depuis le 31 Décembre 2012.
Joseph de Raaij, nommé pour une durée indéterminée depuis le 31 Décembre 2012 en qualité de gérant de catégorie
A, réside désormais professionnellement au 16 rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015047427/14.
(150053805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
58514
L
U X E M B O U R G
Ampere Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 186.920.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015047559/9.
(150055118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
Alacer Gold Holdings Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 174.136.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
Référence de publication: 2015047544/10.
(150054946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
Accenture International Capital SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 84.849.
Les comptes annuels au 31 août 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015047524/10.
(150055128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
Athena Private Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38-40, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 76.053.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Athena Private Equity S.A.
i>Fideco S.A.
Référence de publication: 2015047567/12.
(150054963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
Den Holzwuerm, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4563 Niederkorn, 1, Z.A.C. Haneboesch II.
R.C.S. Luxembourg B 115.412.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM Sàrl
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2015047689/13.
(150055059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
58515
L
U X E M B O U R G
Apex S.A., Société Anonyme,
(anc. L.A. Productions).
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 56.744.
L'an deux mille quinze, le dix-huit mars,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «L.A. PRODUCTIONS», une société anonyme de
droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.744, constituée suivant acte notarié en date du 14 octobre 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 janvier 1997, numéro 20.
Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, rési-
dant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Flora GIBERT, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Lu-
xembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc MOLITOR, administrateur de société, demeurant à L-2240
Luxembourg, 34, rue Notre-Dame.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination en «Apex S.A.» et modification subséquente de l'article 1
er
des statuts de la société;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion du capital social en euros et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts
de la société;
4. Suppression du dernier paragraphe de l'article 9 des statuts de la société;
5. Modification du deuxième paragraphe de l'article 13 des statuts de la société;
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société en «Apex S.A.» et par conséquent de modifier
le premier article des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Apex S.A.».»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de convertir le capital social en euros et par conséquent de modifier le premier paragraphe
de l'article 5 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 5. (premier paragraphe). Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation d'une valeur nominale.»
58516
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer le dernier paragraphe de l'article 9 des statuts de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 13 des statuts de la société pour lui donner
désormais la teneur suivante:
« Art. 13. (deuxième paragraphe). Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire
ou non.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, M. MOLITOR et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 20 mars 2015. 1LAC/2015/8735. Reçu soixante-quinze euros. €75,-
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 25 mars 2015.
Référence de publication: 2015047156/71.
(150053515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Advanced Capital Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.300.
EXTRAIT
En date du 24 mars 2015, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Asa Alund comme gérant de la société avec effet au 29 août 2014;
- Nomination de Peter Lundin, né le 10 septembre 1976 à Kalmar (Suède), demeurant professionnellement au 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, comme nouveau gérant de la société avec effet au 1
er
septembre 2014 et ce pour
une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015046214/15.
(150053271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Arachy Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 161.694.
Par décision du conseil d'administration du 11 février 2015: KOFFOUR S.A., R.C.S. Luxembourg B-86086, 42 rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour son compte au conseil d'administration de la société ARACHY PRIVATE S.A. SPF, Monsieur Anouar BELLI, 42
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, avec effet au 10 février 2015 en remplacement de Monsieur Raphaël EBER, démis-
sionnaire au 9 février 2015.
Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
<i>Pour: ARACHY PRIVATE S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015047588/18.
(150055039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
58517
L
U X E M B O U R G
Mabel 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9952 Drinklange, 26, Elwenterstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 165.216.
L'an deux mil quinze, le dix mars.
Par-devant, Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
A comparu:
Monsieur Francis MASSIN, gérant de sociétés, né le 7 décembre 1954 à Auderghem (B), demeurant à L-9952 Drin-
klange, 26, Elwenterstrooss;
Lequel comparant a exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée MABEL a été constituée sous la législation belge suivant acte reçu le 27 octobre
1999 par devant le Notaire Jean VAN DER WIELEN, de résidence à Bassenge (B)
- que la société a pris la nationalité luxembourgeoise aux termes d'un acte reçu le 17 octobre 2011 par le notaire Anja
Holtz, alors de résidence à Wiltz, publié au Mémorial C des sociétés et associations le 17 janvier 2012 numéro 134
- qu’elle a adopté sa dénomination actuelle MABEL2 suivant un acte passé par devant le même notaire le 28 novembre
2011 publié au Mémorial C des sociétés et associations le 18 janvier 2012 numéro 150
- qu'elle est enregistrée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 165.216 et qu’elle a son siège à
L-9952 Drinklange, 26, Elwenterstrooss;
- qu'elle a un capital de dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-douze virgule zéro un euros mille cinq cents euros
(18.592,01-€) divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf euros (24,79-
€) chacune,
- que le comparant est le seul associé représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée «MA-
BEL2» suivant cession de parts du 23 novembre 2013 inscrite au registre des porteurs de parts, dont une copie est
annexée aux présentes pour être enregistrée avec le présent acte après avoir été signée «ne varietur» par le comparant
et le notaire instrumentaire;
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les constatations et résolutions suivantes, prises en as-
semblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît comme dûment convoqué.
<i>Première résolutioni>
L’associé décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 4. La société a pour objet
- La fourniture de prestations de services ainsi que toute assistance sur le plan administratif et de management, à
l'exclusion de travaux de comptabilité et d'activités régies par la loi relative au secteur financier;
- La société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée;
La société a aussi pour objet:
- La promotion, la location, l'achat, la vente, l'échange, l'exploitation, la gestion, la mise en valeur de tous immeubles,
pour son compte propre, l'organisation de manifestations ou d'évènements de tous types, notamment de régates, tra-
versées, sports nautiques et formations,
- l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous-location,
le tout avec ou sans option d'achat, l'entretient et l'exploitation de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de
commerce, terrains, terres, navires, bateaux et de manière générale, de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que
toutes opérations de financement
- la conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution,
l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissaire ou de courtier, de tout bien immobilier
accessoires aux biens immobiliers et mobiliers visés ci-avant, de tous véhicules en ce compris les navires, bateaux, engins
et équipements nautiques, matériels de sports nautiques et de tous les accessoires
Elle a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours.
En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-
lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réalisation
et le développement.»
58518
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de compléter l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège social de la société est établi à Drinklange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou tout autre pays de la communauté
européenne par décision unanime des associés.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est close.
<i>Déclaration du comparanti>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Le montant des frais dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes, est évalué à environ huit cent cinquante euros (850,00 €).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et
demeures, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Francis MASSIN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 12 mars 2015. Relation: DAC/2015/4219. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 26 mars 2015.
Référence de publication: 2015047226/81.
(150053843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Lennox Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 168.606.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2015.
<i>Pour compte de Lennox Consulting S.A.
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2015047161/12.
(150053792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
LBPAM European Debt Funds, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 176.209.
En date du 17 décembre 2014, Madame Valérie Cluzel, née le 18 novembre 1975 à Lillebonne, France, ayant comme
adresse professionnelle: 34, rue de la Fédération, 75737 Paris, France, a remplacé Monsieur Philippe De Troullioud de
Lanversin en tant que nouveau représentant permanent de l'administrateur de catégorie B, La Banque Postale Asset
Management, avec effet au 17 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
LBPAM European Debt Funds
Signature
Référence de publication: 2015047175/15.
(150054268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
58519
L
U X E M B O U R G
Gleinor Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 99.755.
L'an deux mil quinze, le seize mars.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLEINOR HOLDING S.A., ci-après
«la Société», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 99755, constituée en date du 23 mars 2004 suivant acte
reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 499 du 12 mai 2004. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier
lieu le 27 décembre 2010 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 666 du 7 avril 2011.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Umberto CERASI, licencié en droit, avec adresse profes-
sionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Madame Suet Sum WONG, juriste, avec adresse professionnelle au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, avec adresse professionnelle
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Modification du 2
ème
alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Les actions sont et resteront nominatives.»
2. Décision de fixer une nouvelle date d'échéance du capital autorisé et de renouveler, pour une période de 5 ans et
dans les mêmes termes et conditions que ceux fixés en date du 27 décembre 2010, l'autorisation qui avait été conférée
au conseil d'administration de porter le capital à EUR 1.000.000.
3. Modification de la 1
ère
phrase du 6
ème
alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le ... mars 2020, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d'actions nouvelles.»
II. Le nom de l'actionnaire unique, le nombre d'actions qu'il détient et le nom de son mandataire sont renseignés sur
une liste de présence. Cette liste et la procuration de l'actionnaire unique représenté, une fois signées par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
III. Il résulte de la liste de présence que les 7.000 (sept mille) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont
dûment représentées à la présente assemblée.
IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le 2
ème
alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Les actions sont et resteront nominatives.».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer une nouvelle date d'échéance du capital autorisé et de renouveler, pour une période de
5 ans prenant fin le 16 mars 2020, dans les mêmes termes et conditions que ceux fixés en date du 27 décembre 2010,
l'autorisation qui avait été conférée au conseil d'administration de porter le capital à EUR 1.000.000 (un million d'euros).
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier la 1ère phrase du 6
ème
alinéa de l'article 5 des statuts
pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 16 mars 2020, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d'actions nouvelles.»
58520
L
U X E M B O U R G
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec
Nous, notaire, la présente minute.
Signé: U. CERASI, S. S. WONG, C. GRUNDHEBER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/5709. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société;
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Référence de publication: 2015045811/68.
(150052497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Croc'Time S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 83.757.
- La société INTERNATIONAL NET, ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O.Box N-529,
Nassau Bahamas, IBC numéro 71055.
démission de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société:
Croc'Time S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 83.757.
29, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Philippe GAIN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015045669/16.
(150052385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Brand France S.A.S. succursale Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.
R.C.S. Luxembourg B 128.486.
EXTRAIT
Le président de Brand France S.A.S. a pris les décisions suivantes en date du 15 mars 2015:
1) La description des activités de la succursale a été modifiée comme suit:
«Prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou industrielles, tous placements de capitaux sous toutes
formes, vente, location avec ou sans prestation, entretien, réparation d'échafaudages, étaiement, coffrage, appareils élé-
vateurs et tous matériels pour les entreprises de bâtiment ou de travaux publics ou privés, acquisition, exploitation ou
cession de tous procédés ou brevets concernant ces activités, travaux d'échafaudage et d'isolation pour l'industrie et tous
travaux ou prestations dans le milieu industriel, calorifugeage et ignifugeage.»
2) M. Stéphane Bitschy, représentant permanent de la succursale, a démissionné et a été remplacé par M. Roger Brun,
né le 13 mai 1963 à Lyon IV, France, demeurant au 3, allée Jean Chorel, F-69580 Sathonay Village, France, avec effet au
4 septembre 2014, pour une durée indéterminée.
3) Le pouvoir de signature du représentant permanent de la succursale a été modifié comme suit:
«La succursale est engagée par la signature individuelle de M. Stéphane Schmidt ou, le cas échéant, la signature conjointe
du représentant permanent de la succursale ensemble avec la signature de M. Stéphane Alain Boivin, Directeur Admi-
nistratif et Financier Régional de la Société.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Référence de publication: 2015044908/24.
(150051315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
58521
L
U X E M B O U R G
Atelier d'Architecture din @ 3 Muller & Simon S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 13, allée de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 82.262.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015047592/9.
(150054725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
Zolpan-Selco SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 33.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015047493/10.
(150054202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Cloud Managed Data, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 140.240.
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire en date du 27/10/2014 que:
G.T. Fiduciaires S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrit au RCSL sous le numéro
B121820 est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement de G.T. Experts Comptables S.àr.l., démis-
sionnaire avec effet le 1
er
octobre 2013.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23/03/2015.
G.T. Experts Comptables sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015045639/16.
(150052284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
CID Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 110.645.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 février 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant A, avec effet au 15 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Nomination de Ronald Chamielec, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
3. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant A, avec effet au 15 décembre 2014;
4. Acceptation de la démission de Katherine Ang, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant A, avec effet au 9 avril 2014;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015045660/19.
(150052301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
58522
L
U X E M B O U R G
Starmaker S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 38.386.
EXTRAIT
Il résulte de la décision du Conseil d'Administration tenue en date du 6 mars 2015 que le siège social de la société a
été transféré de son ancienne adresse au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
Dorénavant, Madame Valérie WESQUY, née à Mont-Saint-Martin (France) le 6 mars 1968, demeurant professionnel-
lement au 19 Boulevard Grande-duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, sera inscrite sous le nom de Madame Valérie
RAVIZZA.
En outre, il est à noter que Monsieur Michele CANEPA, actuel administrateur, est désormais domicilié au 10, rue
Antoine Jans L-1820 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2015.
Référence de publication: 2015045421/17.
(150051431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Rehoss S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3428 Dudelange, 21A, route de Boudersberg.
R.C.S. Luxembourg B 102.931.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 20 mars 2015i>
<i>Première résolutioni>
Acceptation de la démission du gérant unique:
Rénato FLOREAN, demeurant au 3, rue Aux Champs F-57640 Argancy.
<i>Deuxième résolutioni>
Décision de nomination en remplacement:
Pascal KOVACS, demeurant au 34, rue de Malling F-57970 Koenigsmaker,
Le nouveau gérant unique sera nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015045354/18.
(150051434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
YG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 157.986.
<i>Extrait des résolutions prises à l'associé unique de la société tenue en date du 16 March 2015 approuvant les comptes de l'exercicei>
<i>clos le 31 décembre 2013i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gé-
rant;
2. Monsieur Alastair SIMPSON, demeurant professionnellement à 22 Ganton Street, Londres, W1F 7BY, Royaume-
Uni, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine l'associé unique de la Société statuant sur les comptes clos en décembre
2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015045498/19.
(150051601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
58523
L
U X E M B O U R G
ISOLA Développement, Société à responsabilité limitée,
(anc. KBK Development).
Siège social: L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 150.680.
L'an deux mil quinze, le vingt avril.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
Ont comparu:
Monsieur Burhan ZUREL, né le 15 mars 1974 à Karakocan (Turquie), demeurant professionnellement à L - 1528
Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire; et
Monsieur Nihat GUNGORDU, né le 3 novembre 1968 à Ovacik (Turquie), demeurant professionnellement à L - 1528
Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire, ici représenté par Monsieur Burhan ZUREL, précité, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le
notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesquelles parties comparantes, présente et/ou représentée comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant
d'acter ce qui suit:
- que Messieurs Burhan ZUREL et Nihat GUNGORDU, précités sont les seuls associés actuels de la société à res-
ponsabilité limitée KBK DEVELOPPEMENT, avec siège social à L- 1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 150680, constituée suivant acte reçu par Maître
Carlo WERSANDT, Notaire de résidence à Luxembourg, le 29 décembre 2009, publié au Mémorial C numéro 360 du
18 février 2010 (la «Société»).
- que le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales,
ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts étant entièrement souscrites
et libérées.
<i>Ordre du jouri>
1.- Transfert du siège social de L-1528 Luxembourg, 8A Boulevard de la Foire à L-8279 HOLZEM, 28, rue de Capellen
et en conséquence modification du premier paragraphe de l'article cinq des statuts de la société.
2.- Modification de la dénomination de la société de «KBK Development» en «ISOLA Développement» et en consé-
quence modification de l'article quatre des statuts de la société.
3.- Modification de l'objet social et modification de l'article deux des statuts de la société pour lui donner la teneur
suivante:
«La société a pour objet tous travaux de plâtrerie, de peinture, de plafonnage, de rénovation, enduits, façades, isolation,
et d‘étanchéité.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation».
4. Abandon de la version anglaise des statuts.
5. Divers.
Tout ceci ayant été déclaré, les associés, représentant l'intégralité du capital, ont requis à l'unanimité le notaire sous-
signé de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident transférer le siège social de la Société de L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire vers
L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen, et de modifier en conséquence l'alinéa premier de l'article 5 des statuts comme suit:
Art. 5. Siège social (alinéa premier). «Le siège social est établi dans la commune de Mamer (Grand-Duché de Luxem-
bourg).»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination de la Société de «KBK Development» en «ISOLA Développement»,
et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts comme suit:
« Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: "ISOLA Développement ".»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article deux des statuts
en lui donnant la teneur suivante:
58524
L
U X E M B O U R G
« Art. 2. Objet social. La société a pour objet tous travaux de plâtrerie, de peinture, de plafonnage, de rénovation,
enduits, façades, isolation, et d‘étanchéité. Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations
commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou
qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation».
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident d'abandonner la version anglaise des statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à environ mille cent euros (EUR 1.100).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les associés
de la Société, au paiement desdits frais.
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire
soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la personne comparante es qualités qu'elle
agit, connue du notaire instrumentaire par nom, prénoms, état et demeure, cette personne a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: Burhan Zurel, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 27 avril 2015. 1LAC / 2015 / 13002. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tom Benning.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 5 mai 2015.
Référence de publication: 2015067173/79.
(150077219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.
BEOOGO S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 142.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044925/9.
(150051816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
UniAbsoluterErtrag, Fonds Commun de Placement.
Das koordinierte Verwaltungsreglement, welches am 7. April 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. April 2015.
Union Investment Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2015052750/10.
(150060056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.
UniAbsoluterErtrag, Fonds Commun de Placement.
Das koordinierte Sonderreglement, welches am 7. April 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschafts-
register von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. April 2015.
Union Investment Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2015052751/10.
(150060057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.
58525
L
U X E M B O U R G
Hansainvest Lux Umbrella, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de HANSAINVEST LUX UMBRELLA modifié au 15 avril 2015 a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, avril 2015.
HANSAINVEST LUX S.A.
Référence de publication: 2015059805/10.
(150068709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2015.
Bib-Be in Balance, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8614 Reimberg, 31, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 196.352.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-deux avril,
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU
Monsieur François STEIES, né le 28 mars 1964 à Luxembourg, demeurant au 31 rue Belle-Vue, L-8614 REIMBERG (le
Comparant ou le Fondateur),
Lequel fondateur a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée
qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment
par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée
et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la réalisation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger: la prestation de services
en coaching et en conseil de tout genre, la prestation de services en techniques de relaxation de tout genre, toute
opération d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de courtage et plus généralement toute opération de commerce
se rapportant à ces activités, l’achat et la vente, à l'état neuf ou d'occasion, de tous supports, accessoires, fournitures et
produits dérivés. La société peut fournir toute prestation de service d'assistance et peut exercer toute activité de mar-
keting sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.
La société peut acquérir et exploiter tous brevets, directement ou par vole de licence, et acquérir ou exploiter toutes
licences, directement ou par voie de sous-licence.
La société peut réaliser son objet directement ou indirectement par des prises de participations dans d'autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères et peut réaliser toute opération se rapportant directement ou indirectement à
son objet social ou pouvant en faciliter l'extension et le développement.
Art. 3. La société prend la dénomination de Bib-Be in Balance.
Art. 4. Le siège social est établi à dans la commune de Préizerdaul.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune; toute souscrites et intégralement
libérées.
Art. 7. Les cessions de parts à des non-associés doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Lorsque
la société comporte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été
signifiées à la société ou acceptées par elles dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
58526
L
U X E M B O U R G
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont obligatoirement au moins un gérant technique dûment
autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à exercer les activités décrites dans l’objet
social, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe (nt) la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont révocables ad nutum.
Chaque gérant technique aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société
pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou par la loi.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 11. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un
procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les
conditions normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier (1
er
) janvier et finit le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente-et-un (31) décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. L'associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et
du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou, salon le cas, par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915, tel
que modifiée, s'appliquent.
<i>Souscription – Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Monsieur
François STEIES, préqualifié, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société; ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’Associé Unique, représentant la totalité du capital social de la
Société adopte les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée avec pouvoir obligatoire de signature:
Monsieur François STEIES, préqualifié.
2. Le siège social de la Société est établi au 31, rue Belle-Vue, L-8614 Reimberg.
<i>Autorisation d’établissementi>
Le notaire soussigné a informé le comparant qu’avant l’exercice de toute activité commerciale ou toute modification
de l’objet social relative à une activité commerciale, ou bien dans l’éventualité où la société serait soumise à une loi
particulière en rapport avec son activité, celui-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et
58527
L
U X E M B O U R G
due forme en relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant; il devra également s’acquitter
de toutes autres formalités éventuelles aux fins de rendre effective l’activité de la Société partout et vis-à-vis de toutes
tierces parties.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: F.STEIES, D.KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 23 avril 2015. Relation: DAC/2015/6649. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): J.THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 27 avril 2015.
Référence de publication: 2015062801/107.
(150071789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.
COF III Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 178.505.
Par résolutions prises en date du 13 mars 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Shari Verschell Silverman, avec adresse professionnelle au 9, West 57
th
Street, 41
st
Floor, 10019
New York, Etats-Unis, au mandat de gérant de classe A, avec effet au 2 mars 2015 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Jill Silverman, avec adresse professionnelle au 9, West 57
th
Street, 41
st
Floor, 10019
New York, Etats-Unis de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 2 mars 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2015.
Référence de publication: 2015044334/15.
(150050823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Metec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 21.173.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Sind erschienen:
I. METEC S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, die am 30. Dezember 1983 gemäß notarieller Urkunde aufge-
nommen durch Maître Frank Baden, damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (das „Mémorial“) Nummer 36 vom 9. Februar 1990 veröffentlicht wurde, gegründet wurde und im Han-
dels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 21173 eingetragen ist,
hier vertreten durch Herrn Michel Nickels, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß eines Beschlusses
des Verwaltungsrats vom 24. April 2015, welcher ne varietur von dem Bevollmächtigten der erschienen Person sowie
dem amtierenden Notar paraphiert und dieser Urkunde beigebogen bleibt, sowie
II. Normann GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter deutschem Recht mit Sitz in Pempelfurtstrasse
1, D-40880 Ratingen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 55833, hier
vertreten durch Herrn Michel Nickels, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, handelnd als bevollmächtigter
Vertreter
gemäß eines Beschlusses des Geschäftsführungsrats vom 8. April 2015, welcher ne varietur von dem Bevollmächtigten
der erschienen Person sowie dem amtierenden Notar paraphiert und dieser Urkunde beigebogen bleibt.
Die erschienenen Personen, hier vertreten wie vorerwähnt, haben den Notar ersucht, den folgenden gemeinsamen
Verschmelzungsplan zu beurkunden.
Die Geschäftsführungen der METEC S.A. und der Normann GmbH stellen den folgenden gemeinsamen Verschmel-
zungsplan auf:
58528
L
U X E M B O U R G
I. Verschmelzungsplan
Präambel
Die Metec S.A. (nachfolgend übertragende Gesellschaft) ist eine im luxemburgischen Handels- und Firmenregister
(Registre de Commerce et des Sociétés - RCS) unter der Nummer B 21173 eingetragene Aktiengesellschaft luxembur-
gischen Rechts mit Sitz in 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg. Ihr voll eingezahltes Aktienkapital beträgt EUR
1.540.000. Alleinige Aktionärin der übertragenden Gesellschaft ist die Normann GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 55833).
Die Normann GmbH (nachfolgend übernehmende Gesellschaft) ist eine im Handelsregister des Amtsgerichts Düs-
seldorf unter HRB 55833 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in D-40880 Ratingen. Ihr voll
eingezahltes Stammkapital beträgt EUR 25.000. Alleiniger Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft ist Herr Mat-
thias Normann.
Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft ist dieser Urkunde als Anlage 1 beigefügt.
Die übertragende Gesellschaft soll im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung zur Aufnahme gemäß §§ 122a
Abs. 2, 2 Nr. 1 UmwG und Artikel 261 ff. und 278 des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften („LGG“) auf die übernehmende Gesellschaft verschmolzen werden.
§ 1. Vermögensübertragung; Verschmelzungsstichtag.
1.1. Die übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung
ohne Abwicklung im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme nach §§ 122a Abs. 2, 2 Nr. 1, 4 ff. UmwG und Artikel
261 ff. und 278 LGG auf die übernehmende Gesellschaft.
1.2. Die Vermögensübertragung erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum 1. April 2015 (Verschmelzungsstichtag).
Von diesem Zeitpunkt an gelten alle Handlungen der übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden
Gesellschaft vorgenommen.
1.3. Der Verschmelzung liegt die Bilanz der übernehmenden Gesellschaft vom 31. Dezember 2014 und der übertra-
genden Gesellschaft vom 31. März 2015 als Schlussbilanz zugrunde.
1.4. Die übernehmende Gesellschaft wird die in der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft angesetzten Werte
der durch die Verschmelzung übergehenden Aktiva und Passiva in ihrer handelsrechtlichen Rechnungslegung fortführen.
Entsprechend werden die steuerlichen Buchwerte fortgeführt. Auch an spätere Änderungen der steuerlichen Buchwerte,
etwa aufgrund einer steuerlichen Außenprüfung, sind die übertragende und die übernehmende Gesellschaft in ihren
Steuerbilanzen gebunden. Die Verschmelzung erfolgt daher handels- und steuerbilanziell ohne Aufdeckung stiller Reser-
ven.
§ 2. Gegenleistung. Eine Gewährung von Geschäftsanteilen als Gegenleistung für die Vermögensübertragung entfällt
gemäß §§ 122a Abs. 2, 54 Abs. 1 Nr. 1 UmwG, da die übernehmende Gesellschaft die alleinige Gesellschafterin der
übertragenden Gesellschaft ist. Die Angaben nach § 122c Abs. 1 Nr. 2, 3 und 5 UmwG entfallen gemäß § 122c Abs. 2
UmwG.
§ 3. Sonderrechte und vorteile.
3.1. Es werden keine Rechte im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG oder Artikel 261 (2) f) LGG für mit Sonderrechten
ausgestattete Gesellschafter und Inhaber von anderen Wertpapieren als Gesellschaftsanteilen gewährt. Es sind auch keine
Maßnahmen im Sinne der vorgenannten Vorschrift für solche Personen vorgesehen.
3.2. Es werden keine besonderen Vorteile im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG oder Artikel 261 (2) g) LGG für
die Sachverständigen, die den Verschmelzungsplan prüfen, oder die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts-
oder Kontrollorgane der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften gewährt.
§ 4. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung.
4.1. Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft beschäftigen Arbeitnehmer. Die
Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die Beschäftigung.
4.2. Weder bei der übertragenden Gesellschaft noch bei der übernehmenden Gesellschaft besteht ein Betriebsrat.
Damit entfällt eine Zuleitung des Verschmelzungsplans bzw. seines Entwurfs an die zuständigen Betriebsräte gemäß §§
122a Abs. 2, 5 Abs. 3 UmwG und Artikel 265 (1) LGG.
4.3. Es sind keine weiteren Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen vorgesehen.
§ 5. Rechte der Gläubiger der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft.
5.1. Die Rechte der Gläubiger der übernehmenden deutschen Normann GmbH ergeben sich aus § 122a Abs. 2 UmwG
iVm. § 22 UmwG. Danach ist den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Normann GmbH Sicherheit zu leisten,
wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes der
Normann GmbH nach § 122a Abs. 2 iVm. § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und
Höhe schriftlich anmelden. Dieses Recht steht den Gläubigern nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Versch-
melzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird. Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der Eintragung der
Verschmelzung bei der Normann GmbH gem. § 122a Abs. 2 iVm. § 22 Abs. 1 Satz 3 UmwG auf dieses Recht hinzuweisen.
Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugs-
58529
L
U X E M B O U R G
weise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und
staatlich überwacht ist.
Hinsichtlich des Anspruchs der Gläubiger ist unerheblich, ob dieser Anspruch auf Vertrag oder Gesetz beruht. Siche-
rheitsleistungen können aber nur Gläubiger eines so genannten obligatorischen Anspruchs verlangen. § 22 UmwG erfasst
keine dinglichen Ansprüche, da insoweit der Gegenstand des dinglichen Rechts die Sicherheit darstellt. Der Inhalt der
Forderung ist nur insoweit von Bedeutung, als diese einen Vermögenswert darstellen muss. Der zu sichernde Anspruch
muss deshalb nicht notwendig unmittelbar auf Geld gerichtet sein, vielmehr besteht auch bei einem Anspruch auf Lieferung
von Sachen oder sonstigen Leistungen ein Sicherheitsbedürfnis hinsichtlich eines später eventuell daraus resultierenden
Schadensersatzanspruches.
Der Anspruch ist unmittelbar gegenüber der Normann GmbH unter deren Geschäftsanschrift Pempelfurtstr.1,
D-40880 Ratingen, Deutschland geltend zu machen. Hierzu ist eine genaue Beschreibung der dem Anspruch zu Grunde
liegenden Forderung erforderlich, sodass eine Individualisierung ohne weitere Nachforschungen möglich ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsleistung spätestens sechs Monate nach Bekanntmachung der Eintragung
der Verschmelzung in das Handelsregister der Normann GmbH gefordert werden muss.
Unter der vorgenannten Anschrift können im Übrigen vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung
der Rechte der Gläubiger und der Minderheitsgesellschafter eingeholt werden.
5.2. Nach luxemburgischen Recht können die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft, deren Forderungen vor der
Veröffentlichung der gemäß Artikel 273 (1) LGG veröffentlichten Verschmelzungsbescheinigung entstanden sind, gemäß
Artikel 268 LGG innerhalb einer zweimonatigen Frist bei dem Vorsitzenden Richter des Bezirksgerichtes (tribunal d'ar-
rondissement), in dessen Bezirk die übertragende Gesellschaft ihren Sitz hat, die Bestellung von Sicherheiten für fällige
oder nicht fällige Forderungen beantragen, wenn glaubhaft bewiesen werden kann, dass die Verschmelzung ein Risiko für
den Bestand der Forderung darstellt und die übertragende Gesellschaft keine ausreichenden Sicherheiten bereitgestellt
hat.
Ausführliche Informationen über das Verfahren zur Ausübung der Rechte der Gläubiger, können kostenlos beim Sitz
der übertragenden Gesellschaft gemäß Artikel 262 LGG angefordert werden.
§ 6. Kosten. Die durch die Verschmelzung und ihren Vollzug entstehenden Kosten, Steuern und Gebühren trägt die
übernehmende Gesellschaft.
§ 7. Schlussvorschriften.
7.1. Die übertragende Gesellschaft hat keinen Grundbesitz. Die übertragende Gesellschafterin ist nicht Gesellschafterin
einer Gesellschaft in der Rechtform der GmbH.
7.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans nicht berührt werden. Das Gleiche
gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass dieser Verschmelzungsplan eine Regelungslücke enthält. An Stelle der unwirk-
samen oder der undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke verpflichten sich die Parteien, eine
angemessene Ersatzregelung zu vereinbaren, die dem Inhalt der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung möglichst nahe
kommt.
<i>Stellungnahmei>
Der unterzeichnende Notar bestätigt hiermit die Gesetzmäßigkeit des vorliegenden Verschmelzungsplans gemäß Ar-
tikel 271(2) ff. des Luxemburgischen Gesetzes.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der übertragenden Ge-
sellschaft aus Anlass dieser Akte entstehen werden, werden auf ungefähr dreitausendsiebenhundert Euro (EUR 3.700.-)
geschätzt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem amtierenden Notar diese
Urkunde unterzeichnet.
Folgt die englische übersetzung des vorherstehenden textes:
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of April.
Before the undersigned Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
I. METEC S.A., a société anonyme existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office
at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated on 30 December 1983
58530
L
U X E M B O U R G
by a deed of Me Frank Baden, at such time notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which was
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 36 of 9 February 1990 and which is registered
with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number
B 21173,
here represented by Mr. Michel Nickels, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to resolutions
of the board of directors dated 24 April 2015 which after having been signed ne varietur by the proxyholder of the
appearing person and shall remain attached to the present deed, and
II. Normann GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung existing under the laws of Germany with registered office
at Pempelfurtstrasse 1, D-40880 Ratlingen, Germany, registered with the commercial register of the the district court of
Düsseldorf under number HRB 55833,
here represented by Mr. Michel Nickels, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to resolutions
of the board of managers dated 8 April 2015 which after having been signed ne varietur by the appearing person and shall
remain attached to the present deed
The appearing persons, represented as aforementionned, requested the notary to record the following common draft
terms of merger.
The board of directors of METEC S.A. and the board of managers of Normann GmbH have prepared the following
common draft terms of merger:
I. Terms of merger
Preamble
Metec S.A. (hereafter referred to as company being transferred) is a société anonyme under Luxembourg Law with
its registered office in 2, avenue Charles de Gaulle L-1653, Luxembourg, and enrolled in the commercial register of
Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés - RCS) under Number B 21173. Its fully subscribed share capital is
EUR 1,540,000. The sole shareholder of the company being transferred is Normann GmbH which has its registered office
in Ratingen (District Court of Düsseldorf, HRB 55833).
Normann GmbH (hereafter referred to as absorbing company) is a limited liability company with its registered office
in D-40880 Ratingen and enrolled in the commercial register of the Local Court of Düsseldorf under HRB 55833. Its fully
subscribed share capital is EUR 25,000. The sole shareholder of the absorbing company is Mr Matthias Normann.
The Articles of Association of the absorbing company are attached to this deed as Appendix 1.
The company being transferred is to be merged by way of a cross-border merger by absorption in accordance with
Sec. 122a para. 2, 2 no. 1 of German Transformation Act (Umwandlungsgesetz, UmwG) and article 261 ff. and 278 of the
Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (“LCC”) into the absorbing company.
§ 1. Transfer of assets; Merger Cut-off Date.
1.1. The company being transferred assigns all of its assets together with all rights and obligations by way of dissolution
without liquidation by way of a merger by absorption to the absorbing company in accordance with Sec. 122a para. 2, 2
No. 1, 4 et seq. UmwG and article 261 ff. and 278 LCC.
1.2. In the companies' relations with each other, the transfer of assets is to take place on 1 April 2015 (Merger Cut-
off Date). With effect from this date, all acts of the company being transferred will be considered as having been carried
out for the account of the absorbing company.
1.3. The merger is based on the absorbing company's balance sheet as of 31 December 2014 and the balance sheet of
the company being transferred as of 31 March 2015 as the closing balance sheet.
1.4. The absorbing company will carry forward in its own commercial law accounting system the values of the assets
and liabilities transferred as a result of the merger reported in the balance sheet of the company being transferred.
Accordingly, the book values for tax purposes will be carried forward. The transferring and the absorbing companies will
also be bound by their fiscal accounts in subsequent changes to the book values for tax purposes, in the event of a tax
audit, for example. The merger does not therefore entail the disclosure of hidden reserves, either in the commercial or
in the fiscal accounts.
§ 2. Consideration. Pursuant to Sec. 122a para. 2, 54 para. 1 no. 1 UmwG, there is no grant of shares as a consideration
in return for the transfer of assets since the absorbing company is the sole shareholder of the company being transferred.
Pursuant to Sec. 122c para. 2 UmwG, information according Sec. 122c para. 1 no. 2, 3, 5 UmwG is not required.
§ 3. Special rights and advantages.
3.1. No rights within the meaning of Sec. 5 para. 1 no. 7 UmwG or article 261 (2) f) LCC will be granted to shareholders
enjoying special privileges and on holders of securities other than shares in the company. Nor are any measures within
the meaning of the above regulation foreseen concerning such persons.
3.2. No special advantages within the meaning of Sec. 5 para. 1 no. 8 UmwG or article 261 (2) g) LCC will be granted
to experts auditing the draft terms of merger or the members of the administrative, management, supervisory, or con-
trolling bodies of the companies involved in the merger.
58531
L
U X E M B O U R G
§ 4. Repercussions of the merger on employment.
4.1. Both the company being transferred and the absorbing company do not have employees. The merger shall not
have any impact on employment.
4.2. Both the company being transferred and the absorbing company do not have a works council. The requirement
to forward the terms of merger or a draft of the same to the members of the works council in accordance with Sec 5
para. 3 UmwG and article 265 (1) LCC is therefore not applicable.
4.3. No further measures with implications for the employees and their representative bodies are foreseen.
§ 5. Rights of the creditors of the absorbed and of the absorbing company.
5.1. The rights of the creditors of the German absorbing Normann GmbH are set forth in Sec. 122a para. 2 UmwG,
22 UmwG. Pursuant to this provision security is to be provided to the creditors of Normann GmbH involved to the
merger, provided they file their claim in writing, citing the merits and the amount of such claim, within six (6) months of
the day on which the entry of the merger in the register kept at the registered seat of Normann GmbH has been published
by notice pursuant to Sec. 122a para. 2, 19 para. 3 UmwG. However, the creditors shall be entitled to this right only if
they demonstrate satisfactorily that the merger will jeopardise the performance of the claim they hold. Pursuant to Sec.
122a para. 2, 22 para. 1 UmwG, this right is to be indicated to the creditors in the publication by notice of the entry of
the merger of Normann GmbH. Those creditors who are entitled to preferred satisfaction of their claims, in the event
of insolvency, shall not be entitled to demand the provision of security out of cover funds that were created for their
protection pursuant to the stipulations of the law and that are monitored by the state.
As to the claim of the creditors, it is irrelevant, whether this claim has a basis in law or contract. However, security
is to be provided only to the creditors of a contractual claim. Sec. 22 UmwG does not include rights in rem, in this respect
the subject of the right in rem constitutes the security.
The content of the claim may only be of relevance in so far as the claim has to represent an asset. It is not necessary
that the claim to be secured is directly based upon money, there is also a need for security with regard to claims for
delivery of items or other services concerning any claims for damages potentially resulting from them.
The claim has to be presented directly to Normann GmbH at its business address Pempelfurtstr. 1, D-40880 Ratingen,
Germany. The demand on which the claim is based, must be accurately described to enable the individualization without
further investigation.
It is recalled that the provision of security must be requested within six (6) months of the day on which the entry of
the merger in the register kept at the registered seat of Normann GmbH has been published by notice.
Complete information regarding the proceedings for the execution of the rights of creditors may be requested at the
address given above.
5.2. In accordance with Luxembourg law, the creditors of the company being transferred, whose claims predate the
date of publication of the notary certificate provided for in article 273 (1) LCC, may in accordance with article 268 LCC,
apply within two months to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial
matters in the district in which the registered office of the company being transferred is located, to obtain adequate
safeguard of collateral for any matured or unmatured debts, where they can credibly demonstrate that due to the merger
the satisfaction of their claims is at stake and that no adequate safeguards have been obtained from the company being
transferred.
Complete information regarding the proceedings for the execution of the rights of creditors may be requested, in
accordance with article 262 LCC, free of charge, at the registered office of the company being transferred.
§ 6. Costs. The absorbing company will pay the costs, taxes and fees incurred as a result of the merger and its imple-
mentation.
§ 7. Concluding provisions.
7.1. The company being transferred does not own any real estate. The company being transferred is not shareholder
of any company in the legal form of a GmbH.
7.2. Should individual provisions of these terms of merger be or become wholly or partly invalid, this will not affect
the remaining provisions of these terms of merger. The same will apply should it emerge that there is an omission in the
terms of merger. The parties undertake to agree an appropriate replacement provision instead of the invalid or unen-
forceable provision or to remedy the omission that corresponds as far as possible with the contents of the void or invalid
provision.
<i>Statementi>
The undersigned notary hereby confirms the legality of the present merger proposal in accordance with article 271
(2) ff. LCC.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company
as a result of the present deed are estimated at three thousand seven hundred Euros (EUR 3,700.-).
58532
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands English states herewith that on request of the above mentioned party the
present deed is worded in German followed by an English translation. In case of divergences between the German and
the English texts, the German version will prevail.
WHEREOF, done in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, said person signed together with the notary the present deed.
Signé: Nickels, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/13501. Reçu douze euros (12,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 6 mai 2015.
Référence de publication: 2015068315/263.
(150077760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2015.
Real Estate Development 2015 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 196.502.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of May.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg)
THERE APPEARED:
FMS Wertmanagement AöR, a German institution under public law (Anstalt des öffentlichen Rechts), having its regis-
tered office at Prinzregentenstrasse 56, 80538 Munich, Germany, registered with the commercial register at the local
court in Munich under number HRA 96076 (the "Founding Shareholder"),
here represented by Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, with business address in L-8510 Redange-sur-Attert, 66,
Grand-Rue (Grand Duchy of Luxembourg) (the "Representative"), by virtue of a power of attorney.
Which proxy, after having been signed “ne varietur” by the Representative and the undersigned notary, shall be annexed
to the present deed for the purpose of registration.
The Founding Shareholder, represented by the Representative, has requested the undersigned notary to draw up the
following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declared
to establish.
Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form.
1.1 There is hereby established a company in the form of a private limited liability company ("société à responsabilité
limitée") (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the Luxembourg Civil Code, as amended,
and the present articles of incorporation (the "Articles").
1.2 The Company may have one sole shareholder or several shareholders, provided that the number of shareholders
does not exceed forty (40).
2. Company name.
2.1 The Company exists under the name "2. Real Estate Development 2015 S.à r.l.".
3. Registered office.
3.1 The Company has its registered office in the city of Luxembourg.
3.2 The Management is authorised to change the address of the Company's registered office within the municipality
of the Company's registered office.
3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of
the Management.
3.4 In the event that, in the opinion of the Management, extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer
the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect
on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a
company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
58533
L
U X E M B O U R G
4. Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form what-
soever, in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such
stakeholdings.
This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public
offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants
and other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests,
limited-liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each
case whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations)
in any type of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or
immovable asset in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of
indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans,
money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security)
to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to
undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing
so is in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged
in a regulated activity or one that requires the Company to have a licence.
5. Duration. The Company is established for an indefinite period of time.
Share capital, Transfer of shares
6. Share capital.
6.1 The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into
twelve thousand five hundred (12,500) shares, each with a par value of one euro (EUR 1.-).
6.2 In addition to the share capital, the shareholder(s) of the Company (the "Shareholder(s)") may decide to set up a
share premium account. Any premium paid on shares in addition to the par value must be transferred into this share
premium account. The funds of the share premium account may be used by the Company to redeem the Company's own
shares from Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to
the legal reserve.
6.3 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution
account 115 (compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres») on which the Company shall
allocate any capital contributions to the Company which will be made without issue by the Company of any new shares
in consideration for the relevant contribution.
6.4 The Company may only acquire its own shares for the purpose of and subject to their immediate cancellation.
6.5 The share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by the Shareholders in
accordance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these
Articles.
7. Shares.
7.1 All shares will be and remain in registered form.
7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.
7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
7.4 Each share of the Company is indivisible vis-à-vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a
common representative vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to the share until a common representative has been notified by the coowners to the Company in writing or by fax.
8. Transfer of shares.
8.1 The shares may be transferred freely amongst the Shareholders.
8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such Shareholder may freely transfer his/her/its shares.
8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the consent of the
Shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.
8.4 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. No transfer of shares is
binding vis-à-vis the Company or vis-à-vis third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company
58534
L
U X E M B O U R G
in accordance with the applicable Luxembourg law on transfers of claims, in particular, without limitation, article 1690 of
the Luxembourg Civil Code.
Management; Auditor
9. Managers.
9.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be Shareholders (the "Manager
(s)").
9.2 The Managers are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii)
the limited or unlimited duration of their mandate.
9.3 The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at
any time, with or without cause, by the Shareholders.
9.4 The Shareholders may decide to qualify the appointed Managers as class A managers and class B managers res-
pectively.
9.5 Even after the term of their mandate, the Managers are not entitled to disclose confidential information of the
Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a
disclosure is mandatory by law.
10. Board of Managers.
10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the
"Board").
10.2 The Board may appoint a Manager as its chair (the "Chair of the Board").
11. Powers of Management.
11.1 The sole Manager or the Board (as applicable) (the "Management") is vested with full powers to act on behalf of
the Company and to authorize, on behalf of the Company, all acts whether of an administrative or of a disposal nature
which the Management in its full discretion deems necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers
not expressly reserved by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg to the Shareholders fall within the competence
of the Management.
11.2 The Management may also set up one or more committee(s) and determine its/their composition and powers
and delegate certain powers and/or special mandates to them.
11.3 The Management may confer certain powers and/or special mandates to act on behalf of and bind the Company,
vis-à-vis third parties, to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third person(s), any of these acting either alone
or jointly as determined by the Management.
12. Meetings of the Board and Written Decisions.
12.1 The Board will meet upon the request of any Manager.
12.2 Such Manager will inform the other Managers of the place, date, time and agenda of the meeting by written notice
or e-mail. Such notice must be received by the Managers at least twenty-four hours prior to the meeting. No separate
notice is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted by a decision
of the Board and in case of urgency.
12.3 The above mentioned notice requirement may be waived in writing by the concerned Manager(s) or by the
unanimous written consent of all Managers at the relevant meeting of the Board.
12.4 At each Board meeting, the Board shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of the majority of the
Managers present or represented at such meeting.
12.5 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the
minutes of the meeting.
12.6 Managers may attend and act at any Board meeting by appointing another Manager in writing as her/his repre-
sentative.
12.7 Managers may participate in a Board meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar
means of communication enabling several persons to communicate with each other. Such methods of participation are
to be considered as equivalent to a physical presence at the relevant meeting.
12.8 A quorum of the Board shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office,
provided, whenever applicable, that at least a Class A Manager and a Class B Manager are present. Decisions will be taken
by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting and this majority shall at least,
whenever applicable, include a Class A Manager and a Class B Manager.
12.9 Decisions of the Board are taken by a majority of the Managers present or represented at the relevant Board
meeting. In the case of a tied vote, the Chair of the Board does not have a casting vote.
12.10 The minutes of Board meetings must be drawn up and signed by all Managers present at the relevant meeting.
Any powers of attorney shall remain attached to the minutes.
58535
L
U X E M B O U R G
12.11 A written decision signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented in either a single document signed by all
Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Managers.
12.12 Where only one Manager has been appointed, such Manager has full power to act on behalf of and validly bind
the Company without the need of any decision in writing or minutes of the sole Manager´s decisions.
12.13 Copies or extracts of the minutes of the Board meeting shall be certified by the Management
13. Representation of the Company.
13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the sole
signature of that Manager.
13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the joint
signatures of any two Board members.
13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound vis-à-vis third parties only by sole signature of one class
A manager if the sole shareholder or the Shareholders (as applicable) have qualified the Managers as class A managers
and class B managers.
13.4 Notwithstanding the above, the Company will also be bound vis-à-vis third parties by any person to whom valid
powers of representation have been delegated by the sole Manager of the Board, as applicable.
14. Conflict of Interests.
14.1 Subject to the following, the conflict of interest rules as set out in article 57 of the Act shall apply.
14.2 No contract or other business between the Company and a third party be affected or invalidated by the sole fact
that one or several duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager may have
a direct or indirect personal interest in the relevant matter.
14.3 If the sole Manager or all Managers are conflicted with respect to a certain matter, the matter shall be resolved
upon by the General Meeting of Shareholders or the Sole Shareholder (as applicable).
15. Indemnification of Managers.
15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administra-
tors, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the
Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indem-
nification by such other company.
15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct or mens rea.
15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by
its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.
15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable
its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.
16. Audit.
16.1 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has more
than twenty-five (25) Shareholders, the Company's annual accounts are to be audited by one or more statutory auditors,
which can either be one or several Shareholders or third persons.
16.2 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has
twenty-five (25) or less Shareholders, the Shareholders may decide, without being obliged to do so, to have the annual
accounts audited by one or more statutory auditors, being either Shareholders or third persons.
16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditors, (ii) remu-
neration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their
successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or
without cause, by the Shareholders.
Shareholders
17. Shareholders' Resolutions.
17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in Shareholders' meetings or, subject to the limitations set
forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolutions.
17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg.
17.3 Any amendment to the Articles must be approved by (i) the majority of Shareholders in number and (ii) three-
quarters of the issued share capital, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by
the Articles.
58536
L
U X E M B O U R G
17.4 All other Shareholders' resolutions will be taken by Shareholders representing more than half of the issued share
capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.
In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time,
by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of issued
share capital represented.
18. Written Resolutions.
18.1 If the Company has twenty five (25) or less Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed
in Shareholders' meetings but may also be passed by written resolution.
18.2 The text of resolutions to be adopted by written resolution will be sent to the Shareholders in writing by the
Management by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send
it back to the Management of the company by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the
receipt of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.
18.3 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions may be waived by
unanimous written resolution of all Shareholders in the relevant written resolution or otherwise.
18.4 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the
Company has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in
writing and signed by the sole Shareholder.
18.5 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Management.
19. Shareholders' meetings.
19.1 An annual Shareholders' meeting needs only be held if the Company has more than twenty-five (25) Shareholders.
In that case, these Articles shall be amended in order to provide for the date and time at which such annual Shareholders'
meeting shall be held.
19.2 Extraordinary Shareholders' meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg by notice of the Management, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of
the issued share capital of the Company (if any).
19.3 A Shareholders' meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Management, this should be necessary
due to circumstances of force majeure.
19.4 The notice convening the Shareholders' meeting shall indicate the place, date, time and agenda of the meeting
and shall be sent to the Shareholders at least eight (8) days prior to the meeting. The above mentioned notice requirement
may be waived in writing by the concerned Shareholder(s) or by the unanimous written consent of all Shareholders at
the relevant meeting of the Shareholders.
19.5 Any duly constituted Shareholders' meeting represents all the Shareholders of the Company.
19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the general
meeting of shareholders by applicable law and these Articles. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915,
as amended from time to time, are not applicable to that situation.
20. Procedure at Shareholders' meetings.
20.1 A Shareholder may act at a Shareholders' meeting by appointing a representative, who does not have to be a
Shareholder, in writing or by fax.
20.2 Shareholder(s) may participate in a Shareholders' meeting by means of a conference call, by videoconference or
by any similar means of communication enabling several persons to communicate with each other. Such participation shall
be deemed equivalent to a physical presence at the relevant meeting.
20.3 The Management may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders'
meeting.
20.4 At each meeting of the Shareholders, the Shareholders shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of
the majority of the Shareholders present or represented at such meeting (the "Chair of the Shareholders' Meeting").
20.5 The Chair of the Shareholders' Meeting will appoint a secretary. The Shareholders will appoint one or several
scrutineer(s). The Chairman of the Shareholders' meeting together with the secretary and the scrutineer(s) form the
bureau of the general meeting (the "Bureau").
20.6 An attendance list indicating the (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable,
(iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.
20.7 Minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.
20.8 Copies or extracts of the minutes of the Shareholders' meeting shall be certified by the Management.
Financial year, Distributions of earnings
21. Financial year.
21.1 The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month
of December.
58537
L
U X E M B O U R G
22. Approval of financial statements.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management will draw up the annual accounts
of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
22.2 The Management will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review
and to the Shareholders for approval.
22.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
23. Allocation of Profits.
23.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The reserve can be used in whole or in
part to (i) absorb existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision, (iii) carry it forward to the next following
financial year or (iv) be distributed to the Shareholders as a dividend.
23.2 The Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated.
24. Interim dividends. The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim
accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for
such a distribution.
Dissolution, Liquidation
25. Dissolution and liquidation.
25.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required
to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
25.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).
25.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses
pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Share-
holders pro rata to the number of the shares held by them.
Applicable law
26. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable law.
<i>Transitory provisions:i>
The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2015.
<i>Subscription and payment:i>
Thereupon, the Founding Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully pay
in cash all the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value amount of one euro (EUR 1.-) each issued
by the Company.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article
183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended by article 1832 of the civil code, as amended,
have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Resolutions of the founding shareholder:i>
The Founding Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as sole shareholder of the Company,
thereupon passed the following shareholders' resolutions:
1. The company shall be represented by three (3) managers (the “Managers”).
2. The following are appointed as Managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Mariano PEREZ-DURANTEZ, born in Valladolid, Spain, on 28 March 1979, residing professionally at Prinzregen-
tenstrasse 56, 80538 Munich, Germany, as class A Manager of the Company;
- Ms Katia CAMBON, born in Le Raincy, France on 24 May 1972, residing professionally at 16, Avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg, as class B Manager of the Company;
- Ms Marina KERNEUR, born in Ploemeur, France on 19 June 1978, residing professionally at 16, Avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg, as class B Manager of the Company.
3. The registered office of the Company shall be at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Lu-
xembourg).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately EUR 1,600.-.
58538
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the date stated at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the French
text, the English text shall prevail.
This document was read to the Representative, who is known to the notary by his surname, first name, civil status
and residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.
Nachfolgend die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausendfünfzehn, am vierten Mai.
Ist vor mir, Maître Danielle KOLBACH, Notar mit Sitz in Redingen (Großherzogtum Luxemburg).
die FMS Wertmanagement AöR, eine nach Deutschem Recht gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts mit einge-
tragenem Sitz in Prinzregentenstrasse 56, 80538 München, Deutschland, eingetragen beim Handelsregister des Amtsge-
richts München, deutschland unter Nummer HRA 96076 (der „Gründungsgesellschafter“) erschienen,
vertreten durch Frau Virginie PIERRU, Notarschreiber, mit Adresse in L-8510 Redingen, 66, Grand-Rue (Großher-
zogtum Luxemburg) (der „Vertreter“), kraft einer Vollmacht.
Welche Vollmacht, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar „ne varietur“
gezeichnet wurde, mit dieser Urkunde verbunden bleiben soll, um zusammen registriert zu werden.
Der Gründungsgesellschafter, repräsentiert durch den Vertreter, hat den unterzeichneten Notar aufgefordert, die
folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, die er zu
gründen erklärt hat.
Gesellschaftsform, Name, Geschäftssitz, Gegenstand, Dauer
1. Gesellschaftsform.
1.1 Hiermit wird durch ein einziges Gründungsmitglied eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung („société à responsabilité limitée“) (die „Gesellschaft“) gegründet, die dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg unterliegt, und zwar insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit
geltenden Fassung (das „Gesetz“), Artikel 1832 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung
sowie der vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).
1.2 Die Gesellschaft besteht anfänglich aus einem alleinigen Gesellschafter. Die Gesellschaft darf jedoch jederzeit aus
einer beliebigen Anzahl von Gesellschaftern bestehen, soweit sie nicht über vierzig (40) beträgt.
2. Firmenname.
2.1 Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „2. Real Estate Development 2015 S.à r.l.“.
3. Eingetragener Firmensitz.
3.1 Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
3.2 Der Vorstand ist ermächtigt, die Anschrift des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde
des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft zu ändern.
3.3 Zweigstellen bzw. sonstige Niederlassungen können auf Beschluss des Vorstands entweder im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
3.4 Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ent-
wicklungen vorliegen oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Firmensitz
oder die problemlose Kommunikation mit dem besagten Sitz oder zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden
Personen beeinträchtigen würden, so darf sie den eingetragenen Firmensitz vorübergehend und bis zum Ende dieser
außerordentlichen Umstände ins Ausland verlegen. Derartige zeitweiligen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Na-
tionalität der Gesellschaft; sie bleibt ungeachtet der zeitweiligen Verlegung des eingetragenen Firmensitzes eine dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft.
4. Gegenstand.
4.1 Der Gegenstand der Gesellschaft besteht in dem unmittelbaren und mittelbaren Erwerb und Halten von Beteili-
gungen, in jedweder Form, an luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmungen, sowie der Verwaltung,
Entwicklung und dem Management von solchen Beteiligungen.
4.2 Dies umfasst, ohne jedoch darauf begrenzt zu sein, die Investition in, den Erwerb von und die Verfügung über, die
Gewährung von oder die Ausgabe (ohne öffentliche Auflegung) von Preferred Equity Certificates, Darlehen, Schuldver-
schreibungen, Anleihen, Pfandbriefe und andere Schuldtitel, Gesellschaftsanteile, Optionsscheine und andere Eigenkapi-
talinstrumente und -rechte, einschließlich und ohne darauf beschränkt zu sein, Stammaktien, Kapitaleinlagen in
Kommanditgesellschaften, Kapitaleinlagen in Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Vorzugsaktien, Wandelschuldver-
schreibungen und Swaps, sowie jede Kombination davon, in jedem Fall unabhängig davon, ob leicht handelbar oder nicht,
und Obligationen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, synthetische Schuldverschreibungen) in jeder Art von
Gesellschaft, juristischen Person oder anderem Rechtssubjekt.
58539
L
U X E M B O U R G
4.3 Die Gesellschaft kann ihre Mittel auch dazu verwenden, in Immobilien, Immaterialgüterrechte oder andere be-
wegliche oder unbewegliche Vermögenswerte in jedweder Form oder jedweder Art zu investieren.
4.4 Die Gesellschaft kann luxemburgischen und ausländischen Rechtssubjekten Bürgschaften, Garantien, Pfandrechte,
Hypotheken und jede andere Form von Sicherheit sowie jede Form von Freistellung, im Hinblick auf ihre eigenen Ver-
pflichtungen und Schulden, gewähren.
4.5 Die Gesellschaft kann zudem den Tochtergesellschaften der Gesellschaft Unterstützung in jedweder Form (ein-
schließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, der Erweiterung von Vorauszahlungen, Darlehen, Geldeinlagen und Krediten
sowie der Gewährung von Bürgschaften, Garantien, Pfandrechten, Hypotheken und jeder anderen Form von Sicherheit)
zukommen lassen. Die Gesellschaft kann Unternehmungen, die Teil der gleichen Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört,
sind, oder Dritten gelegentlich die gleiche Art von Unterstützung zukommen lassen, vorausgesetzt, dass dies im Interesse
der Gesellschaft liegt und keine Genehmigungspflichten auslöst.
4.6 Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jedwede kommerzielle, industrielle und finanzielle Transaktionen durchführen
und solche weiteren Tätigkeiten ausüben, die sie zum Erreichen oder zur Entwicklung des Gesellschaftszwecks notwendig,
ratsam, geeignet, gelegen oder nicht unvereinbar erachtet.
4.7 Ungeachtet des Vorstehenden darf die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen, die dazu führen würden, dass sie eine
reglementierte Tätigkeit ausübt oder eine Tätigkeit, für die die Gesellschaft eine Lizenz benötigt.
5. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Stammkapital und Übertragung von Anteilen
6. Stammkapital.
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), verteilt auf zwölftausend-
fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils ein Euro (EUR 1).
6.2 Der/die Gesellschafter der Gesellschaft (der/die „Gesellschafter“) ist/sind berechtigt, die Bildung einer Agiorücklage
zusätzlich zum Stammkapital zu beschließen. Jedes Aufgeld, das zusätzlich zum Nennwert für Anteile bezahlt wurde, muss
in dieses Agiorücklage übertragen werden. Die Mittel der Agiorücklage dürfen von der Gesellschaft dafür eingesetzt
werden, ihre Anteile von Gesellschaftern zurückzukaufen, Nettoverluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesell-
schafter vorzunehmen oder Mittel in die gesetzliche Rücklage einzustellen.
6.3 Neben dem Stammkapital und der Agiorücklage kann die Gesellschaft ein Kapitaleinlagenkonto 115 (compte
115»Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres«) einrichten, in das die Gesellschaft Einlagen in die Ge-
sellschaft einstellen kann, die erfolgen, ohne dass die Gesellschaft neue Anteile als Gegenleistung für die entsprechende
Einlage ausgibt.
6.4 Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile nur zwecks und vorbehaltlich ihrer unverzüglichen Einziehung erwerben.
6.5 Die Gesellschafter können das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals in Übereinstimmung mit dieser
Satzung und dem auf die jeweiligen Fassung dieser Satzung anwendbaren Recht des Großherzogtums Luxemburg verrin-
gern oder erhöhen.
7. Anteile.
7.1 Alle Anteile sind Namensanteile und bleiben als Namensanteile bestehen.
7.2 Der Besitz eines Anteils ist mit der stillschweigenden Annahme der Satzung und der von den Gesellschaftern
gefassten Beschlüsse verbunden.
7.3 Jeder Anteil berechtigt in den von den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auferlegten Grenzen zu einer
Stimme.
7.4 Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Mitinhaber von Anteilen müssen gegenüber der Gesellschaft
durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die
mit einem Anteil verbunden sind, so lange auszusetzen, bis die Mitinhaber der Gesellschaft gegenüber schriftlich oder per
Telefax einen gemeinsamen Vertreter ernannt haben.
8. Übertragung von Anteilen.
8.1 Die Anteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden.
8.2 Sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, darf dieser Gesellschafter seine/ihre Anteile frei
übertragen.
8.3 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Anteilen an Dritte der Zustim-
mung seitens der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des gesamten begebenen Stammkapitals repräsentieren.
8.4 Jede Übertragung der Anteile muss durch eine notarielle Urkunde oder einen privatschriftlichen Vertrag nachge-
wiesen werden. Für die Gesellschaft oder für Dritte sind keine Anteilsübertragungen bindend, die der Gesellschaft nicht
ordnungsgemäß bekannt gegeben oder nicht gemäß den Regeln für die Übertragung von Ansprüchen gemäß den Gesetzen
des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches von der
Gesellschaft angenommen wurden.
58540
L
U X E M B O U R G
Geschäftsführung; Wirtschaftsprüfer
9. Geschäftsführer.
9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, wobei es sich sowohl um Gesellschafter
als auch um Nicht-Gesellschafter handeln kann (der/die „Geschäftsführer“).
9.2 Der/die Geschäftsführer wird/werden von den Gesellschaftern ernannt, die (i) ihre Anzahl, (ii) ihre Vergütung und
(iii) die begrenzte oder unbegrenzte Dauer ihres Mandats bestimmen.
9.3 Der/die Geschäftsführer bekleidet/bekleiden sein Amt/ihre Ämter, bis sein/ihre Nachfolger gewählt werde(n). Sie
dürfen von den Gesellschaftern wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne sachlichen Grund von ihnen entlassen werden.
9.4 Die Gesellschafter können beschließen, den/die ernannten Geschäftsführer als Klasse-A- und Klasse-B-Geschäfts-
führer zu qualifizieren.
9.5 Auch nach dem Ablauf ihres Mandats ist der/sind die Geschäftsführer nicht zur Offenlegung vertraulicher Infor-
mationen der Gesellschaft oder von Gesellschaftsinformationen berechtigt, die den Interessen der Gesellschaft schaden
könnten, es sei denn, eine solche Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.
10. Vorstand.
10.1 Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer einen Vorstand (der „Vor-
stand“).
10.2 Der Vorstand ernennt einen Geschäftsführer zum Vorstandsvorsitzenden (der „Vorstandsvorsitzende“).
11. Befugnisse der Geschäftsführung.
11.1 Der Geschäftsführer oder der Vorstand (je nachdem, was zutreffend ist) (die „Geschäftsführung“) ist mit der
Befugnis ausgestattet, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Maßnahmen administrativer oder anordnender
Natur durchzuführen bzw. zu genehmigen, die im Sinne der Erreichung des Zwecks der Gesellschaft erforderlich bzw.
nützlich sind. Alle Befugnisse, die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg nicht ausdrücklich den Gesell-
schaftern vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung.
11.2 Die Geschäftsführung kann auch einen oder mehrere beratende Ausschüsse bestellen und deren Zusammenset-
zung und Zweck bestimmen.
11.3 Die Geschäftsführung kann bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate einschließlich der Vertretung
gegenüber Drittparteien auf einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Dritte übertragen, wobei diese
jeweils allein oder gemeinsam handeln können.
12. Sitzungen des Vorstands und Schriftform der Beschlüsse.
12.1 Der Vorstand tritt auf Antrag eines beliebigen Vorstandsmitglieds zusammen.
12.2 Der Vorstandsvorsitzende informiert alle Vorstandsmitglieder mittels einer schriftlichen Mitteilung oder per E-
Mail über den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung. Diese Mitteilung muss den Vorstandsmit-
gliedern mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zugehen. Im Fall von Sitzungen, die an Orten, an Tagen und
zu Uhrzeiten, die im Voraus durch einen Vorstandsbeschluss festgelegt wurden, und in dringenden Fällen ist eine geson-
derte Mitteilung nicht erforderlich.
12.3 Auf das Erfordernis einer Mitteilung kann durch einstimmige schriftliche Zustimmung aller Vorstandsmitglieder
bei der Sitzung des Vorstands oder auf andere Weise verzichtet werden.
12.4 Der/die Vorstandsvorsitzende hält den Vorsitz bei allen Vorstandssitzungen. Ist er/sie abwesend, kann der Vor-
stand ein anderes Mitglied zum/zur Vorstandsvorsitzenden auf Zeit bestimmen, wenn eine Mehrheit der auf der
entsprechenden Sitzung anwesenden bzw. vertretenen Geschäftsführer dies mittels Abstimmung beschließt.
12.5 Der Vorstand kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht selbst Geschäftsführer sein muss und der für die
Führung der Protokolle der Vorstandssitzungen und Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.
12.6 Vorstandsmitglieder können an jeder beliebigen Vorstandssitzung mitwirken, indem sie eine anderes Vorstands-
mitglied schriftlich zur ihrem Vertreter ernennen.
12.7 Vorstandsmitglieder können an einer Vorstandssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher
Kommunikationsmittel teilnehmen, die es mehreren daran teilnehmenden Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander
zu kommunizieren. Eine derartige Teilnahme ist als der physischen Anwesenheit bei einer Sitzung gleichwertig zu be-
trachten.
12.8 Zur Beschlussfähigkeit des Vorstands bedarf es der Anwesenheit oder Vertretung der Mehrheit der amtierenden
Vorstandsmitglieder, vorausgesetzt, dass, sofern anwendbar, zumindest ein Vorstandsmitglied der Kategorie A und ein
Vorstandsmitglied der Kategorie B anwesend sind. Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit der bei der betreffenden
Sitzung anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder getroffen, und diese Mehrheit muss, sofern anwendbar, zu-
mindest ein Vorstandsmitglied der Kategorie A und ein Vorstandsmitglied der Kategorie B einschließen.
12.9 Beschlüsse des Vorstands werden durch eine Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden bzw. ver-
tretenen Vorstandsmitglieder gefasst. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den
Ausschlag.
58541
L
U X E M B O U R G
12.10 Das Protokoll der Vorstandsbeschlüsse muss im Rahmen der entsprechenden Sitzung abgefasst und von allen
anwesenden Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden. Etwaige Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.
12.11 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ebenso ordnungsgemäß und
gültig wie ein Beschluss, der bei einer Vorstandssitzung gefasst wurde, die ordnungsgemäß einberufen und abgehalten
wurde. Eine solche Entscheidung kann entweder durch ein einzelnes Dokument, das von allen Geschäftsführern unter-
zeichnet wurde, oder durch mehrere separate Dokumente belegt werden, die alle den gleichen Inhalt haben und jeweils
von einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet wurden.
12.12 Sofern nur ein Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin ernannt wurde, hat dieser/diese Protokolle seiner/ihrer
Entscheidungen schriftlich aufzusetzen und diese zu unterzeichnen.
12.13 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Vorstandssitzung sind vom Vorstand zu beglaubigen.
13. Vertretung der Gesellschaft.
13.1 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Un-
terzeichnung durch diesen Geschäftsführer gebunden.
13.2 Sofern die Gesellschaft von einem Vorstand geleitet wird, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die
gemeinsame Unterzeichnung seitens zweier beliebige Vorstandsmitglieder gebunden.
13.3 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten nur durch die gemeinsamen Unterschriften
eines Klasse-AGeschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers gebunden, wenn der alleinige Gesellschafter oder
die Gesellschafter (je nachdem, was zutreffend ist) (einen) Klasse-A- und Klasse-B-Geschäftsführer ernannt haben.
13.4 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch jedwede Person vertreten, der vom
Einzelvorstand bzw. vom Vorstand gültige Vertretungsbefugnis erteilt worden ist.
14. Interessenkonflikt.
14.1 Vorbehaltlich des Nachstehenden gelten die in Artikel 57 des Gesetzes vorgesehenen Regeln zum Interessen-
konflikt.
14.2 Kein Vertrag und kein sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder eines
anderen Unternehmens wird allein durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere ordnungsge-
mäß ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich ihrer Geschäftsführer, an der besagten anderen Gesellschaft
oder dem besagten anderen Unternehmen (i) persönlich beteiligt ist oder (ii) einen ordnungsgemäß bevollmächtigter
Vertreter und/oder Gesellschafter derselben ist/sind.
14.3 Falls der Einzelvorstand bzw. alle Vorstandmitglieder einen Interessenkonflikt bzgl. einer bestimmten Angelegen-
heit haben, wird die Angelegenheit von der Gesellschafterversammlung bzw. dem Einzelgesellschafter entschieden.
15. Entschädigung der Vorstandsmitglieder.
15.1 Die Gesellschaft wird den Einzelvorstand bzw. die Vorstandsmitglieder und gegebenenfalls ihre Rechtsnachfolger,
Erben, Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter gegen Schäden und Aufwendungen, die vernünftigerweise in Verbin-
dung mit einem Rechtsstreit, einer Klage oder einem sonstigem Verfahren erlitten hat, an dem/der er (sie) Streitpartei
wurde(n) aufgrund seiner (ihrer) Stellung als amtierendes oder ehemaliges Vorstandsmitglied oder, auf Antrag der Ge-
sellschaft, jeder anderen Gesellschaft, in der die Gesellschaft Aktionärin oder gegenüber der sie Gläubigerin ist und soweit
sie gegenüber dieser anderen Gesellschaft kein Recht auf Entschädigung haben.
15.2 Entschädigung wird nur geleistet wenn und soweit der Einzelvorstand bzw. die Vorstandsmitglieder in einem
Rechtsstreit, einer Klage oder einem sonstigem Verfahren nicht rechtskräftig für grobe Fahrlässigkeit oder Fehlverhalten
oder Vorsatz verurteilt wird.
15.3 Im Falle eines Vergleichs wird Entschädigung nur und nur soweit geleistet, als die Gesellschaft von ihrem Rechts-
beistand darauf hingewiesen wird, dass der Einzelvorstand bzw. die Vorstandsmitglieder seine/ihre Pflichten nicht verletzt
hat/haben.
15.4 Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte, die dem Einzelvorstand bzw. den Vorstands-
mitgliedern und gegebenenfalls ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern gege-
benenfalls zustehen, nicht aus.
16. Audit.
16.1 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer erforderlich
ist und die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaft von
einem oder mehreren gesetzlichen Wirtschaftsprüfern zu prüfen, bei denen es sich entweder um einen oder mehrere
Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.
16.2 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer erforderlich
ist und die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) Gesellschafter oder weniger hat, können die Gesellschafter entscheiden, ohne
hierzu verpflichtet zu sein, die Jahresabschlüsse von einem oder mehreren gesetzlichen Wirtschaftsprüfern prüfen zu
lassen, bei denen es sich entweder um Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.
16.3 Der/Die Wirtschaftsprüfer ist/sind von den Gesellschaftern zu ernennen, die (i) die Anzahl der Wirtschaftsprüfer,
(ii) die Vergütung des/der Wirtschaftsprüfer(s) und (iii) die Dauer des Mandats des/der Wirtschaftsprüfer(s) bestimmen.
58542
L
U X E M B O U R G
Der/Die Wirtschaftsprüfer bleibt/bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie können am Ende ihrer Beauf-
tragungszeit wiedergewählt werden und können jederzeit mit oder ohne Grund von den Gesellschaftern aus ihrem Amt
enthoben werden.
Gesellschafter
17. Gesellschafterbeschlüsse.
17.1 Die Gesellschafter können Beschlüsse entweder im Rahmen von Gesellschafterversammlungen oder, unter Vor-
behalt der in dieser Satzung definierten Beschränkungen und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, durch
schriftliche Beschlüsse fassen.
17.2 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, sofern nicht anderweitig durch die Gesetze des Großherzogtums Lu-
xemburg vorgegeben.
17.3 Änderungen der Satzung müssen (i) durch Mehrheit der Gesellschafter nach Köpfen und (ii) drei Viertel des
ausgegebenen Gesellschaftskapitals genehmigt werden, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzog-
tums Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich.
17.4 Alle anderen Gesellschafterbeschlüsse werden durch Gesellschafter getroffen, die mehr als die Hälfte des ausge-
gebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegeln, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg erforderlich. Wenn bei der ersten Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit erreicht wird,
werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal zusammengerufen oder zur Abstimmung gebeten und Be-
schlüsse werden in diesem Fall durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig von dem Anteil des
vertretenen ausgegebenen Gesellschaftskapitals.
18. Schriftliche Beschlüsse.
18.1 Wenn die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter hat, müssen die Gesellschafterbeschlüsse
nicht in Gesellschafterversammlungen verabschiedet werden, sondern können auch durch schriftliche Beschlüsse verab-
schiedet werden.
18.2 Der Text von Beschlüssen, die durch schriftlichen Beschluss getroffen werden sollen, wird den Gesellschaftern
durch das Management per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zugesandt. Gesellschafter sind verpflichtet, ihre Stimme
abzugeben und sie innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt des Briefes dem Management der Gesellschaft per
Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zurückzusenden. Stimmen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums abgegeben werden,
gelten als Enthaltungen.
18.3 Die formellen in Paragraph 18.2 dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschaf-
terbeschlüssen können durch einstimmigen schriftlichen Beschluss aller Gesellschafter in dem jeweiligen schriftlichen
Beschluss oder anderweitig aufgehoben werden
Die formellen in Paragraph 18.2 dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbe-
schlüssen gelten nicht, wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat. Alle durch einen alleinigen Gesellschafter
getroffenen Beschlüsse müssen jedoch schriftlich dokumentiert und von dem alleinigen Gesellschafter unterzeichnet
werden.
18.4 Kopien oder Auszüge der schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse sind vom Management zu bestätigen.
19. Gesellschafterversammlungen.
19.1 Eine Jahreshauptversammlung muss nur abgehalten werden, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25)
Gesellschafter hat. In diesem Fall werden diese Satzung dahingehend geändert, dass sie das Datum und die Uhrzeit ent-
halten, zu dem solche Jahreshauptversammlung stattzufinden hat.
19.2 Außerordentliche Gesellschafterversammlungen werden im Einklang mit den Gesetzen des Großherzogtums Lu-
xemburg durch Mitteilung des Management, des/der Wirtschaftsprüfer(s) der Gesellschaft oder des/der Gesellschafter
(s), der/die mindestens die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegelt, einberufen.
19.3 Eine Gesellschafterversammlung darf nur im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach Meinung des Manage-
ment aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.
19.4 Die Mitteilung zur Einberufung der Gesellschafterversammlung und zur Angabe des Ortes, des Datums, der
Uhrzeit und der Agenda solcher Versammlung ist den Gesellschaftern mindestens acht (8) Tage vor der Gesellschafter-
versammlung zuzusenden. Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung zugegen oder Vertretern sind,
können sie erklären, dass sie über die Agenda der Versammlung informiert wurden und können auf die obengenannte
Anforderung der vorherigen Mitteilung verzichten.
19.5 Ordnungsgemäß zusammengesetzte Gesellschafterversammlungen vertreten die Gesellschafter der Gesellschaft.
19.6 Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, übt solcher Gesellschafter die Befugnisse aus, die der
Hauptversammlung gemäß geltenden Gesetzen und dieser Satzung gewährt werden. Artikel 194 bis 196 und 199 des
Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung, gelten für diese Situation nicht.
20. Verfahren bei Gesellschafterversammlungen.
20.1 Ein Gesellschafter kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung durch Ernennung eines Vertreters, entweder
schriftlich oder per Fax, handeln. Bei solchem Vertreter muss es sich nicht um einen Gesellschafter handeln.
58543
L
U X E M B O U R G
20.2 Gesellschafter können durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationswege, die die
gleichzeitige Kommunikation mehrerer Personen miteinander ermöglichen, an einer Gesellschafterversammlung teilneh-
men. Solche Teilnahme gilt als gleichwertig zu einer physischen Präsenz bei der Versammlung.
20.3 Das Management kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die erfüllt werden müssen, um an einer Gesell-
schafterversammlung teilzunehmen.
20.4 Der/Die Vorstandsvorsitzende oder im Falle seiner/ihrer Abwesenheit eine beliebige andere von den Gesell-
schaftern ernannte Person, führt den Vorsitz über jede Gesellschafterversammlung (der/die „Vorsitzende der Gesell-
schafterversammlung“).
20.5 Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt ein/e Sekretär/in. Die Gesellschafter ernennen ei-
nen oder mehrere Stimmrechtsprüfer. Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bildet zusammen mit dem/
der Sekretär/in und dem/den Stimmrechtsprüfer(n) das Vorsitzgremium der Hauptversammlung (das „Vorsitzgremium“).
20.6 Die Mitglieder des Vorsitzgremiums müssen eine Teilnehmerliste unter Angabe (i) des Namens der Gesellschafter,
(ii) der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Anteile und, wenn zutreffend, (iii) des Namens ihres Vertreters anfertigen
und unterzeichnen.
20.7 Das Vorsitzgremium hat ferner Protokoll über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zu führen und dieses
Protokoll zu unterzeichnen.
20.8 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Gesellschafterversammlung sind vom Vorstand zu bestätigen.
Finanzjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember.
22. Genehmigung des Jahresabschlusses.
22.1 Am Ende jedes Finanzjahres werden die Bücher abgeschlossen und der Vorstand erstellt den Jahresabschluss der
Gesellschaft gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg.
22.2 Der Vorstand reicht den Jahresabschluss der Gesellschaft bei dem/den etwaigen Wirtschaftsprüfer(n) der Ge-
sellschaft zur Prüfung ein und legt ihn den Gesellschaftern zur Genehmigung vor.
22.3 Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss beim Geschäftssitz der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen der
Gesetze des Großherzogtums Luxemburg einsehen.
23. Gewinnverteilung. Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die Rücklagen eingestellt,
wie gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg erforderlich. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich,
sobald und solange die Rücklagen zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft betragen.
Die Gesellschafter bestimmen, wie der restlichen Jahresnettogewinn verteilt wird. Die Rücklagen können ganz oder
teilweise eingesetzt werden, um (i) etwaige existierende Verluste aufzufangen, (ii) als Rücklagen oder Rückstellungen
genutzt zu werden, (iii) sie zum nächsten folgenden Finanzjahr zu übertragen oder (iv) um den Gesellschaftern als Divi-
dende ausgeschüttet zu werden.
24. Abschlagsdividenden.
24.1 Der Vorstand ist befugt, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt, dass ein Zwischenabschluss erstellt
wurde und dass solcher Zwischenabschluss zeigt, dass die Gesellschaft über ausreichend verfügbare Mittel für solche
Ausschüttung verfügt.
Auflösung, Liquidierung
25. Auflösung und Liquidation.
25.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann von seinen Gesellschaftern mit der gleichen beschlussfähigen Mehrheit be-
schlossen werden, die für die Änderung dieser Satzung erforderlich ist, sofern die Gesetze des Großherzogtums
Luxemburg nicht anderweitige Bestimmungen enthalten.
25.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern
ernannte/n Liquidator(en) durchgeführt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Befugnisse und die Vergütung des
Liquidators/der Liquidatoren.
25.3 Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden und Gebühren gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und
Auslagen in Verbindung mit dem Liquidationsprozess wird das restliche Nettovermögen der Gesellschaft den Gesell-
schaftern anteilig zur Anzahl der Anteile, die sie jeweils halten, ausgeschüttet.
Geltendes recht
26. Geltendes Recht.
26.1 Alle Angelegenheiten, die nicht dieser Satzung unterliegen, werden gemäß geltendem Recht entschieden.
58544
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Datum und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, erklärte danach die Zeichnung und vollständige Zahlung in bar
der gesamten zwölftausend fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennbetrag von jeweils einem Euro (1 EUR), von der
Gesellschaft ausgegeben.
Dem unterzeichnenden Notar wurde ein Beleg für solche Zahlung vorgelegt. Der unterzeichnende Notar erklärt, dass
die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften, wie gemäß Artikel 1832 des Zivilgesetz-
buches geändert, dargelegten Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllt wurden und bezeugt ausdrücklich ihre
Erfüllung.
<i>Außerordentliche Gesellschaftsversammlungi>
Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, verabschiedete danach in seiner Kapazität als alleiniger Ge-
sellschafter der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:
1. Die Gesellschaft wird von drei (3) Geschäftsführern vertreten (die „Geschäftsführer“):
- Herr Mariano PEREZ-DURANTEZ, geboren in Valladolid, Spain am 28. März 1979, mit beruflicher Adresse in Prinz-
regentenstrasse 56, 80538 München, Deutschland, als A Geschäftsführer;
- Frau Katia CAMBON, geboren in Le Raincy, Frankreich am 24. Mai 1972, mit beruflicher Adresse in 16, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxemburg, als B Geschäftsführer; und
- Frau Marina KERNEUR, geboren in Ploemeur, Frankreich am 19. Juni 1978, mit beruflicher Adresse in 16, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxemburg, als B Geschäftsführer.
2. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft ist unter der Adresse 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg
(Großherzogtum Luxemburg).
<i>Kosteni>
Auslagen, Kosten und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu entrichten sind,
betragen etwa 1.600,- EUR.
WORÜBER URKUNDE aufgenommen zu Redingen, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung
der oben erschienen Parteien die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst
ist, und dass auf Hinweis derselben erschienen Parteien im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen
Versionen, die englische Version maßgebend sein soll.
Nachdem diese Urkunde dem anwesenden Bevollmächtigten, welche dem unterzeichnenden Notar nach Name, Nach-
name, Familienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat der Bevollmächtigten zusammen mit dem Notar
diese Urkunde unterzeichnet.
Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 5 mai 2015. Relation: DAC/2015/7309. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J.THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 5 mai 2015.
Référence de publication: 2015067451/689.
(150076923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.
1000.lu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 46, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 151.373.
<i>Ausserordentliche Verwaltungsratsversammlung vom 23. März 2015i>
1. Der Sitz der Firma 1000.lu S.A., wird von L-6630 Wasserbillig, 66, Grand Rue nach L-6630 Wasserbillig, 46, Grand
Rue zum 24.03.2015 verlegt.
Wasserbillig, den 23. März 2015.
Marzena Mirocha.
Référence de publication: 2015047494/11.
(150053509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
58545
L
U X E M B O U R G
Heritam SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 56.140.
HeritageWealth SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 150.901.
En l'an deux mille quinze, le vingt-sept avril:
Par devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg:
ONT COMPARU
(A) HERITAM SICAV, une société de droit luxembourgeois constituée en la forme d'une société anonyme sous le
régime d'une société d'investissement à capital variable (la «SICAV») sous la Partie I de la loi modifiée du 17 décembre
2010 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»), ayant son siège social au 15, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 56.140,
(la «Société Absorbante»),
et
(B) HERITAGEWEALTH SICAV-SIF, une société de droit luxembourgeois constituée en la forme d'une société ano-
nyme sous le régime d'une société d'investissement spécialisée sous la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds
d'investissement spécialisés (la «Loi de 2007»), ayant son siège social au 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 150.901,
(la «Société Absorbée»),
collectivement désignées ci-après comme les «Parties à la Fusion»,
toutes deux représentées par Maître Benjamin BADA avocat, dont l'adresse professionnelle est 33, avenue J-F Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en tant que mandataire des Parties à la Fusion en vertu de
deux procurations conférées par décision du conseil d'administration prise en réunion du 22 avril 2015 dont une copie,
après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par le mandataire des Parties à la Fusion et le notaire instrumentant,
sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Ce projet commun de fusion par absorption (le «Projet Commun de Fusion») a été préparé par le conseil d'adminis-
tration de la Société Absorbée et celui de la Société Absorbante en vue de la fusion de la Société Absorbante et de la
Société Absorbée qui aura lieu par le biais de la fusion, dans la Société Absorbante au sein de son compartiment nouvel-
lement créé «Heritam SICAV - GLOBAL ALLOCATION» (le «Compartiment Absorbant»), des compartiments suivants
de la Société Absorbée (la «Fusion»): «HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED EUR» et «HeritageWealth SICAV-SIF
- BALANCED USD» (les «Compartiments Absorbés»), conformément à:
(a) la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»);
et
(b) les dispositions et conditions de ce Projet Commun de Fusion.
Suivant les dispositions de l'article 261 de la Loi de 1915, il a été convenu entre le conseil d'administration de la Société
Absorbante et celui de la Société Absorbée ce qui suit:
1. Parties à la fusion.
(a) Les Parties à la Fusion sont:
- Heritam SICAV, prénommée, en tant que Société Absorbante, cette dernière étant dûment autorisée au Luxembourg
en tant qu'OPCVM à compartiments multiples de la Partie I de la Loi de 2010, respectivement le Compartiment Absorbant;
et
- HeritageWealth SICAV-SIF, prénommée, en tant que Société Absorbée, cette dernière étant dûment autorisée au
Luxembourg au titre de la Loi de 2007, respectivement les Compartiments Absorbés.
(b) Après la réalisation de la Fusion, la Société Absorbante continuera à avoir son siège social au 15, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
(c) Par l'effet de la Fusion, les Compartiments Absorbés seront fusionnés dans le Compartiment Absorbant.
(d) L'éligibilité des actifs des Compartiments Absorbés fera l'objet d'une vérification dans le cadre de leur transfert au
sein du Compartiment Absorbant par l'effet de la Fusion et les actifs non éligibles seront ainsi réalisés avant la prise d'effet
de la Fusion. Les titres non-éligibles représentent 15.28% des avoirs du Compartiment Absorbé Balanced EUR et 15.39%
des avoirs du Compartiment Absorbé Balanced USD. Les titres non éligibles dans l'univers UCITS seront vendus avant
la Fusion. Si ces actifs ne sont pas éligibles, c'est principalement en raison de la possibilité offerte à ces fonds/ETFs d'investir
58546
L
U X E M B O U R G
plus de 10% de leurs actifs dans d'autres fonds, même si cette possibilité n'est pas utilisée. L'impact de la réalisation des
titres non-éligibles sur la valeur nette d'inventaire des Compartiments Absorbés sera pratiquement neutre. Le Compar-
timent Absorbant se conformera dès sa création par suite de la Fusion aux dispositions applicables, en ce compris les
règles de diversification, dans le cadre de la Loi de 2010.
2. Dispositions et conditions d'ordre réglementaire. La Fusion a été approuvée par la Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
3. Contexte et objectifs de la fusion proposée.
(a) Le conseil d'administration de la Société Absorbée a décidé de proposer à l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société Absorbée de fusionner les Compartiments Absorbés dans le Compartiment Absorbant afin de
permettre une commercialisation plus large des Compartiments Absorbés et donc de permettre une augmentation des
actifs de la structure ayant pour corolaire une optimalisation de la répartition des coûts fixes.
(b) La Fusion sera effectuée par l'absorption de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, respectivement des
Compartiments Absorbés, dans la Société Absorbante, respectivement le Compartiment Absorbant à la Date d'Effectivité
(telle que définie ci-après à la section 11), étant noté que:
- tous les actifs et passifs du compartiment «HeritageWealth SICAV - SIF - BALANCED EUR» de la Société Absorbée
seront transférés à la Société Absorbante pour compte du Compartiment Absorbant dénommé «Heritam SICAV - GLO-
BAL ALLOCATION» et alloués au titre de la classe d'actions dénommée «EUR Class» (comme décrit dans le point5.a.);
- tous les actifs et passifs du compartiment «HeritageWealth SICAV - SIF - BALANCED USD» de la Société Absorbée
seront transférés à la Société Absorbante pour compte du Compartiment Absorbant dénommé «Heritam SICAV - GLO-
BAL ALLOCATION» et alloués au titre de la classe d'actions dénommée «EUR Class» (comme décrit dans le point 5.a.).
4. Impact attendu de la fusion sur les actionnaires de la société absorbée.
(a) La Fusion proposée ne changera pas de manière substantielle la façon dont les actifs de la Société Absorbée,
respectivement des Compartiments Absorbés, sont gérés et alloués. Il n'y aura pas de changement matériel dans les frais
imposés par le Compartiment Absorbant suivant la réalisation de la Fusion.
(b) La Fusion proposée devrait avoir pour principal impact sur les actionnaires de la Société Absorbée, respectivement
les Compartiments Absorbés l'applicabilité des dispositions de la partie I de la Loi de 2010 telle que reflétée dans le
prospectus relatif au Compartiment Absorbant (disponible dans les conditions telles que décrites au point 12). Les ac-
tionnaires des Compartiments Absorbés sont invités à parcourir le prospectus relatif au Compartiment Absorbant.
Les différences principales entre les Compartiments Absorbés et le Compartiment Absorbant sont décrites ci-dessous.
Caractéristiques
principales
Société Absorbée
Société Absorbante
Objectif d’investissement La Société Absorbée a pour objectif
d’investissement le fait d’offrir un vaste
panel d’investissements à travers ses
compartiments et vise à fournir un retour
positif tout en contrôlant les risques. Pour
chaque compartiment, les objectifs
d’investissement, polices et spécificités
concernant l’offre d’actions et la gestion
des compartiments sont détaillés à
l’Appendice 1 du document d’émission
de la Société Absorbée.
L’objectif de la Société Absorbante est
d’offrir un vaste panel de marchés et une
variété de techniques d’investissement à
travers un choix de produits spécialisés
comme décrit pour chaque compartiment
dans le prospectus de la Société Absorbante.
Politique d’investissement Les Compartiments Absorbés visent à investir
principalement (1) dans toutes sortes de
valeurs, avec un revenu fixe ou variable,
incluant mais sans s’y limiter, les actions,
obligations (incluant mais sans s’y limiter les
coupons zéro, les obligations indexées ou
convertibles), (2) toute sorte d’instruments
financiers dérivés comme décrit plus en détail
dans le document d’émission, (3) les
instruments du marché monétaire, (4) dans
des produits structurés (comme décrit plus
en détail dans le document d’émission) en lien
avec la performance des valeurs ci-avant
mentionnées
Le Compartiment, en conformité avec les
dispositions applicables aux OPCVM, aura
une exposition sur les classes d’actifs
suivantes: les titres de dettes de tous types
(étatiques et sociales), incluant les
instruments du marché monétaires, les
actions et les titres apparentés aux actions,
les espèces, les devises, l’immobilier, les
matières premières, à titre accessoire
(incluant les métaux précieux)
Risques
Les risques liés à l’investissement dans la
Les risques liés à l’investissement dans la
Société Absorbée sont détaillés dans la
58547
L
U X E M B O U R G
Société Absorbée sont détaillés dans la partie
générale du document d’émission de la
Société Absorbée, notamment au paragraphe
5. «Risk Factors», et dans l’appendice 1
partie générale du prospectus de la Société
Absorbante, notamment au paragraphe 5.
«Risk Considerations», et dans l’appendice
1.
Profile de l’investisseur
type
Les actions des Compartiments Absorbés
sont réservées à des investisseurs éligibles,
tels que définis dans le document d’émission
de la Société Absorbée
Le profil de l’investisseur type pour les
classes d’actions du Compartiment
Absorbeur est décrit à l’appendice relative
au Compartiment Absorbeur
Classes d’Actions et
devises
HeritageWealth SICAV-SIFBalanced EUR
HeritageWealth SICAV-SIFBalanced USD
Heritam SICAV-Global Allocation “EUR”
Frais de souscription
Une commission de souscription peut être
appliquée, qui sera payée aux intermédiaires
et n’excèdera pas 3% de la valeur nette
d’inventaire de chaque action
Une commission de souscription peut être
appliquée, qui sera payée aux intermédiaires
et n’excèdera pas 5% de la valeur nette
d’inventaire de chaque action
Commission de
performance
Aucun
Aucun
Minimum initial et
investissement
subséquent
Non, sous réserve des exigences de la Loi
de 2007
EUR 1,000.-
Heure limite
Avant 16h00 (heure de Luxembourg), le
jour précédant le «Valuation Day»
(chaque jour ouvrable)
Avant 16h00 (heure de Luxembourg), le jour
précédant le «Calculation Day» (chaque jour
ouvrable)
Valeur net d’inventaire
La valeur net d’inventaire est calculée
chaque mercredi.
La valeur net d’inventaire est calculée chaque
jour ouvrable.
Société de gestion
N/A
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Commission de la société
de gestion
N/A
Max. 0.10% par an de la moyenne des actifs
nets, payable à partir des actifs des
compartiments, avec un minimum de
EUR60.000 pour la Société Absorbante pour
la première année, et ensuite avec un
minimum de EUR100.000 pour la Société
Absorbante les années suivantes.
Gestionnaire
Banque Heritage S.A.
Banque Heritage S.A.
Commission du
gestionnaire
Max. 1% par an de la moyenne des actifs nets,
payable à partir des actifs des compartiments
Max. 1.40% par an de la moyenne des actifs
nets, payable à partir des actifs des
compartiments
Dépositaire
Pictet & Cie (Europe) S.A. 15A, avenue J.
F.Kennedy L 1855 LUXEMBOURG
Pictet & Cie (Europe) S.A. 15A, avenue J.
F.Kennedy L 1855 LUXEMBOURG
Commission du
dépositaire
Les seuils et pourcentages suivants
s’appliquent par compartiment et sont basés
sur la moyenne des actifs nets par an:
- Actifs inférieurs à CHF50 millions (inclus):
0,12%.
- Actifs entre CHF50 millions et CHE100
millions (inclus): 0,1%.
- Actifs supérieurs à CHF100 millions:
0.08%.
Max. 0.12% par an de la moyenne des actifs
nets, payable à partir des actifs des
compartiments, avec un minimum de
EUR10.000 pour le Compartiment
Absorbant la première année, et ensuite
avec un minimum de EUR15.000 pour le
Compartiment Absorbant les années
suivantes.
Administration centrale
FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15,
avenue J. F. Kennedy L 1855
LUXEMBOURG
FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15,
avenue J. F. Kennedy L 1855 LUXEMBOURG
Commission de l’agent
d’administration
Les seuils et pourcentages suivants
s’appliquent par compartiment et sont basés
sur la moyenne des actifs nets par an:
- Actifs inférieurs à CHF50 millions (inclus):
0,2%.
- Actifs entre CHF50 millions et CHE100
millions (inclus): 0,15%.
- Actifs supérieurs
Max. 0.18% par an de la moyenne des actifs
nets, payable à partir des actifs des
compartiments, avec un minimum de
EUR20.000 pour le Compartiment
Absorbant la première année, et ensuite
avec un minimum de EUR150.000 pour la
Société Absorbante les années suivantes.
58548
L
U X E M B O U R G
Auditeur
PricewaterhouseCoopers 2, rue Gerhard
Mercator L-2182 Luxembourg Grand
Duchy of Luxembourg
PricewaterhouseCoopers 2, rue Gerhard
Mercator L-2182 Luxembourg Grand Duchy
of Luxembourg
(c) A compter de la Date d'Effectivité, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, respectivement des Compar-
timents Absorbés deviendront des actifs et passifs du Compartiment Absorbant, tel que décrit dans le point 3.b. La Société
Absorbée et les Compartiments Absorbés cesseront alors d'exister. Les actions des Compartiments Absorbés seront
automatiquement converties en actions du Compartiment Absorbant, comme décrit plus en détail dans la section 6 ci-
dessous.
(d) La Fusion étant effectuée par l'absorption de la Société Absorbée en vertu de laquelle tous les actifs et passifs des
Compartiments Absorbés seront alloués au Compartiment Absorbant nouvellement créé comme indiqué au présent
Projet Commun de Fusion, les actionnaires de la Société Absorbante ne seront pas affectés par la Fusion.
(e) Aucun frais de souscription ne sera prélevé par le Compartiment Absorbant en raison de la Fusion.
(f) Au sein du Compartiment Absorbant, il y aura une classe d'actions qui présentera les caractéristiques suivantes:
Dénomination
"EUR" Class
Devise de référence
euro
Prix de lancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 euros
5. Rémunération des actionnaires de la société absorbée par la société absorbante.
(a) La Société Absorbante, respectivement le Compartiment Absorbant, émettra au bénéfice des actionnaires des
Compartiments Absorbés des actions du Compartiment Absorbant de la classe d'actions suivante:
Compartiments actuels de
la Société Absorbée
Classes d’actions
Compartiment Absorbant
Classes
d’actions
HeritageWealth SICAV – SIF –
Balanced EUR
Actions
(avec une devise de référence en Euro)
Heritam SICAV GLOBAL
ALLOCATION
"EUR" Class
HeritageWealth SICAV – SIF –
Balanced USD
Actions
(avec une devise de référence en USD)
Heritam SICAV – GLOBAL
ALLOCATION
"EUR" Class
(b) Toutes les nouvelles actions du Compartiment Absorbant seront émises sous la forme nominative. Des fractions
d'actions seront émises jusqu'à cinq décimales, les fractions restantes étant arrondies au plus proche de ces cinq décimales.
L'agent de registre et de transfert de la Société Absorbante allouera les nouvelles actions du Compartiment Absorbant
aux anciens actionnaires de la Société Absorbée, respectivement des Compartiments Absorbés, sur base des données
contenues dans le registre des actionnaires de la Société Absorbée, respectivement des Compartiments Absorbés, à la
Date d'Effectivité.
(c) En accord avec ce qui précède, le compartiment «Heritam SICAV - GLOBAL ALLOCATION» est une masse
d'avoirs correspondant à une partie distincte des autres compartiments existants au sein du patrimoine de la Société
Absorbante. Les actionnaires des compartiments «HeritageWealth SICAV - SIF - Balanced EUR» et «HeritageWealth
SICAV - SIF - Balanced USD» de la Société Absorbée deviendront actionnaires du compartiment «Heritam SICAV -
GLOBAL ALLOCATION» de la Société Absorbante par l'effet de la Fusion et recevront donc des actions au titre de la
classe d'actions telle que décrite dans le tableau sous le point 5.a. pour une valeur nette d'inventaire tenant compte de
la valeur nette d'inventaire des actions qu'ils possèdent dans «HeritageWealth SICAV - SIF - Balanced EUR» et «Herita-
geWealth SICAV - SIF - Balanced USD» à la Date d'Effectivité. Dès lors, pour les actionnaires du compartiment
«HeritageWealth SICAV - SIF - Balanced EUR», le ratio d'échange sera déterminé sur base de la valeur nette d'inventaire
par actions calculée à la Date d'Effectivité multipliée par le nombre d'actions détenues dans le compartiment «Heritage-
Wealth SICAV - SIF - Balanced EUR» divisé par le prix initial de lancement des actions du Compartiment Absorbant (c'est-
à-dire divisé par 100 euros).
Actions = (VNI Compartiment Absorbé x Actions Détenues Compartiment Absorbé) / Prix Initial de Lancement
Légende:
«Actions»: nombre d'actions dans le Compartiment Absorbant que reçoit l'actionnaire du Compartiment Absorbé
concerné;
«VNI Compartiment Absorbé»: valeur nette d'inventaire de la classe d'actions concernée du Compartiment Absorbé
concerné, dont l'actionnaire détient des parts au jour du calcul du ratio d'échange;
«Actions Détenues Compartiment Absorbé»: nombre d'actions du Compartiment Absorbé détenues par l'actionnaire
concerné du Compartiment Absorbé concerné au jour du calcul du ratio d'échange;
«Prix Initial de Lancement»: prix initial de lancement fixé pour les actions du Compartiment Absorbant (à savoir 100.-
EUR).
De plus, pour les actionnaires du compartiment «HeritageWealth SICAV - SIF - Balanced USD», le ratio d'échange
sera déterminé sur base de l'équivalent en euro de la valeur nette d'inventaire par actions calculée à la Date d'Effectivité,
au taux de change du jour appliqué par la banque dépositaire de la Société Absorbante, multipliée par le nombre d'actions
détenues dans le compartiment «HeritageWealth SICAV - SIF - Balanced USD» divisé par le prix initial de lancement des
actions du Compartiment Absorbant (c'est-à-dire divisé par 100 euros).
58549
L
U X E M B O U R G
Actions = (VNI Compartiment Absorbé x Actions Détenues Compartiment Absorbé) / Prix Initial de Lancement
Légende:
«Actions»: nombre d'actions dans le Compartiment Absorbant que reçoit l'actionnaire du Compartiment Absorbé
concerné;
«VNI Compartiment Absorbé»: l'équivalent en euros de la valeur nette d'inventaire de la classe d'actions concernée
du Compartiment Absorbé concerné, dont l'actionnaire détient des parts au jour du calcul du ratio d'échange;
«Actions Détenues Compartiment Absorbé»: nombre d'actions du Compartiment Absorbé détenues par l'actionnaire
concerné du Compartiment Absorbé concerné au jour du calcul du ratio d'échange;
«Prix Initial de Lancement»: prix initial de lancement fixé pour les actions du Compartiment Absorbant (à savoir 100.-
EUR).
(d) Chaque actionnaire de la Société Absorbée, respectivement des Compartiments Absorbés, recevra une notification
endéans quinze jours à partir de la Date d'Effectivité confirmant (i) que la Fusion a été réalisée et (ii) le nombre d'actions
(incluant toute fraction d'action le cas échéant) de la classe d'actions dénommée "EUR" Class qu'il détient dans le Com-
partiment Absorbant suite à la Fusion.
6. Effet comptable de la fusion.
(a) L'exercice comptable de chaque société fusionnante coïncide avec l'année civile.
(b) A compter de la Date d'Effectivité, toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée pour compte des
Compartiments Absorbés seront considérées, à des fins comptables et fiscales, comme effectuées pour le compte de la
Société Absorbante, respectivement du Compartiment Absorbant.
(c) A compter de la Date d'Effectivité, les actifs et passifs de la Société Absorbée, respectivement de chacun des
Compartiments Absorbés, ainsi que tous leurs autres droits et obligations seront transmis au Compartiment Absorbant
(en accord avec le point 3.2 ci-dessus) à des fins comptables, et tout engagement pendant de tout compartiment actuel
de la Société Absorbée, respectivement de chacun des Compartiments Absorbés, existant, contingent ou autre, sera pris
en charge par le Compartiment Absorbant.
7. Droits spéciaux.
(a) La Société Absorbante, respectivement le Compartiment Absorbant, n'émettra pas d'actions ou d'autres formes
de valeurs mobilières assorties de droits spéciaux en raison de la Fusion.
(b) Les créanciers des Parties à la Fusion pourront exercer leurs droits conformément aux dispositions de l'article 268
de la Loi de 1915.
8. Réviseur d'entreprises agréé. Conformément aux dispositions de l'article 266(1) de la Loi de 1915, les modalités de
la Fusion seront examinées par un réviseur d'entreprises agréé, lequel sera désigné, sur requête conjointe des Parties à
la Fusion, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme
en matière de référé, dans le ressort duquel la Société Absorbante a son siège social, étant noté à cet égard que le réviseur
d'entreprise agréé désigné établira un seul rapport pour les Parties à la Fusion. Une copie du rapport du réviseur d'en-
treprises pourra être obtenue sur demande et sans frais aux sièges sociaux des sociétés fusionnantes.
9. Avantages spéciaux. Aucun avantage spécial n'a été ni ne sera accordé aux membres des conseils d'administration
de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, aux réviseurs d'entreprises de la Société Absorbante et de la Société
Absorbée, aux experts et conseils de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, ni à toute autre personne ou
entité en raison de la Fusion.
10. Date d'effectivité de la fusion.
(a) Il est noté que conformément à l'article 264 de la Loi de 1915, l'approbation de la Fusion par l'assemblée générale
de la Société Absorbante n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:
(i) la publicité du présent Projet Commun de Fusion est faite, pour la Société Absorbante, un mois au moins avant la
date de la réunion de l'assemblée générale de la Société Absorbée appelée à se prononcer sur le Projet Commun de
Fusion;
(ii) tous les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous le point
(i) ci-dessus, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 12 du présent
Projet de Fusion;
(iii) un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins 5 % des actions du capital souscrit a/
ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la Société Absorbée la convocation
d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la Fusion, étant noté que
l'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
(b) Lors de l'approbation de la Fusion (qui sera documentée par des résolutions sous forme notariée de l'assemblée
générale des actionnaires de la Société Absorbée, ou, le cas échéant, qui sera documentée par des résolutions sous forme
notariée de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée et de l'assemblée générale des actionnaires de
la Société Absorbante), qui ne peut avoir lieu moins d'un (1) mois après la publication du présent Projet Commun de
Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la Fusion deviendra effective et définitive et produira simul-
58550
L
U X E M B O U R G
tanément les effets énoncés à l'article 274 de la Loi de 1915 (la «Date d'Effectivité»). Durant une période de un mois, du
[11 mai 2015] au [10 juin 2015], chaque actionnaire de la Société Absorbée qui s'oppose aux changements induits par la
Fusion peut demander le rachat de ses actions, sans frais.
(c) La Fusion prendra effet et sera considérée comme définitive vis-à-vis des tiers à compter (i) de la date de publication
de l'acte notarié de la Société Absorbée constatant la décision de réaliser la Fusion (ou à compter de la date de publication
de l'acte notarié de la Société Absorbante, le cas échéant, si ce dernier est publié postérieurement à celui de l'acte notarié
de la Société Absorbée), telle qu'envisagée dans le présent Projet Commun de Fusion, et ce conformément aux disposi-
tions de l'article 9 de la Loi de 1915, et (ii) en cas d'absence d'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante,
de la date de publication d'un certificat d'un notaire établi à la requête de la Société Absorbante constatant que les
conditions de l'article 279 de la Loi de 1915 sont remplies.
(d) Calendrier d'implémentation de la Fusion
Notice aux actionnaires
11 mai 2015
Période de rachat sans frais par les actionnaires
11 mai 2015 au 10 juin 2015
Dernier jour de transaction dans les Compartiments Absorbés
10 juin 2015
Calcul du ratio d’échange (suspension des rachats, souscriptions et conversions)
17 juin 2015
Date d’éffectivité
17 juin 2015
11. Documents à la disposition des actionnaires des parties a la fusion.
(a) Les documents suivants seront disponibles aux sièges sociaux des Parties à la Fusion au plus tard un mois avant le
vote des résolutions finales visant à approuver la Fusion:
(i) le présent Projet Commun de Fusion;
(ii) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion de la Société Absorbante pour les périodes (a) du 1
er
janvier
2012 au 31 décembre 2012, (b) du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 et (c) du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre
2014;
(iii) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion de la Société Absorbée pour (a) du 1
er
janvier 2012 au 31
décembre 2012, (b) du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 et (c) du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014;
(iv) le rapport préparé conformément à l'article 265 de la Loi de 1915 par le conseil d'administration de la Société
Absorbée;
(v) le rapport du réviseur d'entreprises agréé pour les Parties à la Fusion préparé selon les dispositions de l'article 266
de la Loi de 1915;
(vi) le prospectus de la Société Absorbante avec l'annexe relative au Compartiment Absorbant; et
(vii) le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) concernant le Compartiment Absorbant.
(b) Les actionnaires des Parties à la Fusion peuvent obtenir, sur demande et sans frais, une copie des documents
susmentionnés.
12. Termes et conditions de la fusion. La Fusion sera sujette aux termes et conditions suivants:
(a) La Société Absorbante devra acquérir, pour compte du Compartiment Absorbant, l'intégralité des actifs de la
Société Absorbée, respectivement des Compartiments Absorbés, en leur état à la Date d'Effectivité, sans aucun droit de
recours contre la Société Absorbée.
(b) La Société Absorbée garantit la Société Absorbante, pour compte du Compartiment Absorbant, de l'existence de
toutes les créances comprises dans les actifs transférés mais n'assume aucune responsabilité quant à la solvabilité des
débiteurs concernés.
(c) La Société Absorbante devra, pour compte du Compartiment Absorbant et à partir de la Date d'Effectivité, payer
le cas échéant toutes les contributions, droits et taxes, ordinaires ou extraordinaires, dus à l'égard de la propriété des
actifs transférés.
(d) Tous les contrats et obligations, de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée, respectivement des Com-
partiments Absorbés, ne seront pas prorogés dans la mesure où la Société Absorbante, pour le compte du Compartiment
Absorbant, conclura les nouveaux contrats afférents nécessaires ou modifiera en conséquence les contrats existants.
(e) La Société Absorbante sera, pour compte du Compartiment Absorbant, subrogée dans tous les droits et obligations
qui découlent des contrats existants jusqu'à la Date d'Effectivité avec les créanciers de la Société Absorbée, respective-
ment des Compartiments Absorbés, à ses propres risques.
(f) Les droits et prétentions compris dans les actifs de la Société Absorbée, respectivement des Compartiments Ab-
sorbés, seront transférés à la Société Absorbante, pour compte du Compartiment Absorbant, avec tous les titres, réels
ou personnels, qui y sont attachés. La Société Absorbante sera, pour compte du Compartiment Absorbant, ainsi subrogée
dans tous les droits, réels ou personnels, de la Société Absorbée à l'égard de tous les actifs et à l'encontre de tous les
débiteurs sans exception.
(g) La Société Absorbante devra, sous réserve du principe de séparations des avoirs entre compartiments, pour compte
du Compartiment Absorbant, assumer toutes les dettes, de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée, respec-
58551
L
U X E M B O U R G
tivement des Compartiments Absorbés, et devra en particulier payer les intérêts et le principal de toutes les dettes et
passifs de toute nature, dus par la Société Absorbée, respectivement les Compartiments Absorbés.
(h) La Société Absorbante devra, pour compte du Compartiment Absorbant, libérer la Société Absorbée, respecti-
vement les Compartiments Absorbés, de toute action et revendication concernant les obligations et les devoirs ainsi
assumés jusque-là par la Société Absorbée, respectivement les Compartiments Absorbés.
(i) La Société Absorbante renonce, pour compte du Compartiment Absorbant, désormais formellement à tout droit
de privilège, d'hypothèque et action résolutoire qu'elle pourrait avoir à l'encontre la Société Absorbée, respectivement
les Compartiments Absorbés, du fait de la reprise par la Société Absorbante, à son nom mais pour compte du Compar-
timent Absorbant, des dettes, charges et obligations de la Société Absorbée, respectivement les Compartiments
Absorbés.
13. Conditions suspensives a la fusion. La Fusion par absorption de la Société Absorbée, respectivement des Com-
partiments Absorbés, au profit du Compartiment Absorbant de la Société Absorbante comme décrit au présent Projet
Commun de Fusion et la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée deviendront définitives à la réalisation des
conditions suspensives suivantes:
(a) l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbée du présent Projet
Commun de Fusion et de la transaction ainsi envisagée; et
(b) le non-exercice par un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins 5 % des actions
du capital du droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la Société Absorbée la convo-
cation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la Fusion (étant
noté que ladite assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition); ou,
(c) en cas d'exercice du droit susmentionné, l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la Société Absorbante du présent Projet Commun de Fusion et de la transaction ainsi envisagée.
14. Divers.
(a) La Société Absorbante procèdera à toutes les formalités, incluant les déclarations prescrites par la Loi de 1915,
nécessaires ou utiles afin de donner effet à la Fusion et de procéder au transfert des actifs et passifs décrit ci-dessus.
(b) A compter de la Date d'Effectivité, les livres et registres de la Société Absorbée, respectivement des Compartiments
Absorbés, seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant la période prescrite par la Loi de 1915.
(c) Les effets de la Fusion tombent sous l'empire du droit luxembourgeois, et dans la mesure où rien n'a été spécia-
lement prévu, les Parties à la Fusion se réfèrent à la Loi de 1915.
(d) Tout litige ou autre contentieux découlant de la Fusion ou lié à celle-ci - y compris tout litige quant à sa validité -
sera soumis aux tribunaux de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
(e) Les coûts et frais de la Fusion seront supportés par le Compartiment Absorbant.
<i>Constatationsi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
En conformité avec l'article 271 (2) de la Loi de 1915, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et attesté la validité,
d'un point de vue du droit luxembourgeois, du présent Projet de Fusion.
<i>Frais et dépensesi>
La Société Absorbante supportera tous les frais, charges et dépenses relatifs au présent accord.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
s'élèvent cinq mille quatre cent cinquante euros (5.450,-EUR).
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes,
le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise et qu'à la demande des mêmes comparantes et
en cas de divergences entre les deux versions, la version française primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparantes, connus du notaire soussigné par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and fifteen, the twenty second day of April.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
(A) HERITAM SICAV, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) organised as an investment
company with variable capital (the SICAV) organised under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010, relating
to undertakings for collective investment (the 2010 Law), having its registered office at 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
58552
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the "Registre de Commerce et des Sociétés" of Lux-
embourg under number B 56.140,
(the Absorbing Company),
and
(B) HERITAGEWEALTH SICAV-SIF, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) organised as an
investment company with variable capital and qualifying as a specialised investment fund organised under the Luxembourg
law of 13 February 2007, relating to specialised investment fund, as amended (the 2007 Law), having its registered office
at 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the "Registre de
Commerce et des Sociétés" of Luxembourg under number B 150.901,
(the Absorbed Company),
hereinafter collectively referred to as the Merging Parties,
all represented for the purpose hereof by Maître Benjamin BADA, lawyer, with professional address at 33, avenue J-
F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in his/her capacity as proxyholder of the Merging
Parties by virtue of a proxy given by the board of Directors, in accordance with the resolutions taken during the meeting
dated on April 22, 2015. The said proxies, after having been initialled and signed “ne varietur” by the proxyholder of the
Merging Parties, and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.
This common merger project by absorption (the Common Merger Project) has been prepared by the board of di-
rectors of the Absorbed Company and the board of directors of the Absorbing Company for the purpose of the merger
of the Absorbing Company and the Absorbed Company which will be made through the merger, in the Absorbing Com-
pany within its newly created compartment "Heritam SICAV - GLOBAL ALLOCATION" (the Absorbing Compartment),
of the following compartments of the Absorbed Company (the Merger): "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED EUR"
and "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED USD" (the Absorbed Compartments), in accordance with:
(a) the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law); and
(b) the terms and conditions included in this Common Merger Project.
In accordance with the article 261 of the 1915 Law, the board of directors of the Absorbing Company and the board
of directors of the Absorbed Company agree as follows:
1. The merging parties.
(a) The Merging Parties are:
- Heritam SICAV, prenamed, as Absorbing Company, the latter being duly authorised in Luxembourg as an umbrella
UCITS under Part I of the 2010 Law, respectively the Absorbing Compartment; and
- HeritageWealth SICAV-SIF, prenamed, as Absorbed Company, the latter being duly authorised in Luxembourg under
the 2007 Law, respectively the Absorbed Compartments.
(b) After the completion of the Merger, the Absorbing Company's registered office will remain at 15, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
(c) As a result of the Merger, the Absorbed Compartments will be merged into the Absorbing Compartment.
(d) The eligibility of the assets of the Absorbed Compartments will be verified in the context of the Merger when
transferring it within the Absorbing Compartment and the non-eligible assets will be realised before the Merger being
effective. Non-eligible assets represent 15.28% of the assets of the Absorbed Compartment “Balanced EUR” and 15.39%
of the assets of the Absorbed Compartment “Balanced USD”. Non-eligible assets will be realised before the Merger being
effective. The reason of the non-eligibility of those assets mainly resides in the possibility offered to the funds/ETFs to
invest more than 10% of their assets in other funds, even if this possibility is not used. The impact of the realisation of
the non-eligible assets on the net asset value of the Absorbed Compartments will be practically neutral. The Absorbing
Compartment will comply from its inception in the context of the Merger with applicable provisions, including but without
limitation to diversification requirements, as provided for by the 2010 Law.
2. Regulatory provisions and conditions. The Merger has been approved by the Luxembourg supervisory authority for
the financial sector (ie, "la Commission de Surveillance du Secteur Financier"").
3. Background and rationale of the proposed merger.
(a) The board of directors of the Absorbed Company decided to propose to the extraordinary general meeting of the
shareholders of the Absorbed Company to merge the Absorbed Compartments into the Absorbing Compartment in
order to enable a broader marketing of the Absorbed Compartments and therefore to lead to an increase of the assets
of the structure which implies an optimal allocation of the fixed costs.
(b) The Merger will be implemented by the absorption of all assets and liabilities of the Absorbed Company, respectively
of the Absorbed Compartments, in the Absorbing Company, respectively in the Absorbing Compartment as of the
Effective Date (as defined hereinafter under section 11), being noted that:
- All the assets and liabilities of the compartment "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED EUR" of the Absorbed
Company will be transferred in the Absorbing Company on behalf of the Absorbing Compartment called "Heritam SICAV
- GLOBAL ALLOCATION" and allocated under the class of shares called "EUR" Class (as described in the point 5.a.);
58553
L
U X E M B O U R G
- All the assets and liabilities of the compartment "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED USD" of the Absorbed
Company will be transferred in the Absorbing Company on behalf of the Absorbing Compartment called "Heritam SICAV
- GLOBAL ALLOCATION" and allocated under the class of shares called "EUR" Class (as described in the point 5.a.).
4. Expected impact of the proposed merger on the shareholders of the absorbed company.
(a) The proposed Merger will not substantially change the way the Absorbed Company's assets, respectively the
Absorbed Compartments, are managed and allocated. There will be no material change in the fees charged by the Ab-
sorbing Compartment further to the completion of the Merger.
(b) The main impact on the shareholders on the Absorbed Company, respectively on the Absorbed Compartments,
concerns the applicability of the provisions of the part I of the 2010 Law as reflected 16 in the prospectus of the Absorbing
Compartment (as further described under item 12). Shareholders of the Absorbed Compartments are requested to read
the prospectus of the Absorbing Compartment.
The main characteristics between the Absorbed Compartments and the Absorbing Compartment are described in
the table below.
Main characteristics
Absorbed Company
Absorbing Company
Investment Objective
The Absorbed Company has as investment
objective to offer a wide range of investments
through its Compartments aiming at
providing a favourable return, while
controlling risks. For each Compartment, the
investment objectives and policies and the
specificities as to the offering of the Shares
and the management of the Compartment are
set out in Appendix 1 of the issuing document
of the Absorbed Company.
The purpose of the Absorbing is to offer
investors access to a worldwide selection of
markets and a variety of investment
techniques via a range of speciality products,
as further described for each Compartment
in the prospectus of the Absorbing
Company.
Investment Policy
The Absorbed Compartments intend to
invest mainly (1) in all kinds of securities, with
fixed or variable income, including, but not
limited to, equity, bonds (including but not
limited to zero-coupon, indexed or
convertible bonds), commodity related
products, (2) in all kind of financial derivative
instruments as further described in the issuing
document (3) in money market instruments
(4) in structured products (as further
described in the issuing document) linked to
the performance of the above-mentioned
securities.
The Compartment will, in full compliance
with dispositions applicable to UCITS and,
have an exposure to the following asset
classes: debt securities of any type
(government debt and corporate debt)
including money market instruments,
equities and equity related securities, cash,
currencies, real estate and commodities on
an ancillary basis (including precious metals).
Investment Risks
Investment risks related to the Company are
further described in the general part of the
issuing document of the Absorbed Company,
in particular under paragraph 5. "Risk factors"
and in Appendix 1.
Investment risks related to the Company are
further described in the general part of the
issuing document of the Absorbed
Company, in particular under paragraph 5.
"Risk consideration" and in the appendix
related to the Absorbed Compartment.
Profile of typical investor Shares of the Absorbed Compartment are
dedicated to Eligible Investors, as defined in
the issuing document of the Absorbed
Company.
The profile of the typical (potential) investor
for classes of shares of the Absorbed
Compartment is further described in in the
appendix related to the Absorbed
Compartment.
Share Classes and
currency
HeritageWealth SICAV – SIF –
Balanced EUR Actions
HeritageWealth SICAV – SIF –
Balanced USD Actions
Heritam SICAV GLOBAL ALLOCATION
"EUR" Class
Subscription Charges
subscription commission may be added,
which will be paid to intermediaries and does
not exceed 3 % of the net asset value of each
share
subscription commission may be added,
which will be paid to intermediaries and does
not exceed 5 % of the net asset value of each
share
Performance related fees None
None
Minimum Initial and
subsequent Investment
No, nothwistanding the requirements of
the Law of 2007
EUR1'000
58554
L
U X E M B O U R G
Cut-Off Time
Cut off Time: before 4.00 p.m. Luxembourg
time, preceding a Valuation Day
(each Business day)
Cut-Off Time: 4.00 p.m. Luxembourg time
on the Business Day before the applicable
Calculation Day (each Business Day).
Net Asset Value
The NAV is calculated on Wednesdays.
The NAV is calculated each business day.
Management Company
N/A
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Management company
fee
N/A
Max. 0.10 fee per year of the average net
assets attributable to this type of share out
of the assets of the compartment, with a
minimum of EUR60,000 for the Absorbing
Company for the first year, and with a
minimum of EUR100,000 for the Absorbing
Companing for the following years.
Investment manager
Banque Heritage S.A.
Banque Heritage S.A.
Investment management
fee
Max. 0.10 fee per year of the average net
assets attributable to this type of share out
of the assets of the compartment.
Max. 1.40 fee per year of the average net
assets attributable to this type of share out
of the assets of the compartment.
Custodian
Pictet & Cie (Europe) S.A. 15A, avenue J.
F.Kennedy L 1855 LUXEMBOURG
Pictet & Cie (Europe) S.A. 15A, avenue J.
F.Kennedy L 1855 LUXEMBOURG
Custodian fee
The following tresholds apply to each
compartment and are based on the average
net assets per year:
- Assets below CHF50 mio. (inclusive): 0.12%.
- Assets between CHF50 and CHF100 mio.
(inclusive):0.1%.
- Assets above CHF100mio.: 0.08%.
Max. 0.12 fee per year of the average net
assets attributable to this type of share out
of the assets of the compartment, with a
minimum of EUR10,000 for the Absorbing
Compartment the first year, .and with a
minimum of EUR15,000 for the Absorbing
Compartment the following years.
Administrative Agent,
Paying Agent, Listing
Agent, Domiciliary and
Corporate Agent and
Registrar and Transfer
Agent
FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15,
avenue J. F. Kennedy L 1855
LUXEMBOURG
FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15,
avenue J. F. Kennedy L 1855 LUXEMBOURG
Administrative agent fee The following tresholds apply to each
compartment and are based on the average
net assets per year:
- Assets below CHF50 mio. (inclusive): 0.2%.
- Assets between CHF50 and CHF100 mio.
(inclusive):0.15%.
- Assets above CHF100mio.: 0.1%.
Max. 0.18 fee per year of the average net
assets attributable to this type of share out
of the assets of the compartment, with a
minimum of EUR20,000 for the Absorbing
Compartment the first year, and with a
minimum of EUR150,000 for the Absorbing
Company the following years.
Auditor
PricewaterhouseCoopers 2, rue Gerhard
Mercator L-2182 Luxembourg Grand
Duchy of Luxembourg
PricewaterhouseCoopers 2, rue Gerhard
Mercator L-2182 Luxembourg Grand Duchy
of Luxembourg
(c) As of the Effective Date, all assets and liabilities of the Absorbed Company, respectively of the Absorbed Com-
partments will become assets and liabilities of the Absorbing Compartment, as described under the point 3.b. The
Absorbed Company and the Absorbed Compartments will then cease to exist. The shares of the Absorbed Compart-
ments will be automatically converted into shares of the Absorbing Compartment, as further described below under
section 6.
(d) The Merger being implemented by the absorption of the Absorbed Company whereby all the assets and liabilities
of the Absorbed Compartments will be allocated to a newly created Absorbing Compartment as indicated in the present
Common Merger Project, the shareholders of the Absorbing Company will not be impacted by the Merger.
(e) No subscription fee will be levied within the Absorbing Compartment as a result of the Merger.
(f) Within the Absorbing Compartment, there will be one call of shares which will have the following features:
Denomination
"EUR" Class
Functional currency
Euro
Launching price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Euro
5. Remuneration of the absorbed company's shareholders by the absorbing company.
(a) The Absorbing Company, respectively the Absorbing Compartment, will issue, to the benefit of the shareholders
of the Absorbed Compartments, shares of the Absorbing Compartment of the following class of shares:
58555
L
U X E M B O U R G
Actual Compartments of the
Absorbed Company
Class of shares
Absorbing Compartment
Class of shares
HeritageWealth SICAV –
SIF – Balanced EUR
Shares
(with a reference currency in Euro)
Heritam SICAV GLOBAL
ALLOCATION
"EUR" Class
HeritageWealth SICAV –
SIF – Balanced USD
Shares
(with a reference currency in USD)
Heritam SICAV – GLOBAL
ALLOCATION
"EUR" Class
(b) All the new shares of the Absorbing Compartment will be issued in registered form. Fractions of shares of up to
five decimal places will be issued, the outstanding fraction will be rounded to the nearest of these five decimals. The
registrar and transfer agent of the Absorbing Company will allocate the new shares of the Absorbing Compartment to
the former shareholders of the Absorbed Company, respectively of the Absorbed Compartments, on the basis of data
contained in the register of shareholders of the Absorbed Company, respectively of the Absorbed Compartments, as of
the Effective Date.
(c) In accordance with the foregoing, the compartment "Heritam SICAV - GLOBAL ALLOCATION" is a pool of assets
corresponding to a distinct part from the other existing compartments within the assets of the Absorbing Company. The
shareholders of the compartments "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED EUR" and "HeritageWealth SICAV-SIF -
BALANCED USD" of the Absorbed Company will become shareholders of the compartment "Heritam SICAV - GLOBAL
ALLOCATION" of the Absorbing Company as a result of the Merger and will therefore receive shares in the class of
shares as described in the table under point 5.a. for net asset value taking into account the net asset value of the shares
they own in "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED EUR" and "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED USD" as of
the Effective Date.
As a consequence, for the shareholders of the compartment "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED EUR", the
exchange ratio will be determined on the basis of the net asset value by shares calculated as of the Effective Date multiplied
by the number of shares held in the compartment "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED EUR" divided by the initial
subscription price of the shares of the Absorbing Compartment (ie, divided by 100 Euro).
Share = (NAV Absorbed Compartments x number of shares hold in the Absorbed Copartment) / Initial subscription
price per share of the Absorbing Compartment
Where:
"Shares" means the number of shares of the Absorbing Compartment to be issued to the relevant shareholder of the
relevant Absorbed Compartment;
"NAV Absorbed Compartment" means the net asset value per share of the corresponding share class of the relevant
Absorbed Compartment in which the relevant shareholder is invested as of the day of the calculation of the share ratio;
"number of shares held in the Absorbed Compartment" means the number of shares held by the relevant shareholder
of the relevant Absorbed Compartment on the day of the calculation of the share ratio;
"Initial subscription price per share of the Absorbing Compartment" means the initial subscription price at the launching
of the Absorbing Compartment (i.e. EUR100) For shareholders of "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED USD", the
exchange ratio will be determined on the basis of the equivalent in Euro of the net asset value by shares calculated as of
the Effective Date, as per the exchange rate on that day applied by the custodian bank of the Absorbing Company,
multiplied by the number of shares held in the compartment "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED USD" divided by
the initial launching price of the shares of the Absorbing Compartment (ie, divided by 100 Euro).
Share = (NAV Absorbed Compartments x number of shares hold in the Absorbed Compartment) / Initial subscription
price per share of the Absorbing Compartment
Where:
"Shares" means the number of shares of the Absorbing Compartment to be issued to the relevant shareholder of the
relevant Absorbed Compartment;
"NAV Absorbed Compartment" means the equivalent in Euro of the net asset value per share of the corresponding
share class of the relevant Absorbed Compartment in which the relevant shareholder is invested as of the day of the
calculation of the share ratio;
"number of shares held in the Absorbed Compartment" means the number of shares held by the relevant shareholder
of the relevant Absorbed Compartment on the day of the calculation of the share ratio;
"Initial subscription price per share of the Absorbing Compartment" means the initial subscription price at the launching
of the Absorbing Compartment (i.e. EUR100).
(d) Each shareholder in the Absorbed Company, respectively in the Absorbed Compartments, will receive a notification
within 15 calendar days as of the Effective Date confirming (i) that the Merger has been carried out and (ii) the number
of shares (including any fraction of share, if applicable) of the class of shares denominated "EUR" Class that he/she/it holds
in the Absorbing Compartment following the Merger.
6. Accounting effect of the merger.
(a) The accounting year of each of the merging companies coincides with the calendar year.
58556
L
U X E M B O U R G
(b) As of the Effective Date, all operations and transactions of the Absorbed Company on behalf of the Absorbed
Compartments shall be considered, for accounting and tax purposes, as being carried out on behalf of the Absorbing
Company, respectively of the Absorbing Compartment.
(c) As of the Effective Date, the Absorbed Company's assets and liabilities, respectively of any of the Absorbed Com-
partments, as well as any of their other rights and obligations shall be transferred to the Absorbing Compartment (in
accordance with the above point 3.b. for accounting purposes, and all outstanding liabilities of any actual compartment
of the Absorbed Company, respectively of each of the Absorbed Compartments, existing, contingent, or otherwise, will
be assumed by the Absorbing Compartment.
7. Special rights.
(a) The Absorbing Company, respectively the Absorbing Compartment, will not issue shares or other forms of se-
curities granting special rights as a result of the Merger.
(b) Creditors of the Merging Companies may exercise their rights in accordance with article 268 of the 1915 Law.
8. Approved independent auditor. In accordance with the provisions of article 266(1) of the 1915 Law, the terms of
Merger will be examined by a single approved independent auditor, the latter being appointed, at the joint request of the
Merging Companies, by the judge presiding the chamber of the District Court (tribunal d'arrondissement) dealing with
commercial matters, in the district in which the registered office of the Absorbing Company is located, sitting as in urgency
matters, being noted that such approved independent auditor will draw up a single report for both Merging Parties. A
copy of the report of the independent auditor will be available on request and free of charge at the registered offices of
the merging companies.
9. Special advantages. No special advantages were or shall be granted in connection with the Merger to the members
of the boards of directors of the Absorbing Company and of the Absorbed Company, the auditors of the Absorbing
Company and of the Absorbed Company, the experts and advisers of the Absorbing Company and of the Absorbed
Company, or any other person or entity.
10. Effective date of the merger.
(a) It is noted that according to article 264 of the 1915 Law, the approval of the Merger by the general meeting of the
Absorbing Company is not required if the following conditions are fulfilled:
(i) the publication of the present Common Merger Project is done, for the Absorbing Company, at least one month
before the date of the general meeting of the Absorbed Company convened to vote on the Common Merger Project;
(ii) all the shareholders of the Absorbing Company are entitled, at least one month before the date indicated under
the above point (i), to consult, at the registered office this company, the documents listed in article 12 of the present
Common Merger Project;
(iii) one or more shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the shares of the subscribed capital
is/are entitled up to the day following the holding of the general meeting of the Absorbed Company to require the
convening of a general meeting of the Absorbing Company to vote on the approval of the Merger, being noted that such
general meeting has to be convened in such a manner as to be held within one month of the request.
(b) During the Merger approval (which will be documented by the resolutions under notarized form of the share-
holders' general meeting of the Absorbed Company, or, as the case may be, which will be documented by the resolutions
under notarized form of the shareholders' general meeting of the Absorbed Company and of the shareholders' general
meeting of the Absorbing Company), which cannot take place less than one (1) month after the publication of the present
Common Merger Project in the Mémorial C, "Recueil des Sociétés et Associations", the Merger shall become effective
and final and shall at the same time produce the effects specified in article 274 of the 1915 Law (the Effective Date). During
the one month period referred to above, from 11 May 2015 until 10 June 2015, any shareholder of the Absorbed Company
who objects to these modifications may request the redemption of their shares, at no cost.
(c) The Merger shall become effective and final vis-à-vis third parties upon (i) publication of the notarial deed of the
Absorbed Company recording the decision to implement the Merger (or as from the publication date of the notarial deed
of the Absorbing Company, as the case may be, if the latter is published after the related notarial deed of the Absorbed
Company), as contemplated by this present Common Merger Project, in accordance with the provisions of Article 9 of
the 1915 Law, and (ii) in the absence of an extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbing Company,
upon the date of publication of a notary certificate drawn up at the request of the Absorbing Company recording that
the conditions of article 279 of the 1915 Law are fulfilled.
(d) Timeline and planned Effective Date
Notice to shareholders
11 May 2015
Redemption period free of charge for shareholders
11 May 2015 - 10 June 2015
Last trading day in the Absorbed Compartments
10 June 2015
Calculation of share exchange ratio (no subscription, redemption or
conversaion accepted)
17 June 2015
Effective Date
17 June 2015
58557
L
U X E M B O U R G
11. Documents available for the shareholders of the merging parties.
(a) The following documents will be available at the registered offices of the Merging Parties not later than one month
before the vote on the final resolutions aiming at approving the Merger:
(i) this present Common Merger Project;
(ii) the annual accounts and the management reports of the Absorbing Company for the periods (A) from 1 January
2012 until 31 December 2012, (B) from 1 January 2013 until 31 December 2013 and (C) from 1 January 2014 until 31
December 2014;
(iii) the annual accounts and the management reports of the Absorbed Company for the periods (A) from 1 January
2012 until 31 December 2012, (B) from 1 January 2013 until 31 December 2013 and (C) from 1 January 2014 until 31
December 2014;
(iv) the report prepared in accordance with article 265 of the 1915 Law by the board of directors of the Absorbed
Company;
(v) the report of the independent auditor for both Merging Parties prepared in accordance with article 266 of the 1915
Law;
(vi) the prospectus of the Absorbing Company which includes the appendix related to the Absorbing Compartment;
and
(vii) the key investor information document (KIID) concerning the Absorbing Compartment.
(b) The shareholders of the Merging Parties may obtain, upon request and free of charge, copies of the above-listed
documents.
12. Terms and conditions of the merger. The Merger will be subject to the following terms and conditions:
(a) The Absorbing Company shall acquire, on behalf the Absorbing Compartment, all the assets of the Absorbed
Company, respectively of the Absorbed Compartments, as they are on the Effective Date, without any right of recourse
against the Absorbed Company.
(b) The Absorbed Company guarantees the Absorbing Company, on behalf the Absorbing Compartment, of the ex-
istence of all receivables comprised in the transferred assets but cannot be held liable with regard to the concerned
debtors' state of solvency.
(c) The Absorbing Company, on behalf the Absorbing Compartment and as from the Effective Date, shall pay, as the
case may be, all ordinary or extraordinary contributions, charges and taxes, arising from the transfer of the transferred
assets.
(d) All the contracts and obligations, of any nature, of the Absorbed Company, respectively of the Absorbed Com-
partments, shall not be continued to the extent the Absorbing Company, on behalf of the Absorbing Compartment, will
enter into the new related contracts which are necessary or will modify accordingly the existing contracts.
(e) The Absorbing Company shall, on behalf the Absorbing Compartment, be subrogated, at its own risks, into the
rights and duties arising from the contracts existing as of the Effective Date with the creditors of the Absorbed Company,
respectively of the Absorbed Compartments.
(f) The rights and claims derived from the assets of the Absorbed Company, respectively of the Absorbed Compart-
ments, will be transferred to the Absorbing Company, on behalf of the Absorbing Compartment, with all their attached
real or personal titles. The Absorbing Company will, on behalf the Absorbing Compartment, thus be subrogated into all
rights, real or personal, of the Absorbed Company in respect of all these assets and towards all the debtors without any
exception.
(g) The Absorbing Company shall, subject to the principle of the segregations of assets between compartments, on
behalf the Absorbing Compartment, undertake all the debts of the Absorbed Company, respectively of the Absorbed
Compartments, and shall more specifically pay all the interests and the principal amount of all debts of any nature what-
soever, due by the Absorbed Company, respectively by the Absorbed Compartments.
(h) The Absorbing Company shall, on behalf the Absorbing Compartment, release the Absorbed Company, respectively
the Absorbed Compartments, from any action and claim concerning the duties and obligations as previously assumed by
the Absorbed Company, respectively by the Absorbed Compartments.
(i) The Absorbing Company now formally waives, on behalf the Absorbing Compartment, any right of privilege, of
mortgage and resolutive action it may have against the Absorbed Company, respectively against the Absorbed Compart-
ments, due to the recovery by the Absorbing Company, in its name but on behalf of the Absorbing Compartment, of the
debts, charges and obligations of the Absorbed Company, respectively of the Absorbed Compartments.
13. Conditions precedent to the merger. The Merger by absorption of the Absorbed Company, respectively of the
Absorbed Compartments, to the benefit of the Absorbing Compartment of the Absorbing Company as described in the
present Common Merger Project and the dissolution without liquidation of the Absorbed Company will become final
upon the fulfilment of the following conditions precedent:
(a) the approval by the extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbed Company of the present
Common Merger Project and of the related specified transaction; and
58558
L
U X E M B O U R G
(b) the non-exercise by one or more shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the shares of the
subscribed capital of the right to require up to the day following the holding of the general meeting of the Absorbed
Company the convening of a general meeting of the Absorbing Company to vote on the approval of the Merger (being
noted that such general meeting has to be convened in such a manner as to be held within one month of the request);
or,
(c) in case of exercise of the above-mentioned right, the approval by the extraordinary general meeting of the share-
holders of the Absorbing Company of the present Common Merger Project and of the related specified transaction.
14. Miscellaneous.
(a) The Absorbing Company shall carry out all formalities, including the declarations prescribed by the 1915 Law,
necessary or relevant to give effect to the Merger and to proceed with the transfer of assets and liabilities described
above.
(b) As of the Effective Date, the books and records of the Absorbed Company, respectively of the Absorbed Com-
partments, shall be kept at the registered office of the Absorbing Company during the period prescribed by the 1915
Law.
(c) The effects of the Merger shall be governed by the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, and to the extent
nothing has been specifically provided for in that respect, the Merging Parties refer to the 1915 Law.
(d) All legal and other disputes arising out of or in connection with the Merger, including disputes about its validity,
shall be exclusively settled by the courts of the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
(e) The expenses and costs of the Merger will be borne by the Absorbing Compartment.
<i>Statementsi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 279 as amended of the law of August 10
th
,
1915 on commercial companies have been observed.
In accordance with article 271 (2) of the 1915 Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the
validity, under Luxembourg law, of the Common Merger Project. Which act made and passed in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, on the date written above.
<i>Costs and expensesi>
The Absorbing Company shall bear all costs, charges and expenses relating to the present merger' statement (constat
de fusion).
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Absorbing Company as a result of the present deed is estimated to be approximately five thousand four hundred fifty
Euro (EUR 5,450.-).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
French followed by an English version and that at the request of the appearing persons and in case of divergences between
the two versions, the French version will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Signé: B. BADA, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/12965. Reçu douze euros (EUR 12,-)
<i>Le Receveuri> (signé): T. BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2015.
Référence de publication: 2015063054/788.
(150072215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.
Hairdreams by M.H. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5480 Wormeldange, 31, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 190.953.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015047788/10.
(150054751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.
58559
L
U X E M B O U R G
Erste Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 97.240.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 23 mars 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015045009/12.
(150051660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
ANFA II S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 195.469.
EXTRAIT
I. Dénomination et durée. La société en commandite spéciale ayant pour dénomination «Anfa II S.C.Sp», a été con-
stituée par acte sous seing privé signé en date du 19 mars 2015 pour une durée illimitée (ci-après la «Société»).
II. Siège social. Le siège social de la Société est établi au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
III. Objet social. Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société est le suivant:
« 4. Objet social de la société.
4.1 La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise quelle que soit sa forme, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.
4.2 La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute sorte et de toute origine, participer
à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie
de vente, de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle.
4.3 La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou
entités dans lesquelles elle détient une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société
(y compris ses Associés ou entités affiliées) ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de
charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses actifs de la Société.
4.4 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique (pour autant que prohibé
par les lois applicables). Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et
obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances.
4.5 En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent direc-
tement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.»
IV. Désignation des associés solidaires. L’associé commandité de la Société est Anfa II Management S.à r.l., une société
à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et en cours d’immatriculation auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg.
V. Désignation des gérants. Anfa II Management S.à r.l., précitée, a été nommée en tant que associé commandité gérant
pour une durée illimitée.
VI. Pouvoir de signature du gérant. Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature de son
associé commandité gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 mars 2015.
Référence de publication: 2015044257/42.
(150050583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
58560
1000.lu S.A.
Accenture International Capital SCA
Advanced Capital Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Alacer Gold Corp. S.à r.l.
Alacer Gold Holdings Corp. S.à r.l.
Ampere Luxembourg S.à r.l.
ANFA II S.C.Sp
Apex S.A.
Arachy Private S.A. SPF
Atelier d'Architecture din @ 3 Muller & Simon S.àr.l.
Athena Private Equity S.A.
BEOOGO S.àr.l.
Bib-Be in Balance
Brand France S.A.S. succursale Luxembourg
Cavim S.A., SPF
CID Holdings S.à r.l.
Cloud Managed Data
COF III Holdings (Lux) S.à r.l.
Croc'Time S.A.
Den Holzwuerm
Erste Reinsurance S.A.
Gleinor Holding S.A.
Hairdreams by M.H. S.à r.l.
Hansainvest Lux Umbrella
HeritageWealth SICAV-SIF
Heritam SICAV
ISOLA Développement
KBK Development
L.A. Productions
LBPAM European Debt Funds
Lennox Consulting S.A.
Mabel 2
Metec S.A.
Real Estate Development 2015 S.à r.l.
Rehoss S.à r.l.
Starmaker S.A. - SPF
Suco S.A.
The Next Big Thing S.à r.l.
Triton Luxembourg II GP Anton S.C.A.
UniAbsoluterErtrag
UniAbsoluterErtrag
YG S.à r.l.
Zolpan-Selco SA