This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1205
8 mai 2015
SOMMAIRE
Allegretto Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . 57807
An-Ca.Lux S,A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57802
Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. . . . . 57816
Belgofin S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57800
Berg Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57800
Bonbonera Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57799
Bonvalot S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57798
Bpi VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57799
Broad Street Loan Partners 2013 Onshore
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57838
Brookfield Properties (Luxembourg)
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57799
BTG Pactual E&P S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . 57812
Business Car Lux SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57801
Capital City Brewing Co. . . . . . . . . . . . . . . . 57794
Cellmedia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57794
C.G.R.H. s.à.r.l. (Conseil en gestion des res-
sources humaines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57800
Clove Management S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . 57794
Colday S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57801
ColLir S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57801
Colony Funds Sants S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . 57801
DD Performance Lux, Société Civile . . . . . 57835
Falco Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57794
Fiduciaire Comptable Luxconcept Sàrl . . . 57795
Finapar S.à r.l. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57796
For-Sci-Tech Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57796
Franciacorta Property Management S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57795
Franciacorta Property Management S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57796
Goron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57840
HBM Place d'Armes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 57796
Heisieh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57795
Huyan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57797
IK Investment Partners A S.à r.l. . . . . . . . . 57795
IK Investment Partners VII A S.à r.l. . . . . . 57798
Immobilière de la Rocade S.à r.l. . . . . . . . . 57797
INVESTIMENTI RETTIFICHE INDUS-
TRIALI Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . 57800
IRAF Heidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57794
Media Inside S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57815
Mediterranean Shipping Company Luxem-
burg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57815
Plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57811
R&S Schmieden Holztreppen S.à r.l. . . . . . 57798
SIG Combibloc Holdings GP S.à r.l. . . . . . . 57797
Treveria Four S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57798
Twinhope Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57816
Vespa A S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57795
Wyeth Ayerst Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57803
57793
IRAF Heidi, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 181.018.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015043548/9.
(150050116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
Capital City Brewing Co., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 127.487.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015044303/10.
(150050794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Clove Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.161.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015044331/10.
(150051010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Cellmedia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 75.417.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2015044325/12.
(150050643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Falco Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 169.867.
<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 19 mars 2015i>
Monsieur Stéphane Cosco, employé privé, né le 5 juin 1976 à Villerupt (F) demeurant professionnellement au 3, Place
Dargent, L-1413 Luxembourg est coopté administrateur en remplacement de Monsieur Pascal De Graeve, démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2017.
Certifié sincère et conforme
FALCO INVESTMENTS S.A
Référence de publication: 2015045769/13.
(150052309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
57794
IK Investment Partners A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 166.976.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 347 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015045867/9.
(150052367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Vespa A S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 144.458.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015046153/10.
(150052288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Fiduciaire Comptable Luxconcept Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 15, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 93.769.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015046408/10.
(150053279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Franciacorta Property Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 102.990.
Je soussigné, M. Alessandro CUSUMANO, suis au regret de vous informer, que je ne serai plus en mesure d'assumer
les fonctions d'administrateur de votre société à compter de ce jour et vous présente donc ma démission.
Je vous saurais gré de bien vouloir procéder aux formalités légales de publication de la présente démission.
Luxembourg, le 27 février 2015.
Alessandro CUSUMANO.
Référence de publication: 2015046421/11.
(150053041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Heisieh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 158.522.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 2 mars 2015 que le siège social
de la société a été transféré de son ancienne adresse au 10, rue Antoine Jans à L-1820 Luxembourg.
En outre, il est à noter que Monsieur Andrea DE MARIA et Madame Laurence BARDELLI, actuels administrateurs,
sont désormais domiciliés au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Référence de publication: 2015046453/14.
(150053330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
57795
For-Sci-Tech Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Z.I. 2000 - route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 61.479.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015046419/9.
(150052891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Franciacorta Property Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 102.990.
Je soussigné, M. Massimiliano SELIZIATO, suis au regret de vous informer, que je ne serai plus en mesure d'assumer
les fonctions d'administrateur de votre société à compter de ce jour et vous présente donc ma démission.
Je vous saurais gré de bien vouloir procéder aux formalités légales de publication de la présente démission.
Luxembourg, le 27 février 2015.
Massimiliano SELIZIATO.
Référence de publication: 2015046422/11.
(150053041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Finapar S.à r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 163.972.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 mars 2015 que:
1. L'assemblée transfère le siège social au 4 avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015046397/15.
(150053409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
HBM Place d'Armes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 5, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 109.899.
<i>Décision de l'associéi>
En date de ce jour, il a été décidé de transférer le siège social de HBM Place d'Armes Sàrl avec effet immédiat:
ancienne adresse: 13, Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
nouvelle adresse: 5, Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
Luxembourg, le 9 mars 2015.
BM Place d'Armes SA
<i>Associé unique
i>Malou MOLITOR
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2015046452/19.
(150052982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
57796
Huyan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 57.090.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 mars 2015, il résulte que les opérations de liquidation
de la société anonyme HUYAN S.A. (en liquidation) (ci-après dénommée la «Société») ont été définitivement clôturées
et que la Société a cessé d'exister.
Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de
la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2015046463/17.
(150053089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Immobilière de la Rocade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 53, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 159.383.
EXTRAIT
La gérance de la Société porte à la connaissance de tiers que:
a. - l'Associée unique de la Société SARL DE L'ALZETTE a changé sa dénomination en PLATINIUM REALTY et a
transféré l'adresse de son siège social vers L-2520 Luxembourg, 53, Allée Scheffer
b. - que l'Adresse du siège social de la Société est transférée vers L-2520 Luxembourg, 53, Allée Scheffer
c. - que l'Adresse professionnelle des gérants est actuellement à: L-2520 Luxembourg, 53, Allée Scheffer
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Miloud / Jamal les AKDIME
<i>Les gérantsi>
Référence de publication: 2015046467/18.
(150053450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
SIG Combibloc Holdings GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 191.807.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mars 2015 que:
- Monsieur John T. McCoy, à démissionné de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 4 mars
2015.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société se compose des gérants suivants:
- Monsieur Jean Lemaire, gérant de catégorie A, et
- Monsieur Christian Dam-Rasmussen, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2015.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015047398/19.
(150053891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
57797
IK Investment Partners VII A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 166.977.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 346 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015045869/9.
(150052465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
R&S Schmieden Holztreppen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodingen, 26, avenue Dr Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 113.711.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG MALDENER S.A.R.L.
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
i>31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature
Référence de publication: 2015046621/13.
(150053462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Bonvalot S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 143.312.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, lei>
<i>22 avril 2014i>
Reconduction du mandat des administrateurs de Messieurs Marc Ambroisien, Adrien Mantione et Madame Elise Le-
thuillier, ainsi que du Commissaire aux Comptes, Fiduciaire Simmer et Lereboulet S.A., pour une durée de un.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015046902/15.
(150054006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Treveria Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 123.350.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises pas l'associé unique de la Société du 20 mars 2015 que:
- La démission de M. Jérôme TIBESAR, gérant de la Société, avec effet immédiat, a été acceptée;
- La personne suivante a été nommée gérant de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée:
* Mme Caroline GOERGEN, née le 9 juin 1979 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Référence de publication: 2015046678/16.
(150053149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
57798
Brookfield Properties (Luxembourg) Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.613.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration de la Maison-mère en date du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2014i>
Le siège de la Succursale a été transféré de 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg à 13-15
avenue de la Liberté, L- 1931 Luxembourg avec effet au 1
er
décembre 2014.
Luxembourg, le 26 mars 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Brookfield Properties (Luxembourg) Branch
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015046884/14.
(150054224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Bonbonera Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 121.311.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 juillet 2014, Monsieur Geoffrey HUPKENS, domicilié
professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été nommé administrateur en remplacement de
Madame Marie Laurence THILL, démissionnaire.
Le mandat du nouvel Administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2019.
Luxembourg, le 25 mars 2015.
<i>Pour: BONBONERA GROUP S.A.
i>Société Anonyme
Experta Luxembourg
Société Anonyme
Référence de publication: 2015046881/16.
(150053900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Bpi VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 192.093.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 24 mars 2015i>
En date du 24 mars 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Madame Anne Catherine GRAVE de son mandat de gérant de catégorie B de la Société
avec effet au 20 mars 2015;
- de nommer Madame Sonia BALDAN, née le 27 janvier 1960 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant
à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie
B de la Société avec effet au 20 mars 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Collin J. BEECROFT, gérant de catégorie A
- Monsieur Ian SANDFORD, gérant de catégorie A
- Madame Catherine KOCH, gérant de catégorie B
- Madame Sonia BALDAN, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2015.
BPI VII S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015046904/24.
(150053687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
57799
C.G.R.H. s.à.r.l. (Conseil en gestion des ressources humaines), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8215 Mamer, 11, rue Bellevue.
R.C.S. Luxembourg B 49.143.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015046914/9.
(150053583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
IRI Luxembourg S.A., INVESTIMENTI RETTIFICHE INDUSTRIALI Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 182.836.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015046485/10.
(150052884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Belgofin S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 35.221.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 8 avril 2014i>
Sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de
2020:
Madame Sylvie THEISEN en tant qu'administrateur et administrateur-délégué, Madame Caterina SCOTTI et Madame
Carla DOS SANTOS en tant qu'administrateurs de la société, toutes trois avec adresse professionnelle au 2bis, rue Astrid,
L-1143 Luxembourg
La société D.S. CORPORATION S.A., ayant son siège social au 2bis, rue Astrid, L-1143 Luxembourg en tant que
Commissaire aux Comptes
Pour extrait sincère et conforme
BELGOFIN S.A. - SPF
Référence de publication: 2015046889/17.
(150054217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Berg Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 97.647.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 23 mars 2015 a renouvelé le mandat de l'administrateur unique.
- Monsieur Richard HAWEL, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, Luxembourg, administrateur
unique.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2019.
L'assemblée générale du 23 mars 2015 a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2019.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
<i>Pour BERG HOLDING S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2015046890/18.
(150053610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
57800
Colday S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 134.365.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015046927/10.
(150054004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Colony Funds Sants S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 149.338.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015046928/10.
(150053979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Business Car Lux SC, Société Civile.
R.C.S. Luxembourg E 5.117.
Le siège social de la société,
Business Car Lux SC, société civile,
RCS Luxembourg E5117
fixé au 22, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 16 mars 2015 et la convention de
domiciliation a été résiliée.
Luxembourg, le 16 mars 2015.
ATS Consulting Sàrl
Signature
Référence de publication: 2015046911/14.
(150054346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
ColLir S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1511 Luxembourgh, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 194.869.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession sous seing privé intervenu en date du 23 Mars 2015, que:
Colony Luxembourg S.à r.l., une Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 88.540, dont le siège social est situé au 121 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg,
a cédé à:
ColFin Lir Funding, L.LC, «a Limited Liability Company», immatriculée sous le numéro 5713259 dont le siège social
est situé au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, l'entièreté des parts sociales de la Société
ColLir S.à r.l. à savoir, douze mille six cents (12.600) parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Najat MOKHNACHE
<i>Mandataire habilitéi>
Référence de publication: 2015046929/20.
(150054134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
57801
An-Ca.Lux S,A,, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-9976 Sassel, Maison 8.
R.C.S. Luxembourg B 83.360.
L’an deux mille quinze, le treize mars.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «AN-CA.LUX S.A.», ayant son siège social
à L-9976 Sassel, 8, Maison, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 83360, constituée sous la dénomination de PARTILUX S.A. suivant acte reçu par Maître Robert SCHUMAN,
notaire alors de résidence à Rambrouch, le 26 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 328 du 8 juillet 1996, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné
du 21 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 754 du 19 avril 2011.
L'assemblée est présidée par Madame Brigitte Bernard, comptable, demeurant professionnellement à Rippweiler.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné.
Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent quarante (1.240) actions représentant l’in-
tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés
se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion en actions nominatives des actions au porteur de la Société ainsi qu’annulation de la totalité des certificats
représentatifs des actions au porteur et création d’un registre des actions nominatives;
2. Modification afférente de l’article 3 des statuts;
3. Pouvoir au conseil d’administration pour l’accomplissement des formalités en relation avec le point 1.;
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, l’assemblée générale
extraordinaire prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de convertir en actions nominatives, les mille deux cent quarante (1.240)
actions au porteur de la Société représentant la totalité des actions au porteur émises par la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts de la Société
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) représenté par mille deux cent quarante
(1.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) par action.
Toutes les actions sont et resteront nominatives. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de donner tout pouvoir au conseil d’administration pour procéder:
- à l’annulation de la totalité des certificats représentatifs des actions au porteur de la Société.
- à la création d’un registre des actions nominatives qui sera tenu au siège social de la Société.
57802
Ledit registre sera établi selon les dispositions de l’article 39 de la loi du 10 août 1915.
<i>Fraisi>
Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prén-
om, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bernard, Nezar, Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8131. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015045566/69.
(150052685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Wyeth Ayerst Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.053.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth of February,
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Pfizer Transactions LLC, a limited liability company organised under the laws of the State of Delaware, United States
of America, with address at: 235 East 42
nd
Street, New York, NY 10017, the United States of America, acting in its
capacity as the sole general partner of Pfizer Business Entreprises C.V., a limited partnership (commanditaire vennoot-
schap) organized under the laws of the Netherlands, having its registered seat in Rotterdam, the Netherlands, registered
with the Trade Register held by the Chamber of Commerce in Rotterdam, the Netherlands, under number 55510213
and having its business address at the address of its sole general partner,
duly represented by Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald,
Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on February 20, 2015;
PFIZER UNIT TRUST, being incorporated and validly existing under the laws of United States of America having its
registered office at 235 East 42
nd
Street, New York, New York 10017 5755, United States of America duly represented
by Pharmacia LLC, a Delaware limited liability company, organized pursuant to the provisions of the Delaware Limited
Liability Act _ having its registered office at 100 Route 206 North Peapack, New Jersey 07977, United States of America,
as custodian for G.D. Searle LLC in its capacity as trustee of the PFIZER UNIT TRUST,
duly represented by Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald,
Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on February 20, 2015.
Which proxies shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named parties and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Pfizer Business Entreprises C.V. and Pfizer Unit Trust are the partners in Wyeth Ayerst S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.053 (the “Company”) incorporated by deed of the
aforementioned notary on October 23, 2009 published in the Memorial C number 2297 on November 24, 2009 and last
amended by deed of the undersigned notary on 20 February 2015, not yet Memorial C.
The appearing parties representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners resolve, in accordance with Article 189 of the Company Law of August 10, 1915, to agree that PFIZER
PFE FRANCE HOLDCO 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 192
874 (“PFIZER PFE FRANCE HOLDCO 2”) enters into the share capital of the Company by subscribing to the New Shares
to be issued (as described below).
57803
<i>Second resolutioni>
The partners resolve to increase the share capital of the Company by an amount of TWO HUNDRED FIFTY NINE
MILLION FIVE HUNDRED SIXTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 259,516,500.-) to bring it
from its present amount of ONE HUNDRED SEVENTY SEVEN MILLION SIX HUNDRED EIGHTY THREE THOUSAND
SIX HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 177,683,600.-) to the amount of FOUR HUNDRED THIRTY SEVEN MILLION
TWO HUNDRED THOUSAND ONE HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 437,200,100.-) by the creation and the issuance
of FIVE MILLION ONE HUNDRED NINETY THREE HUNDRED THIRTY (5,190,330) new shares having a par value of
FIFTY U.S. DOLLARS (USD 50.-) each (the “New Shares”), having the same rights and obligations as the existing shares,
together with a total issue premium of ONE BILLION ONE HUNDRED FIFTEEN MILLION TWENTY SIX THOUSAND
ONE HUNDRED FIFTY SIX U.S. DOLLARS (USD 1,115,026,156.-).
The aggregate contribution of ONE BILLION THREE HUNDRED SEVENTY FOUR MILLION FIVE HUNDRED FOR-
TY TWO THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY SIX U.S. DOLLARS (USD 1,374,542,656.-) in relation to the New Shares
is allocated as follows:
(i) TWO HUNDRED FIFTY NINE MILLION FIVE HUNDRED SIXTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED U.S. DOL-
LARS (USD 259,516,500.-) to the share capital of the Company, and
(ii) ONE BILLION ONE HUNDRED FIFTEEN MILLION TWENTY SIX THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY SIX
U.S. DOLLARS (USD 1,115,026,156.-) to the share premium account of the Company.
<i>Third resolutioni>
The partners resolve to renounce and waive its preferential right as shareholder and to accept that all the FIVE
MILLION ONE HUNDRED NINETY THREE HUNDRED THIRTY (5,190,330) New Shares of the Company with a
nominal value of FIFTY U.S. DOLLARS (USD 50.-) each, be subscribed by the new shareholder PFIZER PFE FRANCE
HOLDCO 2 S.à r.l., by way of a contribution in kind consisting of a receivable of an amount of ONE BILLION THREE
HUNDRED SEVENTY FOUR MILLION FIVE HUNDRED FORTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY SIX U.S.
DOLLARS (USD 1,374,542,656.-) (the “Receivable”).
<i>Subscription - Paymenti>
PFIZER PFE FRANCE HOLDCO 2 S.à r.l., through its proxy holder Me Sonia Bellamine, prenamed declared to fully
subscribe to the above mentioned increase of capital of an amount of TWO HUNDRED FIFTY NINE MILLION FIVE
HUNDRED SIXTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 259,516,500.-) by subscribing to the FIVE
MILLION ONE HUNDRED NINETY THREE HUNDRED THIRTY (5,190,330) New Shares of the Company with a
nominal value of FIFTY U.S. DOLLARS (USD 50.-) each and allocating to the share premium account of the Company an
amount of ONE BILLION ONE HUNDRED FIFTEEN MILLION TWENTY SIX THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY
SIX U.S. DOLLARS (USD 1,115,026,156.-) the whole being fully paid up by contributing the Receivable.
Which proxy shall be signed “ne varietur” by the person representing the parties and the undersigned notary and shall
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Evaluationi>
The value of the Receivable is set at ONE BILLION THREE HUNDRED SEVENTY FOUR MILLION FIVE HUNDRED
FORTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY SIX U.S. DOLLARS (USD 1,374,542,656.-).
Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a valuation statement which has
been produced to the notary.
<i>Fourth resolutioni>
The partners resolve to amend the first paragraph of article 7 of the bylaws of the Company in order to reflect such
increase of capital, which shall be now read as follows:
Art. 7. First paragraph. “The corporate capital of the company is set at FOUR HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION
TWO HUNDRED THOUSAND ONE HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 437,200,100.-) divided into EIGHT MILLION
SEVEN HUNDRED FORTY-FOUR THOUSAND AND TWO (8,744,002) shares having a par value of FIFTY U.S. DOL-
LARS (USD 50.-) each”
<i>Valuation - Costsi>
The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged
to it by reason of the present deed are estimated at EUR 6.700.
Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her here above capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby
grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign
any deed rectifying the present deed.
57804
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt février.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;
ONT COMPARU
Pfizer Transactions LLC, une limited liability company organisée sous le droit de l'Etat de Delaware, USA avec adresse
au 235 East 42
nd
Street, New York, NY 10017, USA, agissant en qualité de l'unique general partner de Pfizer Business
Entreprises C.V., une commanditaire vennootschap, existant sous les lois des Pays-Bas, avec siège social à Rotterdam,
Pays-Bas enregistrée auprès du KVK de Rotterdam sous le numéro 55510213, et avec adresse commerciale à l'adresse
de son unique general partner, représentée par Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle
au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 février
2015.
PFIZER UNIT TRUST, existant sous les lois des Etats Unis d'Amérique avec siège social au 235 East 42
nd
Street, New
York, New York 10017 5755, Etats-Unis d'Amérique représentée par le gérant unique de Pharmacia LLC, une limited
liability company de Delaware organisée suivant les dispositions du Delaware Limited Liability Act, avec siège social au
100 Route 206 North Peapack, New Jersey 07977, Etats-Unis d'Amérique, comme custodian pour G.D. Searle LLC
agissant en qualité de trustee de PFIZER UNIT TRUST, représentée par Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, ayant
son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée le 20 février 2015.
Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par la personne représentant les parties comparantes
susnommées et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Les sociétés prénommées, Pfizer Business Entreprises C.V. et PFIZER UNIT TRUST, sont les associés de Wyeth Ayerst
S.à r.l., Société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège au 51 Avenue
JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149053, constituée par acte devant le notaire susmentionné, en date du 23
octobre 2010 publié au Mémorial C 2297 du 24 novembre 2009 (la «Société») et modifié en dernier lieu par acte du
notaire soussigné le 20 février 210, non encore publié au Mémorial C.
Lesquelles parties comparantes représentées comme dit ci-avant représentant l'intégralité du capital social, ont requis
le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident, conformément à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 d'accepter que PFIZER PFE FRANCE
HOLDCO 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège
au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192874 (“PFIZER PFE FRANCE HOLDCO 2”) entre dans
le capital de la Société en souscrivant les nouvelles Parts à émettre (comme décrit ci-dessous).
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE-NEUF
MILLIONS CINQ CENT SEIZE MILLE CINQ CENTS US DOLLARS (USD 259.516.500,-) pour le porter de son montant
actuel de CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE SIX CENTS US DOLLARS
(USD 177.683.600,-) à un montant de QUATRE CENT TRENTE-SEPT MILLIONS DEUX CENT MILLE CENT US DOL-
LARS (USD 437.200.100,-) par l'émission de CINQ MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE TROIS CENT
TRENTE (5.190.330) de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante US DOLLARS (USD 50) chacune
(les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec
une prime d'émission de UN MILLIARD CENT QUINZE MILLIONS VINGT-SIX MILLE CENT CINQUANTE-SIX US
DOLLARS (USD 1.115.026.156,-).
L'apport total de UN MILLIARD TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-
DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX EUROS (USD 1.374.542.656,-) relativement aux Nouvelles Parts Sociales
est alloué comme suit:
(i) DEUX CENT CINQUANTE-NEUF MILLIONS CINQ CENT SEIZE MILLE CINQ CENTS US DOLLARS (USD
259.516.500,-) au capital social de la Société, et
57805
(ii) UN MILLIARD CENT QUINZE MILLIONS VINGT-SIX MILLE CENT CINQUANTE-SIX US DOLLARS (USD
1.115.026.156,-)au compte de prime d'émission de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel décident d'accepter que les CINQ MILLIONS
CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE TROIS CENT TRENTE (5.190.330) Nouvelles Parts Sociales de la Société ayant une
valeur nominale de cinquante US DOLLARS (USD 50,-) chacune, soient souscrites par PFIZER PFE FRANCE HOLDCO
2 S. à r.l., précité, au moyen d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant de UN MILLIARD TROIS
CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX
EUROS (USD 1.374.542.656,-) (la “Créance”).
<i>Souscription - Paiementi>
PFIZER PFE FRANCE HOLDCO 2 S. à r.l., représentée par son mandataire Me Sonia Bellamine, précitée, a déclaré
souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée de DEUX CENT CINQUANTE-NEUF MILLIONS CINQ CENT
SEIZE MILLE CINQ CENTS US DOLLARS (USD 259.516.500,-) en souscrivant à l'ensemble des CINQ MILLIONS CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE TROIS CENT TRENTE (5.190.330) Nouvelles Parts Sociales de la Société d'une valeur
nominale de cinquante US DOLLARS (USD 50,-) chacune et alloué au compte de prime d'émission de la Société pour un
montant de de UN MILLIARD CENT QUINZE MILLIONS VINGT-SIX MILLE CENT CINQUANTE-SIX US DOLLARS
(USD 1.115.026.156,-) le tout étant entièrement libéré par apport de la Créance.
La procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la personne représentant les parties et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
<i>Evaluationi>
La valeur de la Créance a été fixée à UN MILLIARD TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLIONS CINQ CENT
QUARANTE-DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX EUROS (USD 1.374.542.656,-).
Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport
et de l'évaluation présentée au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident alors de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter
l'augmentation de capital, lequel article sera comme suit:
Art. 7. Premier paragraphe. «Le capital social de la société est fixé à QUATRE CENT TRENTE-SEPT MILLIONS DEUX
CENT MILLE CENT US DOLLARS (USD 437.200.100,-) divisé par HUIT MILLIONS SEPT CENT QUARANTE-QUATRE
MILLE DEUX (8.744.002) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante US DOLLARS (USD 50,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont évalués à EUR 6.700).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à
tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête e la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état
et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Sonia Bellamine, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 5 mars 2015. 1LAC / 2015 / 6840. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 9 mars 2015.
Référence de publication: 2015045491/196.
(150051542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
57806
Allegretto Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 402.981.250,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 194.038.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of February,
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of Allegretto Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée having
its registered office at 11-13, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 194038 (the Company).
The Company was incorporated on 15 January 2015, pursuant to a deed drawn up by Maître Jean SECKLER, notary,
residing in Junglister, Grand Duchy of Luxembourg, acting as replacement of Maître Henri BECK, notary residing in
Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
Mémorial). The Company’s articles of association (the Articles) have not been amended since its incorporation.
The Meeting was opened at 3:00 p.m. and chaired by Jean-Baptiste Beauvoir Planson, lawyer, residing at 18-20, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Régis Galiotto, notary’s clerk, residing at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Joseph Moroney, lawyer, residing at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
The Meeting’s officers having thus been appointed, the chairman declares and requests the notary to state:
1. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the shareholders or their authorised representatives, the Meeting’s officers and the notary. This
attendance list and the powers of attorney will be registered with this deed.
2. That it appears from the attendance list that all the shares are present or represented. The shareholders hereby
acknowledge to be fully aware of the agenda of the Meeting, which has been communicated to them in advance, and
consequently waive the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted and may deliberate and decide on
the items on its agenda.
3. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Increase of the Company’s share capital by an amount of four hundred and two million nine hundred and sixty eight
thousand seven hundred and fifty euros (EUR 402,968,750.-) to raise it from its current amount of twelve thousand five
hundred euros (EUR 12,500.-), to four hundred and two million nine hundred and eighty one thousand two hundred and
fifty euros (EUR 402,981,250.-), by the issue of four hundred and two million nine hundred and sixty eight thousand seven
hundred and fifty (402,968,750.-) new shares in the Company having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each;
2. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles to reflect the share capital increase adopted under item 1.
above;
3. Delegation of powers; and
4. Miscellaneous.
4. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Chairman proceeds with the first item on the agenda and proposes to increase the Company’s share capital by
an amount of four hundred and two million nine hundred and sixty eight thousand seven hundred and fifty euros (EUR
402,968,750.-) to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to four hundred and
two million nine hundred and eighty one thousand two hundred and fifty euros (EUR 402,981,250.-), through the issuance
of four hundred and two million nine hundred and sixty eight thousand seven hundred and fifty (402,968,750) shares in
the Company having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the New Shares).
The Scrutineer informs the Meeting that pursuant to the voting instructions the proxy received:
i. twelve thousand five hundred (12,500) shares; voted in favour of the resolution.
ii. zero (0) shares; abstained from voting the resolution, and
iii. zero (0) shares; voted against the resolution.
Therefore the resolution is unanimously adopted by the Meeting and the Meeting resolves to accept and record the
subscription for, and full payment of, the share capital increase as follows:
57807
<i>Subscription - Paymenti>
Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company, an open joint stock company incorporated under the laws of the
Russian Federation, with registered office at 4 Marksistskaya street, Moscow, 109147, the Russian Federation, registered
with the Unified State Register of Legal Entities of the Russian Federation under number 1027700149124 (the Contri-
butor), here represented by Jean-Baptiste Beauvoir Planson, prenamed, by virtue of a power of attorney given under
private seal, who declares that the Contributor subscribes to all the New Shares and pays them up fully by a contribution
in kind consisting of (i) seven hundred and seventy-three million eight hundred and forty-five thousand four hundred and
ninety-five (773,845,495) ordinary registered shares of par value UAH 0.01 each, representing ninety nine (99)% of the
total share capital of Private Joint Stock Company “MTS UKRAINE”, a private joint stock company incorporated under
the laws of Ukraine, with registered office at 15 Leipzigskaya street, Kiev, 01601, Ukraine, registered with the Unified
State Register of Enterprises and Companies of Ukraine under number 14333937, and (ii) one hundred per cent (100%)
of the charter fund of Enterprise with 100% foreign investment “PTT Telecom Kiev”, a company with limited liability
wholly owned by a foreign investor with 100% foreign investment incorporated under the laws of Ukraine, with registered
office at 15 Leipzigskaya street, Kiev, 01601, Ukraine, registered with the Unified State Register of Enterprises and Com-
panies of Ukraine under number 20069181 (the Contribution Shares). The Contribution Shares having an aggregate value
of at least twelve billion eight hundred and ninety five million Ukrainian hryvnias (UAH 12,895,000,000.-), which is equal
to four hundred and two million nine hundred and sixty eight thousand seven hundred and fifty euros (EUR 402,968,750.-)
based on the conversion rate published by Reuters at close of business on 25 February 2015 (i.e. EUR 1 = UAH 32)
<i>Valuation - Allocationi>
The value of the Contribution Shares to the Company is certified to the undersigned notary by a certificate, issued by
the management of the Contributor and approved by the Company’s management. This certificate states that (i) the
Contributor is the sole owner of the Contribution Shares and that it has the power to dispose of them; (ii) the aggregate
value of the Contribution Shares is at least equal to the aggregate nominal value of the shares issued by the Company in
exchange for the contribution of the Contribution Shares, and since the valuation was made, no material changes have
occurred which may have depreciated the contribution made to the Company; (iii) the Contribution Shares are fully paid-
up and freely transferable and are not subject to any judicial or other proceedings or the object of any third-party rights
which are likely to reduce their value; all formalities for the transfer of the legal ownership of the Contribution Shares
have been or will be carried out, and when the Contribution Shares are contributed to the Company, the latter will
become their full owner.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Contributor and the undersigned notary, this
certificate will remain attached to this deed to be registered with it.
The contribution in kind of the Contribution Shares to the Company for the amount of four hundred and two million
nine hundred and sixty eight thousand seven hundred and fifty euros (EUR 402,968,750) is allocated in its entirety to the
share capital of the Company.
The Meeting resolves to record that following the share capital increase, the shareholding in the Company is as follows:
Stichting Impromptu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500 shares
Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402,968,750 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402,981,250 shares
As a result of this previous resolution, the Contributor enters the meeting and henceforth will vote on the next items
of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The Chairman proceeds with the second item on the agenda and proposes to amend article 5.1 of the Articles as
follows to reflect the above resolution:
“ 5.1. The share capital is set at four hundred and two million nine hundred and eighty one thousand two hundred and
fifty euros (EUR 402,981,250.-), represented by four hundred and two million nine hundred and eighty one thousand two
hundred and fifty (402,981,250) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed
and fully paid up.”
The Scrutineer informs the Meeting that pursuant to the voting instructions the proxy received:
i. four hundred and two million nine hundred and eighty one thousand two hundred and fifty (402,981,250) shares;
voted in favour of the resolution.
ii. zero (0) shares; abstained from voting the resolution, and
iii. zero (0) shares; voted against the resolution.
Therefore, majority of shareholders (in number) holding more than three quarters of the votes were cast in favour of
the proposal and consequently the general meeting of shareholders approves the amendment of the Articles of the
Company.
57808
<i>Third resolutioni>
The Chairman proceeds with the third item on the agenda and proposes to grant power and authority to any manager
of the Company and to any authorised employee of Intertrust in Luxembourg, each acting individually, to amend the
Company’s register of registered shares in order to take into account the share capital increase.
The Scrutineer informs the Meeting that pursuant to the voting instructions the proxy received:
i. four hundred and two million nine hundred and eighty one thousand two hundred and fifty (402,981,250) shares;
voted in favour of the resolution.
ii. zero (0) shares; abstained from voting the resolution, and
iii. zero (0) shares; voted against the resolution.
Therefore the resolution is unanimously adopted by the Meeting.
There being no further business, the Meeting is adjourned.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of the present
deed are estimated at approximately seven thousand five hundred Euros (7,500.- EUR).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.
WHEREOF, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Meeting’s officers and the shareholders’ authorised repre-
sentative.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour de février,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) d’Allegretto Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
dont le siège social se situe au 11-13, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, disposant d’un capital social s’élevant à EUR 12.500 et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194038 (la Société).
La Société a été constituée le 15 janvier 2015 suivant un acte par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence
à Junglister, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à
Echternach, Grand-Duché de Luxembourg et dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations
(le Mémorial) est en cours. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L’Assemblée est ouverte à 15.00 et présidée par Jean-Baptiste Beauvoir Planson, avocat, demeurant au 18-20, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant au 101 rue de Cents, L-1319
Luxembourg.
L’Assemblée nomme comme scrutateur Joseph Moroney, avocat, demeurant au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et a prié le notaire instrumentant d'acter:
1. Que les associés présents ou représentés et le nombre de leurs parts sociales sont renseignés sur une liste de
présence signée par eux ou leurs représentants, par le bureau de l’Assemblée et par le notaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations seront enregistrées avec le présent acte.
2. Qu'il appert de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Les associés
reconnaissent être pleinement au courant de l’ordre du jour de l’Assemblée qui leur a été communiqué à l’avance et
renoncent en conséquence aux formalités de convocation. L’Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et
peut délibérer et décider sur les points de son ordre du jour.
3. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quatre cent deux millions neuf cent soixante-huit mille
sept cent cinquante euros (EUR 402.968.750,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros
(EUR 12.500,-), à quatre cent deux millions neuf cent quatre-vingt-et-un mille deux cent cinquante euros (EUR
402.981.250,-), par l’émission de quatre cent deux millions neuf cent soixante-huit mille sept cent cinquante
(402.968.750,-) nouvelles parts sociales dans la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune;
2. Modification subséquente de l’article 5.1 des Statuts afin de refléter l’augmentation du capital social adoptée au point
1. ci-dessus;
3. Délégation de pouvoir; et
4. Divers.
57809
4. Que l’Assemblée a pris unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le Président présente le premier point à l’ordre du jour et suggère d’augmenter le capital social d’un montant de
quatre cent deux millions neuf cent soixante-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 402.968.750,-) afin de le porter
de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts
sociales d’un valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à quatre cent deux millions neuf cent quatre-vingt-et-un mille
deux cent cinquante euros (EUR 402.981.250,-), par l’émission de quatre cent deux millions neuf cent soixante-huit mille
sept cent cinquante (402.968.750) parts sociales dans la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune
(les Nouvelles Parts Sociales).
Le Scrutateur informe l’Assemblée que selon les instructions de vote reçues par le mandataire:
i. douze mille cinq cents (12.500) parts sociales; ont voté en faveur de la résolution.
ii. zéro (0) part sociale; se sont abstenu de se prononcer sur la résolution, et
iii. zéro (0) part sociale; ont voté contre la résolution.
Par conséquent la résolution est unanimement adoptée par l’Assemblée et l’Assemblée décide d’accepter et de prendre
acte de la souscription et de la libération intégrale de l’augmentation de capital de la manière suivante:
<i>Souscription - Libérationi>
Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company, une société par actions de type ouvert (open joint stock company)
constituée selon le droit de la Fédération de Russie, dont le siège social est située au 4 Marksistskaya street, Moscou,
109147, Fédération de Russie, immatriculée auprès du registre d’état unifié de la Fédération de Russie pour les personnes
morales (Unified State Register of Legal Entities of the Russian Federation) sous le numéro 1027700149124 (l’Apporteur),
représenté ici par Jean-Baptiste Beauvoir Planson, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, qui
déclare que l’Apporteur souscrit à toutes les Nouvelles Parts Sociales et les libère intégralement par un apport en nature
consistant en (i) sept cent soixante-treize millions huit cent quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quinze
(773.845.495) actions nominatives ordinaires d’une valeur nominale de UAH 0,01 chacune, représentant quatre-vingt-
dix-neuf pour cent (99%) de l’intégralité du capital social de Private Joint Stock Company «MTS UKRAINE», une société
par actions de type privé (private joint stock company) constituée selon le droit ukrainien, dont le siège social est située
au 15 Leipzigskaya street, Kiev, 01601, Ukraine, immatriculée auprès du registre d’état unifié des entreprises et sociétés
ukrainien (Unified State Register of Enterprises and Companies of Ukraine) sous le numéro 14333937, et (ii) cent pour
cent (100%) du capital social d’entreprise avec 100% d’investissement étranger «PTT Telecom Kiev», une société à res-
ponsabilité limitée détenue intégralement par un investisseur étranger représentant 100% d’investissement étranger
constituée selon le droit ukrainien, dont le siège social est située au 15 Leipzigskaya street, Kiev, 01601, Ukraine, imma-
triculée auprès du registre d’état unifié des entreprises et sociétés ukrainien (Unified State Register of Enterprises and
Companies of Ukraine) sous le numéro 20069181 (les Actions Apportées). Les Actions Apportées ont une valeur totale
s’élevant au minimum à douze milliards huit cent quatre-vingt-quinze millions de hryvnias ukrainiennes (UAH
12.895.000.000,-), qui est équivaut à quatre cent deux millions neuf cent soixante-huit mille sept cent cinquante euros
(EUR 402.968.750,-) sur base du taux de conversion publié par Reuters à la clôture des activités, le 25 février 2015 (c’est-
à-dire EUR 1 = UAH 32).
<i>Évaluation - Affectationi>
La valeur des Actions Apportées à la Société est attestée au notaire instrumentant par le biais d’un certificat délivré
par la gérance de l’Apporteur et approuvé par l’organe de gestion de la Société. Ce certificat atteste que (i) l’Apporteur
est le propriétaire exclusif des Actions Apportées et à le a le droit d’en disposer, (ii) la valeur totale des Actions Apportées
est au moins égale à la valeur nominale totale des parts sociales émises par la Société en contrepartie des Actions
Apportées, et depuis l’évaluation, aucun changement matériel ne s’est produit qui aurait eu pour effet de déprécier la
valeur de l’apport fait à la Société, (iii) les Actions Apportées sont entièrement libérées et librement cessibles et ne font
l’objet d’aucune procédure judiciaire ou autre, ni ne sont soumises à un quelconque droit de tiers qui serait susceptible
d’en réduire leur valeur; toutes les formalités liées au transfert de propriété des Actions Apportées ont été ou seront
accomplies, et lorsque l’apport à la Société, des Actions Apportées interviendra, cette dernière en deviendra le proprié-
taire en pleine propriété.
Après signature ne varietur par le mandataire de l’Apporteur et le notaire instrumentant, ce certificat restera annexé
au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L’apport en nature des Actions Apportées à la Société pour le montant de quatre cent deux millions neuf cent soixante-
huit mille sept cent cinquante euros (EUR 402.968.750) est entièrement affecté au capital social de la Société.
L’Assemblée décide de noter que suite à l’augmentation du capital social, la participation au sein de la Société est la
suivante:
Stichting Impromptu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500 parts sociales
Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.968.750 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.981.250 parts sociales
57810
En raison de la précédente résolution l’Apporteur se joint à l’assemblée et, par conséquent, prendra part au vote des
prochains points à l’ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Président présente le deuxième point à l’ordre du jour et suggère de modifier l’article 5.1 des Statuts comme suit
afin de refléter la résolution qui précède:
« 5.1. Le capital social est fixé à quatre cent deux millions neuf cent quatre-vingt-et-un mille deux cent cinquante euros
(EUR 402.981.250,-), représenté par quatre cent deux millions neuf cent quatre-vingt-et-un mille deux cent cinquante
(402.981.250) part sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.»
Le Scrutateur informe l’Assemblée que selon les instructions de vote reçues par le mandataire:
i. quatre cent deux millions neuf cent quatre-vingt-et-un mille deux cent cinquante (402.981.250) parts sociales; ont
voté en faveur de la résolution.
ii. zéro (0) part sociale; se sont abstenu de se prononcer sur la résolution, et
iii. zéro (0) part sociale; ont voté contre la résolution.
Par conséquent, la majorité (en nombre) détenant plus des trois quarts des voix s’est exprimée en faveur de la pro-
position, et donc l’assemblée générale des associés approuve la modification des Statuts de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Le Président présente le troisième point à l’ordre du jour et suggère de donner pouvoir à tout gérant de la Société
ainsi qu'à tout salarié autorisé d’Intertrust à Luxembourg, chacun agissant individuellement, pour mettre à jour le registre
des parts sociales de la Société suite à l’augmentation de capital.
Le Scrutateur informe l’Assemblée que selon les instructions de vote reçues par le mandataire:
i. quatre cent deux millions neuf cent quatre-vingt-et-un mille deux cent cinquante (402.981.250) parts sociales; ont
voté en faveur de la résolution.
ii. zéro (0) part sociale; se sont abstenu de se prononcer sur la résolution, et
iii. zéro (0) part sociale; ont voté contre la résolution.
Par conséquent, la résolution est adoptée unanimement par l’Assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est ajournée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte, s’élève à environ sept mille cinq cents Euros (7.500.- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte
en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte, le notaire le signe avec le bureau et le mandataire des parties comparantes.
Signé: R. GALIOTTO, J.-B. BEAUVOIR PLANSON, J. MORONEY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7041. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015045534/263.
(150052593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Plazo, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 146.890.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015046027/10.
(150052564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
57811
BTG Pactual E&P S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 178.405.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of February.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BTG Pactual E&P S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Com-
merce and Companies of Luxembourg under number B 178.405, incorporated on June 13, 2013, pursuant to a deed of
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2022, page 97033 of August 21, 2013 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles)
have been amended for the last time by a deed of the Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, on November 13, 2014, in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
THERE APPEARED:
BTG Pactual Holdings Internacional S.A., a limited company (sociedade anônima) incorporated under the laws of Brazil,
having its registered office at 501, Praia de Botafogo, Torre Corcovado, 5
th
floor, 22250-040 Rio de Janeiro, Brazil,
registered with the Federal Revenue of Brazil under no. 12.552.209/0001-47 (the Sole Shareholder);
here represented by Henri DA CRUZ, notary clerk, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, pre-named and represented as stated above, representing the entire share capital of the Com-
pany, has requested the undersigned notary to record that:
I. The Company's share capital is presently set at one billion and thirty-four million five hundred and eighty-nine
thousand and twenty-six United States Dollars and eighty-three cents (USD 1,034,589,026.83) represented by one hun-
dred and three billion four hundred and fifty-eight million nine hundred and two thousand six hundred and eighty-three
(103,458,902,683) shares in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each,
all subscribed and fully paid-up.
II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of five million one hundred thousand United States
Dollars (USD 5,100,000) in order to bring the said share capital from its current amount of one billion and thirty-four
million five hundred and eighty-nine thousand and twenty-six United States Dollars and eighty-three cents (USD
1,034,589,026.83), to an amount of one billion and thirty-nine million six hundred and eighty-nine thousand and twenty-
six United States Dollars and eighty-three cents (USD 1,039,689,026.83), by way of issuance of five hundred and ten
million (510,000,000) shares having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each;
3. Subscription for the new shares and payment of the share capital increase specified under item 2. above;
4. Subsequent amendment to article 5.1. of the articles of association of the Company;
5. Amendment to the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company and to any employee of Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office located at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg
under number B 103.123, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly
issued shares in the shareholder's register of the Company; and
6. Miscellaneous.
III. Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to
record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.
57812
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase of the share capital of the Company by an amount of five million one hundred thousand
United States Dollars (USD 5,100,000) in order to bring the said share capital from its current amount of one billion and
thirty-four million five hundred and eighty-nine thousand and twenty-six United States Dollars and eighty-three cents
(USD 1,034,589,026.83), to an amount of one billion and thirty-nine million six hundred and eighty-nine thousand and
twenty-six United States Dollars and eighty-three cents (USD 1,039,689,026.83), by way of issuance of five hundred and
ten million (510,000,000) shares having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to five hundred and ten million
(510,000,000) shares in registered form, having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each,
and to fully pay them up in an amount of five million one hundred thousand United States Dollars (USD 5,100,000).
The aggregate amount of five million one hundred thousand United States Dollars (USD 5,100,000) is forthwith at the
disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 5.1. of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at one billion and thirty-nine million six hundred and eighty-nine thousand and twenty-
six United States Dollars and eighty-three cents (USD 1,039,689,026.83) represented by one hundred and three billion
nine hundred and sixty-eight million nine hundred and two thousand six hundred and eighty-three (103,968,902,683)
shares in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each, all subscribed and
fully paid-up."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and empowers and authorised with power and authority given to any manager of the Company and to any employee of
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered
office located at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register
of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 103.123, each acting individually, to proceed on behalf of
the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholder's register of the Company.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 3,600.-.
For registration purposes, the total amount of the Capital increases is valued at EUR 4,506,382.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, such proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BTG Pactual E&P S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 178.405, constituée le 13 juin 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2022, page 97033 du 21 août
2013 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 13 novembre 2014, suivant
57813
un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours de publi-
cation au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
A COMPARU:
BTG Pactual Holdings Internacional S.A., une société anonyme (sociedade anônima) constituée selon les lois du Brésil,
ayant son siège social au 501, Praia de Botafogo, Torre Corcovado, 5
th
étage, 22250-040 Rio de Janeiro, Brésil, imma-
triculée auprès du bureau de recette fédérale du Brésil sous le numéro 12.552.209/0001-47 (l'Associé Unique);
ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé;
Ladite procuration, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la Société,
a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Le capital social de la société est actuellement fixé à un milliard trente-quatre million cinq cent quatre-vingt-neuf
mille vingt-six Dollars américains et quatre-vingt-trois centimes (USD 1.034.589.026,83) représenté par cent trois milliard
quatre cent cinquante-huit million neuf cent deux mille six cent quatre-vingt-trois (103.458.902.683) parts sociales no-
minatives ayant une valeur nominative d'un centime de Dollar américain (USD 0,01) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées;
II. L'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq millions cent mille Dollars américains (USD
5.100.000) afin de porter le montant dudit capital social de son montant actuel d'un milliard trente-quatre million cinq
cent quatre-vingt-neuf mille vingt-six Dollars américains et quatre-vingt-trois centimes (USD 1.034.589.026,83), à un
montant d'un milliard trente-neuf million six cent quatre-vingt-neuf mille vingt-six Dollars américains et quatre-vingt-trois
centimes (USD 1.039.689.026,83), par voie d'émission de cinq cent dix millions (510.000.000) de parts sociales nomina-
tives ayant une valeur nominative d'un centime de Dollar américain (USD 0,01) chacune;
3. Souscription aux parts sociales et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;
4. Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts de la Société;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société et à tout employé d'Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée
ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.123, chacun agissant individuellement,
afin de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société; et
6. Divers.
III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance
de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq millions cent mille Dollars amé-
ricains (USD 5.100.000) afin de porter le montant dudit capital social de son montant actuel d'un milliard trente-quatre
million cinq cent quatre-vingt-neuf mille vingt-six Dollars américains et quatre-vingt-trois centimes (USD
1.034.589.026,83), à un montant d'un milliard trente-neuf million six cent neuf-vingt-neuf mille vingt six Dollars américains
et quatre-vingt-trois centimes (USD 1.039.689.026,83), par voie d'émission de cinq cent dix millions (510.000.000) de
parts sociales nominatives ayant une valeur nominative d'un centime de Dollar américain (USD 0,01) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée accepte et enregistre les souscriptions suivantes aux parts sociales et la libération intégrale de l'augmen-
tation du capital social ci-dessus comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à cinq cent dix millions
(510.000.000) de parts sociales nominatives ayant une valeur nominative d'un centime de Dollar américain (USD 0,01)
chacune, et de les libérer entièrement par voie d'un apport en numéraire d'un montant de cinq millions cent mille Dollars
américains (USD 5.100.000).
57814
Le montant total de cinq millions cent mille Dollars américains (USD 5.100.000) est immédiatement à la libre disposition
de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant par un certificat de blocage.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à d'un milliard trente-neuf million six cent quatre-vingt-neuf mille vingt-six Dollars
américains et quatre-vingt-trois centimes (USD 1.039.689.026,83) représenté par cent trois milliard neuf-cent soixante-
huit million neuf cent deux mille six cent quatre-vingt-trois (103.968.902.683) sous la forme nominative, ayant une valeur
nominale d'un centime de Dollar américain (USD 0,01), toutes souscrites et entièrement payées.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout employé d'Inter trust (Luxembourg) S.à r.l., une société
à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.123, afin
de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ EUR 3,600,-.
Pour les besoins de l'Enregistrement, le montant total de l'augmentation du capital est évalué à EUR 4.506.382,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et
française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte original.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 février 2015. Relation GAC/2015/1554. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015044934/194.
(150051652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Media Inside S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 164.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044577/9.
(150051091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Mediterranean Shipping Company Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 145.643.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015044579/10.
(150050960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
57815
Twinhope Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.955.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue le 17 février 2015 à 10.30i>
<i>heures au siège social de la société.i>
<i>«Première résolutioni>
L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Didier McGaw et de Monsieur Stéphane Lataste, ayant pour
adresse professionnelle 33 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, de leurs fonctions d'administrateurs de la Société,...
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale nomme Monsieur Luc Sünnen et Monsieur Christophe Fender, les deux ayant pour adresse
professionnelle, L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères, en qualité d'administrateurs de la Société.»
Référence de publication: 2015043766/15.
(150050138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.005.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 186.832.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Ascot Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 186831,
here represented by Mr. Brian Gillot, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 21 January 2015, which
proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to
this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., a société
à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 186832, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated 29 April 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1793 on 10 July 2014,
the articles of association modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 4 July 2014 published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3156 on 29 October 2014 (hereafter the "Company").
The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of
the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Creation of additional nine (9) different classes of shares to be named class A shares, class B shares, class C shares,
class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares and class I shares;
2. Increase of the Company's share capital by an amount of fourteen million nine hundred ninety-two thousand five
hundred euro (EUR 14,992,500), in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500) up to a new amount of fifteen million five thousand euro (EUR 15,005,000) through the issuance of (i) one million
six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class A shares, (ii) one million six hundred
and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class B shares, (iii) one million six hundred and sixty-
five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class C shares, (iv) one million six hundred and sixty-five thousand
eight hundred and thirty-three (1,665,833) class D shares, (v) one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred
and thirty-three (1,665,833) class E shares, (vi) one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-
three (1,665,833) class F shares, (vii) one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three
(1,665,833) class G shares, (viii) one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833)
class H shares and (ix) one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-six (1,665,836) class I
shares, with a par value of one euro (EUR 1) each, by means of converting an amount of fourteen million nine hundred
ninety-two thousand five hundred euro (EUR 14,992,500) of share premium of the Company into share capital; and
3. Decision to fully restate the articles of association of the Company.
57816
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to create the following new classes of shares to be denominated as follows: A shares,
B shares, C shares, D shares, E shares, F shares, G shares, H shares and I shares, having a par value of one euro (EUR 1)
each.
Each share of each class shall entitle its holder to one vote at a general meeting of shareholders of the Company and
to such further rights as set forth by law and in the Company's Articles, as amended pursuant to the third resolution
below.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase Company's share capital by an amount of fourteen million nine hundred
ninety-two thousand five hundred euro (EUR 14,992,500), in order to bring it from its current amount of twelve thousand
five hundred euro (EUR 12,500) up to a new amount of fifteen million five thousand euro (EUR 15,005,000) through the
issuance of (i) one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class A shares,
(ii) one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class B shares, (iii) one
million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class C shares, (iv) one million six
hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class D shares, (v) one million six hundred
and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class E shares, (vi) one million six hundred and sixty-
five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class F shares, (vii) one million six hundred and sixty-five thousand
eight hundred and thirty-three (1,665,833) class G shares, (viii) one million six hundred and sixty-five thousand eight
hundred and thirty-three (1,665,833) class H shares and (ix) one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred
and thirty-six (1,665,836) class I shares, with a par value of one euro (EUR 1) each.
All the new shares are subscribed by the Sole Shareholder, here represented as aforementioned.
All the issued new shares are fully paid up by the transfer from the share premium account of the Company of the
amount of fourteen million nine hundred ninety-two thousand five hundred euro (EUR 14,992,500) to the share capital
of the Company.
The existence of the share premium account has been given to the undersigned notary pursuant to the interim financial
statements of the Company which, after having been initialed ne varietur, shall be registered together with this deed.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to fully restate the Company's articles of
association which shall henceforth read as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the Shares (as defined in article 5) and/or anyone
who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of
“Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.” (the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association (the “Articles”).
Art. 3. Purpose.
3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
3.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds
a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,
the Company may especially:
57817
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1. The issued share capital of the Company is set at fifteen million five thousand euro (EUR 15,005,000) and divided
into ordinary shares and preference shares with a nominal value of one euro (Euro 1) each, with such rights and obligations
as set out in the present Articles and upon the following repartition:
i. Twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);
ii. one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class A shares (the “Class
A Shares”);
iii. one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class B shares (the “Class
B Shares”);
iv. one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class C shares (the “Class
C Shares”);
v. one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class D shares (the “Class
D Shares”);
vi. one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class E shares (the “Class
E Shares”);
vii. one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class F shares (the “Class
F Shares”);
viii. one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class G shares (the
“Class G Shares”);
ix. one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-three (1,665,833) class H shares (the “Class
H Shares”); and
x. one million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and thirty-six (1,665,836) class I shares (the “Class I
Shares”, together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares,
the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares, the “Preferences Shares” together with the Ordinary
Shares, the “Shares”).
5.2. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these Articles.
5.3. The Shares may be stapled to any other instruments or debt issued by the Company by virtue of a stapling
agreement entered into between the shareholders of the Company from time to time. Any transfer of Shares or instru-
ments or debt in breach of such stapling agreement shall be considered as null and void.
5.4. A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the
respective Class Periods (as this term is defined in article 5.9.) as follows:
i. the period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 21 January 2015 and ending
no later than on 31 December 2015 (the “Class A Period”);
ii. the period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later
than 31 December 2016 (the “Class B Period”);
iii. the period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than
on 31 December 2017 (the “Class C Period”);
iv. the period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later
than on 31 December 2018 (the “Class D Period”);
57818
v. the period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later
than 31 December 2019 (the “Class E Period”);
vi. the period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later
than 31 December 2020 (the “Class F Period”);
vii. the period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later
than 31 December 2021 (the “Class G Period”);
viii. the period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later
than on 31 December 2022 (the “Class H Period”); and
ix. the period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than
on 31 December 2023 (the “Class I Period”).
5.5. Where a class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the
redemption and cancellation of such class(es) of Preference Shares can be made during a new period (the “New Period”)
which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately
preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first
New Period shall start on the day after the Class I Period and the class of Preference Shares not repurchased and not
cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A to class I (to the extent not previously
repurchased and cancelled).
5.6. For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Preference Shares shall
take place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class
Period (or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of
Preference Shares and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.
5.7. Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount (as this term is
defined in article 5.9.) will become due and payable by the Company to the shareholder(s) pro-rata to their holding in
such class(es). For the avoidance of doubt the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way
of set-off.
5.8. The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the sole
manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers (as both terms defined below) in its reasonable
discretion and within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Sole Manager or, in
case of plurality of managers the Board of Managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its
determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.
5.9. For the purposes of this article 5, the following capitalised terms shall have the following meanings:
i. “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and
legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any
double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles and
(iv) any Profit Entitlement so that:
AA= (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
AA= Available Amount.
NP= net profits (including carried forward profits).
P= any freely distributable reserves.
CR= the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be
cancelled.
L= losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR= any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
OD= any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles. PE= Profit
Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed
by the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers of the Company in good faith and with
the view to the Company's ability to continue as a going concern.
ii. “Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a
remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes
and any receivable which in the opinion of the Board of Managers will be paid to the Company in the short term less any
indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim
Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as Shares,
stock or securities of other kind held by the Company.
57819
iii. “Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class
Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available
Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).
iv. “Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period,
the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period and the Class I Period.
v. “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
vi. “Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before
the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.
vii. “Law” shall mean the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time.
viii. “Profit Entitlement” shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.
Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into Ordinary Shares and Preferences Shares as defined in article 5.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of Shares held by
him/her/it in the Company's share capital subject to article 24.
6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5. The Company may repurchase or redeem its own Shares under the condition that the repurchased or redeemed
Shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly and subject to article 5.
6.6. The Company's Shares are in registered form.
6.7. Fractional Shares shall have the same rights on a fractional basis as whole Shares, provided that Shares shall only
be able to vote if the number of fractional Shares may be aggregated into one or more whole Shares. If there are fractions
that do not aggregate into a whole Share, such fractions shall not be able to vote.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of Shares held by such shareholder, any transfer of Shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on Shares.
7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and transfer of Shares.
8.1. Proof of ownership of Shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-
holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
8.2. The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that Share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a Share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3. The Company's Shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be trans-
ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor,
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law,
the Shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.
8.4. Any transfer of Shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.
57820
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company's corporate bodies.
9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.
9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead
of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in
the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice
of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.
10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each Share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly
passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.
11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,
facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
57821
11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them
to take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders(ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board
of managers” used in these articles of association is to be construed as being a reference to the “sole manager”.
14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).
14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting
alone or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a
chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.
Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-
holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.
16.3. Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph.
17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours
at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
18.2. Quorum
57822
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers including, if several classes of managers are appointed, at least one (1) manager of
each class of managers.
18.3. Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting
of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.
18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.
18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of
the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.
Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the
board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.
Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint
signatures of a class A manager and a class B manager or by the signature of the sole manager or by the joint signatures
or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers
or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the
power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and
the limits of such delegation.
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s).
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and
shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.
21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
57823
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7. If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on
thirty-first December of the same year.
Art. 23. Profits.
23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal
reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general
meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.
Art. 24. Distributions - Dividends - Interim dividends - Share premium.
24.1. Upon recommendation of the Board of Managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
24.2. Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they hold in the Company
and allocated and paid in the following order:
i. the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.01% of the nominal value of the Ordinary
Shares;
ii. the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.20% of the nominal value of the Class
A Shares;
iii. the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.25% of the nominal value of the Class
B Shares;
iv. the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.30% of the nominal value of the Class
C Shares;
v. the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.35% of the nominal value of the Class
D Shares;
vi. the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.40% of the nominal value of the Class
E Shares;
vii. the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.45% of the nominal value of the Class
F Shares;
viii. the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.50% of the nominal value of the Class
G Shares;
ix. the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.55% of the nominal value of the Class
H Shares;
x. the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.60% of the nominal value of the Class I
Shares; and
xi. the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares pursuant to a decision taken by the general
meeting of shareholders.
24.3. In accordance with the Law and these articles of association, the board of managers or the general meeting of
shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been
drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made
since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward
and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve
pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has
stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.
24.4. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)
or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.
57824
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation.
25.1. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution
which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
25.2. After payment of all the debts and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
H. Governing law
Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 6,500.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German translation. On express request of the same
appearing person, and in case any divergences would arise between the German and the English text, the English text will
prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said
person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen texte:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am einundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg.
Ist erschienen:
Ascot Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet und existierend im Großherzogtum Luxembourg, mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxembourg unter der Nummer B 186.831,
vertreten durch Herrn Brian Gillot, wohnhaft in Luxembourg, aufgrund einer am 21. Januar 2015 erteilten Vollmacht,
welche nach Paraphierung „ne varietur“ durch den Notar und den Bevollmächtigten vorliegender Urkunde als Anlage
beigefügt, um dieser Urkunde einregistriert zu werden.
Die erschienene Partei ist Einzelgesellschafterin (die „Einzelgesellschafterin“) der Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à
r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger Recht, eingetragen
in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 186832, mit Gesellschaftssitz in 15, rue
Edward Steichen, L- 2540 Luxemburg, wirksam gegründet am 29. April 2014 gemäß notarieller Urkunde von Herrn Maître
Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations
Nummer 1793 am 10. July 2014, die Gesellschaftssatzung letztmals geändert durch notarielle Urkunde des unterzeichn-
enden Notars am 4 July 2014 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3156 am 29
Oktober 2014 (nachfolgend die „Gesellschaft“).
Die erschienene Partei, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertritt, ersuchte den Notar die folgenden
Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Agendai>
1. Schaffung von zusätzlichen neun (9) unterschiedlichen Anteilsklassen, die Klasse A Anteile, Klasse B Anteile, Klasse
C Anteile, Klasse D Anteile, Klasse E Anteile, Klasse F Anteile, Klasse G Anteile, Klasse H Anteile und Klasse I Anteile
genannt werden;
2. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von vierzehn Millionen neunhundertzwei-
undneunzigtausend fünfhundert Euro (EUR 14.992.500), um es von seinem gegenwärtigen Betrag in Höhe von zwölftau-
send fünfhundert Euro (EUR 12.500) auf einen Betrag in Höhe von fünfzehn Millionen fünftausend Euro (EUR 15.005.000)
durch die Ausgabe von (i) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse
A Anteilen, (ii) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse B Antei-
len, (iii) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse C Anteilen, (iv)
einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse D Anteilen, (v) einer Mil-
lion sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse E Anteilen, (vi) einer Million
57825
sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse F Anteilen, (vii) einer Million sechs-
hundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse G Anteilen, (viii) einer Million sechshun-
dertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse H Anteilen, und (ix) einer Million sechshun-
dertfünfundsechzigtausend achthundertsechsunddreißig (1.665.836) Klasse I Anteilen, mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1) im Wege einer Übertragung des Aktienagios im Betrage von vierzehn Millionen neunhundertzwei-
undneunzigtausend fünfhundert Euro (EUR 14.992.500) in das Stammkapital der Gesellschaft; und
3. Entscheidung über Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft.
Die erschienene Partei, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertritt, fasste die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschluss:i>
Die Einzelgesellschafterin beschließt die folgenden neuen Anteilsklassen zu schaffen, die bezeichnet werden wie folgt:
Klasse A Anteile, Klasse B Anteile, Klasse C Anteile, Klasse D Anteile, Klasse E Anteile, Klasse F Anteile, Klasse G Anteile,
Klasse H Anteile und Klasse I Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1);
Jeder Anteil an jeder Klasse berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme an Hauptversammlungen und zu solchen wei-
teren Rechten, welche sich aus dem Gesetz und der Satzung der Gesellschaft, gemäß seiner erweiterten Fassung wie im
dritten Beschluss dargestellt, ergeben.
<i>Zweiter Beschluss:i>
Die Einzelgesellschafterin beschließt das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von vierzehn Millionen
neunhundertzweiundneunzigtausend fünfhundert Euro (EUR 14.992.500) aufzustocken um es von seinem gegenwärtigen
Betrag in Höhe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) auf einen Betrag in Höhe von fünfzehn Millionen fünf-
tausend Euro (EUR 15.005.000) zu bringen durch die Ausgabe von (i) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend
achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse A Anteilen, (ii) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthun-
dertdreiunddreißig (1.665.833) Klasse B Anteilen, (iii) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdrei-
unddreißig (1.665.833) Klasse C Anteilen, (iv) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddrei-
ßig (1.665.833) Klasse D Anteilen, (v) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig
(1.665.833) Klasse E Anteilen, (vi) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig
(1.665.833) Klasse F Anteilen, (vii) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig
(1.665.833) Klasse G Anteilen, (viii) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig
(1.665.833) Klasse H Anteilen, und (ix) einer Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertsechsunddreißig
(1.665.836) Klasse I Anteilen, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
Sämtliche neuen Geschäftsanteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, hier vertreten wie vorerwähnt gezeich-
net.
Alle ausgegebenen Aktien sind voll eingezahlt durch Übertragung des Aktienagios in Höhe von vierzehn Millionen
neunhundertzweiundneunzigtausend fünfhundert Euro (EUR 14.992.500) in das Stammkapital der Gesellschaft.
Die Existenz und der Bestand des Aktienagios ergibt sich aus einem Zwischenabschluss der Gesellschaft, welcher
gegenwärtiger Urkunde nach ne varietur Paraphierung, beigebogen und mitformalisiert wird.
<i>Dritter Beschluss:i>
In Folge der vorausgehenden Beschlüsse beschließt die Einzelgesellschafterin die wie im Folgenden dargestellte Satzung
der Gesellschaft, neu zu formulieren:
A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz
Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile (wie in Artikel 5 definiert) und/oder
jeder anderen Person, die künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée
unter der Firma “Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.” (die “Gesellschaft”).
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen
Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags (der „Gesellschaftervertrag“) erforderlich ist.
Art. 3. Zweck.
3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus
Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-
gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
57826
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und
- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in
welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.
3.3. Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen.
Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:
- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-
papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;
- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland beteiligen; und
- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes
beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.
Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxem-
burg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.
4.4. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.
B. Stammkapital - Geschäftsanteile -Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-
schäftsanteilen
Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzehn Millionen fünftausend Euro (EUR 15.005.000)
und ist eingeteilt in Stammanteile und Vorzugsanteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil
mit Rechten und Pflichten gemäß des vorliegenden Gesellschaftervertrages und gemäß der folgenden Unterteilung:
i. zwölftausend fünfhundert (12.500) Stammanteile (die „Stammanteile“);
ii. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse A (die
„Klasse A Anteile“);
iii. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse B (die
„Klasse B Anteile“);
iv. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse C (die
„Klasse C Anteile“);
v. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse D (die
„Klasse D Anteile“);
vi. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse E (die
„Klasse E Anteile“);
vii. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse F (die
„Klasse F Anteile“);
viii. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse G (die
„Klasse G Anteile“);
ix. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse F (die
„Klasse F Anteile“);
x. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse G (die
„Klasse G Anteile“);
xi. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertdreiunddreißig (1.665.833) Anteile der Klasse H (die
„Klasse H Anteile“);
xii. eine Million sechshundertfünfundsechzigtausend achthundertsechsunddreißig (1.665.836) Anteile der Klasse I (die
„Klasse I Anteile“, werden zusammen mit den Klasse A Anteilen, den Klasse B Anteilen, den Klasse C Anteilen, den Klasse
D Anteilen, den Klasse E Anteilen, den Klasse F Anteilen, den Klasse G Anteilen, und den Klasse H Anteilen, als die
„Vorzugsanteile“ bezeichnet und zusammen mit den Stammanteilen, als die „Anteile“).
57827
5.2. Das Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafter, welcher in der Weise gefasst wird
wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3. Die Anteile können von der Gesellschaft zu anderen Instrumenten verbunden oder als Schuldtitel ausgegeben
werden aufgrund eines Verbindungsvertrages („Stapling Agreement“) zwischen den Gesellschaftern. Jede Übertragung
der Anteile oder Instrumente oder Schulden im Widerspruch zu solch einem Verbindungsvertrag sind nichtig und ohne
jede rechtliche Wirkung.
5.4. Eine Herabsetzung des Stammkapitals durch den Rückkauf einer Klasse von Vorzugsanteilen kann nur innerhalb
der jeweiligen Klassenlaufzeit (gemäß der Begriffsdefinition in Artikel 5.9.) erfolgen:
i. Die Laufzeit für die Klasse A Anteile ist die Zeit beginnend mit dem Tage der Unterzeichnung der notariellen Urkunde,
dem 21. Januar 2015 und endet spätestens mit dem 31 Dezember 2015 (die „A Klasse Laufzeit“);
ii. Die Laufzeit für die Klasse B Anteile ist die Zeit beginnend nach dem Tage der A Klasse Laufzeit und endet spätestens
mit dem 31 Dezember 2016 (die „B Klasse Laufzeit“);
iii. Die Laufzeit für die Klasse C Anteile ist die Zeit beginnend nach dem Tage der B Klasse Laufzeit und endet spätestens
mit dem 31 Dezember 2017 (die „C Klasse Laufzeit“);
iv. Die Laufzeit für die Klasse D Anteile ist die Zeit beginnend nach dem Tage der C Klasse Laufzeit und endet spätestens
mit dem 31 Dezember 2018 (die „D Klasse Laufzeit“);
v. Die Laufzeit für die Klasse E Anteile ist die Zeit beginnend nach dem Tage der D Klasse Laufzeit und endet spätestens
mit dem 31 Dezember 2019 (die „E Klasse Laufzeit“);
vi. Die Laufzeit für die Klasse F Anteile ist die Zeit beginnend nach dem Tage der E Klasse Laufzeit und endet spätestens
mit dem 31 Dezember 2020 (die „F Klasse Laufzeit“);
vii. Die Laufzeit für die Klasse G Anteile ist die Zeit beginnend nach dem Tage der F Klasse Laufzeit und endet spätestens
mit dem 31 Dezember 2021 (die „G Klasse Laufzeit“);
viii. Die Laufzeit für die Klasse H Anteile ist die Zeit beginnend nach dem Tage der G Klasse Laufzeit und endet
spätestens mit dem 31 Dezember 2022 (die „H Klasse Laufzeit“);
ix. Die Laufzeit für die Klasse I Anteile ist die Zeit beginnend nach dem Tage der H Klasse Laufzeit und endet spätestens
mit dem 31 Dezember 2023 (die „I Klasse Laufzeit“);
5.5. Sollte eine Vorzugsanteilsklasse innerhalb der jeweiligen Klassenlaufzeit nicht zurückgekauft und gelöscht worden
sein, kann die Rücknahme und Löschung dieser Vorzugsanteilssklasse während einer Neuen Laufzeit vornehmen (die
“Neue Laufzeit”), welche am Tag nach der letzten Klassenlaufzeit (oder gegebenenfalls der unmittelbar vorangehenden
Neuen Laufzeit einer andern Stammanteilsklasse) und endet spätestens ein Jahr nach dem Beginn der Neuen Laufzeit. Die
erste Neue Laufzeit soll am Tag nach der I Klasse Laufzeit beginnen und die Klasse der nicht zurückgekauften und nicht
gelöschten Vorzugsanteile in ihrer jeweiligen Klassenlaufzeit soll in alphabetischer Reihenfolge von A Klasse bis I Klasse
beginnen (soweit nicht vorher bereits rückgekauft und gelöscht).
5.6. Sollte ein Wiederkauf und eine Löschung einer Klasse von Vorzugsanteilen vor dem letzten Tag ihrer jeweiligen
Klassenlaufzeit (oder gegebenenfalls der Neuen Laufzeit) eintreten, beginnt die darauffolgende Klassenlaufzeit (oder ge-
gebenenfalls der Neuen Laufzeit) am Tage nach dem Wiederkauf und der Löschung dieser Klasse von Vorzugsanteilen
und endet an dem Tage wie im Gesellschaftsvertrag für Beendigungsfristen vorgesehen.
5.7. Sollte eine gesamte Klasse bzw. alle Klassen zurückgekauft und gelöscht werden, wird der Löschwert (gemäß der
Begriffsdefinition in Artikel 5.9.) fällig und zahlbar seitens der Gesellschaft gegenüber dem Aktionär bzw. den Aktionären
anteilsmäßig ihrer Beteiligung an dieser Klasse bzw. diesen Klassen. Die Gesellschaft kann ihrer Zahlungsverpflichtung
sowohl durch Barzahlung, durch Sacheinlage, als auch durch Forderungsaufrechnung nachkommen.
5.8. Der im obigen Paragraphen genannte einzubehaltende Löschwert wird vom alleinigen Geschäftsführer oder, im
Falle einer Vielzahl von Geschäftsführern, durch den Geschäftsführerrat (im Sinne der unten aufgeführten Begriffsbestim-
mungen) nach pflichtgemäßem Ermessen und im Interesse der Gesellschaft bestimmt. Der alleinige Geschäftsführer, oder
im Falle einer Vielzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat kann, nach seinem alleinigen Ermessen, die frei
ausschüttbaren Reserven, entweder ganz oder teilweise, in die Bestimmung des Löschwertes miteinbeziehen oder davon
ausschließen.
5.9. Im Rahmen des vorliegenden Artikels 5 sollen die folgenden großgeschriebenen Begriffe die ihnen zugeordnete
Bedeutung haben:
i. „Zur Verfügung Stehender Betrag” bedeutet der Gesamtbetrag des Nettogewinns (zuzüglich Gewinnvorträge) erhöht
durch (i) alle frei ausschüttbaren Reserven und (ii) gegebenenfalls die Summe der Kapitalherabsetzung und der Reduzierung
der gesetzlichen Reserve in Zusammenhang mit der zu löschenden Vorzugsanteilsklasse, aber reduziert durch (i) alle
Verluste (zuzüglich Verlustvorträge) nicht mit Minuszeichen darzustellen, (ii) alle Beträge welche einer durch Gesetz oder
den vorliegenden Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Reserve zugeschrieben werden müssen, bestimmt auf der
Grundlage der Zwischenbilanz (ohne Doppelzählung), (iii) jeder Gewinnanteil, zu denen die Inhaber von Stammanteilen
gemäß des Gesellschaftsvertrages ermächtigt sind, und (iv) die Gewinnanteilsberechtigung, die sich wie folgt berechnet:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Wobei:
57828
AA = zur Verfügung stehender Betrag
NP = Nettogewinn (zuzüglich Gewinnvorträge)
P = alle frei ausschüttbaren Reserven
CR = die Summe der Kapitalherabsetzung und der Reduzierung der gesetzlichen Reserve in Zusammenhang mit der
zu löschenden Vorzugsanteilsklasse
L = alle Verluste (zuzüglich Verlustvorträge) nicht mit einem Minuszeichen darzustellen
LR = alle Beträge welche einer durch Gesetz oder den vorliegenden Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Reserve
zugeschrieben werden müssen
OD = jeder Gewinnanteil, zu denen die Inhaber von Stammanteilen gemäß des Gesellschaftsvertrages ermächtigt sind
PE = Gewinnanteilsberechtigung
Der zu Verfügung stehende Betrag muss in der Zwischenbilanz in der jeweiligen Klassenlaufzeit ausgewiesen werden
und wird vom alleinigen Geschäftsführer, oder im Falle einer Vielzahl von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat der
Gesellschaft, nach Treu und Glauben und im besten Gesellschaftsinteresse, dass diese für die Zukunft gut aufgestellt ist,
festgesetzt.
ii. „Zur Verfügung stehende Finanzmittel“ bedeutet (i) jedwedes Bargeld, welches der Gesellschaft zur Verfügung steht
(außer Festgeld mit einer Restlaufzeit von über sechs (6) Monaten), (ii) jedes gängige Geldmarktinstrument, Anleihen und
Depotverbindlichkeiten und jede Forderung, die, gemäß der Einschätzung des Geschäftsführerrats, der Gesellschaft, ab-
züglich der Nettoverschuldung oder anderer Schulden der Gesellschaft, innerhalb von sechs (6) Monaten, gemäß der
Zwischenbilanz in Beziehung zu der jeweiligen Klassenlaufzeit (oder gegebenenfalls Neuen Laufzeit), gutgeschrieben wer-
den können und (ii) jede Art von Vermögenswerten im Sinne von Anteile, Aktien oder Sacheinlagen gehalten von der
Gesellschaft.
iii. „Löschwert“ bedeutet einen Wert, welcher den zur Verfügung stehenden Betrag nicht überschreitet unter Zu-
grundelegung der jeweiligen Klassenlaufzeit (oder gegebenenfalls der Neuen Laufzeit) unter der Voraussetzung, dass dieser
Löschwert nicht höher als die zur Verfügung stehenden Finanzmittel ist, unter Zugrundelegung der jeweiligen Klassen-
laufzeit (oder Neuen Laufzeit).
iv. „Klassenlaufzeit“, bedeutet jede der Klasse A Laufzeit, Klasse B Laufzeit, Klasse C Laufzeit, Klasse D Laufzeit, Klasse
E Laufzeit, Klasse F Laufzeit, Klasse G Laufzeit, Klasse H Laufzeit, und Klasse I Laufzeit.
v. „Zwischenbilanz“, bedeutet der Zwischenabschluss der Gesellschaft zum entsprechenden Zwischenabschlusszeit-
punkt.
vi. „Zwischenabschlusszeitpunkt“, bedeutet das Datum, nicht früher als dreißig (30) Kalendertage aber nicht später als
zehn (10) Kalendertage vor dem Termin des Rückkaufs und der Löschung der entsprechenden Vorzugsanteilsklasse.
vii. „Gesetz“ bedeutet das Gesetz von 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und seine Änderungen.
viii. „Gewinnanteilsberechtigung“ bedeutet die Vorzugsdividende der Vorzugsanteile.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist Stammanteile und Vorzugsanteile, wie in Artikel 5 definiert, aufgeteilt.
6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig
(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.
6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl
der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Anteile gemäß Artikel 24.
6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-
fend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.
6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurückgekauften
oder zurückgenommenen Anteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend herabgesetzt und vorbe-
haltlich Artikel 5.
6.6. Die Anteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.
6.7. Bruchteilgeschäftsanteile sollen auf einer anteilsmäßigen Basis dieselben Rechte gewähren wie ganze Anteile, wobei
aufgrund von Anteilen nur dann Stimmrechte ausgeübt werden können, wenn die Anzahl der Bruchteilgeschäftsanteile in
ein oder mehreren Anteilen zusammengefasst werden können. Falls Bruchteilgeschäftsanteile bestehen, welche nicht zu
einer Anteile zusammengefasst werden können, können aufgrund solcher Bruchteilgeschäftsanteile keine Stimmrechte
ausgeübt werden.
Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-
schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Anteile, jede Übertragung von Anteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die Gesellschaft oder
57829
das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem Gesellschaftsver-
trag sowie jedes über Anteile gewährte Sicherungsrecht.
7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung
mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.
Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Anteilen.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Anteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesellschafterver-
zeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser Eintragungen je
nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen
Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.
8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Personen
gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer des
Anteiles angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum mehrerer
Personen stehenden Anteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet worden ist.
8.3. Die Anteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden
nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden Gesellschaf-
ter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit gesetzlich
nicht anders vorgesehen, können die Anteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Einwilligung der Gesell-
schafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte der überlebenden
Gesellschafter repräsentieren.
8.4. Jede Übertragung von Anteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles in
privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der Ge-
sellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesell-
schafterverzeichnis eintragen kann.
8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen
und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.
C. Gesellschafterversammlung
Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-
terversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff “alleiniger Gesellschafter” nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
“Gesellschafterversammlung” als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“ gelesen werden.
9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich
verliehenen Befugnisse.
9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,
statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.
Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die
satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.
10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-
sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.
10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit
der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.
10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.
57830
Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-
denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.
11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Quorum und Stimmabgabe
11.3.1. Jeder Anteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-
schafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.
11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,
Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.
11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz,
Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesell-
schafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durch-
gehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und
Mehrheit anwesend ist.
11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-
formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.
11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden
müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.
Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag
durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.
Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern
sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.
13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Be-
schlüsse aufnehmen und unterzeichnen.
13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen
oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein
müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff “alleiniger Geschäftsführer” nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den “Geschäftsführerrat”
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer” gelesen werden.
57831
14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.
14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts
können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.
14.4. Die Gesellschaft kann notariellen oder durch privatschriftliche Urkunde auch speziellen Vollmachten an jedwede
Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.
Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten
des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.
Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit
festlegt.
16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen
werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.
16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer
kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.
Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner
Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung
anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.
Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen
18.2. Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
an der Sitzung anwesend oder vertreten ist und, sofern mehrere Klassen von Geschäftsführern ernannt wurden, min-
destens ein (1) Geschäftsführer jeder Klasse anwesend oder vertreten ist.
18.3. Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder
vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.
18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein
anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-
okonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
abgehalten wurde.
18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in
einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
57832
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.
18.7. Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt
oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat
und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inte-
ressenskonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden. Dieser Artikel 18.7 ist nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.
Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung
des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.
19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden
sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame
Unterschrift eines Geschäftsführer der Klasse A und eines Geschäftsführer der Klasse B oder durch die Unterschrift des
alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en)
gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer
übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des
Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in
Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.
E. Aufsicht
Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder
mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.
21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und
ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.
21.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung
abberufen werden.
21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Ge-
schäfte der Gesellschaft.
21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten
der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.
21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher
aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.
21.7. Sofern die Gesellschafter einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in
Übereinstimmung mit Artikel 69 des abgeänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister
und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen bestimmen, so ersetzt/ersetzen dieser/diese unabhängige
(n) Buchprüfer den/die satzungsmäßige(n) Buchprüfer.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-
unddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 23. Gewinne.
23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.
57833
23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage
zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.
23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt
werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.
23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-
versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.
Art. 24. Ausschüttungen - Dividenden - Zwischendividenden - Emissionsagio.
24.1. Nach Empfehlung des Geschäftsführerrates, bestimmt die Hauptversammlung über die Verwendung der Ge-
winnüberschüsse der Gesellschaft wie vorgeschrieben im Gesetz und in dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag.
24.2. Ausschüttungen zu den Gesellschaftern erfolgen im Verhältnis zu den Anteilen, die sie an er Gesellschaft halten
und werden in folgender Reihenfolge ausgezahlt:
i. Stammanteilsinhaber haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,01% des Nominalwertes der Stammanteile;
ii. Inhaber von Klasse A Anteilen haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,20% des Nominalwertes der Klasse
A Anteile;
iii. Inhaber von Klasse B Anteilen haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,25% des Nominalwertes der Klasse
B Anteile;
iv. Inhaber von Klasse C Anteilen haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,30% des Nominalwertes der
Klasse C Anteile;
v. Inhaber von Klasse D Anteilen haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,35% des Nominalwertes der Klasse
D Anteile;
vi. Inhaber von Klasse E Anteilen haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,40% des Nominalwertes der Klasse
E Anteile;
vii. Inhaber von Klasse F Anteilen haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,45% des Nominalwertes der
Klasse F Anteile;
viii. Inhaber von Klasse G Anteilen haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,50% des Nominalwertes der
Klasse G Anteile;
ix. Inhaber von Klasse H Anteilen haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,55% des Nominalwertes der
Klasse H Anteile;
x. Inhaber von Klasse I Anteilen haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,60% des Nominalwertes der Klasse
I Anteile; und
xi. Der Restbetrag wird den Stammanteilsinhabern zugewiesen, wie in einer Entscheidung in der Hauptversammlung
bestimmt.
24.3. In Übereinstimmung mit dem Gesetz und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag kann der Geschäftsführerrat
oder die Gesellschafterversammlung Zwischendividenden zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenkonten er-
stellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der
Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde,
realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rück-
lagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem
Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem
Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.
24.4. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation.
25.1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche
oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die die Auflösung der
Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.
25.2. Nach Bezahlung aller Schulden und Ansprüche gegen die Gesellschaft, die Liquidationskosten inbegriffen, sollen
die Nettoliquidationserlöse an die Gesellschafter ausbezahlt werden, mit der Maßgabe, auf einer aggregierten Grundlage
zu dem gleichen Ergebnis zu kommen wie von den Regelungen zur Ausschüttung von Dividenden vorgesehen.
H. Anwendbares recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-
burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.
57834
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden
Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 6.500,- geschätzt.
Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der
erschienen Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung. Auf Wunsch
der erschienen Partei und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die eng-
lische Fassung maßgeblich sein.
Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde
erwähnt wird.
Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienen Partei vorgelesen, dem Notar mit Nachnamen, Vornamen,
Zivilstand und Wohnsitz bekannt, ferner haben der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: B. GILLOT und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2581. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 16. März 2015.
Référence de publication: 2015045543/1066.
(150052262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
DD Performance Lux, Société Civile, Société Civile.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg E 5.591.
STATUTS
Les soussignés:
1. Mr. Denis DUMONT, Directeur de sociétés, né le 19.07.1958 à Lorgies, France, résidant au 222Bis Route de
Lausanne, CH-1292 Chambesy, Suisse, ici représenté par Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle au 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,
2. La société Fruit Invest, société anonyme, ayant son siège social au, 45 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
inscrite au registre de Commerce et Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.78474, ici représentée par:
- Monsieur Stéphane ALLART, Expert-comptable, né le 19 février 1981 à Uccle, Belgique, et résidant professionnel-
lement au 45, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, et
- Monsieur Olivier DEDOBBELEER, employé privé, né le 9 avril 1983 à Namur, Belgique, et résidant professionnelle-
ment au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
en leur qualité d'administrateur,
ont arrêté les statuts d'une société civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil et pour le surplus par la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes.
Art. 2. La société a pour objet toute acquisition et détention de biens mobiliers.
La société peut entreprendre, soit seule, soit en coopération avec d'autres, soit directement, soit indirectement, pour
son compte ou pour compte de tiers, toute opération mobilière se rattachant directement ou indirectement à son objet
social ou pouvant contribuer à son développement.
La société pourra notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou
complémentaires.
La société peut souscrire tout type de contrat et notamment tout contrat d'assurance-vie.
Art. 3. La dénomination de la société est DD PERFORMANCE LUX, Société Civile
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée
générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant les trois quarts du capital social.
57835
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de € 1.000.000,- (un million d'euros) divisé en 1.000.000 (un million) parts
de € 1,- (un euro) chacune, souscrites comme suit:
Mr. Denis DUMONT, Directeur de sociétés, né le 19.07.1958 à F -Lorgies, France, résidant au 222Bis Route de
Lausanne, CH - 1292 Chambesy, Suisse: 999.999 parts
La société Fruit Invest S.A., pré qualifiée: 1 part
Total: 1.000.000 parts.
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L'intégralité de l'apport devra être libérée
sur demande d'un gérant ou des associés.
Art. 7. La cession des parts s'opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l'article 1690 du Code Civil.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec le consentement de la majorité des associés repré-
sentant au moins les deux tiers du capital social.
Tout associé désirant céder tout ou partie de ses parts à un tiers, doit en informer le gérant, qui, à cet effet, convoquera
une assemblée générale extraordinaire ayant à son ordre du jour l'agrément du cessionnaire.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire n'atteint pas le quorum requis ou qu'elle refuse d'agréer le cessionnaire,
la société est en droit de racheter les parts, visées à l'alinéa précédent, pour son propre compte ou pour compte de
personnes à désigner par elle.
Le non-exercice du droit de rachat par la société ouvre un droit de préemption sur les parts au profit de tous les co-
associés du cédant au prorata de leurs parts dans la société.
Sauf accord du cédant, le droit de rachat et le droit de préemption doivent être exercés sur la totalité des parts faisant
l'objet dudit droit.
Le rachat effectué par la société sans désignation de tiers cessionnaires comporte l'obligation de procéder concomi-
tamment à l'annulation de ces parts et à la réduction correspondante de son capital.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé font naître le droit de rachat au profit de la société et subsidiai-
rement le droit de préemption au profit des co-associés de l'interdit, du failli ou de l'associé en déconfiture conformément
aux stipulations des quatre alinéas précédents.
En cas de décès d'un associé, la société a le droit de racheter à tout moment les parts recueillies par les héritiers pour
son propre compte ou pour compte de personnes à désigner par elle. Les sixième et septième alinéas précédents s'ap-
pliquent à cette hypothèse.
Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts sociales.
Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu'ils détiennent.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code
Civil. Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire
et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer
une action personnelle contrer les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de
poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers ou ayants cause de l'associé ou des associés décédés.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société qui continuera
entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.
Art. 11. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur
nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des gérants, il sera pourvu à son remplacement par décision
des associés.
Art. 12. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-
constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet social.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables.
57836
Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu'elle peut
devoir ou en ordonne le paiement. Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers ou débiteurs. Ils exercent
toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.
Ils autorisent ainsi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes sub-
rogations, prêts, et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés. Ils statuent
sur toutes propositions à faire à l'assemblée générale des associés et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 13. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 14. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenable, mais ils
doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un
cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées
aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou
représentés.
Art. 16. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions
contraires des statuts.
Art. 17. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts
existantes.
Art. 18. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants
ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une autre
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.
Art. 19. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les
statuts.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, les associés ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1/ Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Mr. Denis DUMONT, Directeur de sociétés, né le 19.07.1958 à F -Lorgies, France, résidant au 222Bis Route de
Lausanne, CH - 1292 Chambesy, Suisse,
En cas de décès ou d'empêchement permanent du gérant, la gérance sera assurée par Madame Françoise Berodier,
née le 05.02.1962 à Tournus (France), demeurant professionnellement au 40, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.
2/ Le siège social est établi à L - 1931 Luxembourg, 45 Avenue de la Liberté.
Fait et passé le 23 mars 2015.
Denis DUMONT
Représenté par P. Mestdagh
FRUIT INVEST S.A.
Représentée par S. ALLART
<i>Administrateur
i>O. DEDOBBELEER
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015044995/140.
(150051874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
57837
Broad Street Loan Partners 2013 Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 178.062.
In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of the month of March;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
MBD 2013, L.P., a Delaware Limited Partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered
with the Secretary of State of Delaware under registration number 5288482, having its registered office at 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castel County, Delaware 19801, USA, acting through its General Partner, MBD Advisors, L.L.C.,
here represented by Me Christèle PIERRE-ALEXANDRE, Avocat, with professional address in L-2370 Howald, 2, rue
Peternelchen, by virtue of a proxy given under private seal; and
BROAD STREET LOAN PARTNERS 2013 ONSHORE, L.P., a Delaware Limited Partnership formed and existing under
the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 5347956,
having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castel County, Delaware 19801, USA, acting through
its General Partner, Broad Street Loan Partners 2013 Onshore Advisors, L.L.C.
here represented by Me Christèle PIERRE-ALEXANDRE, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The prenamed parties are the shareholders of Broad Street Loan Partners Onshore S.àr.l., a société à responsabilité
limitée, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 178.062, having its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed dated 11 June 2013 received by the undersigned notary, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”) dated 2 August 2013, number 1865, page
89499 (the “Company”). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a
deed dated 8 August 2013 received by the undersigned notary, published in the Mémorial C dated 30 October 2013
number 2716, page 130322.
Which appearing parties, represented as indicated above, have requested the notary to enact the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The shareholders resolved to amend the third paragraph of article 19 of the articles of association of the Company in
relation to the rights of holders of preference shares, all other paragraphs of such article 19 remaining unchanged. The
third paragraph shall read as follows:
“Notwithstanding anything contained herein to the contrary, the holders of Preference Shares shall be entitled only
to an annual yield on the principal of the Preference Shares not exceeding an annual rate of EURIBOR +12% calculated
on the nominal amount of the Preference Shares which may be payable on (a) an annual date, or (b) may be accrued until
such a date, each as determined by the board of managers, and in any event all accrued and unpaid amount shall be due
and payable on June 11
th
, 2025. Prior to June 11
th
, 2025, no Shareholder will have any right, power, privilege or ability
to demand, sue for or otherwise make claims in respect of, the acceleration, redemption or calling of the Preference
Shares or any portion thereof.”.
<i>Estimated costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the sole resolution, have been estimated at about one thousand Euros (EUR 1,000.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Howald on the date mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by surname, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
57838
ONT COMPARU:
MBD 2013, L.P., une société Delaware Limited Partnership constituée et agissant selon les lois de l’Etat du Delaware,
immatriculée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 5288482, ayant son siège social à 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castel County, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, agissant par son General Partner, MBD
Advisors, L.L.C.,
ici représentée par Maître Christèle PIERRE-ALEXANDRE, Avocat, ayant son adresse professionnelle à L-2370 Ho-
wald, 2, rue Peternelchen, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé; et
BROAD STREET LOAN PARTNERS 2013 ONSHORE, L.P., une société Delaware limited partnership, constituée et
agissant selon les lois du Delaware, immatriculée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 5347956,
ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castel County, Delaware 19801, USA, agissant par son
General Partner, Broad Street Loan Partners 2013 Onshore Advisors, L.L.C.,
ici représentée par Maître Christèle PIERRE-ALEXANDRE, prénommée, en vertu d'une procuration lui conférée sous
seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire
instrumentaire, resteront annexées au présent acte, aux fins d’enregistrement.
Les parties susnommées sont les associés de Broad Street Loan Partners 2013 Onshore S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
178.062, constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 11 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial») du 2 août 2013, numéro 1865, page 89499 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, le 8 août 2013, publié au Mémorial C du 30 octobre
2013, numéro 2716, page 130322.
Lesdites parties comparantes, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d’arrêter la
résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associés ont décidé de modifier le troisième alinéa de l’article 19 des statuts de la Société relatif aux droits des
détenteurs des parts sociales préférentielles, les autres paragraphes dudit article 19 demeurant inchangés. Le troisième
alinéa dudit article 19 doit être lu désormais comme suit:
«Nonobstant toute disposition contraire des présents statuts, les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles auront
seulement droit à un rendement annuel sur le capital des Parts Sociales Préférentielles ne dépassant pas un taux annuel
de EURIBOR +12% calculé sur le montant nominal des Parts Sociales Préférentielles qui peut être payé à (a) une date
annuelle, ou (b) peut être accumulé jusqu’à cette date, déterminée chacune par le conseil de gérance, et dans tous les cas
tout montant impayé et accumulé sera dû et exigible le 11 juin 2025. Avant le 11 juin 2025, les Associés n’auront aucun
droit, pouvoir, privilège ou capacité d’exiger, poursuivre ou faire des réclamations en ce qui concerne, l’exigibilité avancée,
rachat ou l’appel des Parts Sociales Préférentielles ou de toute partie de celles-ci.».
<i>Évaluation et Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui seront mis à sa charge en raison du présent acte de société, s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande du même comparant, il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Howald, date en en-tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et
demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. PIERRE-ALEXANDRE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/5682. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société;
Luxembourg, le 23 mars 2015.
.
Référence de publication: 2015044912/107.
(150051831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
57839
Goron S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 57.476.
L'an deux mille quinze, le douze mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la déno-
mination de "GORON S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 57.476, ayant son siège social à Luxembourg au 3, rue Nicolas
Adames, L-1114 Luxembourg, constituée par acte de Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 18 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 148 du 26 mars 1997.
Les statuts de ladite société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 31 mars 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 563 du 8 août 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, domicilié
professionnellement au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domiciliée profession-
nellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre SCHILL, prénommé.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les soixante-douze mille
(72.000) actions sans indication de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de un million sept cent
quatre-vingt-quatre mille huit cent trente-trois Euros trente-huit Eurocent (EUR 1.784.833,38) sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir
sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Pierre SCHILL,
licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, professionnellement domicilié au 18a, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de
réaliser les opérations prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Schill, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 mars 2015. 2LAC/2015/5747. Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015044463/52.
(150050533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
57840
Allegretto Holding S.à.r.l.
An-Ca.Lux S,A,
Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.
Belgofin S.A. - SPF
Berg Holding S.A.
Bonbonera Group S.A.
Bonvalot S.A.
Bpi VII S.à r.l.
Broad Street Loan Partners 2013 Onshore S.à r.l.
Brookfield Properties (Luxembourg) Branch
BTG Pactual E&P S.à r.l.
Business Car Lux SC
Capital City Brewing Co.
Cellmedia S.A.
C.G.R.H. s.à.r.l. (Conseil en gestion des ressources humaines)
Clove Management S.àr.l.
Colday S.à r.l.
ColLir S.à r.l.
Colony Funds Sants S.à r.l.
DD Performance Lux, Société Civile
Falco Investments S.A.
Fiduciaire Comptable Luxconcept Sàrl
Finapar S.à r.l. - SPF
For-Sci-Tech Lux S.A.
Franciacorta Property Management S.A.
Franciacorta Property Management S.A.
Goron S.A.
HBM Place d'Armes S.à r.l.
Heisieh S.A.
Huyan S.A.
IK Investment Partners A S.à r.l.
IK Investment Partners VII A S.à r.l.
Immobilière de la Rocade S.à r.l.
INVESTIMENTI RETTIFICHE INDUSTRIALI Luxembourg S.A.
IRAF Heidi
Media Inside S.à r.l.
Mediterranean Shipping Company Luxemburg S.A.
Plazo
R&S Schmieden Holztreppen S.à r.l.
SIG Combibloc Holdings GP S.à r.l.
Treveria Four S.à r.l.
Twinhope Finance S.A.
Vespa A S.C.A.
Wyeth Ayerst Sàrl