logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1139

2 mai 2015

SOMMAIRE

Bruni S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54634

CEES Invest II SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54672

Crystal Navy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54634

Digital Services XVI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

54639

Enoue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54663

Immo DM, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54627

Isurus Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54627

Kiawah Island Capital Advisers S.à r.l. . . . .

54638

Leponte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54628

LS2 Consult s. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54627

LSF6 Europe Financial Holdings S.à r.l. . . .

54627

LuxScan Technologies S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

54628

Lys Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54626

Macae Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54668

Neried Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54667

Neuenfelde Navigation AG . . . . . . . . . . . . . .

54626

Novamil Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54627

Nova-Via S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54626

Nova-Via S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54626

Petroceltic S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54626

Pitibech SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54636

Portrea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54635

RRR Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

54633

Sablon Participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54634

SB International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54633

Scania Treasury Luxembourg  . . . . . . . . . . .

54630

Schortgen Galerie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

54630

SCP OCN Acquisition Lux S.à r.l.  . . . . . . .

54633

Scuderia CDS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54628

Searchlight BMS II (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . .

54630

Sistema Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54631

Sisto Armaturen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54631

Sivato Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54632

Skandia Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54631

Sky Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54629

Socialcom Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

54630

Société luxembourgeoise de Leasing BIL-

LEASE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54629

Soico S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54632

Space Liner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54631

SSI Schäfer Shop GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . .

54632

STENA CARRON (Hungary) KFT, Luxem-

bourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54633

STENA TAY (Hungary) LLC, Luxembourg

Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54632

Stericycle Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

54629

Sun Live Solarium S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

54629

Zinnia Hotels Group S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .

54671

54625

L

U X E M B O U R G

Neuenfelde Navigation AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 82.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015043089/9.
(150049441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

Nova-Via S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.

R.C.S. Luxembourg B 157.490.

Par la présente, je soussigné, Monsieur Emmanuel TROUVE, démissionne de mon poste d'administrateur de la société

NOVA-VIA S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157490.

Bettembourg, le 27/02/2015.

Emmanuel TROUVÉ.

Référence de publication: 2015043096/10.
(150049386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

Nova-Via S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.

R.C.S. Luxembourg B 157.490.

Par la présente, je soussigné, Monsieur Michel RECKINGER, démissionne de mon poste d'administrateur de la société

NOVA-VIA S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157490.

Bettembourg, le 06/03/2015.

Michel RECKINGER.

Référence de publication: 2015043097/10.
(150049386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

Petroceltic S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 39.351.

Le siège social de la société PETROCELTIC RESOURCES PLC, associé unique de la Société, se situe désormais au 16,

Old Queen Street, GB - SW1H 9HP Londres (Royaume-Uni).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015043665/11.
(150050220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

Lys Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 187.907.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 19 mars 2015

Le siège social a été transféré du L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas

Bové, avec effet au 1 

er

 septembre 2014.

Luxembourg, le 19 mars 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Lys Investments S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015043587/14.
(150049884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

54626

L

U X E M B O U R G

Novamil Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 100.958.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015043644/9.
(150049772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

LS2 Consult s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 163.431.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2015.

Référence de publication: 2015043600/10.
(150049992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

LSF6 Europe Financial Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 142.579.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2015.

Référence de publication: 2015043601/10.
(150050090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

Isurus Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 100.330.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ISURUS LUX S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2015044509/12.
(150050847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.

Immo DM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 1, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 129.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2015.

<i>Pour la société
Jean-Michel Dangis
<i>Comptable

Référence de publication: 2015044495/13.
(150050557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.

54627

L

U X E M B O U R G

Leponte S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 79.163.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration tenue en date du 5 mars 2015 que le siège social de la société a

été transféré de son ancienne adresse au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

Dorénavant, Madame Valérie WESQUY née à Mont-Saint-Martin (France) le 6 mars 1968, demeurant professionnel-

lement 19 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, sera inscrite sous le nom de Madame Valérie
RAVIZZA.

En outre, il est à noter que Monsieur Michele CANEPA, actuel administrateur, est désormais domicilié au 10, rue

Antoine Jans L-1820 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2015.

Référence de publication: 2015044535/17.
(150050851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.

Scuderia CDS S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-4562 Niederkorn, 12, Z.A.C. Haneboesch II.

R.C.S. Luxembourg B 143.758.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 10 février 2015

Renomination Monsieur RODRIGUES DE SOUSA Carlos Alberto, domicilié professionnellement à L-4562 Nieder-

korn, 12, Z.A.C. Haneboesch II, au poste d'administrateur de la société à partir de la date du 10 février 2015 pour une
période de six ans;

Monsieur GARRUCHO Antonio, employé privé, domicilié à L-4562 Niederkorn, 12, Z.A.C. Haneboesch II, au poste

de Commissaire aux Comptes de la société à partir de la date du 10 février 2015 pour une période de six ans, en
remplacement de Bureau Comptable Jans S. à r.l., avec siège social à Differdange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
SCUDERIA CDS SA
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015045400/18.
(150051097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

LuxScan Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest Ehlerange.

R.C.S. Luxembourg B 130.533.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue en date du 09 mars 2015 que:
- la démission de M. Michael HOLTMANN de ses fonctions de Gérant de la société a été acceptée avec effet au 02

mars 2015.

- M. Johannes Mario KORDT, Gérant, né le 06 juin 1972 à AACHEN (Allemagne), demeurant au Mittelgasse 19,

D-69502 Hemsbach (Allemagne) été nommé aux fonctions de Gérant de la société avec effet le 02 mars 2015 pour une
durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 mars 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015044530/19.
(150050722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.

54628

L

U X E M B O U R G

Stericycle Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.343.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 336 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015045382/9.
(150051876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Sun Live Solarium S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 86, rue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 80.793.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 23/02/2015.

Référence de publication: 2015045383/10.
(150051206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Société luxembourgeoise de Leasing BIL-LEASE, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 136, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 38.718.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/03/2015.

Société Luxembourgeoise de Leasing Bil-Lease
Société Anonyme
Charlotte LIES / Philippe HOUBEN
<i>Directeur / Responsable Comptabilité

Référence de publication: 2015045376/14.
(150051539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Sky Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.621.791,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 145.803.

1. Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société datées du 13 février 2015 que M. Hector Armando

Fernandez Rousselon a démissionné du poste de gérant de classe A de la Société avec effet au 1 

er

 février 2015.

2. Il résulte de ces mêmes résolutions datées du 13 février 2015 que M. Martin Alejandro Martinez Altamirano, né le

23 septembre 1967 à Mexico, Mexique, résidant professionnellement à Guillermo Gonzalez Camarena 800-Piso 4, Col.
Zedec Santa Fe, CP.01210, Mexico, D.F., Mexique, a été nommé au poste de gérant de classe A de la Société avec effet
au 1 

er

 février 2015 et pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance au 1 

er

 février 2015 est composé comme suit:

- M. Jose Antonio Perez Helguera, gérant de classe A;
- M. Martin Alejandro Martinez Altamirano, gérant de classe A;
- M. Daniel Boone, gérant de classe B; et
- M. Pierre Crasquin, gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015045374/21.
(150051765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

54629

L

U X E M B O U R G

Searchlight BMS II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 193.551.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015045370/10.
(150051463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Socialcom Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 2, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 183.839.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015045378/11.
(150051912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Scania Treasury Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 40.137.000,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 72.450.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 06/01/2000

<i>Rectificatif du document enregistré et déposé le 31.01.2014 sous le N° L140020649 concernant le nom et prénom du gérant et

<i>gérant délégué à la gestion journalière de la société:

- le prénom du gérant et gérant délégué à la gestion journalière de la société est «Börje» et le nom de famille est

«Wigfeldt», né le 7 mars 1958 à Hägersten, Suède, résidant professionnellement au Vagnmakarvägen 1, 151 87 Södertälje,
Suède.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SCANIA TREASURY LUXEMBOURG

Référence de publication: 2015045368/16.
(150051729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Schortgen Galerie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 21, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 94.491.

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales du 16 mars 2015 que Monsieur Jean-Paul Schortgen demeurant 286,

rue de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette, a vendu 25 parts sociales à Monsieur Maurice Schortgen demeurant 86, Lan-
gertengaass, L-3763 Tétange.

Après la cession ci-avant décrite, le capital de la société se trouve réparti comme suit:
- Monsieur Jean-Paul Schortgen: 25 parts sociales
- Monsieur Manuel Schortgen: 25 parts sociales
- Monsieur Martin Schortgen: 25 parts sociales
- Monsieur Maurice Schortgen: 25 parts sociales

Luxembourg, le 20 mars 2015.

<i>Le gérant

Référence de publication: 2015045392/17.
(150051205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

54630

L

U X E M B O U R G

Skandia Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 137.401.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015045411/10.
(150051358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Space Liner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 22, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.380.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 19 mars 2015

L'assemblée générale décide de nommer délégué à la gestion journalière pour une durée indéterminée, Monsieur

Joseph  GAGELMANS,  né  le  27  juillet  1960  à  Kalmthout  (Belgique),  demeurant  70,  Grand-Rue  à  B-6800  Libramont-
Chevigny. Monsieur Joseph GAGELMANS peut engager la société par sa seule signature et dispose d'un pouvoir de co-
signature obligatoire.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015045418/13.
(150051373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Sisto Armaturen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 20.425.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung der SISTO Armaturen S.A. vom 16.03.2015

<i>Prüfungsbeauftragter der Geschäftsbuchführung

6. Die Firma BDO Audit, Luxembourg, wurde zum Wirtschaftsprüfer und „Reviseur d'Entreprise“ für das Geschäftsjahr

2015 bestimmt.

Echternach, den 17.03.2015.

SISTO Armaturen S.A.
A. Laschke / M. Schneider
<i>Geschäftsführer / Kfm. Leiter

Référence de publication: 2015045410/15.
(150051374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Sistema Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 93.023.

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société tenue en date du 18 mars 2015:

1. Le mandat d'administrateur de Mr Dmitry Korovkin a été renouvelé, avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale

qui se tiendra en 2015.

2. Le mandat du commissaire aux comptes Grant Thornton Lux Audit S.A. avec adresse au 89A, rue Paferbruch, L-8308

Capellen a été renouvelé, avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Le siège social de la société est sis au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015045409/16.
(150051535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

54631

L

U X E M B O U R G

Soico S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 117.394.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015045415/9.
(150051424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Sivato Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 177.852.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 349 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015045371/9.
(150051640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

SSI Schäfer Shop GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 16, ZI Zare Ilôt Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 191.710.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 23. März 2015.

<i>Für die Gesellschaft
Jean SECKLER
<i>Der Notar

Référence de publication: 2015045420/13.
(150051598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

STENA TAY (Hungary) LLC, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.210.

STENA TAY (HUNGARY) LLC a pris acte de la démission des gérants suivants:
- Monsieur Brian ELDERS avec effet au 26 septembre 2011.
- Monsieur George Albert COWIE avec effet au 27 mai 2011.
STENA TAY (HUNGARY) LLC a décidé de nommer comme nouveaux gérants:
- Madame Judith CZIDRA, née le 21 avril 1980 à Budapest (Hongrie), demeurant à György utca 80. b. ép., 1161

Budapest, Hongrie, avec effet au 24 février 2012 pour une durée indéterminée.

- Monsieur Ole LINDOE, né le 29 mai 1958 à Stavanger (Norvège), demeurant à Sirina utca 13, Paphos Tala, Chypre,

avec effet au 23 mai 2013 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de STENA TAY (HUNGARY) LLC se compose dès lors comme suit:
- Mats Anders CARLSSON;
- Miklos KONKOLY-THEGE;
- Péter CSIBA;
- Judith CZIDRA; et
- Ole LINDOE.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015045426/23.
(150051551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

54632

L

U X E M B O U R G

RRR Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.595.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015045423/10.
(150051681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

SCP OCN Acquisition Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 193.571.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015045399/10.
(150051585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

SB International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.089.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2015.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2015045389/12.
(150051156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

STENA CARRON (Hungary) KFT, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.917.

STENA CARRON (HUNGARY) KFT a pris acte de la démission de Monsieur Brian ELDERS de son mandat de gérant

avec effet au 26 septembre 2011.

STENA CARRON (HUNGARY) KFT a décidé de nommer comme nouveaux gérants:
- Madame Judith CZIDRA, née le 21 avril 1980 à Budapest (Hongrie), demeurant à György utca 80. b. ép., 1161

Budapest, Hongrie, avec effet au 7 mai 2012 pour une durée indéterminée.

- Monsieur Ole LINDOE, né le 29 mai 1958 à Stavanger (Norvège), demeurant à Sirina utca 13, Paphos Tala, Chypre,

avec effet au 27 novembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de STENA CARRON (HUNGARY) KFT se compose dès lors comme suit:
- Mats Anders CARLSSON;
- Miklos KONKOLY-THEGE;
- Péter CSIBA;
- Judith CZIDRA; et
- Ole LINDOE.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015045424/22.
(150051552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

54633

L

U X E M B O U R G

Crystal Navy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.150.000,00.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 145.511.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société datées du 10 mars 2015

L'associé unique a pris connaissance du rapport du liquidateur et l'a approuvé.
L'associé unique a décidé de renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation pour contrôler les actions

effectuées par le liquidateur et a décidé de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 10 mars 2015.

Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel

pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente mention au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2015.

Référence de publication: 2015041450/17.
(150047369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Sablon Participations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 139.123.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

«Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

a ordonné la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- SABLON PARTICIPATIONS SA (B-139123),
Le même jugement a nommé juge commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg et liquidateur Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire leurs déclarations de créances au greffe de la sixième chambre du tribunal de

commerce avant le 10 avril 2015.

Pour extrait conforme
Lionel GUETH-WOLF
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015045367/18.
(150051199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Bruni S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 190.923.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 12 mars 2015, que l'associé unique de la Société,

AIM Services S.à r.l., a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Intermediate Capital Group Plc, une public company limited by shares, constituée et régie selon les lois du Royaume-

Uni, ayant son siège social au: Juxon House, 100 St Paul's Churchyard, Londres EC4M 8BU, Royaume-Uni, immatriculée
auprès du Companies House sous le numéro 2234775.

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

- Intermediate Capital Group Plc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2015.

Bruni S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015041402/19.
(150047496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

54634

L

U X E M B O U R G

Portrea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 160.231.

L'an deux mille quinze, le deux mars.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme PORTREA S.A., ayant son siège

social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 160.231, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du avril 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1377 du 24 juin 2011.

L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Rika Mamdy, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, et le notaire soussigné.
Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 6 des statuts.
2. Modification de l'article 9 des statuts.
3. Divers.
Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au

cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société
n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.»

Suit la traduction anglaise:

“The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be

shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general
meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may
be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more that one
shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.”

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts comme suit:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs

ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul adminis-

54635

L

U X E M B O U R G

trateur  sera  toutefois  suffisante  pour  représenter  valablement  la  société  dans  ses  rapports  avec  les  administrations
publiques.

Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature indivi-

duelle de l'administrateur unique.»

Suit la traduction anglaise:

“Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors or by

the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with the
public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of

the sole director.”

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, R. MAMDY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7055. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015041900/75.
(150047868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Pitibech SCI, Société Civile.

Siège social: L-7793 Bissen, 25, rue Michel Stoffel.

R.C.S. Luxembourg E 5.580.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le treize mars.

Ont comparu:

1Monsieur Joël REUTER, employé privé, né à Ettelbruck le 20 mars 1974,
matricule n° 1974032019283,
demeurant à L-7793 Bissen, 25, rue Michel Stoffel,
2.- Monsieur René THEÎSEN, indépendant, né à Luxembourg, le 05 juillet 1975,
matricule no 1975070509245,
demeurant à L-6571 Osweiler, 10» rue de Dickweiler.
Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les parties ci-devant désignées et toutes personnes, physiques ou morales,

qui pourront devenir associés dans la suite, une société civile immobilière qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de "Pitibech SCI"

Art. 3. La société a pour objet la gestion. L'administration, l'exploitation, la mise en valeur par achat, vente, échange,

location,  construction  ou  de  toute  autre  manière  de  tous  biens  immobiliers  ou  mobiliers  tant  au  Luxembourg  qu'à
l'étranger,

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirec-

tement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au
caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le siège social est établi à BISSEN.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés prise

en assemblée générale.

54636

L

U X E M B O U R G

Titre II. - Apports, Capital social» Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à MILLE EUROS (1.000,00 €), représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation

de valeur nominale, réparties comme suit:

1. - Monsieur Joël REUTER, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. - Monsieur René THEISEN, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été entièrement libérées par des apports en numéraire, de sorte que la somme de mille euros

(1,000,00 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par la loi.

Art. 8. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l'article 1690 du

Code Civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément des associés décidant à l'unanimité.
Les associés fondateurs ont un droit de préemption pour l'acquisition de parts:
a) Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu'à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales, il doit

d'abord les offrir à ses coassociés proportionnellement à leur participation dans la société au moins six (6) mois avant la
date prévue pour la cession; si un ou plusieurs associés ne souhaitent pas acquérir les parts offertes, les autres associés
peuvent se porter acquéreur au prorata des parts détenues.

b) Si aucun des associés ne se porte acquéreur des parts qui ont été offertes aux associés, ou si une partie des parts

à céder n'est pas reprise par des associés, l'associé cédant peut offrir ses parts à des non-associés.

L'associé cédant ses parts doit informer tous les associés du prix de cession convenu avec le ou les non-associé(s) et

dévoiler l'identité du ou des acheteurs.

Tous les associés peuvent ensuite faire valoir ira droit de préemption pendant le mois qui suit la communication du

prix convenu et de l'identité du ou des acheteurs non-associé(s), et se porter acquéreur au même prix des parts à céder.

Si plusieurs associés exercent le droit de préemption, les parts à céder sont réparties entre eux proportionnellement

aux parts détenues par chaque intéressé.

Si aucun associé n'a exercé son droit de préemption dans le délai d'un mois après la communication du prix convenu

et de l'identité du ou des repreneur(s) non-associé(s), l'associé cédant peut transmettre les parts à ces acheteurs qui
deviennent alors associés de la société.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe, La propriété d'une part

sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés» mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite» la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin

à la société qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Art. 10. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 11. Les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il détient.

Art 12. Les parts sociales sont indivisibles à regard de la société qui ne reconnaît qu'un seul titulaire par part. Les

copropriétaires individus ainsi que le nu-propriétaire et usufruitiers de parts sociales sont tenus de se faire représenter
par un seul d'entre eux. Faute d'accord sur ce point, l'exercice des droits attachés à ces parts pourra être suspendu.

Titre III. - Administration de la Société

Art. 13. La société est gérée et administrée par les associés. Pour tout acte de disposition la société est valablement

engagée par la signature conjointe de tous les associés et pour tout acte de gestion courante la société est valablement
engagée par la signature individuelle de chaque associé.

Les associés peuvent emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou

sans garantie et signer valablement tous actes de prêt, d'ouverture de crédit ou autres, et hypothéquer les biens immo-
biliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent,

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède,

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale,

Art. 15. Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur Ses affaires de la société et il pourra en

particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social.

54637

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Assemblée Générale

Art. 16. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du

ou des associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

Art. 17. Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires,

est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présent ou représentés, chaque part donnant droit
à une voix.

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille quinze.

Art. 19. L'assemblée entend le rapport du ou des administrateurs sur les affaires sociales, approuve les comptes,

délibère sur les points portés à l'ordre du jour,

Titre V. - Dissolution et Liquidation

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu'ils ne décident

de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l'acte de nomination.

Titre VI. - Divers

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Fait à Bissen, le 13 mars 2015 en trois exemplaires.

REUTER Joël / THESEN René.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se considérant comme réunis en assemblée générale ont pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

1 - Le nombre d'administrateurs est fixé à deux.
Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée, Monsieur Joël Reuter et Monsieur René Theisen, pré

qualifiés,

Pour tout acte de disposition la société est valablement engagée par la signature conjointe de Monsieur Joel Reuter et

Monsieur René Theisen.

Pour tout acte de gestion courante la société est valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Joël

Reuter, respectivement par la signature individuelle de Monsieur René Theisen.

2- Le siège de la société est fixé à L-7793 Bissen, 25, rue Michel Stoffel.

<i>Frais

Le montant des frais qui incombent à la société à raison de sa constitution sont à charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Bissen le 13 mars 2015.

REUTER Joël / THESEN René.

Référence de publication: 2015041896/120.
(150048034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Kiawah Island Capital Advisers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 171.455.

<i>Cession de parts sociales

Richard GRINDON, propriétaire de 100 parts sociales de la société KIAWAH ISLAND ADVISERS S.à r.l. ayant son

siège social à 111/115 Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, a cédé en date du 25 février 2015 l'ensemble de ces
100 parts sociales à la société GULLWING CAPITAL LTD, 31/33 Commercial Road, Poole, Dorset, BH14 0HU, Registre
de commerce n°8227874.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015043577/15.
(150050083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

54638

L

U X E M B O U R G

Digital Services XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.625,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 186.466.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of February,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) under the laws of Germany with its statutory seat in

Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amts-
gericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany (hereinafter “Rocket”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Berlin, Germany, on 18 February 2015;

2.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister)
at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having its re-
gistered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),

being the holder of one (1) common share,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Berlin, Germany, on 24 February 2015;

3. International Finance Corporation, an international organization established by articles of agreement among its

member countries including Germany, having its business address at 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C.
20433, United States of America (hereinafter “IFC”),

becoming the holder of three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Washington, D.C., United States of America, on 12 February 2015;

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties under 1. and 2. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services XVI S.à r.l. (the

“Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 186.466 and incorporated pursuant to a
deed of the notary Carlo Wersandt, residing in Luxembourg, on 7 April 2014, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1690 dated 1 July 2014. The articles of association have not been amended since.

The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby IFC, appearing
party sub 3, participates and votes for the purpose of agenda point 6 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create two (2) classes of shares, referred to as the common shares (hereinafter the “Common Shares”)

and the series A shares (hereinafter the “Series A Shares”).

2. Conversion of the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one euro (EUR

1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each,
without cancellation of shares.

3. Acceptance of International Finance Corporation, an international organization established by articles of agreement

among its member countries including Germany, having its business address at 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Wash-
ington, D.C. 20433, United States of America, as new shareholder of the Company.

4. Increase of the Company's share capital by an amount of three thousand one hundred twenty-five euro (EUR 3,125)

so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to fifteen thousand six
hundred twenty-five euro (EUR 15,625) by issuing three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A Shares, with
a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

54639

L

U X E M B O U R G

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand six hundred twenty-five euro (EUR 15,625), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one euro (EUR 1) each, and

5.1.2 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A shares, divided into three thousand one hundred twenty-

five (3,125) series A1 shares (hereinafter “Series A Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 Each of Rocket Internet AG (“Rocket”) and International Finance Corporation (“IFC”, Rocket and IFC jointly the

“Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the
course of a capital increase implementing a bona fide investment offer of a third party (being neither a shareholder nor
a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)
(“Affiliate”) nor a closely related person (within the meaning of section 138 of the German Insolvency Code (InsO)) of
the foregoing (“Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory Board (“Third Party Investment”)
by matching (i.e. fully replacing) the Third Party Investment by increasing their respective shareholding in the Company
(“Matching Shareholders”). If more than one Investor wishes to match the offer, such Investor shall be entitled to subscribe
for shares pro rata to the number of shares in the Company held by each such Investor up to the amount of the Third
Party Investment. The Investors shall also be entitled to subscribe for up to such an amount of further shares to be issued
in the course of the capital increase implementing the Third Party Investment - irrespective of whether made by the Third
Party Investor and/or one or more Matching Shareholders - required to maintain their respective shareholding in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment or
the investment by the Matching Shareholders is based on. Each of the Investors intending to exercise its right pursuant
to this Article 5.2 shall inform the Company by binding declaration three (3) weeks after the Investors have been notified
by the Company regarding the Third Party Investment.”

6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services

XVI S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (“Law”), as well as by these articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise. The Company is in the business of
operating online marketplace companies that act as intermediaries where sellers offer services or products to customers,
or list services or products from selected suppliers (“Business”) including currently in Albania, Armenia, Azerbaijan,
Belarus, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Estonia, Greece, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Macedonia,
Malta, Moldova, Mongolia, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turkey, Turkme-
nistan, Ukraine and Uzbekistan (each such country in which the Company is or will become active a “Country”).

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds direct or indirect participations or rights of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of licenses on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

54640

L

U X E M B O U R G

4.2 The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers. It may

be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted
in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand six hundred twenty-five euro (EUR 15,625), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one euro (EUR 1) each, and

5.1.2 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A shares, divided into three thousand one hundred twenty-

five (3,125) series A1 shares (hereinafter “Series A Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 Each of Rocket Internet AG (“Rocket”) and International Finance Corporation (“IFC”, Rocket and IFC jointly the

“Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the
course of a capital increase implementing a bona fide investment offer of a third party (being neither a shareholder nor
a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)
(“Affiliate”) nor a closely related person (within the meaning of section 138 of the German Insolvency Code (InsO)) of
the foregoing (“Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory Board (“Third Party Investment”)
by matching (i.e. fully replacing) the Third Party Investment by increasing their respective shareholding in the Company
(“Matching Shareholders”). If more than one Investor wishes to match the offer, such Investor shall be entitled to subscribe
for shares pro rata to the number of shares in the Company held by each such Investor up to the amount of the Third
Party Investment. The Investors shall also be entitled to subscribe for up to such an amount of further shares to be issued
in the course of the capital increase implementing the Third Party Investment -irrespective of whether made by the Third
Party Investor and/or one or more Matching Shareholders - required to maintain their respective shareholding in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment or
the investment by the Matching Shareholders is based on. Each of the Investors intending to exercise its right pursuant
to this Article 5.2 shall inform the Company by binding declaration three (3) weeks after the Investors have been notified
by the Company regarding the Third Party Investment.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s), as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

6.6 Any premium paid on any share is allocated in accordance with the terms of this Article. The share premium shall

remain reserved and attached to the shares in relation to which it was paid and will be reserved to the relevant holders
of shares in case of distributions, repayment or otherwise unless the general meeting of shareholders decides otherwise.
Decisions as to the use of the share premium reserve(s) are to be taken by the shareholder(s) as the case may be, subject
to the Law and these articles.

6.7 Subject to (i) Article 5.2 and (ii) the provisions of any shareholders' agreement between the shareholders relating

to the Company (if any), if the Company contemplates the issuance of new shares against contribution in cash, each
shareholder shall be entitled to subscribe to the new shares pro rata to the number of shares in the Company held by
each such shareholder, unless the shareholders unanimously decide otherwise.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the requesting shareholder.

54641

L

U X E M B O U R G

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 Inter vivos, the shares may only be transferred subject to the approval of such transfer given by the shareholders

at a majority of 81% of the Company's share capital (“Super Majority”) and subject to the provisions of any shareholders'
agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along
rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To the extent that such
approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.3.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to an Affiliate of such Investor;
7.3.2 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified

employee participation program or (ii) by a shareholder to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option
under a vesting scheme.

7.4 To the extent a transfer, assignment or any other disposal of shares requires no additional consent of the share-

holders' meeting pursuant to article 7.3 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of first refusal, rights
of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.5 Any transfer, assignment or any other disposal shall become effective towards the Company and third parties

through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by shareholders with a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude
the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either
to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an

economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50% of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the shareholders pro rata to their
participation in the Liquidity Event.

8.2 On the first level (“First Level”) the respective Investor shall receive an amount equal to its total investment made

in the Company in order to acquire the respective Series A Shares held by it, consisting of the nominal amount of the
Series A Shares acquired and any share premium and/or other capital contribution (account 115 of the standard chart of
accounts “apport en capitaux propres non rémunérés par des titres” under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg)
paid by it to the Company.

8.3 After the payments on the First Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a second

level (“Second Level”) to all selling shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event. Any amounts received
by any Investor on the First Level shall reduce the amount to be allocated to such Investor on this Second Level provided
that no Investor shall be obliged to repay any amount received on the First Level. Irrespective of whether or not the sale
of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions, no shareholder
shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other shareholders) an amount
exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares sold on a common
equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second Level from a subsequent
sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.

8.4 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective Investor so

long as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according to
the First Level.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. These articles of association together with the

54642

L

U X E M B O U R G

declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law
and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register
the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to be determined

by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached, the
expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or
of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne
by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off
with the redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the re-
maining costs in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation provided for in Article 10 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective decisions of the shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence, the votes of the shareholders not participating in the voting shall be deemed to be abstention from voting.
Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder without
undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has declaratory
significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending

54643

L

U X E M B O U R G

on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General meetings of shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders'  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice. In addition to the calling of a shareholders' meeting set
forth in the foregoing, the invitation shall be submitted (concurrently with the registered letter) to each shareholder by
e-mail.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 14. Quorum and vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 81% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by the Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 15. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 16. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of both (i) a majority in number of shareholders (including always a majority in number of the Investors) and (ii) a Super
Majority. Changes to these articles of association include (without limitation)

16.1 the increase or decrease of the Company's share capital (provided that in the case of a bona fide Third Party

Investor, Article 5.2 shall take precedence);

16.2 any change to the Company's object of Business as described in the Articles;
16.3 division of the Company's capital into different classes of shares; further, the special rights and obligations attached

to any class may be varied or abrogated only with the written consent of the shareholders affected;

16.4 liquidation as well as merger, separation and transformation of the Company;
16.5 acquisition of the Company's own shares (unless specifically provided for in the Articles in connection with a

redemption of Shares or a forced transfer of a Shareholder's Shares to a third party in lieu of redemption); and

16.6 any change to the Company's decision-making process (including the competence of shareholders' meetings,

Advisory Board and any specific majority necessary for adoption of some of the decisions) to the unilateral disadvantage
of any of the Investors shall not be made without such Investor's consent. For the avoidance of doubt, any decrease of
the number of votes or change of the voting rights of a Shareholder required for the adoption of any decision is considered
such a unilateral disadvantage.

Art. 17. Shareholders' resolutions requiring a specific majority.
17.1 To the extent required by Law, shareholders' resolutions shall be passed with the respective qualified majority

and quorum.

17.2 Notwithstanding the foregoing, a Super Majority shall be required in relation to the following matters:
17.2.1 the appointment of the Company's auditors;
17.2.2 distribution of dividends or other distributions;
17.2.3 any change to the existing employee stock participation program or the issuance of a new employee stock

participation program pursuant to a shareholders' agreement relating to the Company;

54644

L

U X E M B O U R G

17.2.4 acquisition, disposition and/or licensing of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights

including copyrights or any other property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation
by  the  enterprise  and/or  a  third  party,  excluding,  however,  such  dispositions  between  the  Company  and  its
“Subsidiaries” (being entities in which the Company holds an interest, directly or indirectly, at present or in the future);

17.2.5 any transactions between the Company and its Subsidiaries on the one hand, and on the other hand a shareholder

or any of its Affiliates or closely related persons (within the meaning of section 138 of the German Insolvency Code
(InsO)) of the foregoing;

17.2.6 entering into, amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the mean-

ing of sections 291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)) to the extent the Company is the dominated party
pursuant to such intra-group agreement; and

17.2.7 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of issuing shares) of any

kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in the
Company's (or its Subsidiaries) profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's (or its Subsi-
diaries) profit (excluding, however, agreements with employees of the Company or its Subsidiaries as well as agreements
with third parties within the ordinary course of business, e.g. agreements with advertising partners).

D. Board of managers - Advisory board

Art. 18. Powers of the sole manager Composition and powers of the board of managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders or the consent requirements of the Advisory
Board.

Art. 19. Election, removal and term of office of managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders' resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong to.

Art. 20. Vacancy in the office of a manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining managers  until the  next  meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Convening meetings of the board of managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

54645

L

U X E M B O U R G

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The board of managers shall prepare an annual business plan (“Annual Business Plan”) and an annual budget

(“Annual Budget”) of the Company, which shall both be subject to the consent of the Advisory Board.

22.9 The managers shall require the prior consent of the Advisory Board for legal transactions and measures of the

Company and its Subsidiaries for legal transactions and measures (i) outside the ordinary course of business or (ii) specified
below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by any approved budget (including the Annual Budget) with the consent of the Advisory Board:

22.9.1 formation, acquisition, closure or disposal of enterprises or partial-businesses;
22.9.2 amendment of statutes, articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as exercise

(or waiver) of shareholders' rights in companies in which an interest is held;

22.9.3 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.9.4 modification of the fields of business of the Company and the termination of existing and commencement of

new fields of business (Geschäftsfelder);

22.9.5 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

22.9.6 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,

however, such loans between the Company and its Subsidiaries;

22.9.7 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two

hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework, excluding,
however, such agreements between the Company and its Subsidiaries;

22.9.8 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.9.9 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.9.10 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.9.11 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount

in controversy of more than one hundred thousand Euros (EUR 100,000.00) in the individual case;

22.9.12 exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent

that this exercise would require the consent of the Advisory Board under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this Article 22.9; and

22.9.13 resolutions regarding the introduction of an employee participation scheme.
The preceding consent requirements do not apply if the management decides, after due assessment of the circums-

tances,  that  a  transaction  and/or  measure  is  required  to  avoid  imminent  substantial  damage  to  the  Company.  The
transactions and/or measures performed by the management may not exceed what is required to avoid such danger to
the Company. The Advisory Board must be notified of the nature and scope of such transaction and/or measure and the
reasons for it in writing without undue delay.

22.10 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders may (by way of a resolution) subject further

54646

L

U X E M B O U R G

transactions and measures to the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may consent to certain groups and
kinds of transactions and measures in advance.

22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all Subsidiaries.

Art. 23. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers) such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealings with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company shall have an advisory board (“Advisory Board”). It shall consist of three (3) voting members. The

shareholders' meeting may, by way of a unanimous shareholders' resolution, increase or decrease the number of voting
members of the Advisory Board.

25.2 The general meeting of shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by

way of a unanimous shareholders' resolution.

25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1  Two (2)  voting members  of  the  Advisory  Board shall be nominated by  Rocket  in  its  sole  discretion  (such

members the “Rocket-Members”); and

25.3.2 One (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by IFC in its sole discretion.
25.4 The advisory board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
25.5 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. One of the Rocket-Members shall be the

chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board (if any) may provide for further provisions
in particular on the self-organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast; provided that as long as Rocket and IFC are the only Investors (i.e. prior to a bona fide Third Party
Investor not being an Affiliate of Rocket becoming a shareholder of the Company), all resolutions of the Advisory Board
shall be adopted unanimously with the votes of all members of the Advisory Board, except for Article 22.8 of these articles
of association.

25.6 The objective and responsibility of the Advisory Board shall be the granting of consents to specific transactions

of the management of the Company which pursuant to (i) any shareholders' agreement relating to the Company, (ii) these
articles of association, (iii) the rules of procedure for the managers, (iv) the rules of procedure for the Advisory Board
or (v) respective shareholders' resolutions require the prior consent of the Advisory Board. Further powers and res-
ponsibilities  may  be  conferred  on  the  Advisory  Board  by  shareholders'  resolution.  In  addition  to  those  consent
requirements, the Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the management of the Company.

25.7 The Advisory Board is a contractual and not a statutory body and, in particular, not a supervisory board within

the meaning of article 60 et seqq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

54647

L

U X E M B O U R G

26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual accounts and allocation of profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law and any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders
and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles of association. Where any matter
contained in these articles of association conflicts with the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders'
agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.

Art. 32. Arbitration.
32.1 All disputes arising between the shareholders or between the Company and the shareholders in connection with

these articles of association shall be finally settled according to the Arbitration Rules (DIS-SchO) and the Supplementary
Rules for Corporate Law Disputes (DIS-SRCoLD) of the German Institution of Arbitration (DIS) without recourse to
the ordinary courts of law subject to the following provisions:

32.2 The effects of an arbitral award extend also to those shareholders that have been identified as Concerned Others

within the time limits provided, irrespective whether they have made use of their opportunity to join the arbitral pro-
ceedings as a party or as an investor (section 11 DIS-SRCoLD). The shareholders named as Concerned Others within
the time limits provided, commit to recognize the effects of an arbitral award rendered in accordance with the DIS-
SRCoLD.

32.3 The Company shall always rise these arbitration provisions as defence against any claim that is filed in the ordinary

courts of law and that relates to disputes in the meaning of this Article 32.

54648

L

U X E M B O U R G

32.4 The place of arbitration is Frankfurt am Main, Germany. The language of the arbitral proceedings is English. The

Arbitral Tribunal consists of three (3) arbitrators.

32.5 No provision of these articles of association or of the DIS-SchO or of the DIS-SRCoLD, nor the submission to

arbitration by IFC, in any way constitutes or implies a waiver, termination or modification by IFC of any privilege, immunity
or exemption of IFC granted in the articles of agreement establishing IFC, international conventions, or any all applicable
statutes, laws, ordinances, rules and regulations, including but not limited to, any license, permit or other governmental
consent, registration, filing, agreement, notarisation, certificate, license, approval, permit, authority or exemption from,
by or with any national, supranational, regional or local government or governmental, statutory, regulatory, administrative,
fiscal, judicial, or government-owned body, department, commission, authority, tribunal, agency or entity, or central bank
(or any person whether or not government owned and howsoever constituted or called, that exercises the functions of
a central bank), whether given by express action or deemed given by failure to act within any specified time period, and
all corporate, creditors' and partners' approvals or consents, in each case as in effect from time to time.”

7. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr

Julien De Mayer and Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign
solely, the shareholders' register of the Company.

8. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned

notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create two (2) classes of shares, referred to as the common shares

(hereinafter the “Common Shares”) and the series A shares, divided into series A1 shares, (hereinafter the “Series A
Shares”).

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders decides to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares,

with a nominal value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a
nominal value of one euro (EUR 1.00) each, without cancellation of shares.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to accept International Finance Corporation, an international organiza-

tion established by articles of agreement among its member countries including Germany, having its business address at
2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433, United States of America, as new shareholder of the Com-
pany.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of three thousand

one hundred twenty-five euro (EUR 3,125) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) up to fifteen thousand six hundred twenty-five euro (EUR 15,625) by issuing three thousand one
hundred twenty-five (3,125) Series A Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A Shares have been duly subscribed by IFC, aforemen-

tioned, for the price of three thousand one hundred twenty-five euro (EUR 3,125).

<i>Payment

The three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A Shares subscribed by IFC, aforementioned, have been

entirely paid up through a contribution in cash in an amount of three thousand one hundred twenty-five euro (EUR 3,125).

The proof of the existence of the above contribution in cash has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of three thousand one hundred twenty-five euro (EUR 3,125) is entirely allocated to

the share capital of the Company.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article five (5) of the articles of association of the Company

so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand six hundred twenty-five euro (EUR 15,625), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one euro (EUR 1) each, and

54649

L

U X E M B O U R G

5.1.2 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A shares, divided into three thousand one hundred twenty-

five (3,125) series A1 shares (hereinafter “Series A Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 Each of Rocket Internet AG (“Rocket”) and International Finance Corporation (“IFC”, Rocket and IFC jointly the

“Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the
course of a capital increase implementing a bona fide investment offer of a third party (being neither a shareholder nor
a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)
(“Affiliate”) nor a closely related person (within the meaning of section 138 of the German Insolvency Code (InsO)) of
the foregoing (“Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory Board (“Third Party Investment”)
by matching (i.e. fully replacing) the Third Party Investment by increasing their respective shareholding in the Company
(“Matching Shareholders”). If more than one Investor wishes to match the offer, such Investor shall be entitled to subscribe
for shares pro rata to the number of shares in the Company held by each such Investor up to the amount of the Third
Party Investment. The Investors shall also be entitled to subscribe for up to such an amount of further shares to be issued
in the course of the capital increase implementing the Third Party Investment -irrespective of whether made by the Third
Party Investor and/or one or more Matching Shareholders - required to maintain their respective shareholding in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment or
the investment by the Matching Shareholders is based on. Each of the Investors intending to exercise its right pursuant
to this Article 5.2 shall inform the Company by binding declaration three (3) weeks after the Investors have been notified
by the Company regarding the Third Party Investment.”

<i>Sixth resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of

association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,

as well as Mr Julien De Mayer and Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update
and sign solely, the shareholders' register of the Company.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 2,100.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechsundzwanzigsten Februar,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit
Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaberin von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 18. Februar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-

stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),

Inhaberin eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 24. Februar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

54650

L

U X E M B O U R G

3. International Finance Corporation, eine internationale Organisation gegründet durch einen Vertrag (articles of ag-

reement) zwischen ihren Mitgliedsstaaten, einschließlich Deutschland, mit Geschäftssitz in 2121 Pennsylvania Avenue,
N.W., Washington, D.C. 20433, Vereinigte Staaten von Amerika („IFC“),

zukünftige Inhaberin von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 12. Februar 2015, ausgestellt in Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur pa-

raphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien unter 1. und 2. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services XVI S.à

r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 186.466, gegründet am 7. April 2014 gemäß
einer Urkunde des Notars Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 1. Juli 2014 im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 1690, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht
geändert.

Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln, wobei IFC, 3. Partie, ausschließlich für die Punkte 6 ff. der Tagesordnung teilnahmeund stimm-
berechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung von zwei (2) Anteilsklassen, die als Stammanteile (die „Stammanteile“) und Anteile

der Serie A (die „Anteile der Serie A“) bezeichnet werden.

2. Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem

Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1,00).

3. Aufnahme von International Finance Corporation, einer internationalen Organisation gegründet durch einen Vertrag

(articles of agreement) zwischen ihren Mitgliedsstaaten, einschließlich Deutschland, mit Geschäftssitz in 2121 Pennsylvania
Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433, Vereinigte Staaten von Amerika, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.125) auf einen Betrag von
fünfzehntausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 15.625) durch die Ausgabe von dreitausendeinhundertfünfund-
zwanzig (3.125) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 15.625),

bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1), und

5.1.2 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A, aufgeteilt in dreitausendeinhundertfünfund-

zwanzig (3.125) Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Jede der Gesellschaften Rocket Internet AG („Rocket“) und International Finance Corporation („IFC“, Rocket und

IFC gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Ka-
pitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein ernsthaftes Investmentangebot (bona fide investment offer)
eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um ein mit einem Gesellschafter
verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) („Verbundenes Unternehmen“),
noch um eine nahestehende Person (im Sinne des § 138 der Deutschen Insolvenzordnung (InsO)) des besagten Dritten
(ein „Drittinvestor“) handelt), und dem vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“), indem die In-
vestition  eines  Dritten  im  Wege  einer  Erhöhung  deren  jeweiliger  Beteiligung  in  der  Gesellschaft  kopiert  wird  (die
„Gleichziehenden Gesellschafter“). Sofern mehr als ein Investor das Angebot kopiert, ist dieser Investor dazu berechtigt,
Anteile proportional zu der Anzahl der von jedem dieser Investoren an der Gesellschaft gehaltenen Anteile bis zu der
Höhe der Investition eines Dritten zu zeichnen. Die Investoren sind zudem zur Zeichnung weiterer Anteile bis zu der
Höhe berechtigt, die bei einer Kapitalerhöhung, welche die Investition eines Dritten umsetzt, ausgegeben wird - unab-
hängig davon, ob diese vom Drittinvestor und/oder einem oder mehreren Gleichziehenden Gesellschaftern vorgenommen
wurde - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich
ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten oder einer Investition der Gleichziehenden
Gesellschafter. Jeder der Investoren, der sein Recht gemäß des vorangehenden Satzes dieses Artikels 5.2 ausüben möchte,

54651

L

U X E M B O U R G

hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung darüber zu unterrichten, und dies innerhalb von drei (3) Wochen,
nachdem die Investoren über die Investition eines Dritten in Kenntnis gesetzt wurden.“

6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Digital Services XVI S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art. Die
Gesellschaft ist Betreiberin von Online-Marktplatz Unternehmen, die dort als Vermittler handeln, wo Verkäufer Kunden
Dienstleistungen oder Produkte, oder Dienstleistungen oder Produkte von ausgewählten Zulieferern anbieten („Ge-
schäftstätigkeit“), zur Zeit in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Estland,
Griechenland, Georgien, Ungarn, Kasachstan, Kosovo, Kirgisistan, Lettland, Mazedonien, Malta, Moldawien, Mongolei,
Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, Türkei, Turkmenistan, Ukraine und
Usbekistan (jedes dieser Länder, in welchen die Gesellschaft tätig ist oder wird, ein „Land“).

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie direkte oder indirekte Beteiligungen oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer innerhalb derselben Gemeinde

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 15.625),

bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1), und

5.1.2 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A, aufgeteilt in dreitausendeinhundertfünfund-

zwanzig (3.125) Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

54652

L

U X E M B O U R G

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Jede der Gesellschaften Rocket Internet AG („Rocket“) und International Finance Corporation („IFC“, Rocket und

IFC gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Ka-
pitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein ernsthaftes Investmentangebot (bona fide investment offer)
eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um ein mit einem Gesellschafter
verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) („Verbundenes Unternehmen“),
noch um eine nahestehende Person (im Sinne des § 138 der Deutschen Insolvenzordnung (InsO)) des besagten Dritten
(ein „Drittinvestor“) handelt), und dem vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“), indem die In-
vestition  eines  Dritten  im  Wege  einer  Erhöhung  deren  jeweiliger  Beteiligung  in  der  Gesellschaft  kopiert  wird  (die
„Gleichziehenden Gesellschafter“). Sofern mehr als ein Investor das Angebot kopiert, ist dieser Investor dazu berechtigt,
Anteile proportional zu der Anzahl der von jedem dieser Investoren an der Gesellschaft gehaltenen Anteile bis zu der
Höhe der Investition eines Dritten zu zeichnen. Die Investoren sind zudem zur Zeichnung weiterer Anteile bis zu der
Höhe berechtigt, die bei einer Kapitalerhöhung, welche die Investition eines Dritten umsetzt, ausgegeben wird - unab-
hängig davon, ob diese vom Drittinvestor und/oder einem oder mehreren Gleichziehenden Gesellschaftern vorgenommen
wurde - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich
ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten oder einer Investition der Gleichziehenden
Gesellschafter. Jeder der Investoren, der sein Recht gemäß des vorangehenden Satzes dieses Artikels 5.2 ausüben möchte,
hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung darüber zu unterrichten, und dies innerhalb von drei (3) Wochen,
nachdem die Investoren über die Investition eines Dritten in Kenntnis gesetzt wurden.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

6.6 Ein Ausgabeagio für einen Anteil wird im Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels zugewiesen. Das Agio

verbleibt in einer Rücklage und bleibt mit denjenigen Anteilen verbunden, in Bezug auf welche es gezahlt wurde und bleibt
im Falle von Ausschüttungen, Rückzahlungen oder anderweitig den jeweiligen Anteilsinhabern vorbehalten, es sei denn,
die Gesellschafterversammlung beschließt etwas Gegenteiliges. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915
und dieser Satzung sind Beschlüsse bezüglich der Verwendung der Agiorücklage(n) gegebenenfalls von dem(den) Gesell-
schafter(n) zu fassen.

6.7 Vorbehaltlich (i) des Artikels 5.2 und (ii) der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Ge-

sellschaftern in Bezug auf die Gesellschaft (sofern vorhanden), ist jeder Gesellschafter, wenn die Gesellschaft die Ausgabe
neuer Anteile gegen eine Bareinlage anstrebt, dazu berechtigt, die neuen Anteile proportional zur Anzahl der von jedem
dieser Gesellschafter an der Gesellschaft gehaltenen Anteile zu zeichnen, es sei denn, die Gesellschafter beschließen
einstimmig etwas Gegenteiliges.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Inter vivos dürfen die Anteile nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die eine Mehrheit von 81%

des Gesellschaftskapitals halten („Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschafterver-
einbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten
oder  Mitverkaufsrechten-  oder  Pflichten  aus  Gesellschaftervereinbarungen  zwischen  den  Gesellschaftern  übertragen
werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von Anteilen nicht
erforderlich:

7.3.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen Investor an

ein mit diesem Investor Verbundenes Unternehmen;

54653

L

U X E M B O U R G

7.3.2  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher Anteile unter einem vereinfachten Mitarbeiterbeteiligungsprogramm erwirbt, oder (ii) durch einen Gesellschafter
an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-
Regelung.

7.4 Sofern eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung keiner weiteren Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung gemäß Artikel 7.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrech-
te, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.5 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel

1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung in
Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen

werden, wenn Gesellschafter einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit zustimmen (wobei die Anteile
des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht
erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen
gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1  Im  Falle  (i)  eines  Verkaufs  von  mindestens  fünfzig  Prozent  (50%)  aller  Anteile  an  der  Gesellschaft  oder  eines

Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren ver-
bundenen Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft, oder (iii) eines
Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter,
was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig
Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis
einer oder mehrerer verbundener Akquisitionen (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden
als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) - vorbehaltlich des Artikels 8.2 - im Einklang
mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf der ersten Ebene („Erste Ebene”) erhält der jeweilige Investor einen Betrag, welcher seiner Gesamtinvestition

in die Gesellschaft entspricht, um die entsprechenden von ihm gehaltenen Anteile der Serie A, bestehend aus dem No-
minalbetrag  der  erworbenen  Anteile  der  Serie  A  und  dem  Agio  und/oder  anderen  Kapitaleinlage  (Konto  115  des
Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von ihm an die Gesellschaft gezahlt wurden, zu erwerben.

8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer zweiten

Ebene („Zweite Ebene”) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Investor auf der Ersten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem
Investor zu erhaltenden Betrag auf dieser Zweiten Ebene mit der Maßgabe, dass Taxi Holding nicht zur Rückzahlung eines
auf der Ersten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines
Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für
den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zu-
rückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu
den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden, oder (ii) als der Betrag, der diesem
Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der
hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

8.4 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Investors solange, wie

dieser den Gesamtbetrag, welcher ihr gemäß der Ersten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Diese Satzung stellt gemeinsam mit der Rück-
kaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft bestätigt
hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung dieser
Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

54654

L

U X E M B O U R G

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung des Anteils an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass die Ausgleichszahlung für die abzutretenden Anteile gemäß

Artikel 10 dieser Satzung durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft als Garant
haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in

der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

54655

L

U X E M B O U R G

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt. Zusätzlich zur Einberufung einer Gesellschafterver-
sammlung auf die oben beschriebene Art ist die Einladung jedem Gesellschafter (gleichzeitig mit dem Einschreiben) per
E-Mail zu übermitteln.

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 81% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 13.2
eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist
dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einbe-
rufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert sowohl die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter (immer einschließlich einer zahlenmäßigen Mehrheit der Investoren), und (ii) einer Qualifi-
zierten Mehrheit. Änderungen dieser Satzung umfassen (ohne Beschränkung)

16.1 Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschaftskapitals (mit der Maßgabe, dass im Falle eines ernsthaften Drit-

tinvestors Artikel 5.2 Vorrang hat);

16.2 eine Änderung des Geschäftszwecks der Gesellschaft wie in der Satzung beschrieben;
16.3 Unterteilung des Gesellschaftskapitals in verschiedene Anteilsklassen; des Weiteren können die mit den Anteilen

verbundenen Rechte und Pflichten nur mit der schriftlichen Zustimmung der betroffenen Gesellschafter verändert oder
aufgehoben werden;

16.4 Liquidation sowie Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
16.5 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft (es sei denn, dies wird spezifisch in der Satzung im Zusammenhang mit

einem Rückkauf von Anteilen oder einer Zwangsübertragung von Anteilen eines Gesellschafters an einen Dritten anstelle
eines Rückkaufs vorgesehen), und

16.6  Änderungen  am  Entscheidungsprozess  der  Gesellschaft  (einschließlich  der  Befugnisse  der  Gesellschafterver-

sammlung, des Beirats und spezifischer Mehrheiten, die bei bestimmten Beschlüssen erforderlich sind) zum einseitigen
Nachteil eines Investors sind nicht ohne die Zustimmung dieses Investors vorgenommen werden. Zur Klarstellung wird
darauf hingewiesen, dass eine Herabsetzung der Stimmanzahl oder eine Änderung der Stimmrechte eines Gesellschafters,
die zur Annahme eines Beschlusses erforderlich sind, einen solchen einseitigen Nachteil darstellen.

Art. 17. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
17.1 Sofern vom Gesetz von 1915 vorgesehen erfordern Gesellschafterbeschlüsse die jeweilige qualifizierte Mehrheit

und Quorum.

17.2 Ungeachtet des Vorstehenden ist eine Qualifizierte Mehrheit bezüglich der folgenden Angelegenheiten erforder-

lich:

17.2.1 Ernennung von Rechnungsprüfern/Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft:
17.2.2 Ausschüttung von Dividenden oder andere Ausschüttungen:
17.2.3 Änderungen am bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramm oder die Einrichtung eines neuen Mitarbeiter-

beteiligungsprogramms gemäß einer Gesellschaftervereinbarung in Bezug auf die Gesellschaft;

54656

L

U X E M B O U R G

17.2.4 Erwerb, Verfügung und/oder Lizenzierung von Nutzungsrechten jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geist-

igem Eigentum, einschließlich Urheberrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte, sowie die Weitergabe von Know-
how  zur  eigenen  Verwertung  durch  die  Firma  und/oder  eine  Drittpartei,  jedoch  unter  Ausschluss  von  Verfügungen
zwischen der Gesellschaft und ihren „Tochtergesellschaften“ (bei denen es sich um Unternehmen handelt, an welchen
die Gesellschaft direkt oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Beteiligung hält);

17.2.5 Transaktionen zwischen der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften auf der einer Seite und einem Ge-

sellschafter oder einem Verbundenen Unternehmen oder nahestehenden Personen (im Sinne des § 138 der Deutschen
Insolvenzordnung (InsO)) dieses Gesellschafters;

17.2.6 Abschluss, Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Akti-

engesetzes (AktG)), sofern die Gesellschaft die dominierte Partei in diesem Unternehmensvertrag ist; und

17.2.7 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Ausgabe von Anteilen)

jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei eine
Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft (oder ihrer Tochtergesellschaften) erhält oder jede Zahlung, welche vom Ge-
winnbetrag der Gesellschaft (oder ihrer Tochtergesellschaften) abhängig ist (jedoch unter Ausschluss von Verträgen mit
Angestellten der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen
Geschäftsgangs, z.B. Verträge mit Werbepartnern).

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse oder
mit Ausnahme der Zustimmungserfordernisse des Beirats.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

19.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

20.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

54657

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

22.8 Der Rat der Geschäftsführer erstellt einen jährlichen Geschäftsplan („Jährlicher Geschäftsplan“) und einen Jah-

reshaushalt („Jahreshaushalt“) der Gesellschaft, welche beide die Zustimmung des Beirats erfordern.

22.9 Die Geschäftsführer benötigen die vorherige Zustimmung des Beirats für Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der

Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften, die (i) sich außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs befinden oder (ii)
unten aufgeführt sind. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise
definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

22.9.1 Gründung, Erwerb, Schließung oder Veräußerung von Unternehmen oder Teilbetrieben;
22.9.2 Änderung der Statuten, der Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge, sowie die Ausübung

(oder der Ausschluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, in denen eine Beteiligung gehalten wird;

22.9.3 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.9.4 Änderung der Geschäftsfelder der Gesellschaft und Aufgabe bestehender und Aufnahme neuer Geschäftsfelder;
22.9.5 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

22.9.6  Gewährung  von  Darlehen,  die,  im  Einzelfall,  einen  Betrag  von  zweihunderttausend  Euro  (EUR  200.000,00)

überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften;

22.9.7 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,

einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, aller-
dings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften;

22.9.8 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.9.9 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
22.9.10 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheb-

licher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.9.11 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über einhunderttausend Euro (EUR 100.000,00) im Einzelfall;

22.9.12 Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, deren Gesellschafter die Gesellschaft

ist, sofern diese Ausübung, wenn die Gesellschaft betroffen wäre, die Zustimmung des Beirats nach dieser Satzung er-
fordern würde, d.h. gemäß dieses Artikels 22.9.

22.9.13 Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms.

54658

L

U X E M B O U R G

Den vorstehenden Zustimmungserfordernissen bedarf es nicht, wenn die Geschäftsführung nach einer ordnungsge-

mäßen Einschätzung der Umstände entscheidet, dass eine Transkation und/oder Maßnahme zur Abwendung unmittelbar
bevorstehender erheblicher Schäden von der Gesellschaft erforderlich ist. Die von der Geschäftsführung durchgeführten
Transaktionen und/oder Maßnahmen dürfen das erforderliche Maß zur Abwendung einer solchen Gefahr von der Ge-
sellschaft nicht überschreiten. Der Beirat ist über die Art und den Umfang einer solchen Transaktion und/oder Maßnahme
und über diesbezügliche Gründe unverzüglich in schriftlicher Form zu unterrichten.

22.10 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erfor-

derlich,  so  ist  die  Zustimmung  ebenfalls  für  die  damit  verbundenen  vertraglichen  Verpflichtungen  erforderlich.  Die
Gesellschafter können (durch einen Beschluss) weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen im Voraus erteilen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche Tochtergesellschaften angewendet werden.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls  vorhanden,  oder  von  zwei  (2)  beliebigen  Geschäftsführern  unterzeichnet.  Sofern  die  Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser besteht aus drei (3) stimmberechtigten Mitgliedern. Die

Gesellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder
des Beirats erhöhen oder herabsetzen.

25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-

schafterbeschluss festlegen und/oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 Zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von Rocket nach eigenem Ermessen ernannt (die

„Rocket-Mitglieder“); und 25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von IFC nach eigenem Ermessen
ernannt.

25.4 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Eines der Rocket-Mitglieder ist der

Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann (sofern vorhanden) weitere Bestimmungen, insbesondere
hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen vorausgesetzt, dass Rocket und IFC die einzigen Investoren sind (d.h. vor einem ernsthaften Drittin-
vestor, bei dem es sich nicht um ein mit Rocket Verbundenes Unternehmen handelt, welches ein Gesellschafter der
Gesellschaft wird), werden alle Beschlüsse des Beirats einstimmig mit den Stimmen aller Beiratsmitglieder gefasst, außer
für Artikel 22.8 dieser Satzung.

25.6 Ziel und Zuständigkeit des Beirats ist die Erteilung von Zustimmungen zu spezifischen Transaktionen der Ge-

schäftsführung der Gesellschaft, welche gemäß (i) einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, (ii) dieser

54659

L

U X E M B O U R G

Satzung, (iii) der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iv) der Geschäftsordnung für den Beirat oder (v) entsprech-
ender Gesellschafterbeschlüsse die vorherige Zustimmung des Beirats erfordern. Weitere Befugnisse und Zuständigkeiten
können dem Beirat durch einen Gesellschafterbeschluss übertragen werden. Neben diesen Zustimmungserfordernissen
hat der Beirat eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

25.7 Der Beirat ist ein vertraglich festgelegtes Organ und kein Satzungsorgan und insbesondere kein Aufsichtsrat im

Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
werden und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebe-
nenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorge-
tragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser
Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

54660

L

U X E M B O U R G

H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht

Art. 31. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der
Gesellschaft eingehen und durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel
dieser Satzung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaf-
tervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

Art. 32. Schiedsgerichtsbarkeit.
32.1 Alle Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern im Zusam-

menhang  mit  dieser  Satzung  werden  nach  der  Schiedsgerichtsordnung  (DIS-SchO)  und  den  Ergänzenden  Regeln  für
gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (DIS-ERGeS) der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter
Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen endgültig entschieden:

32.2 Die Wirkungen des Schiedsspruchs erstrecken sich auf diejenigen Gesellschafter, die innerhalb der in diesen DIS-

ERGeS für die Benennung von Betroffenen vorgesehenen Fristen benannt wurden, unabhängig davon, ob sie von der ihnen
eingeräumten Möglichkeit, den schiedsrichterlichen Verfahren als Partei oder Investor beizutreten, Gebrauch gemacht
haben (§ 11 DIS-ERGeS). Die fristgemäß als Betroffene benannten Gesellschafter verpflichten sich, die Wirkungen eines
nach Maßgabe der Bestimmungen in den DIS-ERGeS ergangenen Schiedsspruchs anzuerkennen.

32.3 Die Gesellschaft hat gegenüber Klagen, die gegen sie vor einem staatlichen Gericht anhängig gemacht werden und

Streitigkeiten betreffen, die diesem Artikel 32 unterfallen, stets die Einrede dieser Schiedsbestimmungen zu erheben.

32.4 Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Frankfurt am Main, Deutschland. Die Verfahrenssprache ist Eng-

lisch. Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt drei (3).

32.5 Weder die Bestimmungen dieser Satzung oder der DIS-SchO oder der DIS-ERGeS, noch die Unterwerfung unter

die Schiedsgerichtsbarkeit durch IFC implizieren oder stellen in irgendeiner Weise einen Verzicht, eine Beendigung oder
eine Abänderung durch IFC von (i) sowohl ausdrücklich, als auch durch Nichthandeln innerhalb einer bestimmten Frist
erteilten Vorrechten, Immunitäten oder Freistellungen von IFC dar, die in dem Gründungsvertrag (articles of agreement)
von IFC, internationalen Konventionen, oder allen anderen anwendbaren Statuten, Gesetzen, Anordnungen, Regeln und
Vorschriften gewährt wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Lizenzen, Genehmigungen oder andere Ge-
nehmigungen von Regierungen, Eintragungen, Hinterlegungen, Vereinbarungen, Beurkundungen, Bescheinigungen, Lizen-
zen,  Zustimmungen,  Genehmigungen  oder  Freistellungen  von,  durch  oder  mit  einer  nationalen,  supranationalen,
regionalen oder lokalen Regierung oder einem Regierungs- oder offiziellen Organ, einer Aufsichts-, Verwaltungs-, Steuer-
oder Gerichtsbehörde, oder einer/m/s sich in staatlichem Eigentum befindlichen Organisation, Abteilung, Amt, Verwal-
tung, Gericht, Agentur oder Unternehmen, oder einer Zentralbank (oder eine Rechtsperson, die sich in staatlichem
Eigentum befindet oder nicht und wie auch immer gegründet wurde oder genannt wird, die die Funktion einer Zentralbank
ausübt), und von (ii) Genehmigungen oder Zustimmungen der Gesellschaft, der Gläubiger oder der Partner, je nach den
jeweils geltenden Regeln.“

7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie

Herrn Julien De Mayer und Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Ein-
zelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeich-
nen.

8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, zwei (2) Anteilsklassen zu schaffen, welche als Stammanteile (die „Stamm-

anteile") und Anteile der Serie A, aufgeteilt in Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A"), bezeichnet werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem No-

minalwert von je einem Euro (EUR 1,00) ohne Einziehung von Anteilen in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile
mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) umzuwandeln.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, International Finance Corporation, eine internationale Organisation ge-

gründet  durch  einen  Vertrag  (articles  of  agreement)  zwischen  ihren  Mitgliedsstaaten,  einschließlich  Deutschland,  mit
Geschäftssitz in 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433, Vereinigte Staaten von Amerika („IFC“), als
neue Gesellschafterin der Gesellschaft aufzunehmen.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500)  um  einen  Betrag  von  dreitausendeinhundertfünfundzwanzig  Euro  (EUR

54661

L

U X E M B O U R G

3.125)  auf  einen  Betrag  von  fünfzehntausendsechshundertfünfundzwanzig  Euro  (EUR  15.625)  durch  die  Ausgabe  von
dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1),
zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteile der Serie A wurden ordnungsgemäß von IFC, vorbenannt,

zu einem Preis von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.125) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die  von  IFC,  vorbenannt,  gezeichneten  dreitausendeinhundertfünfundzwanzig  (3.125)  Anteile  der  Serie  A  wurden

vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.125).

Der Nachweis über die Existenz der oben bezeichneten Bareinlage wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht.
Die Einlage in Höhe von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.125) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 15.625),

bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1), und

5.1.2 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A, aufgeteilt in dreitausendeinhundertfünfund-

zwanzig (3.125) Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Jede der Gesellschaften Rocket Internet AG („Rocket“) und International Finance Corporation („IFC“, Rocket und

IFC gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Ka-
pitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein ernsthaftes Investmentangebot (bona fide investment offer)
eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um ein mit einem Gesellschafter
verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) („Verbundenes Unternehmen“),
noch um eine nahestehende Person (im Sinne des § 138 der Deutschen Insolvenzordnung (InsO)) des besagten Dritten
(ein „Drittinvestor“) handelt), und dem vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“), indem die In-
vestition  eines  Dritten  im  Wege  einer  Erhöhung  deren  jeweiliger  Beteiligung  in  der  Gesellschaft  kopiert  wird  (die
„Gleichziehenden Gesellschafter“). Sofern mehr als ein Investor das Angebot kopiert, ist dieser Investor dazu berechtigt,
Anteile proportional zu der Anzahl der von jedem dieser Investoren an der Gesellschaft gehaltenen Anteile bis zu der
Höhe der Investition eines Dritten zu zeichnen. Die Investoren sind zudem zur Zeichnung weiterer Anteile bis zu der
Höhe berechtigt, die bei einer Kapitalerhöhung, welche die Investition eines Dritten umsetzt, ausgegeben wird - unab-
hängig davon, ob diese vom Drittinvestor und/oder einem oder mehreren Gleichziehenden Gesellschaftern vorgenommen
wurde - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich
ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten oder einer Investition der Gleichziehenden
Gesellschafter. Jeder der Investoren, der sein Recht gemäß des vorangehenden Satzes dieses Artikels 5.2 ausüben möchte,
hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung darüber zu unterrichten, und dies innerhalb von drei (3) Wochen,
nachdem die Investoren über die Investition eines Dritten in Kenntnis gesetzt wurden.“

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-

tegorie, sowie Herrn Julien De Mayer und Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelun-
terschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 2.100,-.geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

54662

L

U X E M B O U R G

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unter-
zeichnet worden.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6278. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 16. März 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015041486/1363.
(150047983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Enoue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8047 Strassen, 56, rue de la Victoire.

R.C.S. Luxembourg B 195.351.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le neuf mars.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

1) La société anonyme «R&amp;J Holding S.A.», ayant son siège social à L-8047 Strassen, 56, rue de la Victoire, inscrite au

Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 97262;

2) Monsieur Salvatore PIRRONITTO, employé, née à Charleroi (Belgique), le 30 octobre 1987, demeurant à B-6250

Aiseau-Presles, 4, Rue des Taillandiers;

3) Monsieur Nicolas DUJARDIN, employé, né à Montigny-le-Tilleul (Belgique), le 3 juin 1988, demaurant à B 6060

Gilly, 38, rue Thiot; et

4) Monsieur Rafael PALACIOS Y RODRIGUES, employé, né à San Roque (Espagne), le 23 mai 1963, demeurant à

B-6060 Gilly, 13, Rue Paradis des Chevaux;

ici tous représentés par Madame Cristiana VALENT, employée, domicilié professionnellement à Junglinster, en vertu

de quatre procurations lui délivrées, lesquels après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire et le notaire ins-
trumentant, resteront annexée aux présentes.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une

société anonyme à constituer comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de “ENOUE S.A.” (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. L’objet de la Société est la conception, la vente, la diffusion, la commercialisation et la distribution de services

publicitaires de solutions de e-commerce.

La société pourra prendre des participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou entreprises

sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscri-
ption, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de
toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordres et de parts sociales et obligations et d’autres titres
représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre

54663

L

U X E M B O U R G

société. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et
accorder des sûretés sur la totalité ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
risques de taux de change, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions

se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand- Duché de Luxembourg par décision de

l'assemblée des actionnaires.

Le siège social pourra être transféré dans les limites de la commune sur simple décision du conseil d’administration.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les  indications prévues  à l'article 39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

54664

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l’assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

54665

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les actions ont été souscrites comme suit:

- R&amp;J Holding S.A., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

- Monsieur Nicolas DUJARDIN, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

- Monsieur Salvatore PIRRONITTO, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

54666

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Rafael PALACIOS Y RODRIGUES, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total des actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente un mille euros (31 000.- EUR)

se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cents
euros (1.200,- EUR).

<i>Décisions des actionnaires

Et aussitôt les actionnaires, par leur représentant susnommé, ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Salvatore PIRRONITTO, employé, née à Charleroi (Belgique), le 30 octobre 1987, demeurant à B-6250

Aiseau-Presles, 4, Rue des Taillandiers;

- Monsieur Nicolas DUJARDIN, employé, né à Montigny-le-Tilleul (Belgique), le 3 juin 1988, demeurant à B 6060 Gilly,

38, rue Thiot; et

- Monsieur Rafael PALACIOS Y RODRIGUES, employé, né à San Roque (Espagne), le 23 mai 1963, demeurant à B-6060

Gilly, 13, Rue Paradis des Chevaux.

3.- Est appelé à la fonction d’administrateur-délégué:
- Monsieur Nicolas DUJARDIN, prénommé.
Il a le pouvoir d’engager valablement la Société par sa seule signature.
4.- A été appelé à la fonction de commissaire aux comptes:
La société anonyme «ROYAL SEA S.A.», ayant son siège social à L-8047 Strassen, 56, rue de la Victoire, inscrite au

Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 145683.

5.- Le siège social est établi à L-8047 Strassen, 56, rue de la Victoire.
6.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire de 2019.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 mars 2015. Relation GAC/2015/1985. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015042277/242.
(150048219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Neried Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 29.328.

Les comptes au 30.09.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2015041162/12.
(150046683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

54667

L

U X E M B O U R G

Macae Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 187.426.

In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of March;
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange/Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in repla-

cement of his prevented colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,
who last named shall remain depositary of the present deed.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Macae Partners S.à.r.l., a société à responsabilité limitée

(private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxem-
bourg, with a share capital of USD 30,000, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of
Trade and Companies) under number B 187.426 (the “Company”).

There appeared the shareholders of the Company, namely:
- HI Holdings Cyprus Limited, a company limited by shares, duly incorporated under the laws of Cyprus, having its

registered office at 4, Riga Feraiou, Omega Court, 1 

st

 Floor, 3095 Limassol, Cyprus, duly registered with the Registrar

of Companies of Cyprus under number 158701,

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney; and

- Makeda Enterprises Company Limited, a company limited by shares, duly incorporated under the laws of Cyprus,

having its registered office at Panteli Katelari, 16, DIAGORAS HOUSE, 7 

th

 floor, 1097, Nicosia, Cyprus, duly registered

with the Registrar of Companies of Cyprus under number 326062,

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney,

the said powers of attorney, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

HI Holdings Cyprus Limited and Makeda Enterprises Company Limited through their proxy holder requested the

notary to enact that:

- the 30,000 shares representing the whole share capital of the Company were represented so that the meeting could

validly decide on all the items of the agenda of which HI Holdings Cyprus Limited and Makeda Enterprises Company
Limited have been duly informed; and

- the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by way of the issuance of new shares of the Company with a global

share premium attached hereto;

2. Subscription and payment of the new shares by way of contributions in cash by HI Holdings Cyprus Limited and

Makeda Enterprises Company Limited;

3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by HI Holdings Cyprus Limited and Makeda Enterprises Company Limited through

their proxy holder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It was resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 10,000 (ten thousand US Dollars)

so as to raise it from its current amount of USD 30,000 (thirty thousand US Dollars) to an amount of USD 40,000 (forty
thousand US Dollars) by the issuance of 10,000 (ten thousand) new shares with:

- a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each (the “New Shares”); and
- a global share premium attached thereto of an aggregate amount of USD 5,026,301 (five million twenty-six thousand

three hundred and one US Dollars) (the “Global Share Premium”).

<i>Second resolution

It was resolved to accept that the New Shares be subscribed as follows:
- 7,000 (seven thousand) New Shares, to which is attached an amount of USD 3,518,411 (three million five hundred

and eighteen thousand four hundred and eleven US Dollars) of the Global Share Premium, be subscribed by HI Holdings

54668

L

U X E M B O U R G

Cyprus Limited by way of a contribution in cash of an amount of USD 3,525,411 (three million five hundred and twenty-
five thousand four hundred and eleven US Dollars) (the “HIHO's Contribution”); and

- 3,000 (three thousand) New Shares, to which is attached an amount of USD 1,507,890 (one million five hundred and

seven thousand eight hundred and ninety US Dollars) of the Global Share Premium, be subscribed by Makeda Enterprises
Company Limited by way of a contribution in cash of an amount of USD 1,510,890 (one million five hundred and ten
thousand eight hundred and ninety US Dollars) (the “Makeda's Contribution”);

(the “HIHO's Contribution” and the “Makeda's Contribution” being together hereinafter referred to as the “Contri-

butions”).

<i>Subscription - Payment

1) HI Holdings Cyprus Limited, through its proxy holder declared to subscribe to 7,000 (seven thousand) New Shares

by paying:

- the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of USD 7,000 (seven thousand US Dollars); and
- the share premium attached thereto for an amount USD 3,518,411 (three million five hundred and eighteen thousand

four hundred and eleven US Dollars) to (i) be allocated to a freely distributable item of the balance sheet of the Company
as share premium and (ii) remain attached to all the shares of the Company held by HI Holdings Cyprus Limited at any
time; the whole being fully paid-up by way of the HIHO's Contribution; and,

2) Makeda Enterprises Company Limited, through its proxy holder declared to subscribe to 3,000 (three thousand)

New Shares by paying:

- the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of USD 3,000 (three thousand US Dollars); and
- the share premium attached thereto for an amount USD 1,507,890 (one million five hundred and seven thousand

eight hundred and ninety US Dollars) to (i) be allocated to a freely distributable item of the balance sheet of the Company
as share premium and (ii) remain attached to all the shares of the Company held by Makeda Enterprises Company Limited
at any time; the whole being fully paid-up by way of the Makeda's Contribution.

<i>Evidence of the Contributions' existence

Proof of the Contributions' existence has been given to the undersigned notary by producing a blocked funds certificate.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions it was resolved to amend article 6 of the articles of

association of the Company to read as follows:

“ Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at USD 40,000 (forty thousand US Dollars) represented by 40,000

(forty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least ninety
percent (90%) of the share capital of the Company.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about EUR 3,500.-.

The contribution is valued at EUR 4,522,090.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons through their attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of
the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the persons appearing, he signed together with us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le cinquième jour de mars,
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert Grand-Duché de Luxembourg, agissant

en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des associés de Macae Partners S.à r.l., une société à responsabilité limitée

dûment constituée et existant valablement selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 30.000

54669

L

U X E M B O U R G

USD, ayant son siège social au 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.426 (la «Société»).

Ont comparu les associés de la Société:

HI Holdings Cyprus Limited, une société («company limited by shares») dûment constituée et existant valablement

selon les lois de Chypre, ayant son siège social au 4, Riga Feraiou, Omega Court, 1 

st

 Floor, 3095 Limassol, Chypre, et

immatriculée auprès du Registre des Sociétés (Registrar of Companies) de Chypre sous le numéro 158701,

ici  représentée  par  Monsieur  Max  MAYER,  employé,  résidant  professionnellement  à  Junglinster,  Grand-Duché  de

Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé; et

Makeda Enterprises Company Limited, une société («company limited by shares») dûment constituée et existant va-

lablement selon les lois de Chypre, ayant son siège social au 16, Panteli Katelari, DIAGORAS HOUSE, 7 

th

 Floor, 1097,

Nicosie, Chypre, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés (Registrar of Companies) de Chypre sous le numéro
326062,

ici  représentée  par  Monsieur  Max  MAYER,  employé,  résidant  professionnellement  à  Junglinster,  Grand-Duché  de

Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées

avec ce dernier.

HI Holdings Cyprus Limited et Makeda Enterprises Company Limited, représentées par leur mandataire, ont prié le

notaire d'acter:

- que les 30.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société étaient représentées de sorte

que l'assemblée pouvait décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont HI Holdings Cyprus Limited
et Makeda Enterprises Company Limited ont été préalablement informées; et

- que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société par l'émission de nouvelles parts sociales de la Société avec une prime

d'émission globale y attachée;

2. Souscription et paiement des nouvelles parts sociales au moyen d'apports en numéraire par HI Holdings Cyprus

Limited et Makeda Enterprises Company Limited;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société; et
4. Divers.
Après que l'ordre du jour a été approuvé par HI Holdings Cyprus Limited et Makeda Enterprises Company Limited,

les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 10.000 USD (dix mille Dollars américains)

pour le porter de son montant actuel de 30.000 USD (trente mille Dollars américains) à un montant de 40.000 USD
(quarante mille Dollars américains) par l'émission de 10.000 (dix mille) nouvelles parts sociales ayant:

- une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»); et
- une prime d'émission globale y attachée d'un montant de 5.026.301 USD (cinq millions vingt-six mille trois cent un

Dollars américains) (la «Prime d'Emission Globale»).

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé d'accepter que les Nouvelles Parts Sociales de la Société soient souscrites comme suit:
- 7.000 (sept mille) Nouvelles Parts Sociales, auxquelles sont attachés 3.518.411 USD (trois millions cinq cent dix-huit

mille quatre cent onze Dollars américains) de la Prime d'Emission Globale, souscrites par HI Holdings Cyprus Limited
par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 3.525.411 USD (trois millions cinq cent vingt-cinq mille quatre
cent onze Dollars américains) (l'«Apport HIHO»); et

- 3.000 (trois mille) Nouvelles Parts Sociales, auxquelles sont attachés 1.507.890 USD (un million cinq cent sept mille

huit cent quatre-vingt-dix Dollars américains) de la Prime d'Emission Globale, souscrites par Makeda Enterprises Company
Limited par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 1.510.890 USD (un million cinq cent dix mille huit cent
quatre-vingt-dix Dollars américains) (l'«Apport Makeda»),

(l'«Apport HIHO» et l'«Apport Makeda» étant définis ensemble comme les «Apports»)

<i>Souscription - Paiement

1) HI Holdings Cyprus Limited, représentée par son mandataire, a déclaré souscrire à 7.000 (sept mille) Nouvelles

Parts Sociales en payant:

- la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant de 7.000 USD (sept mille Dollars américains);

et

54670

L

U X E M B O U R G

- la prime d'émission y attachée d'un montant de 3.518.411 USD (trois millions cinq cent dix-huit mille quatre cent

onze Dollars américains) devant (i) être affectée au poste disponible du bilan «prime d'émission» de la Société en tant
que prime d'émission et (ii) rester attachée à toutes les parts sociales de la Société détenues par HI Holdings Cyprus
Limited à tout moment; le tout étant intégralement libéré au moyen de l'Apport HIHO; et,

2) Makeda Enterprises Company Limited, représentée par son mandataire, a déclaré souscrire à 3.000 (trois mille)

Nouvelles Parts Sociales en payant:

- la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant de 3.000 USD (trois mille Dollars américains);

et

- la prime d'émission y attachée d'un montant de 1.507.890 USD (un million cinq cent sept mille huit cent quatre-vingt-

dix Dollars américains) devant (i) être affectée au poste disponible du bilan «prime d'émission» de la Société en tant que
prime d'émission et (ii) rester attachée à toutes les parts sociales de la Société détenues par Makeda Enterprises Company
Limited à tout moment; le tout étant intégralement libéré au moyen de l'Apport Makeda.

<i>Preuve de l'existence des Apports

Preuve de l'existence des Apports a été donnée au notaire instrumentant par la présentation d'un certificat de blocage

des fonds.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, il a été décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme

suit:

« Art. 6. Capital Social. Le capital social est fixé à 40.000 USD (quarante mille Dollars américains), représentés par

40,000 (quarante mille) parts sociales d'une valeur nominale d'1 USD (un Dollar américain) chacune, entièrement libéré.

Le capital social peut être augmenté ou diminué par une résolution de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés,

par une résolution votée par la majorité des associés représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) du capital
social de la Société.»

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en

raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cet acte notarié est évalué à environ 3.500,- EUR.

L'apport a été évalué à 4.522.090,- EUR.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des personnes compa-

rantes représentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la
demande de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.

Dont Acte, fait et passé à Junglinster, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 mars 2015. Relation GAC/2015/1935. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015041773/201.
(150048018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Zinnia Hotels Group S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.538.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2015.

Manacor Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2015043797/14.
(150050191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

54671

L

U X E M B O U R G

CEES Invest II SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 187.277.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean-Paul MEYERS, Notar mit dem Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxem-

burg,

IST ERSCHIENEN:

„Lampe Alternative Investments S.A., SICAV-FIS“, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme,

S.A.), welche als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in der Form eines spezialisierten Investmentfonds (société
d'investissment à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, SICAV-FIS) -Umbrellafonds mit einem oder mehreren
Teilfonds nach dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner derzeit
gültigen Fassung („Gesetz von 2007“) gegründet worden ist, mit Gesellschaftssitz in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter der Nummer B 160 571, hier han-
delnd für Rechnung des Teilfonds LAI-CEE Sidefund II,

Hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Serge BERNARD, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer „ad hoc“

Vollmacht unter Privatschrift.

Diese Vollmacht bleibt, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeich-

net wurde, dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung als Anlage beigefügt.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die nachstehenden von ihr

gefassten Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:

Die Erschienene („Lampe Alternative Investments S.A., SICAV-FIS“, hier handelnd für Rechnung des Teilfonds LAI-

CEE Sidefund II) ist die alleinige Gesellschafterin (die „Gesellschafterin“) der Gesellschaft „CEES Invest II SARL“, (die
"Gesellschaft"), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher,
gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 15. Mai 2014.

Alsdann fasst die Gesellschafterin, vertreten wie eingangs erwähnt, folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt das Gesellschaftskapital um einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-), von zweihun-

dertausend Euro (EUR 200.000,-) auf dreihunderttausend Euro (EUR 300.000,-), durch Ausgabe von viertausend (4.000)
neuen Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), zu erhöhen.

Die Zeichnung der so ausgegebenen viertausend (4.000) neuen Geschäftsanteile erfolgt gegen Bareinlage in Höhe von

einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) durch die Gesellschafterin, wie dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Im direkten Zusammenhang mit dem vorherigen Beschluss, beschließt die Gesellschafterin Artikel Fünf (5) Absatz Eins

(1) der Gesellschaftssatzung abzuändern, so dass dieser Artikel Fünf (5) Absatz Eins (1) fortan folgenden neuen Wortlaut
erhält:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf dreihunderttausend Euro (EUR 300.000,-) festgesetzt,

eingeteilt in zwölftausend (12.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-),
alle voll eingezahlt."

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Rambrouch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  und  Erklärung  alles  Vorstehenden  an  die  Erschienene,  hat  dieselbe  mit  dem  Notar  gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Serge Bernard, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 05 mars 2015. Relation: DAC/2015/3802. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Eintra-

gung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 13. März 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015040888/51.
(150047165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

54672


Document Outline

Bruni S.à r.l.

CEES Invest II SARL

Crystal Navy S.à r.l.

Digital Services XVI S.à r.l.

Enoue S.A.

Immo DM, S.à r.l.

Isurus Lux S.A.

Kiawah Island Capital Advisers S.à r.l.

Leponte S.A.

LS2 Consult s. à r.l.

LSF6 Europe Financial Holdings S.à r.l.

LuxScan Technologies S.à r.l.

Lys Investments S.à r.l.

Macae Partners S.à r.l.

Neried Finance S.A.

Neuenfelde Navigation AG

Novamil Invest S.A.

Nova-Via S.A.

Nova-Via S.A.

Petroceltic S.à r.l.

Pitibech SCI

Portrea S.A.

RRR Investments S.à r.l.

Sablon Participations

SB International S.à r.l.

Scania Treasury Luxembourg

Schortgen Galerie S.à r.l.

SCP OCN Acquisition Lux S.à r.l.

Scuderia CDS S.A.

Searchlight BMS II (Lux) S.à r.l.

Sistema Finance S.A.

Sisto Armaturen S.A.

Sivato Holding S.à r.l.

Skandia Invest S.A.

Sky Luxco S.à r.l.

Socialcom Luxembourg S.à r.l.

Société luxembourgeoise de Leasing BIL-LEASE

Soico S.A.

Space Liner S.A.

SSI Schäfer Shop GmbH

STENA CARRON (Hungary) KFT, Luxembourg Branch

STENA TAY (Hungary) LLC, Luxembourg Branch

Stericycle Europe S.à r.l.

Sun Live Solarium S.à.r.l.

Zinnia Hotels Group S. à r.l.