logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 782

20 mars 2015

SOMMAIRE

Carros Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

37534

Centrum Leto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37532

CETP III Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . .

37499

Cloverleaf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37510

Colour Hall S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37530

C&O S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37490

Custom Sensors & Technologies Luxem-

bourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37534

Darter Holdings I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

37522

Digital Services XLVIII (GP) S.à.r.l.  . . . . . .

37499

Digital Services XXXV (GP) S.à.r.l.  . . . . . .

37511

E.I.R.E. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37522

Noux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37490

Pasta Mano S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37491

Regency United S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . .

37491

Rembrandt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37491

Rosny S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37498

Rozeo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37495

Rubarc S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37497

RWZ Agri S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37495

Sagittarius S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37497

Saint Aubin Développement S.A.  . . . . . . . .

37492

Sand Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37492

Sanzo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37493

Savings S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37493

Saxa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37493

Scherkamp & Partner S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

37492

Schroder International Selection Fund  . . .

37498

Sem Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37494

Semtex S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37493

Serenitas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37494

Shandella SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37498

Silver Wings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37496

SIPE, Société de Participations Financières

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37496

SIPP SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37496

Skype Communications . . . . . . . . . . . . . . . . .

37497

Skype Technologies S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

37497

SOF-10 Amazona Holdings Lux S.à r.l.  . . .

37495

Sounion Investments S.A., société de ges-

tion de patrimoine familial  . . . . . . . . . . . . .

37490

SPC Lux IV, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37490

Spring Financial Investment S.A.  . . . . . . . .

37498

S.P.R.L. Brico-Sanichel  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37494

S.Promotion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37495

Sun Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37491

Sun Luxco I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37492

Superior Luxco 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

37496

Umweltschutztechnik Luxembourg . . . . . .

37536

Valfleurs S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37536

37489

L

U X E M B O U R G

SPC Lux IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 205.453,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.047.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 29 janvier 2015

L'Associée unique a décidé:
- d'augmenter le nombre de gérants de 2 à 3;
- de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, nouveau gérant de la Société:
* Monsieur Mark Poff, né le 27 février 1967, demeurant au 6108 Ruthland Road, Oakland, CA 94611
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de:
- Monsieur Carl Morris Stout;
- Monsieur Andrew Richards;
- Monsieur Mark Poff.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2015.

<i>Pour SPC Lux IV S.à r.l.
Un Mandataire

Référence de publication: 2015024631/21.
(150027677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Sounion Investments S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Ges-

tion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 56.341.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

<i>Pour: SOUNION INVESTMENTS S.A., société de gestion de patrimoine familial
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015024630/15.
(150027481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

C&amp;O S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9841 Wahlhausen, 1, Veianerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 174.632.

Les statuts coordonnés au 29 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024819/9.
(150029262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Noux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 161.591.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024504/9.
(150027475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

37490

L

U X E M B O U R G

Pasta Mano S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 58.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015025375/11.
(150028305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Regency United S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 186.671.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 31 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025420/12.
(150028116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Rembrandt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 61.330.

Il résulte des décisions adoptées lors du conseil d'administration de la Société qui s'est tenu en date du 11 février 2015

que Maître Maria Dennewald, avocat à la cour, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich,
a été désignée dépositaire des actions au porteur et du registre y afférent de la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015025421/13.
(150028733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sun Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.970.

<i>Extrait des Résolutions prises par l'Associé Unique en date du 5 Février 2015

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique que:
- Madame Myriam Scussel a démissionné de son mandat de gérant de classe B en date du 5 février 2015;
- Monsieur Smaïn Bouchareb, né le 19 août 1978 à Mulhouse (France), résidant professionnellement au 412 F route

d'Esch, L-1030 Luxembourg, est nommé gérant de classe B avec effet au 5 février 2015, pour un mandat à durée illimitée;

- Monsieur Frédéric Gardeur, né le 11 juillet 1972 à Messancy (Belgique), résidant professionnellement au 412 F route

d'Esch, L-1030 Luxembourg, est nommé gérant de classe B avec effet au 5 février 2015, pour un mandat à durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Sun Luxco II S.à r.l.

Référence de publication: 2015025464/18.
(150028447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37491

L

U X E M B O U R G

Sun Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.971.

<i>Extrait des Résolutions prises par l'Associé Unique en date du 5 Février 2015

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique que:
- Madame Myriam Scussel a démissionné de son mandat de gérant de classe B en date du 5 février 2015.
- Monsieur Smaïn Bouchareb, né le 19 août 1978 à Mulhouse (France), résidant professionnellement au 412 F route

d'Esch, L-1030 Luxembourg, est nommé gérant de classe B avec effet au 5 février 2015, pour un mandat à durée illimitée;

- Monsieur Frédéric Gardeur, né le 11 juillet 1972 à Messancy (Belgique), résidant professionnellement au 412 F route

d'Esch, L-1030 Luxembourg, est nommé gérant de classe B avec effet au 5 février 2015, pour un mandat à durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Sun Luxco I S.à r.l.

Référence de publication: 2015025463/18.
(150029245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Scherkamp &amp; Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 63.801.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 7 octobre 2014

L'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société au L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté

avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025482/12.
(150028339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Saint Aubin Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 74.823.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société Saint

Aubin Developpement SA la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon,
L-1140 Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025476/12.
(150028947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sand Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 36.205.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société Sand

Investments SA la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140
Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025477/12.
(150028937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37492

L

U X E M B O U R G

Sanzo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 191.937.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 11 février 2015 à 14.00

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2015025478/14.
(150028078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Savings S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 181.354.

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 11/02/2015:
Il est décidé nommer la société à responsabilité limité UNCOS, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,

immatriculée au RCSL sous le numéro B141298, en tant que dépositaire légal des actions au porteur de la société SAVINGS
S.A., SPF (B181354) et ceci en vertu de la loi du 28 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/02/2015.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015025479/15.
(150028350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Saxa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.487.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 06 février 2015:

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 06 février 2015.

<i>Pour SAXA S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025480/13.
(150028631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Semtex S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 61.738.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015025491/12.
(150028149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37493

L

U X E M B O U R G

Serenitas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 175.288.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 09 Février 2015, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société SERENITAS

<i>S.A.

L'Assemblée générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Eric Yvon Debled, né le 14

janvier 1964 à Montignies-sur-Sambre (Belgique) et résidant professionnellement à L-1630 Luxembourg, au 56, rue Gle-
sener, en tant qu'administrateur de la Société SERENITAS S.A.

L'Assemblée décide également de nommer Monsieur Cédric de Caritat de Peruzzis, né le 05 juin 1979 à Charleroi

(Belgique) et résidant professionnellement à L-1630 Luxembourg au 56, rue Glesener, en tant qu'Administrateur de la
société SERENITAS S.A. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2021.

Dès lors, le conseil d'administration de la société se composera désormais de:
- Mr. Benoît Dabertrand
- Mr. Cédric de Caritat
- Mr. Nicolas Delattre
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025492/22.
(150028013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sem Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 106.324.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 16 janvier 2015:
Conformément à l'article 11Bis, § 1 et 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

tels qu'adoptés par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Admi-
nistration décide de désigner GLOBAL TRUST ADVISORS S.A, B68731, 26-28 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg
comme dépositaire des actions.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025490/15.
(150029256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

S.P.R.L. Brico-Sanichel, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.282.

EXTRAIT

Je soussigné, Armand ROYER, né le 3 juillet 1947 à Reckange, gérant unique en exercice de la sprl Brico-Sanichel dont

le siège social est établi 302, route de Luxembourg à B-6700 ARLON décide de transférer l'établissement stable de son
siège d'exploitation luxembourgeois, actuellement 61, route d'Arlon, L.8211 MAMER vers la nouvelle adresse: 3-5 rue
d'Arlon, L-8399 WINDHOF.

De plus, je vous prie de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant suivant:
Monsieur Armand ROYER, gérant unique, résidant 36, rue Burtaubois à B-6880 BIOURGE.
La présente est établie en vue de l'adaptation des formalités au Registre de Commerce à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015025441/17.
(150028449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37494

L

U X E M B O U R G

RWZ Agri S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9749 Fischbach (Clervaux), 3, Giälle Wee.

R.C.S. Luxembourg B 171.960.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 30. Dezember 2014

Der alleinige Teilhaber der Gesellschaft, die Gesellschaft Raffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG mit Gesellschaftssitz

in 50668 Köln (D) Altenberger Str. 1a, hier vertreten durch den Vorstand Herren Hans-Josef Hilgers und Markus Stüttgen,
hat folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Der bisherige Geschäftsführer Herr PLÜMER Patrick Ascan, geboren am 07. November 1982 in Köln (D) wohnhaft

in D-50672 Köln, Brüsseler Strasse 78, wird mit Wirkung zum 01. Januar 2015 abberufen.

<i>Zweiter Beschluss

Zum Geschäftsführer wird ernannt, ab 01. Januar 2015, auf unbestimmte Dauer, Herr Erik PIETRUSCHKA, geboren

am 08. Januar 1976 in Saarburg (D) wohnhaft in D-54441 Ockfen, Kirschstrasse 30. Zeichnungsberechtigung: Er ist zu-
sammen mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fischbach (Clerf), den 30. Dezember 2014.

<i>Für die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG
Hans-Josef Hilgers / Markus Stüttgen

Référence de publication: 2015025437/22.
(150028647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Rozeo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 173.053.

<i>Extrait des résolutions prises au siège social de la Société par le Conseil d'Administration en date du 3 février 2014

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 1 

er

 février 2014, le siège social de la Société au 14,

Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

<i>Pour Rozeo S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015025433/13.
(150028871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

S.Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 5, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 142.699.

Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner avec effet immédiat de mes fonctions

d'administrateur de votre société.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Laurent MULLER.

Référence de publication: 2015025442/10.
(150028198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

SOF-10 Amazona Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 188.506.

Les statuts coordonnés au 27 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025514/9.
(150028982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37495

L

U X E M B O U R G

SIPP SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 74.540.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 9 février 2015 que:
- les titres au porteur de la société sont déposés auprès de Roosevelt Services S.A., domiciliée 15, boulevard Roosevelt,

L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 février 2015.

<i>Pour la société SIPP SPF S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015025507/14.
(150028459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

SIPE, Société de Participations Financières, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 41.240.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 février 2015

Il résulte de ce Conseil d'administration:
Conformément à l'article 42 des Lois Coordonnées sur les Sociétés commerciales du 10 août 1915 tel que modifié

par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration décide,
à l'unanimité, de nommer comme dépositaire des actions au porteur, la société «Fiduciaire Internationale SA», ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
34813 et représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Stéphan MOREAUX.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015025505/15.
(150029093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Silver Wings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 95.707.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 9 février 2015 à 16.00

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2015025504/14.
(150028887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Superior Luxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 192.737.

Les statuts coordonnés au 30 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015025466/11.
(150028874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37496

L

U X E M B O U R G

Skype Communications, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.644.676,25.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 23-29, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 100.468.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 30 janvier 2015

En date du 30 janvier 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat de Deloitte Audit

en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à
l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes annuels clos au 30 juin 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Skype Communications
Signature

Référence de publication: 2015025451/16.
(150029058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Skype Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 23-29, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 111.886.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 30 janvier 2015

En date du 30 janvier 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat de Deloitte Audit

en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à
l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes annuels clos au 30 juin 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Skype Technologies S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015025452/16.
(150029070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Rubarc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 135.606.

EXTRAIT

Suite à la cession de parts du 11.02.2015, le capital de la Sàrl susmentionnée est réparti comme suit:

Karl Horsburgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015025435/11.
(150028812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sagittarius S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue de Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 178.377.

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon mandat d'administrateur de catégorie A de

votre société avec effet immédiat à la date du 11 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2015.

Mr. Thierry Stas.

Référence de publication: 2015025473/11.
(150028386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37497

L

U X E M B O U R G

Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 8.202.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 février 2015

En date du 5 février 2015, le conseil d'administration de la Société a décidé de nommer Arendt Services S.A., une

société anonyme, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse
suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B145917, en tant que dépositaire des Actions au Porteur de la Société, conformément à
l'article premier de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du
registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
Signature

Référence de publication: 2015025484/18.
(150028399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Shandella SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 183.302.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 29 janvier 2015 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025498/12.
(150028114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Rosny S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 34.826.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015025429/12.
(150028150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Spring Financial Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 64.901.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015025524/12.
(150028148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37498

L

U X E M B O U R G

CETP III Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 184.620.

<i>Dépôt rectificatif au dépôt initial du 22 mai 2014 N° L140084697

Le numéro d'enregistrement du membre du conseil de gérance CETP III Managing GP Holdings, L.L.C., à l'Office of

the Secretary of State of the State of Delaware est le 1207278.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

CETP III Participations S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015024872/15.
(150028318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Digital Services XLVIII (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.460.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XLVIII S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law,

having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 23 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XLVIII (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

37499

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

37500

L

U X E M B O U R G

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining  managers  until  the  next  meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

37501

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

37502

L

U X E M B O U R G

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XLVIII S.àr.l., afo-

rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

37503

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XLVIII S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 23.

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XLVIII (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung
unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

37504

L

U X E M B O U R G

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

37505

L

U X E M B O U R G

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-

37506

L

U X E M B O U R G

sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer

37507

L

U X E M B O U R G

der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

37508

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XLVIII S.àr.l. vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

37509

L

U X E M B O U R G

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2454. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015024919/590.
(150028697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Cloverleaf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8245 Mamer, 2, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 134.657.

L'an deux mil quinze, le vingt-six janvier,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

s’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société CLOVERLEAF S.A., avec siège à L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 134657, consituée aux termes d’un
acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch / Alzette, en date du 21 décembre 2007, publié
au Mémorial C numéro 172 du 22 janvier 2008, et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire actée par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 04 août 2009, publiée
au Mémorial C numéro 1657 du 28 août 2009.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Monsieur Samuel KLEEBLATT, commerçant, né à Hadera,

Israël, le 18 janvier 1950, demeurant à B-6747 Chatillon, 23, rue du Fourneau,

qui désigne comme secrétaire Madame Véronique GILSONBARATON, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marina GLYADENTSEVA, sans état, née à Kemerovo Oblast, Russie,

le 17 novembre 1979, demeurant à B-6747 Chatillon, 23, rue du Fourneau.

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des

actionnaires sont renseignés sur une liste de présences, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux
présentes.

Monsieur le président constate, et l’assemblée approuve, que toutes les 420 actions émises de la société sont vala-

blement représentées, ainsi qu'il résulte de la liste de présences susmentionnée et que tous les actionnaires présents ou
représentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l’avance l’ordre du jour de la présente
assemblée.

Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes qui seront approuvées à l’unanimité:

<i>Siège social:

Le siège de la société est transféré à L-8245 Mamer, 2, rue de la Libération.
La première phrase de l’article 2 des statuts est modifiée comme suit:
«Le siège social est établi dans la Commune de Mamer.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et résidences, tous

ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. KLEEBLATT, M. GLYADENTSEVA, V. BARATON, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3036. Reçu soixante-quinze euros.

75,-€.

<i>Le Receveur (signé): I. Thill.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015024884/42.
(150028757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37510

L

U X E M B O U R G

Digital Services XXXV (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.478.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XXXV S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law,

having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 7 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XXXV (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

37511

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

37512

L

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

37513

L

U X E M B O U R G

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21 Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

37514

L

U X E M B O U R G

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XXXV S.àr.l., afo-

rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in Article 183 of the law on commercial companies

have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

37515

L

U X E M B O U R G

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XXXV S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 7.

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XXXV (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung
unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Artikel

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

37516

L

U X E M B O U R G

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,

37517

L

U X E M B O U R G

welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2  Falls  die  Gesellschaft  von  einem  einzelnen  Geschäftsführer  geleitet  wird  und  soweit  der  Begriff  „alleiniger

Geschäftsführer“nicht  ausdrücklich  verwendet  wird,  ist  jeder  Verweis  in  dieser  Satzung  auf  den  „Rat  der
Geschäftsführer“als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

37518

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

37519

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

37520

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XXXV S.àr.l. vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/714. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015024920/590.
(150029006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37521

L

U X E M B O U R G

E.I.R.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 104.408.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 11 février 2015 que:
- Monsieur Roberto DE LUCA et Monsieur Pedro GONCALVES ont démissionné de leur fonction d'administrateur.
La  société  Lexington  Governance  Limited,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  de  Londres  sous  le  numéro

08454544, ayant son siège social à Londres NW1 1JD, Royaume-Uni, 41, Chalton Street, représentée par Monsieur
Andrew Simon DAVIS, né le 28 juillet 1963 à Londres, Royaume-Uni et domicilié professionnellement à Londres NW1
1JD, Royaume-Uni, 41, Chalton Street et Madame Elena LATORRE, employée privée, née le 6 décembre 1975 à Luxem-
bourg et demeurant professionnellement au 10 rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg ont été nommés respectivement
à la fonction d'administrateur.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
Le mandat de Monsieur Bertrand MICHAUD, en tant qu'administrateur et président et le mandat de la société Con-

solida S.A., en tant que commissaire aux comptes ont été prolongés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2021.

- Le siège social est transféré du 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, au 10 rue Antoine Jans, L-1820 Lu-

xembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024944/24.
(150029132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Darter Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 182.282.

In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of the month of January;
Before Us Me Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

undersigned;

THERE APPEARED:

Motor Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at

Paget-Brown Trust Company Limited, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman
Islands, registered with the Cayman Islands Companies’ Register under number PB 285322 (hereafter referred to as the
“Sole Shareholder”),

here represented by Mr. Frank STOLZ, notary clerk, residing professionally 13, avenue François Clément, L-5612

Mondorf-les-Bains, Luxembourg (the “Proxy-holder”),

by virtue of a proxy given under private seal given on 9 January 2015; such proxy, after having been signed “ne varietur”

by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, declared that it currently holds all the shares issued by Darter Holdings I S.à r.l. (the “Company”),

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg by a deed passed before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, on 27 November 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 61 of 8 January 2014, with a corporate capital
of twenty five thousand euros (EUR 25,000.-), having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 182.282.

The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the

following resolutions and made the following declarations:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to reduce the par value of the shares issued by the Company from their existing twenty-

five euros (EUR 25.-) per share to one euro (EUR 1.-) per share, and increase the number of shares accordingly, in order
to set the share capital of the Company, as a result of this change, at twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-), repre-
sented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

As a result of the above, the Sole Shareholder holds twenty-five thousand (25,000) shares, having a par value of one

euro (EUR 1.-) each.

37522

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company from twenty-five thousand euros (EUR

25,000.-) to one million twenty-five thousand euros (EUR 1,025,000.-) by the creation of ten new classes of Preference
Shares to be denominated “Class A Shares” to “Class J Shares”, and issue one hundred thousand (100,000) Preference
Shares in each of the ten classes.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription / Payment

The Sole Shareholder declared to subscribe for one hundred thousand (100,000) Preference Shares in each of the ten

new share classes, which Preference Shares shall be in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-) each and
issued at a premium value of seventy-two euros and ninety-one cents (EUR 72.91.-) per share and to fully pay for such
Preference Shares by a contribution in cash amounting to seventy-three million nine hundred and ten thousand euros
(EUR 73,910,000.-), out of which one million euros (EUR 1,000,000) shall be allocated to the share capital of the Company
and seventy-two million nine hundred and ten thousand euros (EUR 72,910,000.-) shall be allocated to the share premium
account of the Company.

The amount of seventy-three million nine hundred and ten thousand euros (EUR 73,910,000.-) is at the disposal of the

Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder decided to amend the Articles of the Company

as follows:

1. To introduce a ‘Definitions’ section at the beginning of the Articles which shall read as follows:

“ I. Definition.
- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)

increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and
legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without, for the avoidance of doubt, any
double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles and
(iv) any Profit Entitlement so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves.
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be

cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
OD = any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles.
PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed

by the sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers of the Company in good faith and with
the view to the Company’s ability to continue as a going concern.

- “Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a

remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes
and any receivable which in the opinion of the board of managers will be paid to the Company in the short term less any
indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim
Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares,
stock or securities of other kind held by the Company.

- “Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class

Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available
Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).

- “Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period,

the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

37523

L

U X E M B O U R G

- “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
- “Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before

the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.

- “Law” shall mean the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time.
- “Profit Entitlement” shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.”
As a result of the introduction of the ‘Definitions’ section, the other sections of the Articles shall be renumbered so

that the ‘General provision’ section shall be number VIII.

2. Article 5 of the Company’s Articles shall be amended so that it shall henceforth read as follows:

“ 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at one million twenty-five thousand euros (EUR 1,025,000.-) represented

by:

5.1.1. twenty-five thousand (25,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) in registered form with a par value of

one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;

5.1.2. one million (1,000,000) preference shares (the “Preference Shares”) in registered form with a par value of one

euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, divided into ten classes to be denominated “Class A Shares” to
“Class J Shares” as set out below:

i) one hundred thousand (100,000) Class A Shares;
ii) one hundred thousand (100,000) Class B Shares;
iii) one hundred thousand (100,000) Class C Shares;
iv) one hundred thousand (100,000) Class D Shares;
v) one hundred thousand (100,000) Class E Shares;
vi) one hundred thousand (100,000) Class F Shares;
vii) one hundred thousand (100,000) Class G Shares;
viii) one hundred thousand (100,000) Class H Shares;
ix) one hundred thousand (100,000) Class I Shares;
x) one hundred thousand (100,000) Class J Shares;
5.2 Subject to article 5.3, the share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a

resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.

5.3 A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the

respective Class Periods.

5.3.1. The period for the Class A Shares is the period starting on 12 January 2015 and ending no later than on 31

December 2015 (the “Class A Period”).

5.3.2. The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no

later than 31 December 2016 (the “Class B Period”).

5.3.3. The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later

than on 31 December 2017 (the “Class C Period”).

5.3.4. The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later

than on 31 December 2018 (the “Class D Period”).

5.3.5. The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no

later than 31 December 2019 (the “Class E Period”).

5.3.6. The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no

later than 31 December 2020 (the “Class F Period”).

5.3.7. The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no

later than 31 December 2021 (the “Class G Period”).

5.3.8. The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later

than on 31 December 2022 (the “Class H Period”).

5.3.9. The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later

than on 31 December 2023 (the “Class I Period”).

5.3.10. The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later

than on 31 December 2024 (the “Class J Period”).

5.4. Where a class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the

redemption and cancellation of such class(es) of Preference Shares can be made during a new period (the “New Period”)
which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately
preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first
New Period shall start on the day after the Class J Period and the class of Preference Shares not repurchased and not

37524

L

U X E M B O U R G

cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A to class J (to the extent not previously
repurchased and cancelled).

5.5. For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Preference Shares shall

take place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class
Period (or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of
Preference Shares and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.

5.6. Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due

and payable by the Company to the shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt
the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

5.7. The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the sole

manager or, in case of plurality of managers the board of managers in its reasonable discretion and within the best
corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the sole manager or, in case of plurality the board of
managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount
the freely distributable reserves either in part or in totality.”

3. Article 15 of the Company’s Articles shall be amended so that it shall henceforth read as follows:

“ 15. Allocation of profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 Subject to article 15.4, the general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It

may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 Subject to article 15.4, the general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of

statements of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year
increased by profits carried forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried
forward or, where the distribution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incor-
poration of the Company but, in either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or
by these Articles.

15.4 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:
15.4.1 the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.60% of the nominal value of the

Ordinary Shares;

15.4.2 the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.10% of the nominal value of the

Class A Shares;

15.4.3 the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.15% of the nominal value of the

Class B Shares;

15.4.4 the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.20% of the nominal value of the

Class C Shares;

15.4.5 the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.25% of the nominal value of the

Class D Shares;

15.4.6 the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.30% of the nominal value of the

Class E Shares;

15.4.7 the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.35% of the nominal value of the

Class F Shares;

15.4.8 the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.40% of the nominal value of the

Class G Shares;

15.4.9 the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.45% of the nominal value of the

Class H Shares;

15.4.10 the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.50% of the nominal value of the

Class I Shares; and

15.4.11 the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.55% of the nominal value of the

Class J Shares.

The balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares pursuant to a decision taken by the general

meeting of shareholders.”

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority given to any manager of the Company to individually proceed to the registration in the share

37525

L

U X E M B O U R G

register of the Company of (i) the above increase of the Company's share capital as well as (ii) to see to any formalities
in connection therewith.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven thousand five hundred
Euros (EUR 7,500).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, at the date

indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with us the notary the present deed.

suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le douzième jour du mois de janvier;
Par-devant Nous Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains. Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Motor Holdings Limited., une société constituée selon les lois de Iles Caïmans, ayant son siège social au Paget-Brown

Trust Company Limited, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102, Iles Caïmans, enre-
gistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïmans sous le numéro PB 285322 (“ l’Associé Unique”).

Laquelle comparante est ici représentée par Monsieur Frank STOLZ, clerc de notaire, demeurant professionnellement

à 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Luxembourg, (le “Mandataire”),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 9 janvier 2015; laquelle procuration, après avoir

été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enre-
gistrée avec lui.

Laquelle comparante déclare détenir actuellement l’entièreté des parts sociales émises par Darter Holdings I S.à r.l.

(la «Société»), une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par un acte
de Maître Carlo Wersandt, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 27 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 61 du 8 janvier 2014, ayant un capital social de vingt-cinq mille euros (EUR. 25.000),
ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, et enregistrée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.282.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, dans sa capacité d’Associé Unique de la Société, a dès

lors pris les résolutions suivantes et a fait les déclarations ci-dessous:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de réduire la valeur nominale des parts sociales émises par la Société de son montant actuel

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale à un euro (EUR 1,-) par part sociale, et d’augmenter le nombre de parts
sociales en conséquence, afin d’établir le capital social de la Société, en conséquence de ce changement, à vingt-cinq mille
euros (EUR 25.000,-), représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR
1,-) chacune.

En raison de ce qui précède, l’Associé Unique détient vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ayant une valeur nominale

d’un euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décida d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq mille euros

(EUR 25.000,-) à un montant d’un million vingt-cinq mille euros (EUR 1.025.000,-) par la création de dix nouvelles Caté-
gories de Parts sociales Préférentielles, à savoir les «Parts sociales de catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I, et J», et d’émettre
cent mille (100.000) Parts sociales Préférentielles dans chacune des dix Catégories.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique a décidé d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante pour et l’entière libération de l’aug-

mentation du capital social comme suit:

37526

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription - Libération

L’Associé Unique a déclaré souscrire à cent mille (100.000) Parts sociales Préférentielles dans chacune des dix nouvelles

Catégories de parts sociales, lesquelles seront sous forme nominative et ayant chacune une valeur nominale d’un euro
(EUR 1,-) et émises à une valeur prime de soixante-douze euros et quatre-vingt-onze centimes (EUR. 72,91) par part
sociale et de libérer entièrement lesdites Parts sociales Préférentielles par un apport en espèces de soixante-treize millions
neuf cent dix mille euros (EUR 73.910.000,-) desquels un million d’euros (EUR 1.000.000,-) seront affectés au capital social
de la Société et soixante-douze millions neuf cent dix mille euros (EUR 72.910.000,-) seront affectés à la prime d’émission
de la Société.

La somme de soixante-treize millions neuf cent dix mille euros (EUR 73.910.000,-) est à la disposition de la Société,

ce qui a été prouvé au notaire soussigné, lequel le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décida de modifier les Statuts de la Société comme

suit:

1. D’introduire une section «Définitions» au début des Statuts qui se lit comme suit:

« I. Définitions.
-“Montant Disponible” signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés) aug-

mentés de (i) toute réserve librement distribuable attachée aux Parts sociales Préférentielles et (ii), le cas échéant, du
montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale relatives aux Catégories des Parts Sociales
Préférentielles devant être annulées mais réduit par (i) toute perte (incluant les pertes reportées) exprimée comme
positive, (ii) toute somme à effectuer aux réserve(s) en vertu des exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois tel que
figurant dans les Comptes Intérimaires concernés (et afin d’éviter toute ambiguïté, sans double comptage), (iii) de tout
dividende auxquels a (ont) droit le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires en accord avec les Statuts et (iv) tout
Droit au Bénéfice de telle sorte que:

MD = (BN + B+ RC) - (P + RL+DO+DB)
Sachant que:
MD = Montant Disponible.
BN = Bénéfices Nets (incluant les bénéfices reportés).
B = toute réserve librement distribuable attachée aux Parts sociales préférentielles.
RC = le montant de la Réduction de Capital et la réduction de la réserve légale relative à la Catégorie des Parts Sociales

Préférentielles devant être annulée.

P = Pertes (incluant les pertes reportées) exprimées comme positives.
RL = toute somme devant être allouée dans une (des) réserve(s) conformément aux Exigences de la Loi ou des Statuts.
DO = tout Dividende auquel a (ont) droit le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires conformément aux Statuts.
DB = Droit aux Bénéfices.
Le Montant Disponible doit figurer dans les Comptes Intérimaires de la Période de Catégorie correspondante et sera

être évalué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité des gérants, par le Conseil de gérance de la Société, de bonne
foi et en prenant en compte la possibilité de la Société de poursuivre ses activités.

- “Liquidités Disponibles” désigne (i) toutes les espèces détenues par la Société (excepté pour les dépôts à terme en

espèces) ayant une échéance supérieure à six mois (6), (ii) tous les instruments du marché monétaire immédiatement
négociables, obligations et billets et toute créance qui, selon l’avis du Gérant Unique, ou en cas de pluralité de gérants,
du Conseil de gérance, seront versés à la Société à court terme, moins les dettes existantes ou autre dette de la Société
payable endéans six (6) mois déterminés sur base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de Catégorie concernée
(ou Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tous les actifs tels que des Parts Sociales, titres ou valeurs mobilières de
toute sorte détenus par la Société.

- “Montant d’Annulation” désigne un montant n’excédant pas le montant Disponible relatif à la Période de Catégorie

correspondante (ou Nouvelle Période, le cas échéant) à condition que ledit Montant d’Annulation ne soit pas supérieur
aux Liquidités Disponibles relatives à la Période de Catégorie correspondante (ou Nouvelle Période).

- “Période de Catégorie” désigne chacune des Période de Catégorie A, Période de Catégorie B, Période de Catégorie

C, Période de Catégorie D, Période de Catégorie E, Période de Catégorie F, Période de Catégorie G, Période de Catégorie
H, Période de Catégorie I, Période de Catégorie J.

- “Comptes Intérimaires” signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires.
- “Date des Comptes Intérimaires” signifie la date comprise entre trente (30) jours minimum et dix jours(10) maximum

avant la date de rachat et d’annulation de la Catégorie de Parts Sociales Préférentielles concernée.

- “Loi” signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autre.
- “Droit au Bénéfice” signifie les dividendes préférentiels des Parts Sociales Préférentielles.»

37527

L

U X E M B O U R G

En conséquence de l’introduction de la section «Définitions», les autres sections des Statuts sont renumérotées de

sorte que la section «Disposition Générale» soit numérotée VIII.

2. L’article 5 des Statuts de la Société est modifié de sorte qu’il se lit comme suit:

« 5. Capital.
5.1. Le capital de la Société est fixé à un million vingt-cinq mille euros (EUR 1.025.000,-) représenté par:
5.1.1. Vingt-cinq mille trente-quatre (25.000) parts sociales ordinaires (les «parts sociales ordinaires») sous forme

nominative d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

5.1.2. Un million (1.000.000) de parts sociales préférentielles (les «Parts sociales préférentielles») sous forme nomi-

native d’une valeur nominale d’un euro (EUR. 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, divisées en dix
Catégories de «Parts sociales de Catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I et J» comme défini ci-dessous:

i) Cent mille (100.000) sociales de Catégorie A;
ii) Cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie B;
iii) Cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie C;
iv) Cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie D;
v) Cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie E;
vi) Cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie F;
vii) Cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie G;
viii) Cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie H;
ix) Cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie I;
x) Cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie J;
5.2. L’article 5.3 prévoit que le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs

fois par résolution de l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en
matière de modification des Statuts.

5.3. Une réduction du capital social par le rachat d’une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles ne peut s’effectuer

que durant les Périodes de Catégories respectives.

5.3.1. La période pour les Parts Sociales de Catégorie A est la période commençant le 12 janvier 2015 et terminant

au plus tard le 31 décembre 2015 (la “Période de Catégorie A”).

5.3.2. La période pour les Parts Sociales de Catégorie B est la période commençant le jour suivant la Période de

Catégorie A et terminant au plus tard le 31 Décembre 2016 (la “Période de Catégorie B”).

5.3.3.  La  période  pour  les  Parts  Sociales  de  Catégorie  C  est  la  période  commençant  le  jour  après  la  période  de

Catégorie B et terminant au plus tard le 31 Décembre 2017 (la “Période de Catégorie C”).

5.3.4.  La  période  pour  les  Parts  Sociales  de  Catégorie  D  est  la  période  commençant  le  jour  après  la  période  de

Catégorie C et terminant au plus tard le 31 Décembre 2018 (la “Période de Catégorie D”).

5.3.5. La période pour les Parts Sociales de Catégorie E est la période commençant le jour après la période de Catégorie

D et terminant au plus tard le 31 Décembre 2019 (la “Période de Catégorie E”).

5.3.6. La période pour les Parts Sociales de Catégorie F est la période commençant le jour après la période de Catégorie

E et terminant au plus tard le 31 Décembre 2020 (la “Période de Catégorie F”).

5.3.7.  La  période  pour  les  Parts  Sociales  de  Catégorie  G  est  la  période  commençant  le  jour  après  la  période  de

Catégorie F et terminant au plus tard le 31 Décembre 2021 (la “Période de Catégorie G”).

5.3.8. La période pour les Parts Sociales de Catégorie H est période commençant le jour après la période de Catégorie

G et terminant au plus tard le 31 Décembre 2022 (la “Période de Catégorie H”).

5.3.9. La période pour les Parts Sociales de Catégorie I est la période commençant le jour après la période de Catégorie

H et terminant au plus tard le 31 Décembre 2023 (la “Période de Catégorie I”).

5.3.10.  La  période  pour  les  Parts  Sociales  de  Catégorie  J  est  la  période  commençant  le  jour  après  la  période  de

Catégorie I et terminant au plus tard le 31 Décembre 2024 (la “Période de Catégorie J”).

5.4. Dans le cas où une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles n’a pas été rachetée et annulée au cours de la

Période de Catégorie concernée, le rachat et l’annulation de cette (ces) Catégorie(s) de Parts Sociales Préférentielles
peut s’effectuer au cours d’une nouvelle période (la “Nouvelle Période”) laquelle débutera à la date suivant la dernière
période de Catégorie (ou, le cas échéant, à la date après la fin de la Nouvelle Période immédiatement précédente d’une
autre Catégorie) et se terminera au plus tard un an après la date de début de ladite Nouvelle Période. La première
Nouvelle Période débutera le jour suivant la période de Catégorie J et la Catégorie de Parts Sociales Préférentielles qui
n’aura été ni rachetée ni annulée pendant leur Période de Catégorie respective viendront dans l’ordre de la Catégorie A
à la Catégorie J (dans la mesure où elles n’ont été précédemment ni rachetées ni annulées).

5.5. Afin d’éviter toute ambiguïté, dans le cas d’un rachat ou d’une annulation d’une Catégorie de Parts Sociales Pré-

férentielles doit avoir lieu avant le dernier jour de sa Période de Catégorie respective (ou, le cas échéant, la Nouvelle
Période), la Période de Catégorie suivante (ou, le cas échéant, la Nouvelle Période) commence le jour suivant le rachat

37528

L

U X E M B O U R G

et l’annulation de ladite Catégorie des Parts Sociales Préférentielles et devra continuer à se terminer au jour tel que défini
initialement dans les Statuts ci-dessus.

5.6. Lors du rachat et de l’annulation de l’entièreté de la (des) Catégorie(s) concernée(s), le Montant d’Annulation

sera exigible et payable par la Société à (aux) l’Associé(s) au prorata de leur participation dans ces Catégorie(s). Afin
d’éviter toute ambiguïté, la Société peut s’acquitter de ses obligations de paiement, en espèces, en nature ou par voie de
compensation.

5.7. Le Montant d’Annulation mentionné dans le paragraphe ci-dessus, pour être retenu, sera déterminé par le Gérant

Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance à sa raisonnable discrétion et dans le meilleur intérêts
social de la Société. Afin d’éviter toute ambiguïté, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
gérance peut choisir, à sa seule discrétion, d’inclure ou d’exclure, lorsqu’il déterminera le Montant d’Annulation, tout ou
partie des réserves librement distribuables attachées aux Parts sociales Préférentielles."

3. L’article 15 des Statuts de la Société est modifié et se lit comme suit:

“ 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui
sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’article 15.4 prévoit que l’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde

restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la
réserve ou le reporter.

15.3. L’article 15.4 prévoit que l’assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires

sur la base d’un état comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d’émission, mais
diminué des pertes reportées ou, lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date
de constitution de la Société mais, dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction
de la loi ou des présents statuts.

15.4. En cas de déclaration de dividendes, ledit dividende sera attribué et payé dans l’ordre suivant:
15.4.1. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires aura droit à un dividende égal à 0.60% de la valeur nominale

des Parts Sociales ordinaires;

15.4.2. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie A aura droit à un dividende égal à 0.10% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie A;

15.4.3. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie B aura droit à un dividende égal à 0.15% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie B;

15.4.4. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie C aura droit à un dividende égal à 0.20% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie C;

15.4.5. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie D aura droit à un dividende égal à 0.25% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie D;

15.4.6.Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie E aura droit à un dividende égal à 0.30% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie E;

15.4.7. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie F aura droit à un dividende égal à 0.35% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie F;

15.4.8. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie G aura droit à un dividende égal à 0.40% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie G;

15.4.9. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie H aura droit à un dividende égal à 0.45% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie H;

15.4.10. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie I aura droit à un dividende égal à 0.50% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie I

15.4.11. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie J aura droit à un dividende égal à 0.55% de la valeur nominale

des Parts Sociales de Catégorie J;

Le solde sera alloué au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles en vertu d’une décision prise par l’assemblée

générale des Associés."

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-

dessus, pouvoir et autorité ayant été conférés à tout gérant de la Société afin de procéder individuellement à l’enregis-
trement dans le registre des parts sociales de la Société de (i) l’augmentation du capital social de la Société mentionnée
ci-dessus et (ii) de veiller à effectuer toutes les formalités à cet égard.

37529

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept mille euros
(EUR 7.000).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête d de la

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, à la date indiquée en tête des pré-

sentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 20 janvier 2015. GAC/2015/635. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024902/436.
(150028596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Colour Hall S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2716 Luxembourg, 30, rue Batty Weber.

R.C.S. Luxembourg B 194.468.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le vingt-huit janvier.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Peintures ROBIN S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 31 rue de la Gare L-8705

Useldange, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
92537, ici représentée par ses deux administrateurs délégués Monsieur Pierre Welter, désigné sub 2.- et Monsieur Hubert
Clasen, désigné sub 3.-.

2.- Monsieur Pierre Welter, ingénieur, né le 12 mai 1956 à Luxembourg, demeurant au 30 rue Batty Weber, L-2716

Luxembourg.

3.- Monsieur Hubert Clasen, industriel, né le 22 juin 1951 à Luxembourg, demeurant à L-6689 Mertert, Scheidberg.
4.- Monsieur Michel Welter, économiste, né le 13 juin 1958 à Luxembourg, demeurant au 2 rue Belle-Vue, L-1227

Luxembourg, ici représenté par Monsieur Pierre Welter, précité, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le
31 décembre 2014 à Luxembourg.

5.- Madame Andrée Wolff vve. Eicher, retraitée, née le 28 septembre 1934 à Bertrange, demeurant au 15 rue Goethe,

L- 1637 Luxembourg.

6.- Monsieur Gérard Zoller, né le 25 janvier 1964 à Luxembourg, demeurant au 5 Op der Seërie, L - 8561 Schwebach.
La procuration signée ne varietur par les comparants es qualités qu'ils agissent et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, es qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

La Société prend la dénomination de “Colour Hall S. à r.l.“

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être transféré à l'intérieur de la même

commune par décision de la gérance.

Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée générale des associés.

37530

L

U X E M B O U R G

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur, la gestion et la location de tous immeubles ou parts

d'immeubles qu'elle pourra acquérir.

Elle peut à cet effet affecter ses immeubles en hypothèque, contracter des prêts et ouvertures de crédit ainsi que

mettre à disposition et consentir des sûretés et autres privilèges ou se porter caution réelle d'engagement.

La Société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconque de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à son objet social,
ou qui peuvent favoriser l'extension et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent trente mille euros (EUR 130.000,-), divisé en 1.300 (mille trois cents) parts

sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et les rémunérations.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts sont décidées à la majorité des associés re-

présentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2015.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

37531

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1.- Peintures ROBIN S.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts sociales

2.- Monsieur Pierre Welter, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts sociales

2.- Monsieur Hubert Clasen, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts sociales

4.- Monsieur Michel Welter, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts sociales

5.- Madame Andrée Wolff vve. Eicher, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 parts sociales

5.- Monsieur Gérard Zoller, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300 Parts sociales

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

trente mille euros (EUR 130.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents
euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Hubert Clasen, précité, industriel, né le 22 juin 1951 à Luxembourg, demeurant à L-6689 Mertert, Scheid-

berg.

- Monsieur Pierre Welter, précité, ingénieur, né le 12 mai 1956 à Luxembourg, demeurant au 30 rue Batty Weber,

L-2716 Luxembourg.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Ils peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.
2.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
30 rue Batty Weber, L-2716 Luxembourg.

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de

l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Pierre Welter, Hubert Clasen, Andrée Wolff-Eicher, Gérard Zoller, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 3 février 2015. 1LAC / 2015 / 3302. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015024835/130.
(150028259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Centrum Leto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 136.804.

L'an deux mille quatorze, le premier décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue

37532

L

U X E M B O U R G

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’actionnaire unique de Centrum Leto S.A. (l’Actionnaire),

une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136804 (la Société). La Société a été
constituée le 1 février 2008 en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2 mars 2008 numéro 801 à la page 38405. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés depuis la constitution de la Société le 19 mars 2010 conformément l’acte de Maître Francis
Kesseler notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 19 mai 2010
numéro 1043 à la page 50047.

La séance est ouverte sous la présidence de Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg (le Président).

Le Président désigne comme secrétaire (le Secrétaire) et l’Assemblée choisit comme scrutateur Solange Wolter, clerc

de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau.
L’Actionnaire présent ou représenté à l’Assemblée et le nombre d’actions détenues est indiqué sur une liste de pré-

sence, signée par l’Actionnaire et/ou le mandataire de l’Actionnaire représenté en vertu de la procuration émise par ce
dernier et les membres du Bureau.

Cette liste de présence ainsi que la procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de l’Actionnaire

représenté et par le Bureau, restera annexée au présent procès-verbal;

Le Bureau ayant été constitué, le Président déclare et l’Assemblée acte que:
I. Que toutes les actions, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent considérée comme

dûment constituée et apte à valablement délibérer des points suivants de l’ordre du jour reproduit ci-dessous;

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation des comptes pro forma de la Société pour la période allant du 1 

er

 janvier 2014 jusqu’à la date de

l’assemblée générale extraordinaire décidant de la dissolution de la Société et de sa mise en liquidation volontaire (les
Comptes Pro forma);

3. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
4. Nomination du liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
5. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
6. Décharge (quitus) accordé aux membres du conseil d’administration de la Société et au commissaire aux comptes

de la Société pour l’exercice de leurs mandats respectifs; et

7. Pouvoirs et autorités.
III. L’Actionnaire approuve les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, l’Actionnaire représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L’Actionnaire décide d'approuver les Comptes Pro forma dans la forme annexée aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’Actionnaire décide avec effet immédiat de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation

volontaire.

<i>Quatrième résolution

L’Actionnaire décide de nommer Fairland Property Limited, une société de droit des Iles Vierges britanniques ayant

son siège social au P.O Box 957 Offshore Incorporations Centre, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro 517295, en tant que Liquidateur.

<i>Cinquième résolution

L’Actionnaire décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et

seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

L’Actionnaire décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L’Actionnaire décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable l’Actionnaire

37533

L

U X E M B O U R G

unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs
personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité.

L’Actionnaire  décide  également  de  conférer  pouvoir  et  autorité  au  Liquidateur,  pour  le  compte  de  la  Société  en

liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L’Actionnaire décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature s’il y a lieux du boni de liquidation à l’Actionnaire, conformément à
l’article 148 de la Loi.

<i>Sixième résolution

L’Actionnaire décide d'accorder décharge (quitus) aux administrateurs de la Société et au commissaire aux comptes

de la Société pour l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

<i>Septième résolution

L’Actionnaire décide, en outre, d'accorder pouvoir et autorité à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., chacun

agissant individuellement, afin d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
concernant les résolutions figurant ci-dessus; et, généralement, d'effectuer toutes autres opérations qui pourraient être
nécessaires ou utiles pour l’accomplissement des résolutions figurant ci-dessus.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec le notaire, l’original du présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. Relation: LAC/2014/58783. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024831/86.
(150029050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Custom Sensors &amp; Technologies Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Carros Finance Luxembourg S.à r.l.).

Capital social: USD 4.871.151,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 182.766.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of November.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Custom Sensors &amp; Technologies Ltd, a limited liability company incorporated and existing under the laws of England

and Wales, registered under number 08967909, having its registered office at Technology Gateway, Cornwall Road, South
Wigston, Leicester, LE18 4XH, United Kingdom,

here represented by Solange Wolter-Schieres, notary clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Carros Finance Luxembourg S.à r.l., a société

à responsabilité limitée, having its registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 182 766, incorporated
pursuant to a deed of the notary Me Jean-Paul Meyers, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, dated 3
December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 309, on 4 February 2014
(hereinafter the “Company”). The articles of association have been amended pursuant to a deed of the notary Me Henri
Hellinckx, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 30 September 2014, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, has required the undersigned notary to

enact the following resolution:

37534

L

U X E M B O U R G

<i>Resolution

The Sole Shareholder resolves to change the corporate name of the Company to “Custom Sensors &amp; Technologies

Luxembourg S.à r.l.” and to subsequently amend article 4 of the articles of association of the Company, so that it shall
henceforth be enforced and read as follows:

“ Art. 4. Name. The Company will have the name “Custom Sensors &amp; Technologies Luxembourg S.à r.l.”.”

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Custom Sensors &amp; Technologies Ltd, une société constituée et existant selon les lois de l'Angleterre et du pays de

Galles, immatriculée sous le numéro 08967909, ayant son siège social au Technology Gateway, Cornwall Road, South
Wigston, Leicester, LE18 4XH, Royaume-Uni,

ici représenté par Solange Wolter-Schieres, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Carros Finance Luxembourg S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.766,
constituée selon acte reçu par Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg
en date du 3 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 309 en date du 4 février
2014 (ci-après la «Société»). Les statuts ont été modifiés selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 septembre 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter la

résolution suivante:

<i>Résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en «Custom Sensors &amp; Technologies Lu-

xembourg S.à r.l.» et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la Société, qui désormais sera appliqué et aura
la teneur suivante:

« Art. 4. Nom. La société doit avoir le nom «Custom Sensors &amp; Technologies Luxembourg S.à r.l.».»

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de la même partie comparante et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et

résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57475. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015024827/79.
(150028837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37535

L

U X E M B O U R G

Umweltschutztechnik Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2521 Luxembourg, 44, rue Demy Schlechter.

R.C.S. Luxembourg B 39.100.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.

Sind erschienen:

1) Herr Edouard BRIX, Staatsbeamter, wohnhaft in L-5681 Dalheim, 22, Luissgaass;
2) Herr Herbert MÜLLER, Rentner, wohnhaft in D-66701 Beckingen, 36, Hauptstrasse;
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, Folgendes zu beurkunden:
Die Komparenten sind alleinige Anteilhaber der Gesellschaft "Umweltschutztechnik Luxembourg S.à r.l." mit Sitz in

L-2521 Luxembourg, 44, rue Demy Schlechter, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B
39.100, gegründet gemäß notarieller Urkunde am 12. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 255 vom 12. Juni 1992.

Das  Gesellschaftskapital  beträgt  zwölftausenddreihundertvierundneunzig  komma  achtundsechzig  Euro  (12.394,68.-

EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile ohne Nennwert vollständig eingezahlt.

Alsdann erklären die Gesellschafter, folgende Beschlüsse zu dokumentieren:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung in Liquidation gesetzt.

<i>Zweiter Beschluss

Zum Liquidator wird ernannt Herr Edouard BRIX, Staatsbeamter, wohnhaft in L-5681 Dalheim, 22, Luissgaass.
Der Liquidator hat sämtliche Befugnisse, die Artikel 144 und folgende des Luxemburgischen Gesetzes über die Han-

delsgesellschaften  vom  10.  August  1915  für  einen  Abwickler  vorsehen  mit  der  Maßgabe,  dass  er  die  in  Artikel  145
angesprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Gesellschafter vornehmen kann.

Der Liquidator ist nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und kann sich auf die Bücher und Konten der Gesellschaft

berufen.

<i>Erklärung

Die erschienenen Parteien erklären hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirt-

schaftlich berechtigt sind und bestätigen dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. BRIX, H. MÜLLER, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 janvier 2015. Relation: GAC/2015/888. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Pierret.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, erteilt.

Remich, den 11. Februar 2015.

Référence de publication: 2015024668/42.
(150028046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Valfleurs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 64.388.

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre société avec effet

ce jour.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Eric HERREMANS.

Référence de publication: 2015025604/10.
(150028919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

37536


Document Outline

Carros Finance Luxembourg S.à r.l.

Centrum Leto S.A.

CETP III Participations S.à r.l.

Cloverleaf S.A.

Colour Hall S.à.r.l.

C&amp;O S.A.

Custom Sensors &amp; Technologies Luxembourg S.à r.l.

Darter Holdings I S.à r.l.

Digital Services XLVIII (GP) S.à.r.l.

Digital Services XXXV (GP) S.à.r.l.

E.I.R.E. S.A.

Noux S.A.

Pasta Mano S.à.r.l.

Regency United S.A. SPF

Rembrandt S.A.

Rosny S.A., SPF

Rozeo S.A.

Rubarc S.à r.l.

RWZ Agri S.à.r.l.

Sagittarius S.A. - SPF

Saint Aubin Développement S.A.

Sand Investments S.A.

Sanzo S.A.

Savings S.A., SPF

Saxa S.A.

Scherkamp &amp; Partner S.à r.l.

Schroder International Selection Fund

Sem Investment S.A.

Semtex S.A., SPF

Serenitas S.A.

Shandella SPF

Silver Wings S.A.

SIPE, Société de Participations Financières

SIPP SPF S.A.

Skype Communications

Skype Technologies S.à r.l.

SOF-10 Amazona Holdings Lux S.à r.l.

Sounion Investments S.A., société de gestion de patrimoine familial

SPC Lux IV, S.à r.l.

Spring Financial Investment S.A.

S.P.R.L. Brico-Sanichel

S.Promotion S.A.

Sun Luxco II S.à r.l.

Sun Luxco I S.à r.l.

Superior Luxco 3 S.à r.l.

Umweltschutztechnik Luxembourg

Valfleurs S.A.