logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 781

20 mars 2015

SOMMAIRE

Affinia Luxembourg Finance S.à r.l.  . . . . . .

37484

AIPP Asia Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

37481

Castle 45 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37478

Cazelia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37476

Cevet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37473

CT GP Acquisition S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .

37451

Digital Services XLIX (GP) S.à r.l.  . . . . . . .

37462

Digital Services XLVI (GP) S.à.r.l.  . . . . . . .

37451

MS Isoliertechnik S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

37484

Odyssey Financial Technologies S.A.  . . . . .

37488

Odyssey Financial Technologies S.A.  . . . . .

37447

Sagittarius S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37446

Sagittarius S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37446

Schroedinger Inv. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37445

Seaman S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37445

Servolux S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37444

Sesvenna Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

37445

Seven Vegas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37445

Sipor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37449

Sister Line S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37449

SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l.  . . .

37449

Sopaluxe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37487

SPF 2 Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37443

SS&C European Holdings  . . . . . . . . . . . . . . .

37443

SS&C Technologies Holdings Europe  . . . .

37442

STM Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37442

Storvik S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37446

Sumala S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37442

Superbond S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37450

Sustainable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37446

Svinvest S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37450

Tara Trade S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37447

Taurus S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37444

Taurus S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37443

Taurus S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37444

Tecon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37444

Temenos Software Luxembourg S.A.  . . . .

37488

Temenos Software Luxembourg S.A.  . . . .

37447

Thomé & Martin, Senc . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37448

Totham S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37448

Triangle Productions S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

37448

Trilux Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37448

T.S.D. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37450

Turret Lux Participation S.à r.l.  . . . . . . . . .

37447

UBS ETF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37447

Valfleurs S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37449

Vitruvian II Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

37449

37441

L

U X E M B O U R G

SS&C Technologies Holdings Europe, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 6.554.748,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.061.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date 11 février 2015 que:
- Monsieur David Reid a démissionné de son mandat de gérante de type A de la Société avec effet au 11 février 2015.
- Il est décidé de nommer Monsieur Paul Igoe, né le 30 avril 1962, à New York, Etats-Unis d'Amérique, résidant

professionnellement au 80, Lamberton Road, Windsor, CT 06095, Etats-Unis d'Amérique, comme gérant de type A de
la Société avec effet au 11 février 2015 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Patrick Pedonti, comme gérant de type A de la Société;
- Paul Igoe, comme gérant de type A de la Société;
- Christophe Maillard, comme gérant de type B de la Société; et
- Marjorie Allo, comme gérante de type B de la Société.

Le 12 février 2015.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025526/21.
(150028873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

STM Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 193.604.

<i>Extrait analytique

Il est porté à la connaissance du public que Sofiya Machulskaya, née à Moscou (Russie) le 10 novembre 1992, ayant

son adresse au 1, Hyde Park Gardens, Flat 3, Londres W2 2LT, Royaume-Uni, a été nominée comme gérant A le 10
février 2015 pour un temps sans limitation de durée et que Sean Patrick Murray, a été redésigné comme gérant B le 10
février 2015.

En conséquence, le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Mme Sofiya Machulskaya (gérant A);
- M. Sean Patrick Murray (gérant B); et
- M. Wilhelmus Casparus Petrus Jongman (gérant B);
Il convient de noter qu'un gérant A agissant conjointement avec un gérant B représentent et engagent la société et

disposent du pouvoir de signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

<i>Pour la société
Van Campen Liem Luxembourg

Référence de publication: 2015025527/23.
(150028346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sumala S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 49.364.

I hereby resign as director of your company with effect as from 13/04/2012.
Par la présente, je vous remets ma démission comme administrateur de votre société avec effet au 13/04/2012.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Marc KOUENE.

Référence de publication: 2015025530/10.
(150028490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37442

L

U X E M B O U R G

SS&amp;C European Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.734.140,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 173.925.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date 11 février 2015 que:
- Monsieur David Reid a démissionné de son mandat de gérant de type A de la Société avec effet au 11 février 2015.
- Il est décidé de nommer Monsieur Paul Igoe, né le 30 avril 1962, à New York, Etats-Unis d'Amérique, résidant

professionnellement au 80, Lamberton Road, Windsor, CT 06095, Etats-Unis d'Amérique, comme gérant de type A de
la Société avec effet au 11 février 2015 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Patrick Pedonti, comme gérant de type A de la Société;
- Paul Igoe, comme gérant de type A de la Société;
- Christophe Maillard, comme gérant de type B de la Société; et
- Marjorie Allo, comme gérante de type B de la Société.

Le 12 février 2015.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025525/21.
(150028872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

SPF 2 Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.329.068,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.720.

Il résulte des résolutions circulaires de l'associé unique de la Société en date du 19 décembre 2014 que les décisions

suivantes ont été prises:

- de prendre note de la démission de Monsieur Sven Rein aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 31

décembre 2014.

- de nommer aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 1 

er

 janvier 2015, et ceci pour une durée indéterminée:

* Madame Elena Toshkova, née le 23 décembre 1976 à Razlog (Bulgarie), demeurant professionnellement au 44, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

* Monsieur Abed Khaldi, né le 29 août 1977 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 44, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SPF2 Holdco S. à r.l.
BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. en abrégé «BNPP REIM Lux S.A.»

Référence de publication: 2015025523/22.
(150028878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Taurus S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 178.278.

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon mandat d'administrateur de catégorie A de

votre société avec effet immédiat à la date du 11 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2015.

Mr. Thierry Stas.

Référence de publication: 2015025550/11.
(150028656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37443

L

U X E M B O U R G

Taurus S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 178.278.

Par la présente, nous vous informons de notre décision de démissionner de notre mandat d'administrateur de catégorie

A de votre société avec effet immédiat à la date du 11 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2015.

Maprima Luxembourg S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025549/13.
(150028656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Taurus S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 178.278.

Par la présente, nous vous informons de notre décision de démissionner de notre mandat de commissaire aux comptes

de votre société avec effet immédiat, à compter du 11 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2015.

CAC Service S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025551/13.
(150028656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Tecon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 46.889.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 10 février 2015:

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 10 février 2015.

<i>Pour TECON S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025556/13.
(150028689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Servolux S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 181.358.

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 11/02/2015:
Il est décidé nommer la société à responsabilité limité UNCOS, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,

immatriculée au RCSL sous le numéro B141298, en tant que dépositaire légal des actions au porteur de la société SER-
VOLUX S.A., SPF (B181358) et ceci en vertu de la loi du 28 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/02/2015.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015025493/15.
(150028367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37444

L

U X E M B O U R G

Sesvenna Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 181.935.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 janvier 2015

Il résulte de ce Conseil d'administration:
Conformément à l'article 42 des Lois Coordonnées sur les Sociétés commerciales du 10 août 1915 tel que modifié

par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration décide,
à l'unanimité, de nommer comme dépositaire des actions au porteur, la société «Fiduciaire Internationale SA», ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
34813 et représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Stéphan MOREAUX.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015025494/15.
(150029097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Seaman S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 136.651.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 février 2015 que la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015025487/13.
(150028325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Schroedinger Inv. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 63.539.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 février 2015 que la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015025485/13.
(150028262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Seven Vegas S.A., Société Anonyme.

Siège de direction effectif: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 135.762.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 12 février 2015 que la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015025495/13.
(150029078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37445

L

U X E M B O U R G

Sagittarius S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue de Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 178.377.

Par la présente, nous vous informons de notre décision de démissionner de notre mandat de commissaire aux comptes

de votre société avec effet immédiat, à compter du 11 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2015.

CAC Services S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025474/13.
(150028386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sagittarius S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue de Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 178.377.

Par la présente, nous vous informons de notre décision de démissionner de notre mandat d'administrateur de catégorie

A de votre société avec effet immédiat à la date du 11 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2015.

Maprima Luxembourg S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025472/13.
(150028386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sustainable, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 154.053.

<i>Berichtigung zu der Hinterlegung L140006232

Bei dem Geschäftsführer Herrn Claus Bering, berufliche ansässig in der 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg,

ist die Handlungsbefugnis richtig zu stellen. Er ist nicht nur Manager, sondern Manager der Klasse B. Dies gilt ab dem
Bestellungsdatum, dem 7. November 2013.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Februar 2015.

<i>Ein Beauftragter

Référence de publication: 2015025468/14.
(150028193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Storvik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 106.411.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 11/02/2015

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11/02/2015.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015025461/14.
(150028882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37446

L

U X E M B O U R G

Turret Lux Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 39.655.150,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 111.373.

EXTRAIT

En date du 10 Août 2007, le conseil d'administration de Luxgate, S.à. r.l. un des associés de la Société, a changé son

adresse du 14A , rue des Bains, L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet immédiate.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/02/2015.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015025546/14.
(150028992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Tara Trade S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 78.632.

Nous soussignés, FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA SARL (R.C.S. Luxembourg B-85.775), dont le siège social se

situe au 4, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, représentée par son gérant Monsieur LA MENDOLA Vincent,
dénonçons avec effet immédiat la domiciliation du siège social de la société TARA TRADE SARL (R.C.S. Luxembourg
B-78.632) sise 4, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Fiduciaire Vincent LA MENDOLA S.àr.l

Référence de publication: 2015025548/12.
(150028713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Temenos Software Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Odyssey Financial Technologies S.A.).

Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 51.921.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025557/10.
(150028535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

UBS ETF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 83.626.

Il résulte que M. Clemens Reuter a changé d'adresse du 30 Talacker CH-8098 Zurich au Stockerstrasse 64 CH-8002

Zurich, avec effet immédiat

Il résulte que M. Andreas Haberzeth a changé d'adresse du 3-5, Gessnerallee, CH-8098 Zurich au Stockerstrasse 64

CH-8002 Zurich, avec effet immédiat.

Il résulte que M. Frank Muesel a changé d'adresse du 48-50, Aeschenvorstadt, CH-4051 Basel au Stockerstrasse 64

CH-8002 Zurich, avec effet immédiat.

Il résulte qu'en date du 20 Octobre 2014 PricewaterhouseCoopers Société coopérative a changé d'adresse du 400,

Route d'Esch, L-1014 Luxembourg au 2 rue Gerhard Mercator L-1014 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 Février 2015.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015025585/18.
(150028191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37447

L

U X E M B O U R G

Trilux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2499 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.843.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 10 février 2015:

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 10 février 2015.

<i>Pour TRILUX INVEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025576/13.
(150028752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Triangle Productions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 43.746.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société Triangle

Productions SA la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140
Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025575/12.
(150028936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Thomé &amp; Martin, Senc, Société en nom collectif.

Siège social: L-6370 Haller, 6, Beim Basseng.

R.C.S. Luxembourg B 31.560.

EXTRAIT

<i>Première résolution

Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital social

fixé à 2.500 EUR, représenté par 100 parts sociales se répartit comme suit:

Monsieur Jean Thomé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 parts

Madame Marie-Jeanne Martin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 parts

Total: cent parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2015.

Thomé &amp; Martin senc

Référence de publication: 2015025564/17.
(150028929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Totham S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 37.022.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015025572/12.
(150028147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37448

L

U X E M B O U R G

SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 187.996.

Les statuts coordonnés au 23 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025515/9.
(150028964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sister Line S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 141.053.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 09 février 2015.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2015025508/11.
(150028466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sipor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 37.499.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 9 février 2015 que:
- les titres au porteur de la société sont déposés auprès de Roosevelt Services S.A., domiciliée 15, boulevard Roosevelt,

L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 février 2015.

<i>Pour la société SIPOR S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015025506/14.
(150028458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Valfleurs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 64.388.

Par la présente, nous vous informons de notre décision de démissionner en tant que délégué à la gestion journalière

de votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

BPH FINANCE S.A.

Référence de publication: 2015025600/11.
(150028563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Vitruvian II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 454.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 184.359.

Les statuts coordonnés au 28 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025596/9.
(150028990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37449

L

U X E M B O U R G

Superbond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 66.182.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date

du 10 février 2015 que:

- Les administrateurs Monsieur Roberto Carbonetti et Monsieur Giovanni Patri demeurant professionnellement au

30, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg ont démissionné de ses fonctions à partir de la date 15 janvier 2014.

- 2 administrateurs ont été nommés en son remplacement, à savoir: Monsieur Cristian Cordella, demeurant profes-

sionnellement au 8 Avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg et Monsieur Emanuele Chichi demeurant au 111 Avenue
de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2017.
- Le siège de la société a été transféré du 30, Boulevard Royal L-2249 Luxembourg au 3 rue Belle-Vue L-1227 Lu-

xembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 12 février 15.

Référence de publication: 2015025535/20.
(150029238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

T.S.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 76, rue d'Asselborn.

R.C.S. Luxembourg B 61.166.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 février 2015

La résolution suivante a été adoptée à l'unanimité des voix:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet immédiat, la société a responsabilité limitée de droit lu-

xembourgeois, FIDUNORD S.à r.l., avec siège social à L - 9991 WEISWAMPACH, 61, Gruuss-Strooss, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous le numéro B 91.906, en qualité de Dépositaire des actions au porteur
de la société, conformément aux articles 2 et suivants de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions
et parts au porteur et à la tenue du registre des actions au porteur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 12 février 2015.

<i>Pour T.S.D. S.A.
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2015025538/19.
(150028668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Svinvest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 187.324.

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 11/02/2015:
Il est décidé nommer la société à responsabilité limité UNCOS, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,

immatriculée au RCSL sous le numéro B141298, en tant que dépositaire légal des actions au porteur de la société SVIN-
VEST S.A., SPF (B187324) et ceci en vertu de la loi du 28 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/02/2015.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015025537/15.
(150028366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37450

L

U X E M B O U R G

CT GP Acquisition S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 179.013.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société CT GP Acquisition S.C.A. tenue en

date du 19 Décembre 2014 que:

1. La liquidation de la Société a été clôturée;
2. Les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans au siège social de la

société au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg;

3. Un pouvoir spécial a été accordé à VP Services, après l'expiration de son mandat de liquidateur, afin de payer

n'importe  quelle  dette  restante,  signer  et  envoyer  les  déclarations  de  revenus  qui  doivent  être  déposées  auprès  de
l'Administration Fiscale et de distribuer aux actionnaires tout solde restant sur le compte bancaire de la société après
réception des derniers bulletins d'imposition à émettre par l' Administration Fiscale du Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

VP Services

Référence de publication: 2015024900/21.
(150028825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Digital Services XLVI (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.459.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XLVI S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law,

having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 23 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XLVI (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

37451

L

U X E M B O U R G

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

37452

L

U X E M B O U R G

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining  managers  until  the  next  meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

37453

L

U X E M B O U R G

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20 Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

37454

L

U X E M B O U R G

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XLVI S.àr.l., afore-

mentioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

37455

L

U X E M B O U R G

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XLVI S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 23.

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XLVI (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

37456

L

U X E M B O U R G

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

37457

L

U X E M B O U R G

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

37458

L

U X E M B O U R G

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)

37459

L

U X E M B O U R G

oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur

37460

L

U X E M B O U R G

Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XLVI S.àr.l. vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.

37461

L

U X E M B O U R G

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2452. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015024916/589.
(150028696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Digital Services XLIX (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.448.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XLIX S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law,

having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 23 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XLIX (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

37462

L

U X E M B O U R G

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending

37463

L

U X E M B O U R G

on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager  by  the  remaining  managers  until  the  next  meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

37464

L

U X E M B O U R G

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

37465

L

U X E M B O U R G

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XLIX S.àr.l., afo-

rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

37466

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XLIX S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 23.

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XLIX (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

37467

L

U X E M B O U R G

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

37468

L

U X E M B O U R G

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des  Abschnitts  XII  des  Gesetzes  von  1915  und  dieser  Satzung  aus.  In  diesem  Fall  ist  jeder  Bezug  auf  die
„Gesellschafterversammlung«in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2  Falls  die  Gesellschaft  von  einem  einzelnen  Geschäftsführer  geleitet  wird  und  soweit  der  Begriff  „alleiniger

Geschäftsführer«nicht  ausdrücklich  verwendet  wird,  ist  jeder  Verweis  in  dieser  Satzung  auf  den  „Rat  der
Geschäftsführer«als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer«auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-

37469

L

U X E M B O U R G

sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer

37470

L

U X E M B O U R G

der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden.

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

37471

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XLIX S.àr.l. vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

37472

L

U X E M B O U R G

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2455. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015024913/590.
(150028363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Cevet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Helmsingen, 1-3, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 25.848.

Im Jahre zweitausendfünfzehn,
am neunundzwanzigsten Tag des Monats Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg),

fand die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft „CEVET S.A.“, (die „Gesellschaft“), eine Aktienge-

sellschaft, die dem Luxemburger Recht unterliegt, mit Sitz in 5A rue des Dahlias, L-1411 Luxemburg, eingetragen im
Handels-und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 25 848, statt.

Die Gesellschaft wurde früher gegründet unter der Bezeichnung „RESECOM S.A.“ gemäß einer notariellen Urkunde

aufgenommen am 03-April 1987, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“),
am 22. Juli 1987 unter der Nummer 205.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert, gemäß einer außerordentlichen Generalversammlung der Ak-

tionäre, welche unter Privatschrift am 31. Dezember 2001 abgehalten wurde und welche, am 08. Januar 2003, unter der
Nummer 18 und Seite 838, im Mémorial veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Brendan D. KLAPP, Angestellter, berufsansässig in

Beles (Großherzogtum Luxemburg).

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Frau Nadia WEYRICH, Angestellte, berufsansässig in Beles (Großher-

zogtum Luxemburg).

Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Jean-Jacques SCHERER, Steuerberater, berufsansäs-

sig in Helmsingen (Großherzogtum Luxemburg).

Der Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:
a) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien sowie der anwesenden und vertretenen Aktionären bei-

gegeben. Diese Liste und auch die Vollmachten werden, nachdem sie unterschrieben wurden, mit der gegenwärtigen
Urkunde einregistriert.

b) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die eintausend (1'000) Aktien ohne Nennwert, die das gesamte Ak-

tienkapital in Höhe von einunddreißigtausend Euro (31'000.- EUR) darstellen, bei dieser außerordentlichen Generalver-
sammlung vertreten sind, so dass gegenwärtige Versammlung rechtsmäßig zusammengesetzt ist und über alle Punkte der
nachstehenden Tagesordnung beschließen kann.

c) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

<i>Tagesordnung

1. Sofortige Sitzverlegung der Gesellschaft von 5A, rue des Dahlias, L-1411 Luxemburg, nach 1-3, Millewee, L-7257

Helmsingen.

2. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache, infolge der vorerwähnten Sitzverlegung,

ohne  jedoch  weder  den  Gesellschaftszeck,  noch  die  Rechtsform  der  Gesellschaft  abzuändern,  welche  weiterhin  der
Rechtsform einer Aktiengesellschaft unterliegt und insbesondere um sie an das neue Gesetz vom 25. August 2006, welches
das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 abgeändert hat, anzupassen.

Nach Erläuterung und Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die sofortige Sitzverlegung der Gesellschaft von 5A, rue des Dahlias, L-1411 Lu-

xemburg, nach 1-3, Millewee, L-7257 Helmsingen.

37473

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache,

infolge der vorerwähnten Sitzverlegung, ohne jedoch weder den Gesellschaftszeck, noch die Rechtsform der Gesellschaft
abzuändern, welche weiterhin der Rechtsform einer Aktiengesellschaft unterliegt und insbesondere um sie an das neue
Gesetz vom 25. August 2006, welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 abgeändert hat, anzupassen und
verabschiedet sie mit der folgenden neuen Fassung:

NEUE FASSUNG DER SATZUNG DER „CEVET S.A.“

„Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) [die „Gesellschaft“] unter der Bezeichnung

„CEVET S.A.“.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Walferdingen, Großherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum  verlegt
werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4.  Zweck  der  Gesellschaft  ist  die  Unternehmungsberatung  und  -  bewertung,  die  Wirschaftsprüfung  und  die

Steuerberatung.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen im In- und Ausland erwerben an Firmen, welche die Zwecke dieser Firma fördern

und entwickeln können. Sie Kann außerdem Liegenschaften und Grundstücke erwerben und verkaufen im Sinne der
Gewerbstätigkeit der Firma, sowie alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobiliarer Natur
tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31'000.- EUR)

eingeteilt in eintausend (1‘000) Aktien ohne Nennwert.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Inhaberaktien müssen, im Einklang mit Artikel 42 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften,

sowie die späteren Abänderungen, hinterlegt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Si können

von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwir-

klichung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

37474

L

U X E M B O U R G

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitest

gehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind
oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail
erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder
E-mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen

Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-
lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsan-

gelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie

die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertra-
gung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen
Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen
Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflich-
tet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-

chreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Freitag des Monats Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen.  Sie  muß  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  zehn  Prozent  (10%)  des  Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des gezeichneten Kapitals vertreten, können

die Aufnahme eines oder mehrerer zusätzlicher Punkte in die Tagesordnung jeder Hauptversammlung verlangen. Eine
solche Anfrage ist spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung per eingeschriebenen Brief an den Gesellschaftssitz
der Gesellschaft zu richten.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;

für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,

37475

L

U X E M B O U R G

welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden

Geschäftsjahres zu schreiten.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.“

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Helmsingen, am neuen Gesellschaftssitz der Gesellschaft, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem amtierenden Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. D. KLAPP, N. WEYRICH, J.J. SCHERER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 3. Februar 2015. Relation: EAC/2015/2646. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-

EUR).

<i>Der Einnehmer

 (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2015024873/189.
(150029276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Cazelia, Société Anonyme.

Enseigne commerciale: Immo Cazelia.

Siège social: L-7526 Mersch, 5, allée John W. Leonard.

R.C.S. Luxembourg B 147.139.

L'an deux mille quinze, le seize janvier.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "Cazelia", une société anonyme, établie et ayant son

siège à L-7526 Mersch, 5, Allée John W. Leonard, constituée suivant acte du notaire Marc LECUIT de Mersch, en date
du 26 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1505 du 4 août 2009, non modifiée
depuis, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 147.139,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Alain MEURISSE, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri,

qui désigne comme secrétaire Jack Michael SWORD, administrateur de sociétés, demeurant à L-7594 Beringen, 17,

rue des Noyers.

L'assemblée choisit comme scrutateur Jack Michael SWORD, administrateur de sociétés, demeurant à L-7594 Berin-

gen, 17, rue des Noyers.

37476

L

U X E M B O U R G

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Création d'une enseigne commerciale et modification subséquente de l’article 1 des statuts;
2.- Changement de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l’enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de créer une enseigne commercial et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts, de sorte

qu'il aura désormais la teneur suivante:

''  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Cazelia. La société exploitera la marque et

enseigne commerciale suivante:

- Immo Cazelia''

suit la version anglaise de l’article 1 

er

'' Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of Cazelia. The company exploits the following

brand and trading name:

- Immo Cazelia''

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article 4 aura dorénavant la teneur

suivante:

Art. 4. La société a pour objet principal le commerce de tous produits et services en relation avec l’immobilier.
Elle a pour objets secondaires:
L’exploitation de toutes activités découlant des autorisations gouvernementales suivantes:
Agent immobilier
Promoteur immobilier
Administrateur de biens
Syndic de copropriété
Activités et services commerciaux
Gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue.
Elle peut s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, et notamment par les créations de filiales et/ou succursales.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favo-
risent.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également

se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l’étranger."

37477

L

U X E M B O U R G

suit la version anglaise de l’article 4

Art. 4. The company's main purpose is the trade of all products and services related to real estate.
Its secondary purposes are:
The operation of any activities arising from the following government authorizations:
Real Estate Agent
Real Estate Promoter
Property Administrator
Co-ownership property agent
Activities and commercial services
Management of an institution for ongoing professional training
It may get involved with any company or business related to its purpose or that facilitates its achievement in any form

and by any means whatsoever, and in particular by the creation of subsidiaries and / or branches.

The company also provides all transactions relating directly or indirectly to the acquisition of investments in any form

whatsoever, in any Luxembourg or foreign company, as well as the administration, management, control and the devel-
opment of those investments.

It may use its funds for the creation, management, development and liquidation of a portfolio consisting of securities

and patents of any origin and other rights attached to these patents or able to complete them, participate in their creation,
in the development and control of any company, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or purchase
option and any other way, all securities and patents and others attached to these patents or able to complete them,
achieve them by way of sale, transfer, exchange or otherwise enhance such securities and patents. It may borrow and
grant assistance, loans, advances or guarantees to companies in which it has an interest.

It will take all measures to safeguard its rights and will make any commercial, industrial and financial transactions, both

moveable or immoveable property, which are related to its purpose or that contribute to it.

It may borrow, mortgage or pledge its assets to other business firms or companies. It may also give guarantees for

other companies or third parties.

The company will operate in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.''
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: MEURISSE, SWORD, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 janvier 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 196. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024829/111.
(150028037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Castle 45 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 184.337.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of December,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Castle 45 S.à r.l., a Luxembourg private

limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée),  with  registered  office  at  67,  boulevard  Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 184337 (the Company).

The Company was incorporated on January 16, 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 872, page 41810, dated April 4, 2014. The articles of association
of the Company have not been amended since its incorporation.

37478

L

U X E M B O U R G

There appeared:

BSREP International I(A) Holdings L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, having

its registered office at Ugland House, Grand Cayman, KYI-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exemp-
ted Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC73329 (the Sole Shareholder);

hereby represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal; and

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. The twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares of the Company and the one thousand (1,000) mandatory

redeemable preferred fixed and variable dividend shares of the Company, with a nominal value of one euro (EUR 1) each,
representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at the Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Dissolution and liquidation of the Company;
3. Appointment of I.L.L. Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limi-

tée), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153141, with registered
office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and having a share capital of EUR 12,500.-, as liquidator of the
Company and determination of the powers of the liquidator and liquidation procedure;

4. Discharge to be granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
5. Miscellaneous.
Now, therefore, the Sole Shareholder, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the

Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting decides to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation.

<i>Third resolution

The Meeting decides to appoint I.L.L. Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à res-

ponsabilité limitée), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153141,
with  registered  office  at  6,  rue  Eugène  Ruppert,  L-2453  Luxembourg  and  having  a  share  capital  of  EUR  12,500.-,  as
liquidator of the Company and determination of the powers of the liquidator and liquidation procedure;, as liquidator of
the Company (the Liquidator).

<i>Fourth resolution

The Meeting decides that the Liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities, that

the Liquidator will have the broadest powers pursuant to the Luxembourg law on commercial companies of August 10,
1915, as amended (the Law) to perform its duties (including without limitation to dispose of the Company’s assets) and
that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

For such a purpose, the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those

referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders. The
Liquidator may, under its sole responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks, to one or several
persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni

de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

<i>Fifth resolution

The Meeting decides to grant full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandates.
There being no further business, the Meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred Euros
(1,500.- EUR).

37479

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, such proxyholder signed together with

the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre,
Pardevant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Castle 45 S.à r.l., une société à responsa-

bilité  limitée  de  droit  luxembourgeois,  ayant  son  siège  social  au  67,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  L-1331
Luxembourg  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B  184337  (la
Société).

La Société a été constituée le 16 janvier 2014 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 872, page 41810, daté du 4 avril 2014. Les statuts de la Société n’ont été modifiés
depuis la constitution.

A comparu:

BSREP International I(A) Holdings L.P., une limited partnership, constituée selon les lois des Iles Caïmanes, ayant son

siège social à Ugland House, Grand Cayman, KYI-1104, les Iles Caïmanes, immatriculée auprès du Registrar of Exempted
Limited Partnerships of the Cayman Islands sous le numéro MC73329 (l’Associé Unique),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé.

Ladite  procuration,  après  avoir  été  signées  "ne  varietur"  par  le  mandataire  de  la  partie  comparante  et  le  notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique a prié le notaire instrumentant d’acter que:
I. les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires de la Société et les mille (1.000) parts sociales privilégiées

obligatoirement rachetables à dividende fixe et variable de la Société, ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP
1) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui
est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l’ordre du jour reproduits ci-après;

II. L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution et liquidation de la Société;
3. Nomination de I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 153141, ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg et ayant un capital social d’EUR 12,500.-, en qualité de liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs du
liquidateur et de la procédure de liquidation;

4. Décharge à accorder aux gérants de la Société pour l’exercice de leur mandat; et
5. Divers.
Sur ce, l’Associé Unique, représenté par son mandataire, a prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l’Assemblée renonce aux formalités de convocation, l’As-

socié Unique représenté à l’Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de nommer I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, immatri-

culée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 153141, ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg et ayant un capital social d’EUR 12,500.-, en qualité de liquidateur de la Société (le Liquidateur).

37480

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide que le Liquidateur dressera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le Liqui-

dateur sera investi des pouvoirs les plus étendus en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi), afin
d’accomplir ses fonctions (y inclus le droit de disposer sans limite des actifs de la Société) et que la Société sera engagée
vis-à-vis des tiers par la signature unique du Liquidateur.

A ces fins, le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et accomplir toutes opérations, y inclus ceux prévus par

l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des associés. Le Liquidateur pourra, sous sa
seule  responsabilité,  déléguer  ses  pouvoirs  pour  des  opérations  ou  devoirs  spécifiques  et  définis  à  une  ou  plusieurs
personnes ou entités.

Le Liquidateur est autorisé, à sa seule discrétion, de payer des avances sur les bonis de liquidation à l’Associé Unique,

et ce conformément à l’article 148 de la Loi.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’accorder pleine décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leurs mandats.
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre la version anglaise et la
version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire

instrumentant, le présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63755. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024828/153.
(150028145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

AIPP Asia Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 53.100.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 133.607.

In the year two thousand and fifteen,
on the twenty-third day of the month of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

1) “Aberdeen Management Services S.A.”, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered

office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 119.541, acting in its capacity as management company of “AIPP
Asia Select”, a fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé governed by the law of 13 February 2007
on specialised investment funds, as amended; and

2) “Aberdeen Management Services S.A.”, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered

office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 119.541, acting in its capacity as management company of “AIPP
Asia”, a fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé governed by the law of 13 February 2007 on
specialised investment funds, as amended;

(Collectively hereafter referred to as, the “Shareholders”),
both Shareholders,

37481

L

U X E M B O U R G

here represented by Mrs Martha ALEXAKI, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of two (2) proxies under private seal given to her in Luxembourg, on 19 January 2015.
Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholder are the two (2) sole share-

holders of “AIPP Asia Soparfi S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a
share capital of fifty-three million one hundred thousand Japanese Yen (53'100'000.- JPY), with its current registered office
at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed enacted
on 08 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 2889
of 12 December 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 133
607 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a
notarial deed enacted on 28 September 2012, published in the Mémorial on 26 October 2012, under number 2649 and
page 127125.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To transfer its registered office from the municipality of Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg to Luxembourg

City;

2 To amend paragraph 2.1 of article 2 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the transfer

of the registered office;

3 To determine the new address of the registered office;
4 Miscellaneous;
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to transfer, with immediate effect, the registered office of the Company from the munici-

pality of Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg to Luxembourg City.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to amend paragraph 2.1 of article 2 of the articles of incorporation of the Company in

order to reflect the above resolution. Said paragraph will read henceforth as follows:

Art. 2. Registered office.
“2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.”

<i>Third resolution

The Shareholders resolved to fix the new registered office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such proxy holder signed together with Us the undersigned notary,
this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze,
le vingt-trois janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

1) «Aberdeen Management Services S.A.», une société régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2b,

rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119 541, agissant en sa capacité de société de gestion de «AIPP Asia
Select» un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé régi par la loi du 13 février 2007 sur les fonds
d'investissement spécialisés, telle que modifiée; et

2) «Aberdeen Management Services S.A.», une société régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2b,

rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce

37482

L

U X E M B O U R G

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119 541, agissant en sa capacité de société de gestion de «AIPP Asia»
un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé régi par la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'in-
vestissement spécialisés, telle que modifiée;

(Collectivement désignées ci-après: «les Associés»),
les deux Associés,
représentés aux fins des présentes par Madame Martha ALEXAKI, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
aux termes de deux (2) procurations sous seing privé lui données à Luxembourg, le 19 janvier 2015.
Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire des parties comparantes et le notaire

soussignée, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont les deux (2) seuls et uniques associés

de «AIPP Asia Soparfi S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social
de cinquante-trois millions cent mille yen japonais (53'100'000.- JPY), dont le siège social actuel est au 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 08 novembre 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») sous le numéro 2889 du 12 décembre 2007
et immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 133 607 (la «Société»). Les
statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu le 28 septembre 2012, lequel acte fut
publié au Mémorial, le 26 octobre 2012, sous le numéro 2649 et page 127125.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des déci-

sions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Transfert du siège social de la Société de la commune de Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg-

Ville;

2 Modification de l'alinéa 2.1 de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le transfert du siège social;
3 Déterminer la nouvelle adresse du siège social;
4 Divers;
ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la commune de Hesperange, Grand-Duché

de Luxembourg à Luxembourg-Ville.

<i>Deuxième résolution

Les Associées ont décidé de modifier l'alinéa 2.1 de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter la précédente

résolution. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 2. Siège social.
«2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

Les Associés ont décidé d'établir le nouveau siège social au 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties

comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des
mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes connue du notaire

soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. ALEXAKI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 janvier 2015. Relation: EAC/2015/2113. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015024744/123.
(150028266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37483

L

U X E M B O U R G

MS Isoliertechnik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.

R.C.S. Luxembourg B 170.969.

<i>Beschluss des Alleinigen Gesellschafters vom 12. November 2014

Am Mittwoch, den 12. November um 11.00 Uhr, hat der alleinige Gesellschafter der MS ISOLIERTECHNIK S.à.r.l.

folgende Bestimmungen getroffen:

- Herr Kai SCHMIEDER, geboren am 07/12/1983 in Saarburg, wohnhaft in D-54314 Zerf, Bahnhofstrasse 70,
wird von seinem Amt als technischer Geschäftsführer abberufen.
- Herr Hans Jürgen MACHMÜLLER, Wärme-Kälte und Schallschutzisolier, geboren am 19/02/1963 in Bornheim (D),

wohnhaft in D-53332 Bornheim, Am Goldacker 3

wird auf unbestimmte Zeit zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.
Dementsprechend besteht die Geschäftsführung nun aus zwei Geschäftsführern d.h.:
- Herr Hans Jürgen MACHMÜLLER, technischer Geschäftsführer
- Herr Murat SARISOY, administrativer Geschäftsführer
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift von beiden Geschäftsführern verpflichtet.

Luxemburg, den 12. November 2014.

Murat SARISOY.

Référence de publication: 2015025291/21.
(150028320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Affinia Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 140.609.000,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 161.119.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth of December.
Before us Maitre Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Wix-Filtron Sp.Zo.o., a private company with limited liability incorporated under the laws of Poland, having its regis-

tered office at Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyñ, Poland, registered with the entrepreneurs' register under number KRS
0000049910 by the District Court Poznañ-Nowe Miasto i Wilda in Poznañ, IX Economy Department of the National
Court Register,

here represented by Mrs Alexandra Fuentes, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given on the 12 

th

 December 2014.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. Wix-Filtron Sp.Zo.o., prequalified, declares that it is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Affinia Lu-

xembourg Finance S.a r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161119, incorporated by a notarial deed
on the twenty-third day of May, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1828,
on the 10 

th

 day of August, 2011. The articles of incorporation were amended for the last time by a notarial deed on the

tenth day of September, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3173, on the
30 

th

 October, 2014.

<i>Agenda

1. To increase the Company's share capital by an amount of sixteen million Dollars of the United States of America

(USD 16,000,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred twenty four million six hundred and nine
thousand Dollars of the United States of America (USD 124,609,000.-), divided into one hundred twenty four million six
hundred and nine thousand (124,609,000) shares with a nominal value of one Dollar of the United States of America
(USD 1.-) each to an amount of one hundred forty million six hundred and nine thousand Dollars of the United States of
America (USD 140,609,000.-), divided into one hundred forty million six hundred and nine thousand (140,609,000) shares
with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, by the issue of sixteen million (16,000,000)
new shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each having the same rights and
privileges as those attached to the existing shares.

37484

L

U X E M B O U R G

2. To accept the subscription of sixteen million (16,000,000) shares with a nominal value of one Dollar of the United

States of America (USD 1.-) each, by Wix-Filtron Sp.Z.o.o., the full payment of these shares by means of a contribution
in cash of sixteen million Dollars of the United States of America (USD 16,000,000.-).

3. To amend article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Incorporation.
4. Miscellaneous.
The appearing party, duly represented, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of sixteen million Dollars of the

United States of America (USD 16,000,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred twenty four million
six hundred and nine thousand Dollars of the United States of America (USD 124,609,000.-), divided into one hundred
twenty four million six hundred and nine thousand (124,609,000) shares with a nominal value of one Dollar of the United
States of America (USD 1.-) each to an amount of one hundred forty million six hundred and nine thousand Dollars of
the United States of America (USD 140,609,000.-), divided into one hundred forty million six hundred and nine thousand
(140,609,000) shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, by the issue of sixteen
million (16,000,000) new shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each having the
same rights and privileges as those attached to the existing shares and to accept the following subscription:

<i>Subscription/Payment

Thereupon intervenes Mrs Alexandra Fuentes, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney appointed

by Wix-Filtron Sp.Zo.o, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy.

The person appearing declared to subscribe to sixteen million (16,000,000) shares, and to make payment in full for all

such new shares by means of a contribution in cash of sixteen million Dollars of the United States of America (USD
16,000,000.-).

Proof of the payment in cash has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5, first paragraph of the Company's Articles of Incorporation, which

shall forthwith read as follows:

Art. 5. Share Capital. (Paragraph 1).

“ Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at one hundred forty million six hundred and nine

thousand Dollars of the United States of America (USD 140,609,000.-) divided into one hundred forty million six hundred
and nine thousand (140,609,000) shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each”.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately six thousand euros (EUR 6.000.-)

The  amount  of  USD  16.000.000.-  (sixteen  million  United  States  Dollars)  corresponds  to  the  amount  of  EUR

12,999,665.25 (twelve million nine hundred ninety-nine thousand six hundred sixty-five and twenty-five euro cents) ac-
cording to the exchange rate published on XE.COM on 17 

th

 December 2014.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons' proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
persons' proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous, Maitre Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Wix-Filtron Sp.Z.o.o., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois Polonaises, ayant son siège social

a Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyñ, Poland, enregistrée au Registre des entrepreneurs sous le numéro KRS 0000049910
par la Cour du District de Poznañ-Nowe Miasto i Wilda a Poznañ, IX Département Economique du Registre de la Cour
Nationale,

37485

L

U X E M B O U R G

ici représentée par Mme Alexandra Fuentes, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée le 12 décembre 2014.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.
II. Wix-Filtron Sp.Z.o.o., préqualifié, déclare qu'il est l'associé unique (l'"Associe Unique") de Affinia Luxembourg Fi-

nance S.a r.l.., une société à responsabilité limitée constituée d'après les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 124, Boulevard de la Petrusse, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.119, constituée par acte notarié du 23 mai 2011,
publie au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1828 du 10 août 2011. Les statuts ont été modifies
pour la dernière fois par acte notarié du 10 septembre 2014, publie au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 3173 du 30 octobre 2014.

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société de seize millions dollars américains (USD 16.000.000.-) pour le porter

de son montant actuel de cent vingt-quatre millions six cent neuf mille dollars américains (USD 124.609.000.-) représenté
par  cent  vingt-quatre  millions  six  cent  neuf  mille  (124.609.000)  parts  sociales  ayant  une  valeur  nominale  d'un  dollar
américain  (USD  1.-)  chacune  a  un  montant  de  cent  quarante  millions  six  cent  neuf  mille  dollars  américains  (USD
140.609.000.-), divise en cent quarante millions six cent neuf mille dollars (140.609.000) actions d'une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, par l'émission de seize millions (16.000.000) de nouvelles parts sociales ayant
une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes.

2. Acceptation de la souscription de seize millions (16.000.000) de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale

d'un dollar américain (USD 1.-) chacune par Wix-Filtron Sp.Z.o.o., le paiement intégral de ces parts sociales par un apport
en espèce d'un montant de seize millions de dollars américains (USD 16.000.000.-).

3. Modification de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions précédentes.
4. Divers.
La partie comparante, préqualifiée, a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé  Unique  décide  d'augmenter  le  capital  social  de  la  Société  de  seize  millions  dollars  américains  (USD

16.000.000.-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-quatre millions six cent neuf mille dollars américains
(USD 124.609.000.-) représenté par cent vingt-quatre millions six cent neuf mille (124.609.000) parts sociales ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune à un montant de cent quarante millions six cent neuf mille dollars
américains (USD 140.609.000.-), divise en cent quarante millions six cent neuf mille dollars (140.609.000) actions d'une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, par l'émission de seize millions (16.000.000) de nouvelles parts
sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD

1.-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et d'accepter la souscription

suivante:

<i>Souscription/Paiement

Ensuite, a comparu Mme Alexandra Fuentes, susmentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisée

de Wix-Filtron Sp.Z.o.o., préqualifié, en vertu de la procuration prémentionnée.

La comparante déclare souscrire à seize millions (16.000.000) de nouvelles parts et de libérer intégralement ces nou-

velles parts sociales par un apport en espèce d'un montant de seize millions de dollars américains (USD 16.000.000.-).

La preuve du paiement en espèce a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5, paragraphe premier des statuts de la Société qui aura dorénavant la

teneur suivante:

Art. 5. Capital Social. (Paragraphe 1).

« Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la société est fixé cent quarante millions six cent neuf mille dollars

américains (USD 140.609.000.-) représenté cent quarante millions six cent neuf mille (140.609.000) parts sociales ayant
une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées».

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

a six mille euros (EUR 6.000.-).

Le montant de USD 16.000.000.- (seize millions) correspond à la somme de EUR 13,693.23 (EUR treize mille six cent

quatre-vingt-treize et vingt-trois euros cent) conformément au taux de change publié sur XE.COM en date du 19 dé-
cembre 2014.

37486

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des

comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du
mandataire des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

Le présent acte notarié a été rédigée au Luxembourg, à la date mentionne au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant

par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. LAC/2014/62816. Reçu soixante-quinze euros (75.-.).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024719/155.
(150029272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sopaluxe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 139.907.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 29 novembre 2014

Les actionnaires prennent acte de la fin du mandant d’administrateur de Madame Catherine, Marie-Elisabeth RENARD,

née le 15/02/1965 à Le Mans, France, demeurant 117 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,

Les actionnaires prennent acte de la fin du mandant de délégation à la gestion journalière de Madame Catherine, Marie-

Elisabeth RENARD, administrateur, née le 15/02/1965 à Le Mans, France, demeurant 117 Avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg.

En  remplacement  des  fonctions  d’administrateur-délégué  exercées  précédemment  par  Madame  Catherine,  Marie-

Elisabeth RENARD, les actionnaires appellent aux fonctions d’administrateur:

Nom: BACHELLERIE Prénom: Marie-Thérèse
Fonction: Administrateur
Née à LYON le 22/04/1942
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
47, rue de Clementy, CH – 1260 NYON
Durée du mandat: Déterminée
Date de nomination: 22/11/2014
Jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2019
Pouvoir de signature: signature collective de deux administrateurs
Nom: GIRBAUD Prénom: François
Fonction: Administrateur
Né à MAZAMET le 22/02/1945
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
47, rue de Clementy, CH – 1260 NYON
Durée du mandat: Déterminée
Date de nomination: 22/11/2014
Jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2019
Pouvoir de signature: signature collective de deux administrateurs
Nom: FREULET Prénom(s): Arnaud
Né à Mulhouse (France) le 07 mai 1977
Fonction: Administrateur
Adresse professionnelle de la personne physique:
20, rue de Hollerich – L 1740 LUXEMBOURG
Durée du mandat: Déterminée
Date de nomination: 22/11/2014

37487

L

U X E M B O U R G

Jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2019
Pouvoir de signature: signature collective de deux administrateurs

Pour avis conforme
<i>Le Conseil d’Administration

Référence de publication: 2015023121/44.
(150027089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Temenos Software Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Odyssey Financial Technologies S.A.).

Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 51.921.

L’an deux mille quinze, le vingt-six janvier.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

ODYSSEY GROUP S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 39, Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50331,

dûment représenté par Gersende Masfayon, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La partie comparante est l’actionnaire unique (l’«Actionnaire Unique») de ODYSSEY FINANCIAL TECHNOLOGIES

S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social
au 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51921, constituée originairement sous la dénomination de
«ODYSSEY ASSET Management SYSTEMS S.A.» selon acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Eich,  Grand-Duché  de  Luxembourg  en  date  du  2  août  1995,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, numéro 532 du 18 octobre 1995. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître
Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 9 mai 2011 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1738, en date du 1 

er

 août 2011 (ci-après la “Société”).

L’Actionnaire Unique adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Actionnaire Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de «ODYSSEY FINANCIAL TECH-

NOLOGIES S.A.» en «TEMENOS SOFTWARE LUXEMBOURG S.A.».

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 1 des statuts de la

Société qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront

propriétaires des actions ci-après créées, une société (la «Société») sous la forme d’une société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination TEMENOS SOFTWARE LUXEMBOURG S.A.».

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. MASFAYON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 4 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3426. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015022961/45.
(150025999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

37488


Document Outline

Affinia Luxembourg Finance S.à r.l.

AIPP Asia Soparfi S.à r.l.

Castle 45 S.à r.l.

Cazelia

Cevet S.A.

CT GP Acquisition S.C.A.

Digital Services XLIX (GP) S.à r.l.

Digital Services XLVI (GP) S.à.r.l.

MS Isoliertechnik S.à r.l.

Odyssey Financial Technologies S.A.

Odyssey Financial Technologies S.A.

Sagittarius S.A. - SPF

Sagittarius S.A. - SPF

Schroedinger Inv. S.A.

Seaman S.A.

Servolux S.A., SPF

Sesvenna Investment S.A.

Seven Vegas S.A.

Sipor S.A.

Sister Line S.A.

SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l.

Sopaluxe S.A.

SPF 2 Holdco S.à r.l.

SS&amp;C European Holdings

SS&amp;C Technologies Holdings Europe

STM Invest S.à r.l.

Storvik S.A.

Sumala S.A.

Superbond S.A.

Sustainable

Svinvest S.A., SPF

Tara Trade S.à.r.l.

Taurus S.A. - SPF

Taurus S.A. - SPF

Taurus S.A. - SPF

Tecon S.A.

Temenos Software Luxembourg S.A.

Temenos Software Luxembourg S.A.

Thomé &amp; Martin, Senc

Totham S.A.

Triangle Productions S.A.

Trilux Invest S.A.

T.S.D. S.A.

Turret Lux Participation S.à r.l.

UBS ETF

Valfleurs S.A.

Vitruvian II Luxembourg S.à r.l.