logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 779

20 mars 2015

SOMMAIRE

2LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37392

Angel & Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

37386

AngelPay S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37386

Asia Investment Soparfi S.à r.l.  . . . . . . . . . .

37389

AVL Investments S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . .

37383

Daditra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37355

Digital Services XLIII (GP) S.à r.l.  . . . . . . .

37366

Fondation Ste Zithe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37377

Ire Hotel II Rad Blu Cologne  . . . . . . . . . . . .

37355

Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.  . . . .

37391

Racol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37355

Sumala S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37346

Sumala S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37346

Sumala S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37346

Thelos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37347

Tipalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37347

TMLH 1970 SA, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37346

UNA Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

37348

Unipatent Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37348

Universal Commerce and Finance S.A.  . .

37348

Universal Management Services Sàrl  . . . .

37347

Valfleurs S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37354

Valfleurs S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37351

Valfleurs S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37354

Vartema S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37352

V Concept Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37354

Venusia Real Estate Investment S.A. . . . . .

37349

Vertime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37346

Vicari S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37349

Vinci Real Estate Management  . . . . . . . . . .

37349

Vinox S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37348

Vionelle S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37350

Vison  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37350

Vontobel Management S.A.  . . . . . . . . . . . . .

37350

Walgreen Asia Services S.à r.l.  . . . . . . . . . .

37350

Wela Internet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37354

Wester Wassertechnik s.à r.l.  . . . . . . . . . . .

37349

Wildfire Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . .

37351

Wise Services S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37351

World Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

37352

Worldline Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37351

World's Flash S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .

37352

WTC Sub-Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

37352

WW Brand S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37353

WWW.Pétange s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37353

WWW.Pétange s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37353

Xara Asset Management S.A. SPF  . . . . . . .

37353

37345

L

U X E M B O U R G

Sumala S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 49.364.

I hereby resign as director of your company with effect as from 13/04/2012.
Par la présente, je vous remets ma démission comme administrateur de votre société avec effet au 13/04/2012.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Jean-Yves NICOLAS.

Référence de publication: 2015025531/10.
(150028490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sumala S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 49.364.

I hereby resign as director of your company with effect as from 13/04/2012.
Par la présente, je vous remets ma démission comme administrateur de votre société avec effet au 13/04/2012.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Andrea DANY.

Référence de publication: 2015025532/10.
(150028490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

TMLH 1970 SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 187.715.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 10 février 2015 à 15.00

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d administration

Référence de publication: 2015025568/14.
(150028075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Vertime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 50.977.

Les comptes annuels au 30 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015025610/10.
(150028281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Sumala S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 49.364.

I hereby resign as director of your company with effect as from 13/04/2012.
Par la présente, je vous remets ma démission comme administrateur de votre société avec effet au 13/04/2012.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Nicole Thommes.

Référence de publication: 2015025529/10.
(150028490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37346

L

U X E M B O U R G

Thelos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 93.520.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 11 février 2015:

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

<i>Pour THELOS S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025563/13.
(150028686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Tipalux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 49.035.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 8 décembre 2014 que:
- les démissions des administrateurs suivants ont été acceptées:
* Mme Foteini CHANTZIVANGELI-ZERITIS, avec effet immédiat;
* M. Michail SIDERIDIS, avec effet immédiat;
* M. Christos-Spyr CAVALLIS, avec effet au 25 novembre 2014.

<i>- les administrateurs sortants:

* M. Panagiotis ZERITIS, également Président du Conseil d'Administration, demeurant au 150, Iera Odos, GR-12242

Athènes, Grèce, Président;

* M. Dimitrios Alexandros ZERITIS, demeurant au 150, Iera Odos, GR-12242 Athènes, Grèce;
ainsi que le Commissaire aux comptes sortant, SG Services S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg, ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour une nouvelle période de six ans.

Tous les mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2020.
- M. George Anastasios ZERITIS, demeurant au Papanastasiou &amp; Malakasi 67 Str., GR-15452 Palaio Psyxiko, Grèce, a

été nommé à la fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

- le nombre des administrateurs de la société a par conséquent été réduit de cinq à trois.
Il résulte en outre du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration du 8 décembre 2014 que M. Panagiotis

ZERITIS, demeurant au 150, Iera Odos, GR-12242 Athènes, Grèce, a été confirmé dans sa fonction d'administrateur-
délégué pour une nouvelle période de six ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2020.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2015025565/27.
(150028178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Universal Management Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 64.474.

Une liste de signatures autorisées de la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES SARL en fonction au 12 février

2015 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025590/14.
(150028951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37347

L

U X E M B O U R G

Universal Commerce and Finance S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 32.116.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 31 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025589/12.
(150028661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Unipatent Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 23.391.

<i>Extrait de la résolution prise par le liquidateur en date du 4 février 2015

En application de la loi du 28 juillet 2014, le liquidateur décide de nommer pour une durée indéterminée avec effet au

4 février 2015, Maître Cédric HIRTZBERGER, Avocat à la Cour. 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, en tant
que dépositaire des actions au porteur émises par la Société.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour UNIPATENT HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025588/14.
(150028976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

UNA Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 166.626.

Le  bilan  rectificatif  en  remplacement  du  bilan  arrêté  au  31/12/2013,  déposé  le  3  février  2015  sous  la  référence

L150021487 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015025587/13.
(150028285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Vinox S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 153.497.

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 11/02/2015:
Il est décidé nommer la société à responsabilité limité UNCOS, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,

immatriculée au RCSL sous le numéro B141298, en tant que dépositaire légal des actions au porteur de la société VINOX
S.A., SPF (B153497) et ceci en vertu de la loi du 28 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/02/2015.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015025614/15.
(150028365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37348

L

U X E M B O U R G

Vinci Real Estate Management, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.911.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 février 2015

Il résulte de ce Conseil d'administration:
Conformément à l'article 42 des Lois Coordonnées sur les Sociétés commerciales du 10 août 1915 tel que modifié

par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration décide,
à l'unanimité, de nommer comme dépositaire des actions au porteur, la société «Fiduciaire Internationale SA», ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
34813 et représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Stéphan MOREAUX.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015025613/15.
(150029178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Vicari S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 172.877.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 11 février 2015 à 9.00

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2015025611/14.
(150028889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Venusia Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 96.585.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 février 2015

Il résulte de ce Conseil d'administration:
Conformément à l'article 42 des Lois Coordonnées sur les Sociétés commerciales du 10 août 1915 tel que modifié

par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration décide,
à l'unanimité, de nommer comme dépositaire des actions au porteur, la société «Fiduciaire Internationale SA», ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
34813 et représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Stéphan MOREAUX.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015025609/15.
(150029177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Wester Wassertechnik s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1121 Luxembourg, 7, rue des Alouettes.

R.C.S. Luxembourg B 57.199.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025631/10.
(150028794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37349

L

U X E M B O U R G

Vison, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 173.151.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 31 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025616/12.
(150028129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Vionelle S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 96.813.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015025615/12.
(150028146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Vontobel Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 2-4, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 115.113.

AUSZUG

Es wurde beschlossen
- Carmen Lehr mit beruflicher Adresse an 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg per 14. Januar 2015
- Sophie Dupin mit beruflicher Adresse an 2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg per 23. Januar 2015
als Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Generalversammlung im Jahre 2015 zu kooptieren.
Weiter scheiden
- Philippe Hoss per 14. Januar 2015
- Bernhard Schneider per 23. Januar 2015
als Verwaltungsratsmitglieder aus.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 10. Februar 2015.

Vontobel Management S.A.

Référence de publication: 2015025598/19.
(150028549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Walgreen Asia Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.159.

Les statuts coordonnés au 30 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015025621/11.
(150028826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37350

L

U X E M B O U R G

Worldline Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 79.303.

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration prises le 15 janvier 2015

La démission de Monsieur Christophe DUQUENNE de ses fonctions de délégué à la gestion journalière de la société

est constatée avec effet immédiat.

Monsieur Nick DALGAARD, administrateur de société, né à Arhus (Danemark) le 14 novembre 1965, demeurant au

64 rue de la Montagne à L-2162 Luxembourg est nommé avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, délégué
à la gestion journalière (General Manager) de la Société, avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature en
ce qui concerne cette gestion.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015025625/15.
(150028767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Wise Services S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 137.823.

Les comptes annuels de la société du 1 

er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015025624/13.
(150028220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Wildfire Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 155.655.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 6 février 2015

Le Conseil d'administration nomme Orangefield (Luxembourg) S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à

L-2163 Luxembourg, en tant qu'agent dépositaire.

Luxembourg, le 6 février 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015025623/14.
(150029026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Valfleurs S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 64.388.

Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A. résilie avec effet immédiat la convention de domiciliation conclue en date

du  15/09/2005  la  liant  à  la  société  anonyme  VALFLEURS  S.A.,  dont  le  siège  social  est  au  3  Avenue  Pasteur,  L-2311
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 64.388.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2015025605/12.
(150029025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37351

L

U X E M B O U R G

WTC Sub-Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.564,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 168.183.

<i>Extrait de la convention de cession de parts sociales en date du 10 octobre 2014

Interamerican Realty Limited Liability Partnership a décidé de transférer ses 3,892 parts sociales d'une valeur nominale

de USD 1 à WTC Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 205, route d'Arlon, L-1150
Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.787.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

WTC Sub-Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2015025638/15.
(150029120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

World's Flash S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.746.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 03 février 2015:

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 03 février 2015.

<i>Pour WORLD'S FLASH S.A., SPF
Signature

Référence de publication: 2015025637/13.
(150028381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

World Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.238.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 03 février 2015:

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société,

Luxembourg, le 03 février 2015.

<i>Pour WORLD IMMOBILIERE S.A.
Signature

Référence de publication: 2015025636/13.
(150028379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Vartema S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 87.789.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 12 février 2015 que la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015025606/13.
(150029083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37352

L

U X E M B O U R G

WW Brand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 178.702.

<i>Cession de parts sociales

En vertu d’un acte de cession de parts sous seing privé en date du 8 janvier 2015, la société SIRUS FINANCE LIMITED

a cédé la totalité des parts sociales qu'elle détient dans la Société, soit 12.500 parts sociales, à la société SOLUTIONS 30
SE, société européenne ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, R.C.S. Luxembourg B 179097.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l'associé unique en date du 12 janvier 2015

L'associé unique, la société SOLUTIONS 30 SE, avec siège social à L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, R.C.S. Luxem-

bourg B 179097, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Francesco ZITO de son poste de gérant de la Société.

<i>Seconde résolution

L'associé unique décide de nommer, en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Gianbeppi FORTIS, né le

er

 août 1962 à Armeno (Italie), demeurant à L-1258 Luxembourg, 29, rue Brasseur, en qualité de nouveau gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025639/20.
(150028531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Xara Asset Management S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 191.881.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 09 février 2015 à 10.00

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2015025643/14.
(150028077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

WWW.Pétange s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 117.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015025642/10.
(150028655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

WWW.Pétange s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 117.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015025641/10.
(150028642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37353

L

U X E M B O U R G

Wela Internet S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 36.355.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 24 avril 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme WELA
INTERNET S.A., dont le siège social à L-5480 Wormeldange, 11, rue Principale, a été dénoncé en date du 17 janvier 2003.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, premier juge au Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Jonathan BURGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxem-

bourg avant le 15 mai 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Jonathan BURGER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015025630/20.
(150028626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Valfleurs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 64.388.

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015025603/11.
(150028919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Valfleurs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 64.388.

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Norbert SCHMITZ.

Référence de publication: 2015025602/9.
(150028919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

V Concept Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 107.351.

<i>Extrait de la résolution prise par le liquidateur en date du 4 février 2015

En application de la loi du 28 juillet 2014, le liquidateur décide de nommer pour une durée indéterminée avec effet au

4 février 2015, Maître Cédric HITZBERGER, Avocat à la Cour, 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, en tant que
dépositaire des actions au porteur émises par la Société.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour V CONCEPT LUX
Signature

Référence de publication: 2015025592/14.
(150028979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37354

L

U X E M B O U R G

Daditra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue Mil Neuf Cents.

R.C.S. Luxembourg B 166.477.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 février 2015 que
CF Corporate Services
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 165872
a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société DADITRA S.A pour une durée indéterminée,

en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024922/17.
(150028633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Ire Hotel II Rad Blu Cologne, Société à responsabilité limitée,

(anc. Racol).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.225.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of January.
Before, Maître Roger Arrensdorff, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1) IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 158.137 and having a share
capital of EUR 4,132,004;

2) Alan Hynes, an Irish citizen, born on 1 October 1969 in Roscommon, Ireland, company director, residing in Moor-

town House, Moortown, Dublin Road, Dundalk, Co Louth, Ireland;

Both represented by Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies

given under private seal on the 19 

th

 December 2014, respectively the 17 

th

 December 2014.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed together with such deed with the registration authorities.

IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l. and Alan Hynes, prenamed, are being referred to below as the Shareholders.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. The Shareholders are the sole shareholders of RACOL, a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 43, Boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
131.225 and having a share capital of EUR 5,450,500.-, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary,
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et des Associations number 2217 of 6 October 2007, amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Paul Decker, on 3 March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 1032 of
25  April  2008  (the  Company);  the  relevant  proxies,  after  having  been  signed  ne  varietur  by  the  proxyholder  of  the
respective appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

II. The agenda of the meeting is the following:
1) Waiver of the convening notices;
2) Change of the Company's name into IRE Hotel II Rad Blu Cologne;
3) Deletion of the distinction between the categories of shares in the share capital of the Company;
4) Change of the Company's address of registered office to 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
5) As a consequence of the above, full restatement of the articles of association of the Company (the Articles);
6) Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognised as true by the meeting, the meeting unanimously requested the

undersigned notary to enact the following resolutions:

37355

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Shareholders note that they represent the entire capital of the Company, so that the meeting can validly decide

on all the issues of the agenda, which are known to the Shareholders. The Shareholders resolve to waive any applicable
convening notices.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to change the Company's denomination into "IRE Hotel II Rad Blu Cologne" and to amend

article 3 of the Articles accordingly, which will henceforth read as stated under the fifth resolution below.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to delete the distinction between the categories of shares in the share capital of the Company

and to amend the Articles accordingly, which will henceforth read as stated under the fifth resolution below.

<i>Fourth resolution

The Shareholders further resolve to change the Company's address of registered office to 37A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above, the Shareholders resolve to amend and restate the articles of association of the

Company which shall henceforth be read as follows:

A. General provisions

§ 1. Legal form, name and registered office.
(1) There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name IRE Hotel II Rad

Blu Cologne (the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the
law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Company Act), as well as by the present articles
of association (the Articles), as well as by any shareholders’ agreement that may be entered into by and between the
shareholders of the Company from time to time (the Shareholders’ Agreement).

(2) The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the single manager, or as the case
may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of share-
holders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

(3) Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

§ 2. Object of the Company.
(1) The object of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

(2) This shall include without limiting the scope of the above provision the management of its own assets, in particular

the acquisition and holding of real property (Grundstücke) and real property rights (Rechte an Grundstücken), the cons-
truction and maintenance of buildings and amenities thereon and their economic use, in particular renting out (Verpach-
tung), as well as any business and activities necessary for these purposes; in particular within the city boundaries of
Cologne, Germany.

(3)  The  Company  may,  either  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  or  abroad,  directly  or  indirectly  carry  out  all

transactions associated with real property and the rights attaching thereto, including but not limited to the acquisition,
development, sale, management and/or rental of real property.

(4) The Company can resort, in any place, to all deeds and transactions, whatever their nature and importance may

be, and including through the setting up of new legal entities, to the subscription or purchase of securities or corporate
rights, the acquisition, the merger, as long as deeds and transactions contribute or can contribute to, facilitate or can

37356

L

U X E M B O U R G

facilitate the implementation of the activities defined above, or as long as they allow the direct or indirect safeguard of
the commercial, industrial or financial interests of the Company, of its subsidiaries or of the companies with which it has
a business relationship.

(5) The Company may borrow in any form except by way of public offer in Luxembourg and abroad, in euro or other

currency. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity
securities. The Company may lend funds in Luxembourg and abroad, in euro or other currency, including, without limi-
tation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or to
any other legal entity, especially the ones which objects covers solely or partially the object of the Company. It may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets
to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other legal entity and,
generally, for its own benefit and/or the benefit of any other legal entity or person.

(6) The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

(7) The Company shall be entitled to carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions

with respect to real estate or movable property, which are connected to the object of the Company or are appropriate
to serve directly or indirectly the object of the Company.

B. Share capital, capital contributions, duration of the company

§ 3. Share capital and capital contributions.
(1) The Company’s share capital amounts to five million four hundred fifty thousand euro (EUR 5,450,000) represented

by fifty four thousand five hundred (54,500) ordinary shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each.

(2) The share capital is fully subscribed and entirely paid up.

(3) The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, in a manner required for the amendment of
the Articles.

(4) Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

(5) Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

(6) The shares are in registered form. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in

accordance with the provisions of the Company Act and may be examined by each shareholder who so requests.

(7) Shares are freely transferable among shareholders unless otherwise provided in a Shareholders’ Agreement. The

transfer of shares to third parties is subject to the below clauses, clauses set out in §12 “Disposition of shares” and any
other agreements that the shareholders may enter into.

(8) Inter vivos, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of

shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer
of the shares of the deceased shareholder to new shareholders is subject to the approval given by the other shareholders
in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the
event of death, the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

(9) A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

(10) For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Company Act.

§ 4. Duration of the Company and financial year.
(1) The Company will be established for an indefinite period of time.

(2)  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

(3) The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December of each year.

(4) Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

(5) Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

37357

L

U X E M B O U R G

C. Management

§ 5. Management and procedure.
(1) The Company is managed by one or more managers appointed or revoked by a resolution of the single shareholder

or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they
will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

(2) The managers may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholder

(s).

(3) All powers not expressly reserved by the Company Act or the present Articles to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the
board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s object.

(4) The managers shall conduct the business of the Company in accordance with the Company Act, the Articles of

Association, as well as, if applicable, with the specific provisions concerning the management of the Company fixed in a
Shareholders’ Agreement, as may be concluded by the shareholders of the Company from time to time.

(5) Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by two managers of the Company acting jointly.

(6) The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any managers at

the place indicated in the convening notice. The board of managers shall meet at least annually. The board of managers
may elect among its member a chairman.

(7) Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

(8) No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

(9) Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

(10) The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

(11)  Any  manager  may  exceptionally  participate  in  any  meeting  of  the  board  of  managers  by  telephone  or  video

conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in
person at such meeting.

(12) Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

§ 6. Representation of the Company. If the Company has only one manager, this manager is granted power of sole

representation. If several managers are appointed, the Company will be represented by any two managers acting jointly,
or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance
with article §5 (5).

D. Shareholders‘ Meetings and Shareholders’ Resolutions

§ 7. Powers and voting rights.
(1) If there is a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred by the Company Act to the

general meeting of shareholders.

(2) Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
(3) Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

§ 8. Shareholders' Meetings.
(1) Shareholders‘ meetings shall be convened by the managers of the Company; the convocation by one manager is

sufficient. The convocation shall be effected by the managers in written form, observing a notice period of two weeks,
beginning on the day on which the invitation is sent, stating the agenda.

(2) The annual general meeting of the shareholders shall take place once a year within two month after the production

of the annual financial statement at the place of business of the Company. Moreover, extraordinary shareholders’ meetings

37358

L

U X E M B O U R G

shall be convened when this is necessary in the interest of the Company or shareholders with at least 10 % of the share
capital combined do request so.

(3) Minutes of the shareholders’ meetings shall be kept for later documentation which in particular shall state the place

and date of the meeting, attendees, items on the agenda, all motions, the result of the votes as well as all shareholders’
resolutions. The minutes shall be signed by the chairman. Each shareholder shall receive a copy of the minutes within one
month after the shareholders’ meeting.

§ 9. Shareholders’ Resolutions.
(1) If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

(2) Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

(3) However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

(4) A shareholder may be represented and/or accompanied at shareholders’ meeting by a different shareholder or a

law or tax professional who is bound to observe professional secrecy.

E. Annual accounts, use of results

§ 10. Annual accounts. The annual financial statement (balance sheet, notes and the profit and loss account) and a

management’s report for the expired financial year shall be produced by the managers within the statutory deadlines, and
shall be sent to the auditors for audition if this is provided for by law.

§ 11. Allocation of profits.
(1) The managers shall provide all shareholders with the annual financial statement, any management’s report and any

auditor’s report together with a proposal for the use of results.

(2) The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

(3) The shareholders‘ meeting shall decide on the approval of the annual financial statement and on the use of profits

within the statutory deadlines. As the case may be, the annual profit shall be carried forward unless the shareholders’
meeting does not resolve another use of profits.

(4) Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

F. Dispositions of shares

§ 12. Dispositions of shares.
(1) Until 31 December 2019, any shareholder holding at the moment of a proposed share transfer less than 10% of

the share capital in the Company (the Minority Shareholder) shall not be entitled to transfer or pledge part or all the
shares held by it.

(2) After 31 December 2019, transfers of part of the shares of the Minority Shareholder will remain proscribed, while

transfers of all the shares and pledging of part or all of the shares of the Minority Shareholder require the approval of all
shareholders. Exempted of the preceding provision under this article §12 (2) are disposals in favour of other shareholders,
as well as disposals made as a result of the enforcement of pledges aimed at securing the credit contracted by the Company
in order to finance the acquisition of its real estate assets.

(3) The same regulations, set out under the articles §12 (1) and (2) above, apply to the granting or modification of a

right of usufruct or a sub-participation, and the creation or modification of fiduciary relationships, with respect to the
shares held by the Minority Shareholder.

§ 13. Drag Along Right. If Shareholders, who individually or jointly hold at least 50% of the total share capital of the

Company (the Majority Shareholders), propose to sell at any time all their shares to a third party or several third parties
(the Proposed Purchaser), then these Majority Shareholders may request the other shareholders to sell all their shares
by sale, exchange, transfer, contribution or conversion (e.g. merger) - depending on the choice of the requesting share-

37359

L

U X E M B O U R G

holders - to the Proposed Purchaser, for a price in an amount at least equal to the price per share offered by the Proposed
Purchaser for the shares of the Majority Shareholders.

§ 14. Right of acquisition and preemption right.
(1) If the Minority Shareholder intends to dispose of all or part of its shares (hereinafter the Minority Shares) to a third

party that is not a shareholder of the Company or an entity affiliated to a shareholder of the Company, the Majority
Shareholders shall have a right of acquisition in accordance with the following provisions

(2) The Minority Shareholder has to offer the Minority Shares to be disposed first to the Majority Shareholders for

purpose of acquisition by registered mail specifying the favored acquirers (with name/name of the company, address and,
if applicable, information of the commercial register), the price and the other conditions of the disposal and has to inform
the Company in written form on its intention to dispose. If the Majority Shareholders intend to acquire the offered
Minority Shares for the named conditions, then they have to declare this within 2 weeks since receipt of the letter of
offer by registered mail (the Acceptance Notice) to the Minority Shareholder, and with written notification sent to the
Company. The Majority Shareholders may in their Acceptance Notice determine a third party willing to acquire the
Minority Shares in their stead.

(3) The right of acquisition can only be exercised for the entirety of the offered Minority Shares.
(4) The sale and the assignment of the Minority Shares have to take place within 2 weeks after expiry of the deadline

for the acceptance of the right of acquisition according to section (2) above.

G. Liquidation

§ 15. Liquidation.
(1) After dissolution of the Company, the latter will be unwound. The liquidation will be carried out by one or several

liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general
meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the
resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation
of the assets and payments of the liabilities of the Company.

(2) The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholders in proportion to their shareholdings, unless the shareholders agree or have agreed otherwise.

H. General Provisions

§ 16. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Company Act for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimated costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be paid by the Company as a result of this

deed, are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties

the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing parties, in
case of discrepancies between the English and the German texts, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

surname, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with Us, notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorigen Textes

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am einundzwanzigsten Januar.
Vor Maître Roger Arrensdorff, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg,

SIND ERSCHIENEN:

1) IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxem-

burgischen Rechts mit Sitz in 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, einem Stammkapital von EUR 4.132.004
und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Handelsregisternummer B 158.137;

2) Alan Hynes, irischer Staatsbürger, geboren am 1. Oktober 1969 in Roscommon, Irland, Geschäftsführer, wohnhaft

in Moortown House, Moortown, Dublin Road, Dundalk, Co Louth, Irland;

beide  vertreten  durch  Maître  Claude  Feyereisen,  Avocat  à  la  Cour,  niedergelassen  in  Luxembourg,  aufgrund  von

privatschriftlich am 19, Dezember 2014, respektive am 17. Dezember 2014 erteilten Vollmachten.

Diese Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar “ne varietur” unterzeichnet

wurden, bleiben dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigebogen.

37360

L

U X E M B O U R G

IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l. und Alan Hynes, wie vorgenannt, werden im Folgenden als die Gesellschafter bezeichnet.
Die Gesellschafter haben den unterzeichnenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
I. Die Gesellschafter, wie oben dargestellt vertreten, sind die einzigen Gesellschafter der RACOL, einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts mit dem Sitz in 43, Boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, einem Stammkapital von EUR 5.450.500, im luxemburgischen Handelsund Gesellschaftsre-
gister eingetragen unter der Handelsregisternummer B 131.225, gegründet durch die von Maître Paul Decker, Notar mit
Amtssitz in Luxemburg, angefertigte notariellen Urkunde vom 16. August 2007, welche im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 2217 vom 6. Oktober 2007 veröffentlicht und zuletzt durch notarielle Urkunde vom
3. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1032 vom 25. April 2008
geändert wurde (die Gesellschaft); die benötigten Vollmachten, bleiben dieser Urkunde zum Zweck der Hinterlegung bei
der Registrierungsbehörde angefügt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der Komparenten und der unterzeichnenden
Notarin "ne varietur" unterzeichnet wurden.

II. Die Tagesordnungspunkte sind die Folgenden:
1) 1. Verzicht auf die Einberufungschreiben;
2) 2. Änderung der Firma der Gesellschaft zu IRE Hotel II Rad Blu Cologne;
3) 3. Aufhebung der verschiedenen Kategorien zur Unterscheidung der Anteile im Stammkapital der Gesellschaft;
4) 4. Änderung des Sitzes der Gesellschaft zu 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
5) 5. Infolge der obigen Änderungen und Aufhebungen, die vollständige Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft

(die Satzung);

6) 6. Verschiedenes.
Diese Tatsachen wurden von den Teilnehmern dieser Versammlung, nachdem sie ihnen bekannt gegeben wurden, als

zutreffend anerkannt. Die Versammlung hat den unterzeichnenden Notar einstimmig dazu ersucht, folgende Beschlüsse
zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter zeigen an, dass sie das gesamte Kapital der Gesellschaft vertreten, so dass die Versammlung wirksam

über alle in der Tagesordnung erwähnten Angelegenheiten, die den Gesellschaftern bekannt sind, entscheiden kann. Die
Gesellschafter beschließen, auf jedwede notwendige Einberufungsbekanntmachungen zu verzichten.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Firma der Gesellschaft zu "IRE Hotel II Rad Blu Cologne" zu ändern und Artikel 3

der Satzung entsprechend zu ändern, welcher fortan so lautet wie gemäß des fünften Beschlusses geändert.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Unterscheidung der Anteile im Stammkapital der Gesellschaft durch ihre Klassifi-

zierung in verschiedene Kategorien und die entsprechenden Artikel der, fortan gemäß des fünften Beschlusses geänderten
Satzung, aufzuheben.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen weiter, dass der Sitz der Gesellschaft zu 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

geändert wird.

<i>Fünfter Beschluss

Infolge der obigen Beschlüsse, beschließen die Gesellschafter die Satzung wie folgt zu ändern und neu zu formulieren:

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Gesellschaftsform, Firma und Sitz.
(1) Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Firma „IRE Hotel

II Rad Blu Cologne" (die „Gesellschaft"), die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweiligen Fassung (das „Gesetz über die Handelsgesellschaften"),
der vorliegenden Satzung (die „Satzung") und den zum jeweiligen Zeitpunkt zwischen den Gesellschaftern beschlossenen
Gesellschaftervereinbarungen (die „Gesellschaftervereinbarungen“).

(2)  Der  Sitz  der  Gesellschaft  ist  Luxemburg,  Großherzogtum  Luxemburg.  Er  kann  durch  einfachen  Beschluss  des

alleinigen Geschäftsführers, oder gegebenenfallsdes Geschäftsführungsrates der Gesellschaft, an einen anderen Ort in-
nerhalb der Gemeinde verlegt werden. Des Weiteren kann der Sitz durch einen in der für einen Satzungsänderungsbe-
schluss  vorgesehenen  Art  und  Weise  gefassten  Beschluss  des  Alleingesellschafters  oder  der  Hauptversammlung  der
Gesellschafter an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

(3) Zweigniederlassungen, Filialen und andere Geschäftsräume können durch einen Beschluss des alleinigen Geschäfts-

führers,  oder  gegebenenfalls,  des  Geschäftsführungsrates  entweder  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland
errichtet werden. Sollte der alleinige Geschäftsführer, oder gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat beschließen, dass

37361

L

U X E M B O U R G

außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind, und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die Verbindung der-
selben mit dem Ausland behindern würden oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz vorübergehend
ins Ausland verlegt werden, und zwar bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Derartige provi-
sorische Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der provisorischen Sitzverlegung
des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

§ 2. Gesellschaftszweck.
(1) Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an luxemburgischen oder

ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung, die Steuerung und die Entwicklung solcher Be-
teiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Rentenwerte, Geld-
markteinlagen und andere Schuldtitel aller Art durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonst wie erwerben, und im
Allgemeinen alle Wertschriften und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder
Art, einschließlich Personengesellschaften, ausgegeben werden. Sie kann an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und
Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Des Weiteren darf sie in den Erwerb und die Verwaltung
eines Bestandes von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten jeder Art und jeden Ursprungs investieren.

(2) Dies umfasst, ohne die obigen Bestimmungen einzugrenzen, auch die Verwaltung ihres eigenen Vermögens, insbe-

sondere der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, der Bau von Gebäuden und
Einrichtungen auf diesen, ihre wirtschaftliche Verwendung, insbesondere ihre Verpachtung, sowie die Vornahme jeder
diesen Zwecken dienenden Geschäfte, insbesondere im Gemeindegebiet der Stadt Köln, Deutschland.

(3) Die Gesellschaft darf, sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland, unmittelbar oder mittelbar alle

Transaktionen im Zusammenhang mit Grundstückseigentum oder Rechten an Grundstücken ausführen, einschließlich -
aber  nicht  ausschließlich  -  des  Erwerbs,  der  Entwicklung,  des  Verkaufs,  der  Verwaltung  und/oder  Vermietung  von
Grundstückseigentum.

(4) Die Gesellschaft kann, zur Verfolgung ihrer oben definierten Ziele, an jedem Ort auf die Vornahme eines jeden

Vertrags  oder  jeden  Geschäftes,  ungeachtet  seiner  Natur  und  seines  Gewichtes,  einschließlich  der  Gründung  neuer
Rechtspersönlichkeiten, der Zeichnung und des Kaufs von Wertpapieren oder Gesellschaftsrechten, des Unternehmens-
erwerbs und des Zusammenschlusses, zurückgreifen, solange diese Verträge oder Geschäfte zur Umsetzung der oben
genannten Aktivitäten beitragen oder beitragen können oder solange sie die unmittelbare oder mittelbare Sicherstellung
der kommerziellen, industriellen oder finanziellen Interessen der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften oder von Ge-
sellschaften mit denen sie in geschäftlicher Verbindung steht, erlauben.

(5) Die Gesellschaft kann, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, Darlehen jeder Art, in Euro oder in anderen

Währungen, aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Anleihen. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierung,
Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder Dividendenpapieren ausgeben. Die
Gesellschaft  kann, sowohl  in Luxemburg  als auch  im  Ausland, Geldmittel,  in Euro  oder in anderen Währungen, ein-
schließlich - aber nicht ausschließlich - die Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuld- oder
Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, angegliederte Gesellschaften und/oder jede andere Gesellschaft verlei-
hen,  insbesondere  wenn  ihr  Gesellschaftszweck  ganz  oder  teilweise  mit  dem  der  Gesellschaft  übereinstimmt.  Die
Gesellschaft kann, generell zu eigenem Nutzen und/oder zum Nutzen jeder anderen Gesellschaft oder Person, mit ihrem
gesamten Vermögen oder Teilen hiervon Sicherheiten leisten, dieses verpfänden, übertragen, belasten oder sonst Si-
cherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Unternehmungen und/oder die Verpflichtungen
und Unternehmungen jeder anderen Gesellschaft nachzukommen und diese abzusichern.

(6) Mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung kann sich die Gesellschaft im Allgemeinen in Bezug auf ihre Anlagen aller

Techniken und Instrumente bedienen, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu bestimmt sind, die Gesell-
schaft gegen Kredit-, Währungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

(7) Die Gesellschaft darf im Allgemeinen alle kommerziellen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Transak-

tionen, sowie alle Transaktionen über Immobilien und Mobilien ausführen, die dazu bestimmt sind ihren Gesellschafts-
zweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

B. Stammkapital, Zahlung der Einlagen, Dauer der Gesellschaft

§ 3. Stammkapital und Einlagen.
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünf Millionen vierhundertfünzigtausend Euro (EUR 5.450.000) eingeteilt

in vierundfünfzigtausendfünfhundert (54,500) Stammanteile im Nennbetrag von jeweils einhundert Euro (EUR 100).

(2) Das Stammkapital ist vollständig gezeichnet und eingezahlt.
(3) Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder mehrmalig durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, ge-

gebenenfalls, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter in der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen
vorgesehen ist, erhöht oder vermindert werden.

(4) Jeder Gesellschaftsanteil erteilt dem Halter ein Anrecht auf einen Bruchteil der gemeinschaftlichen Vermögens-

werte und Gewinne der Gesellschaft in unmittelbarem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Anteile.

37362

L

U X E M B O U R G

(5) Die Anteile der Gesellschaft sind unteilbar, da je Anteil nur ein Eigentümer anerkannt wird. Gemeinschaftliche

Eigentümer haben eine einzige Person zu ihrem Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.

(6) Die Anteile sind Namensanteile. Ein Gesellschafterverzeichnis, welches den Vorgaben des Gesetzes über die Han-

delsgesellschaften  entspricht,  wird  am  Sitz  der  Gesellschaft  geführt  und  kann  durch  jeden  Gesellschafter  auf  Antrag
eingesehen werden.

(7) Die Gesellschaftsanteile sind, vorbehaltlich einer gegenteiligen Regelung in der Gesellschaftervereinbarung, zwi-

schen den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Übertragung an Dritte unterliegt den nachfolgenden, in § 12 „Veräußerung
von Anteilen“ stipulierten, Klauseln und jeglichen anderen Vereinbarungen, die die Gesellschafter eingehen.

(8) Unter Lebenden unterliegt die Übertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter der vorherigen Zustimmung der

Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten.
Im Falle des Todes, unterliegt der Übergang der Gesellschaftsanteile auf neue Gesellschafter der vorherigen Zustimmung
der anderen Gesellschafter in der Hauptversammlung, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesell-
schaft vertreten. Dieser Zustimmung bedarf es nicht wenn, im Falle des Todes, die Gesellschaftsanteile entweder an die
Eltern, Abkömmlinge oder dem überlebenden Ehegatten übertragen werden.

(9) Eine Anteilsübertragung bindet die Gesellschaft oder Dritte nur infolge ihrer Anzeige an die Gesellschaft, oder

ihrer Billigung, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

(10) Bezüglich aller anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes hingewiesen.

§ 4. Gesellschaftsdauer und Geschäftsjahr.
(1) Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit geschlossen.
(2) Die Gesellschaft kann wegen eines Sterbefalls, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz,

Konkurs oder ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, nicht aufgelöst werden.

(3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines

jeden Jahres.

(4) In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft, hat der alleinige Geschäftsführer, oder gegebenenfalls

der Geschäftsführungsrat, das Inventar, einschließlich der Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu
erstellen.

(5) Jeder Gesellschafter darf das oben genannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

C. Geschäftsführung

§ 5. Geschäftsführung und Prozedur.
(1) Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geführt. Die Geschäftsführer werden durch

einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter unter Festlegung ihrer Amtszeit
ernannt. Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, bilden diese einen Geschäftsführungsrat. Die Geschäftsführer müssen
nicht auch gleichzeitig Gesellschafter sein.

(2) Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne besonderen Grund, durch Gesellschafterbeschluss vom Amt abgesetzt

werden.

(3)  Alle  Vollmachten,  welche  nicht  ausdrücklich  durch  das  Gesetz  über  die  Handelsgesellschaften  oder  durch  die

gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen unter den Zuständigkeitsbereich
des Alleinigen Geschäftsführers, oder wenn die Gesellschaft von mehr als einem Geschäftsführer geführt wird, des Ge-
schäftsführungsrats, der alle Befugnisse hat, um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu bestätigen, die mit
dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen.

(4) Die Geschäftsführung soll die Geschäfte der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesetz über die Handelsgesellschaf-

ten,  der  Satzung,  sowie,  gegebenenfalls,  mit  besonderen  Regelungen  zur  Geschäftsführung  der  Gesellschaft  in  den
jeweiligen von den Gesellschaftern geschlossenen Gesellschaftervereinbarungen führen.

(5) Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten vom Geschäftsführer, oder, im Falle

mehrerer Geschäftsführer, von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft gemeinsam, an einen oder mehrere Vertreter
vergeben werden, die nicht auch Gesellschafter sein müssen.

(6) Der Geschäftsführungsrat tritt so oft wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen oder auf Einberufung eines

Geschäftsführers am Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben ist, zusammen. Der Geschäftsführungsrat tritt min-
destens einmal jährlich zusammen. Der Geschäftsführungsrat darf unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.

(7) Schriftliche Mitteilung über jede Geschäftsführungsratssitzung ergeht mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor

dem Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art dieser Umstände im Einbe-
rufungsschreiben für die Geschäftsführungsratssitzung anzugeben ist.

(8) Ein Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft

in einer Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Sitzung rechtmäßig informiert worden zu sein und
die Tagesordnung zu kennen. Es kann von jedem Mitglied des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft per Brief, Faksimile
oder E-Mail auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

37363

L

U X E M B O U R G

(9) Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, indem er schriftlich einen anderen

Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

(10) Der Geschäftsführungsrat kann nur gültig tagen und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats sind gültig, wenn sie mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst werden. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden in Protokollen festgehalten, die von zwei in
der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet sind.

(11) An einer Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen kann jeder Geschäftsführer über Telefon- oder Videokonferenz

oder durch andere, ähnliche Kommunikationsmittel, die allen Personen, die an der Sitzung teilnehmen, ermöglichen,
einander zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung über diese Kommunikationsmittel steht
einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

(12) Umlaufbeschlüsse die von allen Geschäftsführern unterschrieben sind, sind in gleicher Weise wie ein Versamm-

lungsbeschluss gültig. Die Unterschriften der Geschäftsführer können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren
Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet werden, und per Brief oder per Faksimile bescheinigt werden.

§ 6. Vertretung der Gesellschaft. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, kann dieser die Gesellschaft alleine

vertreten.  Sind  mehrere  Geschäftsführer  bestellt,  wird  die  Gesellschaft  durch  zwei  gemeinschaftlich  handelnde  Ge-
schäftsführer oder durch die einzelne oder die gemeinschaftlichen Unterschriften der Personen, denen in Übereinstim-
mung mit § 5 (5), wirksam eine solche Unterschriftenvollmacht erteilt wurde, vertreten.

D. Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse

§ 7. Befugnisse und Stimmrechte.
(1) Sofern es einen Alleingesellschafter gibt, nimmt dieser alle Rechte wahr, die durch das Gesetz über die Handels-

gesellschaften der Hauptversammlung der Gesellschafter übertragen sind.

(2) Jeder Gesellschafter hat eine der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile entsprechende Anzahl Stimmen.
(3) Jeder Gesellschafter kann eine natürliche oder juristische Person per Brief, Telegramm, Telex, Faksimile oder E-

Mail zu seinem Bevollmächtigten bestellen, um ihn bei den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu vertreten.

§ 8. Gesellschafterversammlungen.
(1) Die Gesellschafterversammlungen werden von den Geschäftsführern der Gesellschaft einberufen; die Einberufung

durch einen Geschäftsführer genügt hierbei. Die Einberufung durch die Geschäftsführer erfolgt schriftlich unter Angabe
der Tagesordnung und unter Berücksichtigung einer zweiwöchigen Frist, welche am Tag beginnt, an dem die Ladung
verschickt wird.

(2) Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter findet einmal jährlich innerhalb von zwei Wochen nach Fer-

tigstellung des Jahresabschlusses am Sitz der Gesellschaft statt. Darüber hinaus werden außerordentliche Gesellschafter-
versammlungen  einberufen,  wenn  die  Interessen  der  Gesellschaft  dies  erfordern  oder  die  Gesellschafter,  die
gemeinschaftlich über mindestens 10 % des Stammkapitals verfügen, dies beantragen.

(3) Zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit werden Protokolle der Gesellschafterversammlungen geführt und archiviert,

die insbesondere Angaben zu Ort und Datum der Versammlung, den Teilnehmern, den Tagesordnungspunkten, allen
Anträgen, Abstimmungsergebnissen, sowie allen Gesellschafterbeschlüssen enthalten. Das Protokoll wird vom Vorsit-
zenden unterzeichnet. Jeder Gesellschafter erhält eine Kopie des Protokolls innerhalb eines Monats nach der Gesell-
schafterversammlung.

§ 9. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Falls die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht übersteigt, können ihre Entscheidungen durch Zirkular-

beschluss gefasst werden, dessen Text schriftlich, sei es im Original oder über Faksimile oder Email, an alle Gesellschafter
geschickt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme durch Unterzeichnung des Zirkularbeschlusses ab. Die Unter-
schriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden
Beschlusses geleistet werden, und per Brief oder per Faksimile bescheinigt werden.

(2)  Kollektivbeschlüsse  sind  nur  gültig,  wenn  sie  von  Gesellschaftern  gefasst  werden,  die  mehr  als  die  Hälfte  des

Stammkapitals halten.

(3) Ungeachtet dessen können diese Satzung ändernde Beschlüsse oder Beschlüsse zur Auflösung und Liquidation der

Gesellschaft nur mit der Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Ge-
sellschaft halten, gefasst werden.

(4) Ein Gesellschafter kann in einer Gesellschafterversammlung von einem anderen Gesellschafter oder einem Rechts-

oder Steuerberater, der der beruflichen Schweigepflicht unterliegt, vertreten oder begleitet werden.

E. Jahresabschlüsse, Verwendung der Ergebnisse

§ 10. Jahresabschlüsse. Der Jahresabschluss (Bilanzaufstellung, Anhang zur Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung) und

ein Lagebericht der Geschäftsführung für das vergangene Geschäftsjahr werden von den Geschäftsführern innerhalb der
gesetzlichen Fristen erstellt und den Rechnungskommissaren zur Prüfung zugestellt, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist.

37364

L

U X E M B O U R G

§ 11. Gewinnverteilung.
(1) Die Geschäftsführung legt allen Gesellschaftern den Jahresabschluss, jeden Lagebericht der Geschäftsführung und

jeden Bericht der Rechnungskommissare gemeinsam mit einem Vorschlag zur Verwendung der Ergebnisse vor.

(2) Der in den Jahresabschlüssen aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft stellt nach Abzug der Allgemeinkosten,

Tilgungen und Kosten, den Nettogewinn dar. Ein Betrag von fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft wird
der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent (10 %) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

(3) In der Hauptversammlung der Gesellschafter wird über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Ver-

wendung des Überschusses innerhalb der gesetzlichen Fristen entschieden. Gegebenenfalls wird der jährlich erwirtschaf-
tete Überschuss vorgetragen, wenn die Gesellschafter nicht eine andere Verwendung der Überschüsse beschließen.

(4) Jederzeit können Zwischendividenden unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) Ein Kontenauszug oder ein Inventar oder Bericht wird vom Geschäftsführer oder Geschäftsführungsrat erstellt;
(ii) Dieser Kontenauszug, dieses Inventar oder dieser Bericht zeigen, dass genügend Geldmittel zur Ausschüttung zur

Verfügung stehen; wohlverstanden darf der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäfts-
jahres realisierten Gewinne, zuzüglich der vorgetragenen Gewinne und der ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich
der vorgetragenen Verluste und der Beträge, die der gesetzlichen Rücklage zuzuführen sind, nicht übersteigen;

(iii) Die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird vom einzigen Gesellschafter oder von der Haupt-

versammlung der Gesellschafter getroffen, und

(iv) Eine Zusicherung wurde gegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.

F. Veräußerung von Anteilen

§ 12. Veräußerung von Anteilen.
(1) Bis zum 31. Dezember 2019 darf kein Gesellschafter, der zum Zeitpunkt eines Angebots zu einer Anteilsübertragung

weniger als 10 % der Gesellschaftsanteile hält (Minderheitsgesellschafter), seine Anteile oder Teile dieser übertragen oder
verpfänden.

(2) Nach dem 31. Dezember 2019 bleibt die teilweise Anteilsübertragung durch den Minderheitsgesellschafter un-

tersagt,  während  die  Übertragung  sämtlicher  Anteile  des  Minderheitsgesellschafters  oder  deren  Verpfändung  der
Zustimmung aller Gesellschafter bedarf. Von den Bestimmungen dieses § 12 (2) ausgenommen sind Veräußerungen an
andere Gesellschafter, sowie Veräußerungen, die aus der Durchsetzung von Verpfändungen zur Sicherung der von der
Gesellschaft zur Finanzierung des Erwerbs von Immobilien getätigten Kreditverträge, resultieren.

(3) Die in den Artikeln §12 (1) und (2) enthaltenen Regelungen sind auch auf die Gewährung oder Umgestaltung eines

Nutzungsrechts oder einer Unterbeteiligung sowie die Schaffung oder Umgestaltung eines Treuhandverhältnisses an den
von Minderheitsgesellschaftern gehaltenen Anteilen entsprechend anzuwenden.

§ 13. Drag Along Right (Mitverkaufspflicht). Wenn Gesellschafter, die einzeln oder gemeinschaftlich mindestens 50 %

des Gesellschaftskapitals halten (die Mehrheitsgesellschafter), einem oder mehreren Dritten (dem vorgeschlagenen Er-
werber) anbieten, ihm sämtliche Anteile zu verkaufen, können die Mehrheitsgesellschafter die anderen Gesellschafter
ersuchen ihre Anteile - nach Wahl der ersuchenden Gesellschafter - im Wege des Verkauf, des Tauschs, der Übertragung,
der Einbringung oder der Umwandlung (z.B. durch Zusammenschluss) dem vorgeschlagenen Erwerber zu einem Preis zu
überlassen, der mindestens dem Preis entspricht, den der vorgeschlagene Dritte an die Mehrheitsgesellschafter entrichtet.

§ 14. Erwerbsrecht und Vorkaufsrecht.
(1)  Beabsichtigt  der  Minderheitsgesellschafter  sämtliche  seiner Anteile oder Teile  seiner Anteile (nachfolgend: die

Minderheitenanteile) einer dritten Partei, die kein Gesellschafter oder mit einem Gesellschafter verbundene Rechtsper-
sönlichkeit ist, zu veräußern, so haben die Mehrheitsgesellschafter ein Kaufrecht gemäß den nachfolgenden Regelungen.

(2) Der Minderheitsgesellschafter muss die Minderheitenanteile zunächst den Mehrheitsgesellschaftern zum Erwerb

anbieten, indem er ihnen durch eingeschriebenen Brief die vorgeschlagenen Käufer (einschließlich Name/Name der Ge-
sellschaft, Adresse und gegebenenfalls Informationen über die Handelsregistereintragung), den Preis und die anderen
Konditionen der Veräußerung mitteilten und gleichzeitig die Gesellschaft schriftlich über ihre Veräußerungsabsicht in-
formiert.  Sollten  die  Mehrheitsgesellschafter  beabsichtigen,  die  angebotenen  Minderheitenanteile  zu  den  mitgeteilten
Konditionen zu erwerben, haben sie dies innerhalb von zwei Wochen nach Empfang des Angebots durch eingeschriebenen
Brief  (die  Annahme)  den  Minderheitsgesellschaftern  mitzuteilen  und  der  Gesellschaft  dies  schriftlich  anzuzeigen.  Die
Mehrheitsgesellschafter dürfen in ihrer Annahme eine dritte Partei benennen, die willens ist, die Minderheitenanteile an
ihrer Stelle zu erwerben.

(3) Das Recht zum Erwerb kann nur für die Gesamtheit der zur Veräußerung angebotenen Gesellschaftsanteile aus-

geübt werden.

(4) Der Verkauf und die Zuteilung der Minderheitenanteile müssen innerhalb von 2 Wochen nach Ablauf der Frist zur

Annahme des Angebots, gemäß obigem Absatz (2), erfolgen.

37365

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

§ 15. Liquidation.
(1) Nach der Auflösung der Gesellschaft wird diese abgewickelt. Die Liquidation wird von einem oder mehreren

Liquidatoren, die nicht auch Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Sie werden, unter gleichzeitiger Festlegung ihrer
Befugnisse und Entlohnung, durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschaf-
ter benannt. Vorbehaltlich einer anderen Regelung im Gesetz oder im Beschluss des oder der Gesellschafter sind die
Liquidatoren mit den am weitesten gehenden Befugnissen für die Realisierung der Vermögenswerte und die Zahlung der
Verpflichtungen der Gesellschaft versehen.

(2) Vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung durch die Gesellschafter, wird der Überschuss aus der Realisierung der

Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft den Gesellschaftern im Verhältnis zu der Anzahl der
Anteile, die sie an der Gesellschaft halten, ausgezahlt.

H. Allgemeine Bestimmungen

§ 16. Anwendbares Recht. Sofern in der vorliegenden Satzung keine speziellen Regelungen vorsehen, wird auf das

Gesetz über die Handelsgesellschaften verwiesen.

Nach Erledigung der Tagesordnung ist die Sitzung geschlossen.

<i>Voraussichtliche kosten

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft wegen ihrer Gründung zu tragen

sind, werden auf ungefähr eintausend einhundert euro (EUR 1.100) geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der vor-

stehenden Komparenten gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache abgefasst ist, gefolgt von einer Fassung in deutscher
Sprache, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung
entscheidend ist.

ZU URKUNDE DESSEN, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Und nach Verlesung dieser Urkunde an den Bevollmächtigten der Komparenten, welcher dem Notar bekannt ist mit

seinem Familiennamen, Vornamen, Stand und Wohnort, hat dieser Bevollmächtigte zusammen mit Uns Notar gegen-
wärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: FEYEREISEN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 janvier 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 1975. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025413/621.
(150029001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Digital Services XLIII (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.490.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XLIII S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law,

having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 23 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

37366

L

U X E M B O U R G

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XLIII (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

37367

L

U X E M B O U R G

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

37368

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by  the remaining managers  until  the next meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,

37369

L

U X E M B O U R G

if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,

37370

L

U X E M B O U R G

the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XLIII S.àr.l., afore-

mentioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XLIII S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

37371

L

U X E M B O U R G

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 23.

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XLIII (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

37372

L

U X E M B O U R G

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

37373

L

U X E M B O U R G

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

37374

L

U X E M B O U R G

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

37375

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XLIII S.àr.l. vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

37376

L

U X E M B O U R G

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800,- geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2449. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015025824/589.
(150029539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Fondation Ste Zithe, Fondation.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 32, rue Ste Zithe.

R.C.S. Luxembourg G 69.

<i>Comptes annuels et rapport du reviseur d'entreprises agrée

<i>31 décembre 2014

<i>Table des matières

Pages

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2

COMPTES ANNUELS
- Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4

- Compte de profits et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

- Annexes aux comptes annuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6- 13

<i>Bilan au 31 décembre 2014

ACTIF

Notes

31.12.2014

EUR

31.12.2013

EUR

C. ACTIF IMMOBILISE
III. Immobilisations financières

37377

L

U X E M B O U R G

1. Parts dans des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2

1,00

1,00

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

1,00

D. ACTIF CIRCULANT
III. Valeurs mobilières
3. Autres valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5/3.3 1.444.113,86

704.069,74

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux,
chèques et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4

467.281,54 1.161.976,90

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.911.395,40 1.866.046,64

E. COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.a

423,93

0,00

charges à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

423,93

0,00

TOTAL DE L'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.911.820,33 1.866.047,64

<i>Bilan au 31 décembre 2014

PASSIF

Notes

31.12.2014

EUR

31.12.2013

EUR

A. CAPITAUX PROPRES
I. Fonds sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000,00

25.000,00

IV. Réserves
3. Réserves - fonds dédiés sur dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1/2.7/3.8

566.066,32

536.480,85

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6/3.5 1.275.000,00 1.275.000,00

VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.974,58

13.963,49

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.875.040,90 1.850.444,34

D. DETTES NON SUBORDONNEES
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
a) Dettes fiscales - impôts, taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6

117,45

1.107,82

9. Autres dettes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . .

3.7

36.661,98

14.495,48

TOTAL DES DETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.779,43

15.603,30

E. COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.911.820,33 1.866.047,64

<i>Compte de profits et pertes pour l'exercice allant du 1 

<i>er

<i> janvier 2014 au 31 décembre 2014

Notes

2014

(01.01.2014-

31.12.2014)

EUR

2013

(01.01.2013-

31.12.2013)

EUR

A. CHARGES
1. Consommation de marchandises et de matières premières
consommables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

2. Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3

18.921,03

12.667,97

4. Corrections de valeur
b) sur éléments de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3/4.2

9.870,00

2.490,45

5. Autres charges d'exploitation - dépenses pour projets statutaires . . . . . . . . .

4.3.a

634.155,75

665.665,77

- libéralités qui consistent dans la fourniture gratuite d'appareils médicaux . . . .

3.8

47.761,13

0,00

7. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments financiers
de l'actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières . . . . . . . . .

3.3

2.752,95

5.506,67

8. Intérêts et autres charges financières
b) autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4

1,80

0,00

9. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5

174,37

174,37

11. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6

117,45

1.107,82

12. Profit de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.974,58

13.963,49

TOTAL DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

722.729,06

701.576,54

B. PRODUITS
5. Autres produits d'exploitation - produits d'utilisation des dons . . . . . . . . . . . 3.8/4.6

499.923,36

527.191,24

- libéralités en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8/4.6

47.761,13

0,00

37378

L

U X E M B O U R G

6. Reprise sur fonds pour projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8

134.232,39

138.474,53

7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant
b) autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7

37.474,49

33.687,50

8. Autres intérêts et autres produits financiers
b) autres intérêts et produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7.a

3.337,69

2.223,27

9. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

10. Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

TOTAL DES PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

722.729,06

701.576,54

Les notes en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

Annexes aux comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2014

1. Généralités. La Fondation Sainte Zithe («la Fondation»), établissement d'utilité publique, a été constituée le 28

décembre 1994 pour une durée illimitée.

Son capital est de 25.000 EUR.
La Fondation a pour objet (extrait des statuts coordonnés du 7 juin 2006):
«...
a)  Die  umfassende  Versorgung  aller  in  Luxemburg  wie  im  Ausland  lebenden  Schwestern,  die  der  Kongregation

"Schwestern Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel" mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 32, rue Sainte Zithe, (nachfolgend
"die Kongregation" genannt) angehören.

Hierzu gehört die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Lebensraumes, Aus-und Weiterbildung, Behandlung und

Verpflegung  in  Krankheit  und  Alter  sowie  die  Voraussetzungen  für  ein  religiöses  Leben  in  Gemeinschaft  gemäß  den
Satzungen der Kongregation.

b) Die Förderung der Krankenhaus-, Alten- und Betreuungseinrichtungen, die im Sinne der Gründer der Kongregation

fortzuführen sind.

In Afrika, insbesondere in Malawi, gehört neben der Gesundheitsversorgung umfassende Entwicklungsarbeit zu den

Aufgaben der Kongregation. Hierzu sind Maßnahmen gegen Hunger und Unterernährung sowie Bildungsarbeit und Ge-
sundheitsvorsorge zu rechnen.

Die Stiftung soll unbeschadet ihrer Aktivitäten im Ausland dauerhaft karitative Aufgaben in Luxemburg wahrnehmen.
c) Die Förderung eines religiösen, kulturellen und sozialen Rahmens für alte, verlassene oder notleidende Personen.
d) Die Unterstützung aller Projekte oder Initiativen, die diesen Tätigkeitsbereichen entsprechen.
...»

2. Principes, règles et méthodes comptables.
2.1. Généralités
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg.

Les politiques comptables et les principes d'évaluation sont, en dehors des règles imposées par la loi, déterminés et mis
en place par le Conseil d'Administration.

Les recettes et les dépenses relatives aux projets humanitaires de la Fondation sont reprises en autres produits d'ex-

ploitation respectivement en autres charges d'exploitation.

L'excédent des recettes relatives aux projets de la Fondation est repris dans le compte de réserves - fonds dédiés sur

dons, au passif du bilan.

Nous renvoyons à la note 3.8. relative au compte de réserves qui détaille les recettes et dépenses de 2014 ainsi que

le cumul au 1er janvier 2014; note qui permet la comparabilité directe de l'excédent des fonds dédiés sur dons entre les
exercices 2013 et 2014.

2.2. Périmètre comptable
Les présents comptes annuels représentent exclusivement les comptes annuels de la «Fondation Ste Zithe».
Ainsi les activités imputables à des personnes et/ou structures annexes existant sous la forme de fondation, d'asso-

ciation ou autres (amicales par exemple) et n'entrant pas directement dans le cadre de la «Fondation Ste Zithe» sont
exclues des présents comptes annuels.

2.3. Devises
Les comptes de la Fondation sont établis en Euro (EUR).
Les avoirs et les dettes libellés en devises étrangères sont convertis en Euro au cours de change en vigueur au moment

de la transaction. L'omission de leur évaluation au cours de change en vigueur à la clôture de l'exercice n'a pas d'effet
significatif sur les comptes.

Les produits et les charges en devises étrangères sont convertis en Euro au cours de change en vigueur au moment

de la transaction. Les gains et les pertes de change résultant de leur règlement sont comptabilisés dans le compte de
profits et pertes.

37379

L

U X E M B O U R G

2.4. Créances
Les créances figurent à l'actif du bilan à leur valeur nominale.
S'il devient évident que le montant récupérable est inférieur à la valeur nominale, la réduction de valeur y afférente

est comptabilisée en compte de profits et pertes.

2.5. Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont évaluées au plus bas de leur coût d'acquisition, incluant les frais accessoires, et de leur

valeur de marché, exprimée dans la devise de préparation des comptes annuels. Une correction de valeur est enregistrée
lorsque le prix du marché est inférieur au prix d'acquisition. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque
les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d'exister.

Les revenus d'intérêts sur obligations détenues en portefeuille sont enregistrés à la date d'encaissement du coupon.

Les intérêts courus non échus sur obligations détenues en portefeuille ne sont donc pas comptabilisés à la date de clôture
au 31 décembre de chaque année.

2.6. Résultats reportés
Les résultats (bénéfices et pertes) générés par la Fondation ont été reportés à nouveau au passif du bilan. Toutefois,

au début de l'exercice 2013 le montant de 13.963,49 EUR a été affecté aux fonds dédiés sur dons (voir note 3.5.).

2.7. Fonds dédiés
Les fonds dédiés sont renseignés à leur valeur nominale et correspondent aux dons reçus. Les dons reçus au cours

de l'exercice pour lesquels des dépenses sont engagées au cours de l'exercice seront repris dans les autres produits
d'exploitation. Pour les dons reçus dont des dépenses ne sont pas reconnues dans l'exercice en cours, la reprise de ces
dons sera reconnue dans les comptes reprise sur fonds pour projets des exercices postérieurs.

2.8. Dettes
Les dettes de la Fondation sont reprises au passif du bilan à leur valeur nominale.

3. Détail des postes du bilan.
3.1. Généralités
Avec un total bilantaire de 1.911.820,33 EUR, la Fondation génère un bénéfice de l'exercice de 8.974,58 EUR.
3.2. Participations
En date du 31 décembre 2007, la Fondation a reçu donation de 350 actions de la Congrégation des Sœurs du Tiers

Ordre Régulier de Notre Dame du Mont Carmel S.A.. Ces actions ont fait l'objet d'une comptabilisation avec une valeur
symbolique de 1,00 EUR dans les présents comptes annuels.

3.3. Valeurs mobilières
La  Fondation  détient  un  portefeuille  d'obligations  cotées.  En  date  du  16  janvier  2014  un  titre  d'un  montant  de

250.000,00 EUR a été remboursé par l'émetteur. Le montant en question a été versé au compte épargne. Des prélève-
ments d'un montant total de 1.000.176,62 EUR ont été opérés en date du 23.05.2014, 23.09.2014 et 30.09.2014. La
somme en question a été investie dans des titres cotés à la bourse. Le détail des titres se décompose comme suit:

31.12.2014

31.12.2013

Prix d'acquisition au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

706.560,19

962.066,86

Acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.176,62

0,00

Ventes / cessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (250.000,00) (250.000,00)
Moins-value de cession (titre remboursé en 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2.752,95)

(5.506,67)

Prix d'acquisition à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.453.983,86

706.560,19

Corrections de valeur au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2.490,45)

0,00

Corrections de valeur de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9.870,00)

(2.490,45)

Reprise de corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.490,45

0,00

Corrections de valeur à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9.870,00)

(2.490,45)

Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.444.113,86

704.069,74

La valeur de marché des valeurs mobilières s'élève à 1.492.998,98 EUR au 31 décembre 2014 (735.182,50 EUR au 31

décembre 2013). La plus-value latente correspondante (39.015,12 EUR au 31 décembre 2014) n'a pas été enregistrée
dans les comptes eu égard au principe de prudence.

3.4. Avoirs en banques, avoirs en CCP, chèques et en caisse
Le détail des «avoirs en banques, avoirs en CCP, chèques et en caisse» au 31 décembre 2014 se décompose comme

suit:

31.12.2014

31.12.2013

Comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.366,07

4.865,16

Comptes épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450.915,47 1.157.111,74

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

467.281,54 1.161.976,90

3.4. a Compte de régularisation actif

37380

L

U X E M B O U R G

Le compte de régularisation actif correspond à une facture pour un montant de 423,93 EUR comptabilisée au cours

de l'exercice 2014 mais se rapportant à l'exercice 2015.

3.5. Résultats reportés
L'évolution du solde du compte «Résultats reportés» au cours des deux derniers exercices se présente de la façon

suivante (voir note 2.6.):

31.12.2014

31.12.2013

Résultats reportés à l'ouverture de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.275.000,00 1.275.000,00
Résultat de l'exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.963,49

25.762,23

Somme affectée aux fonds dédiés pour projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(13.963,49)

(25.762,23)

Résultats à reporter à la clôture de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.275.000,00 1.275.000,00

Suivant décision du Conseil d'Administration le capital qui doit être à disposition de façon permanente à la Fondation

a été fixé à 1.300.000,00 EUR (compte non tenu des réserves - fonds dédiés sur dons). Pour cette raison l'excédent, soit
13.963,49 EUR, a été libéré pour financer des projets.

3.6. Dettes fiscales
Les dettes fiscales correspondent au montant de la TVA due à l'Administration de l'Enregistrement pour l'acquisition

intracommunautaire de biens faite par la Fondation au cours de l'exercice 2014.

3.7. Autres dettes
Le poste des «Autres dettes» au 31 décembre 2014 correspond à des factures reçues ou à recevoir et impayées à

cette date.

Aucune des dettes reprises sous le poste des «Autres dettes» n'est garantie par des sûretés réelles.
Par ailleurs, la Fondation n'a pas, au 31 décembre 2014, d'«Autres dettes» dont la durée résiduelle est supérieure à

cinq ans.

3.8. Comptes de réserves - fonds dédiés sur dons
L'évolution du solde du «Compte de réserves - fonds dédiés sur dons» au cours des deux derniers exercices se

présente de la façon suivante:

Projets

au

Malawi

Projets

au

Luxembourg

Total

Situation au 1 

er

 janvier 2014

456.190,78

80.290,07

536.480,85

Dons reçus au cours de l'exercice 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406.498,85

75.094,44

481.593,29

Legs reçus au cours de l'exercice 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168.184,44

0,00

168.184,44

Libéralités en nature reçues au cours de l'exercice 2014 . . . . . . . . . . . . .

47.761,13

0,00

47.761,13

Reprises des fonds dédiées 2013
pour couvrir les dépenses de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (127.667,79)

(6.564,60) (134.232,39)

Reprises des fonds dédiées reçus en 2014
pour couvrir les dépenses de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (482.470,46)

(17.452,90) (499.923,36)

Affectation des libéralités en nature reçues en 2014
(fourniture gratuite d'appareils médicaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(47.761,13)

0,00

(47.761,13)

Somme affectée aux fonds dédiés pour projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.963,49

0,00

13.963,49

Solde à la clôture au 31 décembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

434.699,31

131.367,01

566.066,32

La composition des fonds dédiés au 31 décembre 2014 se décompose de la manière suivante:

Projets

au

Malawi

Projets

au

Luxembourg

Total

Fonds dédiés jusqu'à 2012 au 31 décembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.253,33

13.658,76

21.912,09

Fonds dédiés jusqu'à 2013 au 31 décembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.269,66

60.066,71

380.336,37

Fonds dédiés 2014 au 31 décembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.176,32

57.641,54

163.817,86

Solde à la clôture au 31 décembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

434.699,31

131.367,01

566.066,32

4. Détail des postes du compte de profits et pertes.
4.1. Frais de personnel
Les frais de personnel représentant les salaires versés à trois médecins exerçant à l'hôpital St Gabriel au Malawi, sont

comptabilisés dans les charges d'exploitation relatives aux projets (voir note 3.7.).

Ces personnes exerçant à l'étranger, elles ne relèvent pas de la sécurité sociale luxembourgeoise. Leurs salaires n'ont,

à ce titre, pas fait l'objet de prélèvements sociaux au Luxembourg.

37381

L

U X E M B O U R G

4.2. Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant
Pour l'exercice 2014 une correction de valeur de 9.870,00 EUR a été enregistrée pour les valeurs mobilières, du fait

qu'au 31.12.2014 le prix du marché d'un fonds détenu en portefeuille était inférieur au prix d'acquisition (voir à ce sujet
la note 3.3.).

4.3. Autres charges externes
Les autres charges externes correspondent aux frais et commissions bancaires, aux honoraires du réviseur, aux coti-

sations, etc....

4.3. a Autres charges d'exploitation
Les autres charges d'exploitation se composent des projets statutaires au Malawi et au Luxembourg financés par la

Fondation (voir note 3.8.).

Les libéralités pour un montant de 47.761,13 EUR consistent principalement dans la fourniture gratuite d'appareils

médicaux mis en service dans le St. Gabriel's Hospital à Namitete, Malawi.

4.4. Intérêts et charges assimilées
Les intérêts et charges assimilées correspondent aux charges financières relatives aux comptes courants bancaires.
4.5. Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles pour un montant de 174,37 EUR se composent principalement de charges relatives à

l'exercice 2013.

4.6. Autres produits d'exploitation
Les autres produits d'exploitation se composent de dons utilisés pour des projets (voir note 3.8.).
Le montant de 47.761,13 EUR correspond aux libéralités en nature reçues en 2014.
4.7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant
Les produits des éléments financiers de l'actif circulant correspondent aux intérêts créditeurs perçus sur les valeurs

mobilières.

4.7.a Autres intérêts et autres produits financiers
Les intérêts et produits financiers correspondent aux intérêts créditeurs perçus sur les comptes bancaires.

5. Engagements hors bilan. Au 31 décembre 2014, il n'existe aucun engagement hors-bilan.

6. Evénements postérieurs a la clôture. Il n'y a pas d'événements postérieurs à la clôture et susceptibles d'avoir une

influence sur les comptes de la Fondation.

<i>Budget 2015

Montants

en EUR

Projets en voie de réalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859.000,00
Charges externes, charges de comptes et frais financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.500,00

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873.500,00
Produits divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517.000,00
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000,00

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.000,00

<i>Membres du Conseil d'Administration

Soeur Brigitte, née Brigitte Schneiders, Supérieure Générale, Luxembourg, présidente
Soeur Wilfrieda, née Elisabeth Hoffmann, Assistante Générale, Luxembourg, vice-présidente
Soeur docteur Myriam, née Margareta Ney, membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxem-

bourg, trésorerie,

Soeur Françoise, née Fanny Koedinger, membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,
Soeur Michèle, née Josette Koedinger, membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,
Monsieur le professeur docteur Ernest Gillen, membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Lu-

xembourg,

Monsieur Pit Hentgen membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,
Monsieur Michel Wurth, membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,
Monsieur Guy Schleder membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,

37382

L

U X E M B O U R G

Etabli à Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Dr Hans Jürgen GOETZKE / Soeur Brigitte SCHNEIDERS
<i>Directeur général / Présidente

Référence de publication: 2015025012/291.
(150029049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

AVL Investments S.A., SPF, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 190.122.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of December,
Before Us, Maître Heri Hellinckx, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of AVL Investments S.A., SPF, société anonyme

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which registered office is located at 4, rue
Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under registration number B 190.122 (the “Company”), incorporated by a deed of undersigned notary on 14
August 2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3092 of October 24, 2014.

The Meeting was opened with Mrs. Maria TKACHENKO, director, residing in Luxembourg, being in the chair (the

“Chairman”).

The  chairman  appointed  as  secretary  and  the  Meeting  elected  as  scrutineer  Mrs  Arlette  SIEBENALER,  employee

residing professionally in Luxembourg.

The Board of Meeting having been validly constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is as follows (the “Agenda”)

<i>Agenda

1. Change the currency of the share capital of the Company from EUR to USD.
2. Fix the nominal value of the shares at USD 1.34 (one US dollars and thirty four cents) for 1 EUR (one Euro) the

official exchange rate of the European Central Bank on 14 

th

 August 2014 (the date of the incorporation of the Company)

rounded down to two decimal places

3. Increase of the share capital of the Company by contribution in cash;
4. Issue of new shares -- subscription to the new shares and related payment;
5. Amendment to Article 5 of the Company’s articles of association so as to reflect the items 1 to 4 above
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of

their shares are shown on an attendance list (the “Attendance List”). This Attendance List, which has been duly signed
by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the Board of the Meeting, will remain annexed
to the present deed in order to be filed with it at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, which have been initialled “ne varietur” by the proxyholders, shall also

remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital of the Company being present or represented at the present Meeting, and the sha-

reholders present or represented declaring that he has had due notice and due knowledge of the Agenda prior to this
Meeting, no convening notice was necessary.

IV. That, as a consequence of the entire share capital of the Company being present or represented, the present

Meeting is regularly constituted and may therefore validly deliberate on all of the items composing the Agenda,

After having duly considered the items set out in the Agenda, the Meeting unanimously adopted the following reso-

lutions:

<i>First resolution

The Meeting converts, with effect from the 14 

th

 August 2014, the currency of the share capital of the Company from

EUR to USD, on the basis of the exchange rate displayed on the 14 

th

 August 2014 (the date of the incorporation of the

Company) on the website of the European Central Bank rounded down to two decimal places, which is set at EUR (one
Euro) for USD 1.34. (one US Dollar and thirty four cents).

As a consequence, the Meeting resolves that articles 5.1.1 of the Articles shall be amended and shall read as set forth

in the fifth resolution below (as further amended in the following resolutions).

37383

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Meeting resolves, that following the conversion of the currency, the share capital consequently is set at forty one

thousand five hundred and forty US Dollars (USD 41,540) represented by 31 000 (thirty one thousand) shares having a
par value of one US Dollar and thirty four cents (USD 1.34) each which are allocated to the existing shareholder.

As a consequence, the Meeting resolves that article 5.1.1 of the Articles shall be amended and shall read as set forth

in the fifth resolution below (as further amended in the following resolutions).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by a total amount of four hundred and eighty one

thousand five hundred US dollars and eighty-six cents (481 500.86 USD) in order to bring it from its current amount of
forty one thousand five hundred and forty US Dollars (USD 41 540) represented by 31 000 (thirty one thousand) shares
having a par value of one US Dollar and thirty four cents (USD 1.34) each up to a new amount of five hundred and twenty
three thousand and forty US dollars and eighty-six cents (523 040.86 USD) represented by three hundred and ninety
thousand three hundred and twenty nine (390 329) shares with a nominal value of one US Dollar and thirty four cents
(1.34 USD) each.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to issue three hundred and fifty nine thousand three hundred and twenty nine (359 329) new

shares with a nominal value of one US Dollar and thirty four cents (1.34 USD) each, having the same rights and obligations
of the existing shares.

<i>Subscription and payment

The Meeting resolves to accept the subscription by the existing shareholder, here represented by Mrs Maria TKA-

CHENKO, prenamed, by virtue of a proxy hereto attached, of all the three hundred and fifty nine thousand three hundred
and twenty nine (359 329) new shares with a nominal value of one US Dollar and thirty four cents (1.34 USD) each, being
issued for a total subscription price of four hundred and eighty one thousand five hundred US dollars and 86 cents (481
500.86 USD) paid up by a contribution in cash of four hundred and eighty one thousand five hundred US dollars and
eighty-six cents (481 500.86 USD)

The proof of both the existence and the value of the total cash contribution by the sole subscriber to the Company

as consideration for his subscription for three hundred and fifty nine thousand three hundred and twenty nine (359 329)
new shares of the Company has been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Fifth resolution

In order to reflect the capital increases here above resolved, the Meeting resolves to amend Article 5.1.1 of the

Company’s articles of association which reads as follows:

“ Art. 5.1.1. The Company’s issued share capital is set at five hundred and twenty three thousand and forty US dollars

and eighty-six cents (523 040.86 USD) represented by three hundred and ninety thousand three hundred and twenty
nine (390 329) shares with a nominal value of one US Dollar and thirty four cents (1.34 USD) each

<i>Expenses - Valuation

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at EUR 2,500.-.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person duly represented by the proxyholder, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request
of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will
prevail.

The document having been read to the appearing person duly represented by the proxyholder, known to the notary

by his name, first name, civil status and residence, this person signed this deed with the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf de décembre
Par-devant Nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

S’est tenue

l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique (l’«Assemblée») de la société AVL Investments S.A., SPF,

une société dûment constituée sous la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), immatriculée auprès du Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.122, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 14 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3092 du 24 octobre 2014.

37384

L

U X E M B O U R G

L’Assemblée a été ouverte sous la présidence de Madame Maria TKACHENKO, demeurant professionnellement à

Luxembourg (le «Président»).

Le Président a désigné comme secrétaire et l’Assemblée a désigné o comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler,

employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le Bureau valablement constitué, le Président a déclaré et demandé au notaire d’établir:
I. Que l’agenda de l’Assemblée est le suivant (l’«Ordre du Jour»):

<i>Ordre du jour

1. Changer la devise du capital social de la Société d’Euros en Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD);
2. Fixer la valeur nominale des actions à 1,34 USD (un Dollars des Etats-Unis d’Amérique et trente-quatre cents) pour

1 EUR (un euro) au taux de change officiel de la Banque centrale Européenne du 14 août 2014;(la date de la constitution
de la Société) arrondi à deux décimales.

3. Augmentation du capital social de la Société par apport en espèces.
4. Emission des actions nouvelles- souscription des actions et libération.
5. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications mentionnées aux points (1) à

(4) ci-dessus.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre de leurs

actions sont répertoriés dans une feuille de présence (la «Feuille de Présence»), Cette Feuille de Présence, dûment signée
par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et le Bureau, sera annexée au présent acte afin d’être
enregistrée concomitamment par les autorités compétentes.

Les procurations des actionnaires représentées, paraphées “ne varietur” par les parties comparantes, seront également

annexes au présent acte.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, et que les actionnaires

présents ou représentés ayant déclaré qu'ils avaient été dûment notifiés et qu'ils avaient pris connaissance de l’Ordre du
Jour préalablement à l’Assemblée, aucune convocation n’était nécessaire.

IV. Que du fait que l’intégralité du capital social de la Société soit représentée à la présente Assemblée, celle-ci est

régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer sur tous les points de l’Ordre du Jour.

Après avoir dûment pris connaissance des points de l’Ordre du Jour, l’Assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de convertir, avec effet au 14 août 2014, la devise du capital social de la Société afin de la faire

passer de l’Euro au Dollar des Etats-Unis d’Amérique, sur la base du taux de change indiqué à la date du 14 août 2014
(la date de la constitution de la Société) sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne arrondi à deux décimales,
selon lequel EUR 1,- (un euro) équivaut à USD 1,34 (un Dollar des Etats-Unis d’Amérique et trente-quatre cents).

En conséquence, l’Assemblée décide que l’article 5.1.1. des statuts est modifiée et doit se lire comme indiqué dans le

cinquième résolution ci-dessous (tel que modifié par les résolutions suivantes).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide, qu'à la suite de la conversion de la devise, le capital social est fixé à 41.540,-USD (quarante et un

mille cinq cent quarante Dollars des Etats-Unis d’Amérique), représenté par 31.000 (trente et une mille) actions ayant
une valeur nominale d’un Dollar des Etats-Unis d’Amérique et trente-quatre cents (USD 1.34) chacune, toutes entière-
ment détenues par l’Action Unique.

En conséquence, l’Assemblée décide que l’article 5.1.1 des statuts est modifié et doit se lire comme indiqué dans la

cinquième résolution ci-dessous (tel que modifié par les résolutions suivantes).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 481 500,86, USD (quatre cent quatre-

vingt-un mille cinq cents Dollars des Etats-Unis d’Amérique et quatre-vingt-six cents) afin de le porter de son montant
actuel de 41.540,-USD (quarante et un mille cinq cent quarante Dollars des Etats-Unis d’Amérique) représenté par 31.000
(trente et un mille) actions ayant chacune une valeur nominale d’un Dollar des Etats-Unis d’Amérique et trente-quatre
cents (USD 1.34) à 523 040,86,- USD (cinq cent vingt-trois mille quarante Dollars des Etats-Unis d’Amérique et quatre
vingt-six cents) représenté par 390 329 (trois cents quatre vingt dix mille trois cents vingt neuf) actions ayant chacune
une valeur nominale d’un Dollar des Etats-Unis d’Amérique et trente-quatre cents (USD 1.34).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée a décidé de l’émission par la Société de 359 329 (trois cent cinquante neuf mille trois cents vingt neuf)

actions nouvelles d’une valeur nominale d’un Dollar des Etats-Unis d’Amérique et trente-quatre cents (USD 1.34). cha-
cune, ayant les même droits et obligations que les actions existantes.

37385

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

L’Assemblée accepte à la souscription des trois cent cinquante-neuf mille trois cent vingt-neuf (359.329) actions nou-

velles  d’une  valeur  nominale  d’un  Dollar  des  Etats-Unis  d’Amérique  et  trente-quatre  cents  (USD  1.34)  l’actionnaire
existant, ici représenté par Madame Maria TKACHENKO, prénommée, en vertu d’une procuration ci-annexée, pour un
prix de souscription de 481 500,86, USD (quatre cent quatre-vingt-un mille cinq cents Dollars des Etats-Unis d’Amérique
et quatre-vingt-six cents) entièrement libéré par un apport en numéraire de 481 500,86, USD (quatre cent quatre-vingt-
un mille cinq cents Dollars des Etats-Unis d’Amérique et quatre-vingt-six cents).

La preuve du paiement en numéraire par le souscripteur en contrepartie de la souscription de trois cent cinquante-

neuf  mille  trois  cent  vingt-neuf  (359.329)  actions  nouvelles  a  été  rapportée  au  notaire  soussigné  qui  le  constate
expressément.

<i>Cinquième résolution

Afin de refléter l’augmentation du capital social de la Société ci-avant décidée, l’Assemblée a décidé de modifier l’article

5.1.1. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

« Art. 5.1.1. La Société a un capital social émis de 523 040,86,- USD (cinq cent vingt-trois mille quarante Dollars des

Etats-Unis d’Amérique et quatre vingt-six cents) représenté par 390 329 (trois cent quatre vingt dix mille trois cent vingt
neuf) actions ayant chacune une valeur nominale d’un Dollar des Etats-Unis d’Amérique et trente-quatre cents (USD
1.34).

<i>Frais - évaluation

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à EUR 2.500.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par ses nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. TKACHENKO A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/51. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024775/187.
(150028810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

AngelPay S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Angel &amp; Partners S.à r.l.).

Siège social: L-8079 Bertrange, 127A, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 189.507.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of January.
Before us Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs Angela NICKEL, born on the 14 

th

 July 1967 in Dresden, Deutschland, residing at Speicherstrasse 38 in D-60327

Frankfurt,

Such appearing person declaring to act in its capacity as the current sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of "

ANGEL &amp; PARTNERS S.à r.l.", with registered office at L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves registered with the
Trade and Companies Register in Luxembourg, section B number 189507, has been incorporated by deed dated July 29,
2014 enacted by Maître Jacques Castel notary residing in Grevenmacher, as published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations dated October 10, 2014 under number 2853, (the “Company”) has required the undersigned
notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder decides to transfer the Company’s registered office from L-2633 Senningerberg, 6e, route de

Trèves, to L-8079 Bertrange, 127a, rue de Leudelange and to amend subsequently article 2, first paragraph of the articles
of incorporation of the Company, which henceforth shall read as follows:

37386

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. "

<i>Second resolution:

The Sole Shareholder decides to amend the corporate name of the Company from ANGEL &amp; PARTNERS S.à r.l. to

AngelPay S.à r.l. and to amend subsequently article 1 of the articles of incorporation of the Company, which henceforth
shall read as follows:

« Art. 1. Name. The name of the company is «AngelPay S.à r.l.» (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).»

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder decides to amend the corporate object of the Company and to amend subsequently article 3 of

the articles of incorporation of the Company, which henceforth shall read as follows:

« Art. 3. Corporate object. The purpose of the company is the development, marketing and operation of payment

programs based on mobile, wireless and internet technologies.

The Company may constitute, acquire, develop, sell, exchange or take interest in any other manner to all patents,

licences, trademarks and other intellectual property as well as to any other intangible rights right relating thereto or
which may complete them

The Company may borrow in any form including through the issuance of bonds, convertible or not, bank loan or

shareholder current account and grant to or to the interest of other companies in which the Company holds a direct
interest  or  indirect  interest,  in  the  same  group  or  linked  in  one  way  or  another,  any  assistance,  loans,  advances  or
guarantees.

In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees,
issue all types of securities and financial instruments and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions.»

<i>Fourth resolution:

The Sole Shareholder decides to fix the number of managers at three and appoints the following persons as additional

Managers of the Company for an indeterminate time:

- Mr. Jan Reus, born on July, 15 1952 in Medan (NL), with professional residence at L-8079 Bertrange, 127a, rue de

Leudelange, and

- Mr. Roger Blomquist, born on February, 5 1958 in Västervick (SE), with residence at Gartnergatan 6, S-256 61

Helsingborg, Sweden.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).

The undersigned notary has drawn the attention of the appearing person to the fact that prior to any commercial

activity of the company hereby incorporated, it has to obtain the trading permit(s) in connection with the social object,
which is hereby expressly acknowledged by the appearing person.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by her first and surnames, civil status

and residence, this person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le trentième jour de janvier.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

A comparu:

37387

L

U X E M B O U R G

Madame Angela NICKEL, née à Dresde, Allemagne, le 14 juillet 1967, demeurant à D-60327 Francfort, 38, Speichers-

trasse.

Laquelle comparante déclarant agir en sa qualité d’associé unique actuel (l’«Associé Unique») de la société à respon-

sabilité limitée ANGEL &amp; PARTNERS S.àr.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 189.507, a été constituée suivant acte reçu
en date du 29 juillet 2014 par le Maître Jacques Castel, notaire de résidence à Grevenmacher, tel que publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 octobre 2014 sous le numéro 2853, (la «Société») a requis le notaire
soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-2633 Senningerberg, 6e, route de Trèves vers

L-8079 Bertrange, 127a, rue de Leudelange et de modifier en conséquence l’article 2, premier paragrpahe des statuts de
la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. Siège social. (premier paragraphe).
«2.1. Le siège social de la Société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg
par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. Plus rien n'étant
à l’ordre du jour, la séance est levée.»

<i>Deuxième résolution:

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la Société de ANGEL &amp; PARTNERS S.àr.l. en AngelPay S.à r.l.

et de modifier en conséquence l’article 1 

er

 des statuts de la Société comme suit:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AngelPay S.à r.l. (la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier,
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).».

<i>Troisième résolution:

L'associé unique décide de modifier l’objet social de la Société et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts de

la Société comme suit:

« Art. 3. Objet social. L’objet de la Société consiste en le développement, la commercialisation et l’exploitation de

programmes de payement base sur les technologies d’information mobile, sans fil et internet.

La Société peut également constituer, acquérir, mettre en valeur, vendre, échanger ou s'intéresser de toute autre

manière à tous brevets, licences, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi qu'à tous autres
droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles la Société
détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou liées d'une manière ou d'une autre, tous
concours, prêts, avances ou garanties.

De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières

pouvant être utiles à l’accomplissement et le développement de son objet, et dans ce contexte donner ou recevoir des
garanties, émettre tout type d’actions et d’instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commerciales,
de «hedging» et de dérivées.»

<i>Quatrième résolution:

L'associé unique décide de fixer le nombre des gérants à trois et nomination des personnes suivantes pour une periode

indéterminée:

- Monsieur Jan Reus, né le 15 juillet 1952 à Medan (Pays-Bas), avec adresse professionnelle à L-8079 Bertrange, 127a,

rue de Leudelange

- Mr. Roger Blomquist, born on February, 5 1958 in Västervick (SE), demeurant à Gartnergatan 6, S-256 61 Helsingborg,

Suede.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire instrumentant a rendu la comparante attentive au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

37388

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la personne comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état civil et demeure, ladite

comparante a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: Angela Nickel, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 3 février 2015. 1LAC / 2015/ 3316. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015024759/139.
(150029281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Asia Investment Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 63.000.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 158.093.

In the year two thousand and fifteen,
on the twenty-third day of the month of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

1) “Aberdeen Management Services S.A.”, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered

office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 119.541, acting in its capacity as management company of “AIPP
Asia Select”, a fonds commun de placement – fonds d'investissement spécialisé governed by the law of 13 February 2007
on specialised investment funds, as amended; and

2) “Aberdeen Management Services S.A.”, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered

office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 119.541, acting in its capacity as management company of “AIPP
Asia”, a fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé governed by the law of 13 February 2007 on
specialised investment funds, as amended;

(Collectively hereafter referred to as, the “Shareholders”),
both Shareholders,
here represented by Mrs Martha ALEXAKI, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of two (2) proxies under private seal given to her in Luxembourg, on 19 January 2015.
Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholder are the two (2) sole share-

holders of “Asia Investment Soparfi S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having
a share capital of sixty-three million Japanese Yen (63'000'000.- JPY), with its current registered office at 33, rue de
Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed enacted on 15
December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 567 of 25
March 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185 093 (the
"Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial
deed enacted on 28 September 2012, published in the Mémorial on 30 October 2012, under number 2665 and page
127877.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To transfer its registered office from the municipality of Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg to Luxembourg

City;

2 To amend paragraph 2.1 of article 2 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the transfer

of the registered office;

37389

L

U X E M B O U R G

3 To determine the new address of the registered office;
4 Miscellaneous;
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to transfer, with immediate effect, the registered office of the Company from the munici-

pality of Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg to Luxembourg City.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to amend paragraph 2.1 of article 2 of the articles of incorporation of the Company in

order to reflect the above resolution. Said paragraph will read henceforth as follows:

Art. 2. Registered office.
“2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.”

<i>Third resolution

The Shareholders resolved to fix the new registered office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such proxy holder signed together with Us the undersigned notary,
this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze,
le vingt-trois janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

1) «Aberdeen Management Services S.A.», une société régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2b,

rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119 541, agissant en sa capacité de société de gestion de «AIPP Asia
Select» un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé régi par la loi du 13 février 2007 sur les fonds
d'investissement spécialisés, telle que modifiée; et

2) «Aberdeen Management Services S.A.», une société régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2b,

rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119 541, agissant en sa capacité de société de gestion de «AIPP Asia»
un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé régi par la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'in-
vestissement spécialisés, telle que modifiée;

(Collectivement désignées ci-après: «les Associés»),
les deux Associés,
représentés aux fins des présentes par Madame Martha ALEXAKI, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
aux termes de deux (2) procurations sous seing privé lui données à Luxembourg, le 19 janvier 2015.
Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire des parties comparantes et le notaire

soussignée, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont les deux (2) seuls et uniques associés

de «Asia Investment Soparfi S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital
social de soixante-trois millions de yen japonais (63'000'000.- JPY), dont le siège social actuel est au 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 15 décembre 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») sous le numéro 567 du 25 mars 2011 et
immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 185 093 (la «Société»). Les
statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu le 28 septembre 2012, lequel acte fut
publié au Mémorial, le 30 octobre 2012, sous le numéro 2665 et page 127877.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des déci-

sions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

37390

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1 Transfert du siège social de la Société de la commune de Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg-

Ville;

2 Modification de l'alinéa 2.1 de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le transfert du siège social;
3 Déterminer la nouvelle adresse du siège social;
4 Divers;
ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la commune de Hesperange, Grand-Duché

de Luxembourg à Luxembourg-Ville.

<i>Deuxième résolution

Les Associées ont décidé de modifier l'alinéa 2.1 de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter la précédente

résolution. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 2. Siège social.
«2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

Les Associés ont décidé d'établir le nouveau siège social au 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties

comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des
mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes connue du notaire

soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. ALEXAKI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 janvier 2015. Relation: EAC/2015/2112. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015024729/123.
(150028253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Nevastar Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 31, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 139.605.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 30 avril 2014, tenue au siège de la société

Les mandats des Administrateurs sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2015, à savoir:

<i>Administrateurs de cat A:

- Mr Stanislas ROTMAN, né le 28/10/1966 à Lausanne (Suisse) résidant au 1 Mayfair Place, W1J 8AJ Londres, Royaume-

Uni;

- Mr Ignace ROTMAN, né le 24/06/1972 à Lausanne (Suisse), résidant au 1 Mayfair Place, W1J 8AJ Londres, Royaume-

Uni.

<i>Administrateurs de cat B:

- Mr Daniel VAN HOVE, né le 20/08/1950 à Bukavu (Congo) résidant au 370 route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
- Mr Grégory GUISSARD, né le 01/08/1980 à Barine l'Alleud (Belgique), résidant au 23 boulevard de la Cluse, CH-1205

Genève, Suisse.

Le mandat du Réviseur d'entreprises, à savoir Deloitte Audit, ayant son siège au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-

bourg et enregistrée au RCS sous le numéro B67895 est également renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra
en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

37391

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015025308/24.
(150029076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

2LED, Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-84 Pétange, 84, Jean Baptiste Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 82.511.

L'an deux mille quinze, le vingt janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Laurent Gabriel LEVY, promoteur immobilier, né à Casablanca (Maroc) le 10 novembre 1967, demeurant à

F-75008 Paris, 20, avenue de Wagram,

détenteur de cent vingt-quatre (124) parts sociales.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "2LED" (numéro d’identité

2001 24 08 499), avec siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 82.511,
constituée sous la dénomination de «TOOTSIE, S. à r.l.» suivant acte reçu par le notaire Georges d’HUART, alors de
résidence à Pétange, en date du 13 juin 2001, publié au Mémorial C, numéro 1188 du 18 décembre 2001 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Luxembourg, en date du 9
octobre 2013, publié au Mémorial C, numéro 3049 du 3 décembre 2013, ledit acte contenant entre autres changement
de la dénomination sociale en "2LED",

a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social à L-4735 Pétange, 84, rue Jean-Baptiste Gillardin et en conséquence

de modifier la 1 

ère

 phrase de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Pétange.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’insérer à l’article 3 des statuts, relatif à l’objet social, un deuxième alinéa ayant la teneur

suivante:

«La société  a également pour  objet  l’achat,  la  vente  ainsi que l’import  et export  de boissons alcooliques et  non-

alcooliques.»

Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l’objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que la société ne se
livre pas et ne s’est pas livrée à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à environ mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: LEVY, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2413. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015023976/46.
(150027495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

37392


Document Outline

2LED

Angel &amp; Partners S.à r.l.

AngelPay S.à r.l.

Asia Investment Soparfi S.à r.l.

AVL Investments S.A., SPF

Daditra S.A.

Digital Services XLIII (GP) S.à r.l.

Fondation Ste Zithe

Ire Hotel II Rad Blu Cologne

Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.

Racol

Sumala S.A.

Sumala S.A.

Sumala S.A.

Thelos S.A.

Tipalux S.A.

TMLH 1970 SA, SPF

UNA Management S.à r.l.

Unipatent Holding S.A.

Universal Commerce and Finance S.A.

Universal Management Services Sàrl

Valfleurs S.A.

Valfleurs S.A.

Valfleurs S.A.

Vartema S.A.

V Concept Lux

Venusia Real Estate Investment S.A.

Vertime S.A.

Vicari S.A., SPF

Vinci Real Estate Management

Vinox S.A., SPF

Vionelle S.A., SPF

Vison

Vontobel Management S.A.

Walgreen Asia Services S.à r.l.

Wela Internet S.A.

Wester Wassertechnik s.à r.l.

Wildfire Holding S.A., SPF

Wise Services S.àr.l.

World Immobilière S.A.

Worldline Luxembourg

World's Flash S.A., SPF

WTC Sub-Holdings S.à r.l.

WW Brand S.à r.l.

WWW.Pétange s.à r.l.

WWW.Pétange s.à r.l.

Xara Asset Management S.A. SPF