This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 769
20 mars 2015
SOMMAIRE
ABN AMRO Multi-Manager Funds . . . . . . .
36872
Alpine Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36912
Aool S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36875
Argenta Fund of Funds . . . . . . . . . . . . . . . . .
36869
Cadogan Capital Partners S.C.A. . . . . . . . .
36912
CR Lux Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36908
Cybea Cyber Asset Managers S.A. . . . . . . .
36875
DB Platinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36877
DB Platinum III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36876
Digital Services Holding I S.à r.l. . . . . . . . . .
36875
Diners Club Beneflux S.A. . . . . . . . . . . . . . .
36906
Dream International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36895
ECommerce Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
36878
Ernst & Young International Pension Sche-
me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36868
EURO DIRECT MARKETING S.à r.l. . . . .
36867
Euroteam S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36867
Exclusive Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36912
F&B International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36866
F&B International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36866
Frontier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36912
GDL Asset Management S.à r.l. . . . . . . . . .
36872
GeoVille Environmental Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36872
GP Lux HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36871
GSC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36871
Hallard Investments Limited S.A. . . . . . . .
36866
Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A. . . .
36868
Kwong S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36870
Les Aubépines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36869
Levia Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36875
Malouvag S.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36867
N. Hypothek Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
36868
Pelican S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36911
Petercam L Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36870
Pictet International Capital Management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36871
Raik Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36876
Robiontex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36866
Rosenberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36870
Saint Aubin Développement S.A. . . . . . . . .
36874
Savings & Investments S.A., SPF . . . . . . . .
36869
Seapoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36874
SGI Ingénierie S.A. Luxembourg . . . . . . . .
36874
SM - IMMO g.m.b.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36874
Société Internationale de Participation
dans l'Acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36874
Société Internationale de Participation
dans l'Acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36873
Société Internationale de Participation
dans l'Acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36873
Solar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36873
Suo Tempore AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36867
Swiss Park Hotel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36873
Telefónica Luxembourg Holding S.à r.l. . .
36873
36865
L
U X E M B O U R G
Hallard Investments Limited S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 129.970.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 12 mars 2015, la sixième section du tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société HALLARD INVESTMENTS
LIMITED S.A., ayant eu son siège social au 74, rue de Merl, L - 2146, Luxembourg, enregistrée au R.C.S. Luxembourg
sous le numéro B129970.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2015.
Maître Robert Kayser
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015042351/17.
(150048753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
Robiontex S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 130.522.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 12 mars 2015, la sixième section du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société ROBIONTEX S.A., ayant
eu son siège social au 370, route de Longwy, L - 1940, Luxembourg, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro
B130522.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2015.
Maître Robert Kayser
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015042553/17.
(150048749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
F&B International S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare.
R.C.S. Luxembourg B 82.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025877/10.
(150029555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
F&B International S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare.
R.C.S. Luxembourg B 82.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025878/10.
(150029556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36866
L
U X E M B O U R G
Suo Tempore AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 129.831.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 12 mars 2015, la sixième section du tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société SUO TEMPORE AG, ayant
eu son siège social au 196, rue de Beggen, L - 1220, Luxembourg, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro
B129831.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2015.
Maître Robert Kayser
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015042601/17.
(150048752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
Malouvag S.A.,, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 161.124.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>9 avril 2015i> à 09.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015043297/833/19.
EURO DIRECT MARKETING S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8821 Rambrouch, Zoning Industriel de Riesennhaff, Rte de Martelange.
R.C.S. Luxembourg B 101.708.
Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025868/9.
(150030022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Euroteam S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 167.378.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 205 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025871/9.
(150029899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36867
L
U X E M B O U R G
Ernst & Young International Pension Scheme, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
R.C.S. Luxembourg B 92.212.
Notice is hereby given to the shareholders of Ernst & Young International Pension Scheme Sepcav that the
ANNUAL GENERAL MEETING
will be held at the offices of Ernst & Young Luxembourg Société Anonyme, 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité
Syrdall 2, L-5365 Munsbach, on <i>9th April 2015i> at 11.00, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts for the financial year ended 31st December, 2014
2. Report of the Board of Directors
3. Report of the Asset Manager
4. Report of the Independent Auditor concerning the annual accounts for the financial year ended 31st December,
2014
5. Approval of the Annual Accounts
6. Discharge to the Directors
7. Election and appointment of Directors
8. Appointment of the Independent Auditor
9. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the majority of the
shares present or represented will take the decisions.
Each share is entitled to one vote.
In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly
appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to the address of the Sepcav for the attention of Mr Arnaud Bianchi to arrive no later than the 3th April
2015.
Luxembourg, 12th March 2015
<i>By order of the Board of Directors
i>Référence de publication: 2015042105/30.
Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 71.013.
Les statuts coordonnés au 15/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015025994/12.
(150029523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
N. Hypothek Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.847.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015025292/12.
(150028582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36868
L
U X E M B O U R G
Argenta Fund of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 149.912.
Le conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") de la Sicav Argenta Fund of Funds (ci-après dénommée le
"Fonds") a le plaisir d'inviter les actionnaires du Fonds à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 avril 2015i> à 10.00 heures au siège social du Fonds.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du Fonds (l'"Assemblée") est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Communication et discussion du rapport de gestion annuel du conseil d'administration du Fonds concernant
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014;
2. Communication et discussion du rapport annuel du réviseur d'entreprises agréé du Fonds sur les comptes annuels
pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014;
3. Communication et approbation des comptes annuels du Fonds pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014
et affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration;
4. Décharge et nomination d'administrateurs et d'administrateurs-délégués;
5. Nomination du réviseur d'entreprises agréé et fixation de sa rémunération;
6. Divers.
Pour être admis à l'Assemblée, les actionnaires doivent faire bloquer leurs actions au plus tard le 09 avril 2015 au siège
social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (Argenta Spaarbank nv) à B-2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 (qui assure le service
financier en Belgique) ou au siège social d'Argenta Asset Management S.A. à L-1724 Luxembourg, 29, Boulevard du Prince
Henri.
Les actionnaires peuvent obtenir la version française des statuts et du rapport annuel, ainsi que les versions françaises
et néerlandaises du prospectus du Fonds actuellement en vigueur et des KIIDs des différents compartiments du Fonds
gratuitement auprès des adresses mentionnées ci-dessus. Vous pouvez consulter ces documents sur www.argenta.be.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015038941/29.
Savings & Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 184.215.
Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 11/02/2015:
Il est décidé nommer la société à responsabilité limité UNCOS, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,
immatriculée au RCSL sous le numéro B141298, en tant que dépositaire légal des actions au porteur de la société Savings
& Investments S.A., SPF (B184215) et ceci en vertu de la loi du 28 juillet 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2015.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015025446/15.
(150028351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Les Aubépines, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 46, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 163.864.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015026044/10.
(150030025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36869
L
U X E M B O U R G
Petercam L Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 27.128.
Le conseil d'administration de la SICAV (ci-après le "Conseil d'Administration") invite, par la présente, les actionnaires
à participer à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(ci-après l'"AGO") qui se tiendra le <i>8 avril 2015i> , à 14.00 heures au siège social de la SICAV, allée Scheffer 5 - L-2520
Luxembourg et qui aura, à l'ordre du jour, les points suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs;
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé; et
6. Nominations statutaires.
<i>PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREi>
L'AGO n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement (quel que soit le nombre d'actionnaires participant à la
réunion, en personne, par procuration ou par correspondance). Les résolutions seront valablement adoptées à la majorité
simple des voix exprimées, conformément à l'article 28, alinéa 2 des statuts de la SICAV (ci-après les "Statuts").
Conformément à l'article 25, alinéa 4 des Statuts, la majorité requise sera déterminée par référence aux actions émises
et en circulation à la date du 2 avril 2015 (ci-après la "Date Butoir"), étant entendu que le droit d'un actionnaire de
participer à l'AGO et d'exercer le droit de vote attaché à son/ses action(s) sera déterminé en fonction du nombre d'actions
détenues par l'actionnaire à la Date Butoir
Une brochure explicative, reprenant les modalités de participation à la présente AGO, est disponible, sans frais et sur
simple demande, au siège social de la SICAV (dont les coordonnées sont reprises plus haut).
Les formulaires de vote et de procuration sont disponibles au siège social de la SICAV et peuvent être obtenus, sans
frais, sur simple demande.
Référence de publication: 2015040110/30.
Rosenberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 92.812.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 janvier 2015i>
Il résulte de ce Conseil d'administration:
Conformément à l'article 42 des Lois Coordonnées sur les Sociétés commerciales du 10 août 1915 tel que modifié
par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration décide,
à l'unanimité, de nommer comme dépositaire des actions au porteur, la société «Fiduciaire Internationale SA», ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
34813 et représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Stéphan MOREAUX.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015025428/15.
(150029103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Kwong S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 151.591.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026015/9.
(150029862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36870
L
U X E M B O U R G
Pictet International Capital Management, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 43.579.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui sera tenue au siège social de la société le mardi <i>7 avril 2015i> à 11 h 00
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport annuel incluant les états financiers
révisés au 31 décembre 2014 ;
2. Approbation du rapport annuel incluant les états financiers révisés au 31 décembre 2014 ;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2014 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Elections statutaires :
- Notification de la démission au poste d'administrateur de Mme Michèle Berger en date du 1er août 2014.
- Ratification de la cooptation de M. Christoph Oppenheim en remplacement de Mme Michèle Berger en date du
1er août 2014.
- Renouvellement des mandats d'Administrateur de M. Giovanni Viani, M. Frédéric Fasel et M. Christoph Oppen-
heim jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
- Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, Deloitte Audit S.à r.l., jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
6. Divers.
Le rapport annuel est disponible au siège social de la société sur simple demande.
L'adoption des résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requiert aucun quorum spécial.
Ces dernières seront adoptées, si elles sont votées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Le quorum et la majorité à l'assemblée seront déterminés en fonction des actions émises et en circulation à minuit
(heure de Luxembourg) le deuxième jour ouvrable avant l'assemblée, soit le 2 avril 2015 (la "Date d'Enregistrement").
Les droits d'un actionnaire d'assister à la réunion et à exercer un droit de vote afférent à son / sa / ses actions sont
déterminées en conformité avec les actions détenues par cet actionnaire à la date d'enregistrement.
Chaque action donne à son détenteur le droit d'exprimer une voix. Les actionnaires ne pouvant assister à l'Assemblée
Générale Ordinaire peuvent s'y faire représenter au moyen de la procuration ci-jointe.
Cette procuration restera valable pour toute Assemblée Générale convoquée ultérieurement et ayant le même agenda.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015043308/755/35.
GSC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 193.940.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015025935/10.
(150029371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
GP Lux HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 177.804.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025931/9.
(150030121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36871
L
U X E M B O U R G
ABN AMRO Multi-Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 78.762.
Notice is hereby given to the shareholders of ABN AMRO Multi-Manager Funds (the "Company") that the
ANNUAL GENERAL MEETING
shall be held at the Registered Office of the Company on <i>24 April 2015i> at 14:00 CET (the "Meeting"), with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member
individually a "Director") and of the Company's approved statutory auditor for the fiscal year ended 31 December
2014 (the "Auditor");
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement for the fiscal year ended 31 December 2014;
3. Allocation of net results;
4. Approval of the dividend;
5. Discharge to the Directors and the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year
ended 31 December 2014;
6. Appointment of Directors and the approved statutory Auditor of the Company;
7. Miscellaneous.
The resolutions on the agenda may be passed without quorum, by a majority of the votes cast thereon at the Meeting.
Each share is entitled to one vote. The quorum and majority requirements for a general meeting shall be determined in
accordance with the number of shares issued and outstanding at midnight 5 (five) days prior to the date of the general
meeting. A shareholder may act at any Meeting by proxy. Proxy forms can be obtained from the Registered Office of the
Company.
In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that proof of the shareholder's
identity is given and that the shareholder has informed the Company, for organisational reasons, in writing of his intention
to attend the Meeting by 17 April 2015, 17:00 CET at the latest (by mail to ABN AMRO Multi-Manager Funds, 562, rue
de Neudorf, L-2017 Luxembourg or by fax to the number +352 43 88 76 07).
Shareholders not attending the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to arrive
no later than 17 April 2015, 17:00 CET (by mail to ABN AMRO Multi-Manager Funds, 562, rue de Neudorf, L-2017
Luxembourg or by fax to the number +352 43 88 76 07). The Meeting will be held in English language.
<i>By order of the Board of Directors
i>Luxembourg, March/April 2015
Référence de publication: 2015043313/755/35.
GeoVille Environmental Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 124.588.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015025913/10.
(150029541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
GDL Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 142.446.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025922/9.
(150029487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36872
L
U X E M B O U R G
Telefónica Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 166.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015027019/10.
(150030329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Solar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 115.762.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015027003/9.
(150030292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
S.I.P.A.C. Holding S.A., Société Internationale de Participation dans l'Acier, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 52.987.
Les comptes annuels au 30.06.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2015.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2015026992/12.
(150030823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
S.I.P.A.C. Holding S.A., Société Internationale de Participation dans l'Acier, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 52.987.
Les comptes annuels au 30.06.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2015.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2015026991/12.
(150030822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Swiss Park Hotel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Swiss Park Hotel S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015026965/11.
(150030405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
36873
L
U X E M B O U R G
SGI Ingénierie S.A. Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.
R.C.S. Luxembourg B 7.463.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 février 2015.
Bruno THUNUS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015026980/12.
(150030805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
SM - IMMO g.m.b.h., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9511 Wiltz, 77C, rue Aneschbach.
R.C.S. Luxembourg B 135.090.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015026985/10.
(150030452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Société Internationale de Participation dans l'Acier, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 52.987.
Les comptes annuels au 30.06.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2015.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2015026990/12.
(150030821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Seapoint, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 22.929.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2015026977/10.
(150030424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Saint Aubin Développement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 74.823.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015026969/10.
(150030911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
36874
L
U X E M B O U R G
Aool S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 160.459.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 12. Februar 2015.
<i>Für: AOOL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015026436/15.
(150030331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Digital Services Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 180.879.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015026545/12.
(150030818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Cybea Cyber Asset Managers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8064 Bertrange, 40, Cité Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 70.049.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015026539/12.
(150030573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Levia Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 92.671.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2015i>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société Levia Holding S.A., tenue en date du 12 février 2015,
que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
Acceptation des démissions des anciens administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de
six ans:
Madame Rosa SAURINI, demeurant 55 via XX Settembre, 03039 Sora, Italie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Levia Holding S.A.
Référence de publication: 2015026058/15.
(150029495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36875
L
U X E M B O U R G
Raik Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 106.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 137.060.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 janvier 2015i>
1. Mme Katia CAMBON a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
2. Mlle Virginie GUILLAUME a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
3. M. Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant pro-
fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une
durée indéterminée.
4. Mme Mariateresa BATTAGLIA, administrateur de sociétés, née à Cropani (Italie), le 1
er
janvier 1963, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante de catégorie B pour
une durée indéterminée.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Raik Property S.àr.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015025402/21.
(150029259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
DB Platinum III, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 107.709.
Shareholders of DB Platinum III (the "Company"), are hereby invited to participate in the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company (the "AGM"), which will be held on <i>16 April 2015i> at 11:00 a.m. (Luxembourg time)
at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member
individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for
the fiscal year ended 31 January 2015;
2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2015;
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2015 and ratification of the distribution of dividends,
if any, in respect of the shares of distributing share classes of the sub-funds of the Company where shares of such
distributing share classes have been issued;
4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year
ended 31 January 2015;
5. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Alexander McKenna and Freddy Brausch as Directors
of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual
accounts for the fiscal year ending on 31 January 2016;
6. Election of Ben O'Bryan and Philippe Ah-Sun as Directors of the Company, subject to the approval of the Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg, until the next annual general meeting of shareholders
of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending 31 January 2016.
7. Re-election of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company
until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for
the fiscal year ending on 31 January 2016;
8. Miscellaneous.
Voting Arrangements for the AGM
A shareholder may act at the AGM by person or by proxy.
Shareholders who wish to participate in person at the AGM, are kindly asked to inform RBC Investor Services Bank
S.A. hereof, no later than 13 April 2015, 5:00 p.m. (Luxembourg time).
Shareholders who are not able to participate personally in the AGM, are permitted to have themselves represented.
A proxy form for the AGM may be obtained at the registered office of the Company or from the Company's website
36876
L
U X E M B O U R G
www.funds.db.com and has to be returned, completed and duly signed, to RBC Investor Services Bank S.A., to the
attention of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 13 April 2015, 5:00 p.m. (Luxembourg time) at the
latest.
Shareholders who are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, should note
that:
- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward trans-
mission to the Company by 13 April 2015; and
- if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on the shareholders behalf, it may
not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained
in the prospectus of the Company).
Specific Rules of Voting at the AGM
The shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the AGM and that the
resolutions will be taken at the majority vote of the shareholders present or represented at the AGM and voting. Each
share is entitled to one vote.
Audited Annual Report
The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company
(including the audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2015
will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website www.funds.db.com as
of 31 March 2015.
Further information can be obtained from RBC Investor Services Bank S.A., acting in its capacity as Registrar and
Transfer Agent (tel.: +352 2605 9815, fax: +352 2460 9500, attn. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com) or from
the local representative of the Company or from the relevant financial intermediary through whom the shares of the
Company have been purchased.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015043299/755/61.
DB Platinum, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 104.413.
Shareholders of DB Platinum (the "Company"), are hereby invited to participate in the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company (the "AGM"), which will be held on <i>16 April 2015i> at 11:00 a.m. (Luxembourg time)
at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member
individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for
the fiscal year ended 31 January 2015;
2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2015;
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2015 and ratification of the distribution of dividends,
if any, in respect of the shares of distributing share classes of the sub-funds of the Company where shares of such
distributing share classes have been issued;
4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year
ended 31 January 2015;
5. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Alexander McKenna and Freddy Brausch as Directors
of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual
accounts for the fiscal year ending on 31 January 2016;
6. Election of Ben O'Bryan and Philippe Ah-Sun as Directors of the Company, subject to the approval of the Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg, until the next annual general meeting of shareholders
of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending 31 January 2016.
7. Re-election of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company
until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for
the fiscal year ending on 31 January 2016;
8. Miscellaneous.
Voting Arrangements for the AGM
A shareholder may act at the AGM by person or by proxy.
36877
L
U X E M B O U R G
Shareholders who wish to participate in person at the AGM, are kindly asked to inform RBC Investor Services Bank
S.A. hereof, no later than 13 April 2015, 5:00 p.m. (Luxembourg time).
Shareholders who are not able to participate personally in the AGM, are permitted to have themselves represented.
A proxy form for the AGM may be obtained at the registered office of the Company or from the Company's website
www.funds.db.com and has to be returned, completed and duly signed, to RBC Investor Services Bank S.A., to the
attention of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 13 April 2015, 5:00 p.m. (Luxembourg time) at the
latest.
Shareholders who are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, should note
that:
- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward trans-
mission to the Company by 13 April 2015; and
- if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on the shareholders behalf, it may
not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained
in the prospectus of the Company).
Specific Rules of Voting at the AGM
The shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the AGM and that the
resolutions will be taken at the majority vote of the shareholders present or represented at the AGM and voting. Each
share is entitled to one vote.
Audited Annual Report
The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company
(including the audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2015
will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website www.funds.db.com as
of 31 March 2015.
Further information can be obtained from RBC Investor Services Bank S.A., acting in its capacity as Registrar and
Transfer Agent (tel.: +352 2605 9815, fax: +352 2460 9500, attn. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com) or from
the local representative of the Company or from the relevant financial intermediary through whom the shares of the
Company have been purchased.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015043300/755/61.
ECommerce Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.500.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED,
Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany, registered with the
commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 159634 B, having its registered address
at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Berlin, Germany, on 19 January 2015.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company
(société anonyme) which they wish to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name ECommerce
Holding S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
36878
L
U X E M B O U R G
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities
or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, public offering,
exchange or otherwise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these Articles.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the Management
Board. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these Articles.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the Management Board.
4.4 In the event that the Management Board determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000), represented by thirty-one thousand
(31,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these Articles or as set out in article 6 hereof.
5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of
plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by
them in the Company’s share capital. The Management Board shall determine the period of time during which such
preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period The general meeting
of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner
required for an amendment of these Articles. The Management Board may limit or suppress the preferential subscription
right of the existing shareholder(s) in accordance with article 6 hereof.
5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.
Art. 6. Authorised capital.
6.1 The authorised capital, excluding the share capital, is set at four thousand six hundred and fifty euro (EUR 4,650),
consisting of four thousand six hundred and fifty (4,650) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each. During
a period of time of five (5) years from the date of the publication of these Articles or, as the case may be, of the resolution
to renew or to increase the authorised capital pursuant to this article, the Management Board is hereby authorised to
issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within
the limits of the authorised capital to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to
such issue without reserving a preferential right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders. Such
authorisation may be renewed through a resolution of the general meeting of the shareholders adopted in the manner
required for an amendment of these Articles, each time for a period not exceeding five (5) years.
6.2 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for amendments of these Articles.
36879
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Shares.
7.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
7.2 The shares of the Company are in registered form.
7.3 The Company may have one or several shareholders.
7.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
7.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the member(s) of the Management Board as the case may be, subject to the Law
and these Articles.
Art. 8. Register of shares - Transfer of shares.
8.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of
the relevant shareholder.
8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
8.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law.
8.4 Any transfer of registered shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either
(i) through a declaration of transfer recorded in the register of shares, signed and dated by the transferor and the
transferee or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by
the Company.
C. General meetings of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted
general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these Articles.
9.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders”
shall be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers
conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 10. Convening of general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the Management Board,
by the Supervisory Board or by the internal auditor(s), as the case may be.
10.2 It must be convened by the Management Board, by the Supervisory Board or the internal auditor(s) upon written
request of shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general
meeting of shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.
10.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of
the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this
formality has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may
be made by registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days
before the date scheduled for the meeting.
10.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.
11.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the first Wednesday
of June each year at 2 p.m. CET. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following
business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective
convening notices.
11.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer who need neither be shareholders nor members of the Management Board. If all the share-
holders present at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may
unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the
36880
L
U X E M B O U R G
board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the “board of the meeting”
shall in such case be construed as a reference to the “chairman and secretary” or, as the case may be to the “single person
who assumes the role of the board”, depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially
ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in
relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on
a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present
for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place
of the meeting.
11.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening
notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and
time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal
three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate
box.
11.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the
proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into
account voting forms received prior to the general meeting to which they relate.
11.8 The Management Board may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Quorum and vote.
12.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.
12.2 Except as otherwise required by the Law or these Articles, resolutions at a general meeting of shareholders duly
convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast
regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 13. Amendments of these Articles. Except as otherwise provided herein, these Articles may be amended by a
majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the
Company’s share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be
convened in accordance with the Law and these Articles which may deliberate regardless of the quorum and at which
resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be
taken into account.
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the Management Board
may adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The Management Board shall do
so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the
event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.
Art. 16. Minutes of general meetings of shareholders.
16.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by
the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.
16.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the Management Board or by any
two of its members.
D. Management
Art. 17. Dual management and supervisory structure.
17.1 The Company’s management shall be subject to articles 60bis-1 to 60bis-19 of the Law, unless otherwise provided
in these Articles.
17.2 The Company shall be managed by a management board, which exercises its functions under the control of a
supervisory board (respectively the “Management Board”, and the “Supervisory Board”).
36881
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Composition and powers of the Management Board.
18.1 The Management Board is composed of at least three (3) members. However, where the Company has been
incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders’ meeting that all the shares issued by the
Company are held by a sole shareholder, the functions of the Management Board may be exercised by a sole director
until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the
extent applicable and where the term “sole director” is not expressly mentioned in these articles of association, a refe-
rence to the “Management Board” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole
director”.
18.2 The Management Board is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by
the Law or by these Articles to the Supervisory Board or to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Daily management.
19.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily
management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one (1) or several members of the Management
Board, officers or other agents, but no Supervisory Board members, acting individually or jointly. Their appointment,
removal and powers shall be determined by a resolution of the Management Board.
19.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 20. Appointment, removal and term of office of members of the Management Board.
20.1 The members of the Management Board shall be appointed by the Supervisory Board which shall determine their
remuneration and term of office. The first members of the Management Board shall be appointed by the general meeting
of shareholders.
20.2 The Supervisory Board may decide to appoint member of the Management Board of two (2) different classes,
being class A member of the Management Board and class B member of the Management Board. Any such classification
of members shall be duly recorded in the minutes of the relevant Supervisory Board resolutions and the member of the
Management Board be identified with respect to the class they belong.
20.3 The term of office of a member of the Management Board may not exceed five (5) years and any member of the
Management Board shall hold office until his successor is appointed. Members of the Management Board may also be re-
appointed for successive terms.
20.4 Any member of the Management Board may be removed from office at any time, with or without cause by the
Supervisory Board.
20.5 The Management Board shall appoint a chairman among its members. A deputy chairman may be elected by the
Management Board among its members at a simple majority. If the chairman is impeded from performing his duties, he
shall be represented by the deputy chairman, if applicable.
20.6 If a legal entity is appointed as member of the Management Board of the Company, such legal entity must designate
a physical person as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity.
The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An
individual may only be a permanent representative of one (1) member of the Management Board and may not be a member
of the Management Board at the same time. An individual cannot be a permanent representative of a member of the
Management Board and of a member of the Supervisory Board at the same time.
Art. 21. Vacancy in the office of a member of the Management Board.
21.1 In the event of a vacancy in the office of a member of the Management Board because of death, legal incapacity,
bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not
exceeding the initial mandate of the replaced member of the Management Board, by the remaining members of the
Management Board until the next meeting of the Supervisory Board which shall resolve on a permanent appointment in
compliance with the applicable legal provisions.
21.2 Alternatively, the Supervisory Board may temporarily appoint one (1) of its members in order to exercise the
functions of a member of the Management Board. His mandate as member of the Supervisory Board is suspended for the
time of his appointment as member of the Management Board.
Art. 22. Convening meetings of the Management Board.
22.1 The Management Board shall meet upon call by the chairman at least every three (3) months. Additional Mana-
gement Board meetings shall be held without undue delay if two (2) members of the Management Board request so. If
the chairman does not fulfil such obligation, the deputy chairman shall be entitled to summon the requested meeting and
represent the chairman for all purposes of such meeting. Meetings of the Management Board shall be held at the registered
office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
22.2 Written notice of any meeting of the Management Board must be given to its members in writing by facsimile,
electronic mail or any similar means of communication to its members seven (7) days at least in advance of the time
scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency
36882
L
U X E M B O U R G
must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each member of the Management Board
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a Management Board meeting to be held at a time
and location determined in a prior resolution adopted by the Management Board.
22.3 No convening notice shall be required in case all the members of the Management Board are present or repre-
sented at a meeting of the Management Board and waive any convening requirements or in the case of resolutions in
writing approved and signed by all members of the Management Board.
Art. 23. Conduct of meetings of the Management Board.
23.1 The chairman shall chair all meetings of the Management Board, but in his absence, the deputy chairman shall
chair the meeting. The Management Board shall designate one of its class B members as recorder of the minutes of the
meetings of the Management Board.
23.2 Any member of the Management Board may be represented by another member of the Management Board
belonging to the same class of member for the adoption of resolutions in meetings. In this case a written proxy must be
presented for the adoption of the resolution and must be attached to the minutes. One member of the Management
Board may represent several of his/her/its Management Board’s colleagues within the same class.
23.3 Generally, the Management Board adopts resolutions in meetings. However Management Board resolutions may
also be adopted by way of circular procedure in writing, by telefax or by e-mail if no member of the Management Board
objects to such procedure within a period of one (1) week following the request to cast its vote by way of circulation
procedure. Each member of the Management Board may express his consent separately, the entirety of the consents
evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.
23.4 Resolutions of the Management Board are adopted by a simple majority of the votes cast of the members of the
Management Board taking part in the voting unless provided otherwise under these Articles or any shareholders agree-
ment.
23.5 Each voting member shall have one (1) vote. In case of a tie, the chairman of the Management Board shall have a
casting vote.
23.6 Save as otherwise provided by the Law, any member of the Management Board who has, directly or indirectly,
an interest in a transaction submitted to the approval of the Management Board which conflicts with the Company’s
interest, must inform the Management Board of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the
minutes of the meeting of the Management Board. The relevant member of the Management Board may not take part in
the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the
next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item. In addition, the
authorisation of the Supervisory Board for such transaction is required. However, these provisions shall not apply when
the decisions relate to current operations proceeded in the course of ordinary business.
23.7 The Supervisory Board may adopt rules of procedure for the Management Board. The Management Board shall
consider and follow such rules of procedure for the Management Board for all legal transactions, actions and measures
of the Company and its direct or indirect subsidiaries.
23.8 The Management Board shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this article 23 apply in the
same manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present
or in the future.
Art. 24. Minutes of meetings of the Management Board.
24.1 Management Board meetings and the resolutions adopted therein shall be recorded in minutes which shall be
signed by the chairman of the Management Board or by any member of the Management Board to whom such power
may have been delegated.
24.2 The minutes shall be submitted to all members of the Management Board immediately after their recording and
are to be kept with the Company at the registered office in Luxembourg. The minutes are deemed to be approved if no
member of the Management Board objects in writing within a period of four (4) weeks following receipt. Any objections
must be forwarded to the chairman of the Management Board and shall be dealt with in the subsequent Management
Board meeting. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be
signed by the chairman solely or jointly by a class A member and a class B member of the Management Board or by any
member of the Management Board to whom such power may have been delegated.
Art. 25. Dealing with third parties.
25.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole member
of the Management Board, (ii) by the joint signature of one (1) class A Member and one (1) class B Member (including by
way of representation) or (iii) by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such power may
have been delegated by the Management Board within the limits of such delegation.
25.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of
any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly within the limits of such
delegation.
36883
L
U X E M B O U R G
Art. 26. Powers of the Supervisory Board.
26.1 The Supervisory Board shall be in charge of the permanent supervision and control of the Company’s management
by the Management Board. It may in no case interfere with such management.
26.2 The Supervisory Board has an unlimited right of information regarding all operations of the Company and may
inspect any of the Company’s documents. It may request the Management Board to provide any information necessary
for exercising its functions and may directly or indirectly proceed to all verifications which it may deem useful in order
to carry out its duties.
26.3 At least every three (3) months, the Management Board provides a written report to the Supervisory Board on
the business of the Company and the foreseeable future development thereof. In addition, the Management Board shall
promptly pass to the Supervisory Board any information on events likely to have an appreciable influence on the situation
of the Company.
Art. 27. Composition of the Supervisory Board.
27.1 The Supervisory Board shall be composed of at least three (3) members.
27.2 The Supervisory Board shall elect among its members a chairman of the Supervisory Board. It may also choose
a secretary who does not need to be a shareholder or a member of the Supervisory Board.
27.3 A member of the Management Board cannot be a member of the Supervisory Board at the same time.
Art. 28. Appointment, removal and term of office of members of the Supervisory Board.
28.1 Members of the Supervisory Board shall be appointed by way of unanimous consent of the general meeting of
shareholders which shall determine their remuneration and term of office. The general meeting of shareholders may
increase or decrease the number of members of the Supervisory Board at a simple majority vote of the shares present
or represented.
28.2 The term of office of a member of the Supervisory Board may not exceed three (3) years and each member of
the Supervisory Board shall hold office until his/its/her successor is appointed. Members of the Supervisory Board may
be re-appointed for successive terms.
28.3 Any member of the Supervisory Board may be removed from office at any time, with or without cause by the
general meeting of shareholders at a simple majority vote of the shares present or represented.
28.4 If a legal entity is appointed member of the Supervisory Board of the Company, such legal entity must designate
an individual as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The
relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual
may only be a permanent representative of one (1) member of the Supervisory Board and may not be a member of the
Supervisory Board at the same time. An individual cannot be a permanent representative of a member of the Supervisory
Board and of a member of the Management Board at the same time.
Art. 29. Vacancy in the office of a member of the Supervisory Board.
29.1 In the event of a vacancy in the office of a member of the Supervisory Board because of death, legal incapacity,
bankruptcy, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period not exceeding the
initial mandate of the replaced member of the Supervisory Board, by the remaining members of the Supervisory Board
until the next general meeting of shareholders which shall resolve on a permanent appointment in compliance with the
applicable legal provisions.
29.2 If the total number of members of the Supervisory Board falls below three (3) or below such higher minimum
set by these Articles, as applicable, such vacancy must be filled without undue delay either by the general meeting of
shareholders or in accordance with article 29.1.
Art. 30. Convening meetings of the Supervisory Board.
30.1 The Supervisory Board shall meet upon call by the chairman at least every three (3) months. Additional Supervisory
Board meetings shall be held without undue delay if two (2) members of the Supervisory Board request so. If the chairman
does not fulfil such obligation, the deputy chairman shall be entitled to summon the requested meeting and represent the
chairman for all purposes of such meeting. Meetings of the Supervisory Board shall be held at the registered office of the
Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
30.2 Written notice of any meeting of the Supervisory Board must be given in writing by facsimile, electronic mail or
any similar means of communication to its members seven (7) days at least in advance of the time scheduled for the
meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned
in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each member of the Supervisory Board in writing, by
facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a
prior resolution adopted by the Supervisory Board.
30.3 No convening notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented
at a meeting of the Supervisory Board and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing
approved and signed by all members of the Supervisory Board.
36884
L
U X E M B O U R G
Art. 31. Conduct of meetings of the Supervisory Board. The provisions of article 23 of these Articles apply mutatis
mutandis to the conduct of meetings of the Supervisory Board.
Art. 32. Minutes of meetings of the Supervisory Board.
32.1 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman of the Supervisory Board shall draw minutes
of any meeting of the Supervisory Board, which shall be signed by the chairman and by the secretary, if any. In his absence,
minutes shall be signed jointly by any two members of the Supervisory Board.
32.2 Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the supervisory or by any two (2) members of the Supervisory Board.
E. Audit and supervision
Art. 33. Auditor(s).
33.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The
general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office, which shall
be an annual term until the next annual general meeting of the shareholders approving the annual accounts of the relevant
year..
33.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
33.3 The internal auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
33.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur
(s) d’entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is
suppressed.
33.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 34. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 35. Annual accounts and allocation of profits.
35.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management Board draws up an inventory of
the Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
35.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
35.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
35.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
35.5 Upon recommendation of the Management Board, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these Articles.
35.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 36. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
36.1 The Management Board may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.
36.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these Articles.
G. Liquidation
Art. 37. Liquidation.
37.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these Articles, the liquidation shall
be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
37.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 38. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
36885
L
U X E M B O U R G
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first of
December 2015.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The thirty-one thousand (31,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned, for the
price of thirty-one thousand euro (EUR 31,000).
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand
euro (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is entirely allocated to the share capital.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred
to in articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law and expressly states that they have been complied with.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg;
2. The following persons are appointed as members of the supervisory board of the Company until the general meeting
of shareholders convened to approve the Company’s annual accounts for the first financial year;
(i) Mr. Oliver Samwer, born in Cologne on 09 August 1972, professionally residing at Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Germany,
(ii) Mr. Alexander Kudlich, born in Bonn on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany, and;
(iii) Mr. Arnt Jeschke, born in Cologne on 23 April 1971 professionally residing at Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Germany.
3. The following person is appointed as independent auditor until the general meeting of shareholders convened to
approve the Company’s annual accounts for the first financial year:
Ernst and Young Services S.A., réviseur d’entreprises agréé, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L
-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B69847.
4. The following person is appointed as member of the management board of the Company until the general meeting
of shareholders convened to approve the Company’s annual accounts for the first financial year:
Mr. Ralf Wenzel, born in Berlin on 08 August 1979, professionally residing at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zweiundzwanzig Januar.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland,
36886
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 19. Januar
2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und der unterzeichnenden Notarin ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat die amtierende Notarin ersucht, die Gründung einer Aktiengesellschaft (société anonyme)
zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen ECommerce Holding S.A. (die
„Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner ak-
tuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher
Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligati-
onen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst
werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Vorstands verlegt werden.
Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Vorstands im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Vorstand entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen
aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesell-
schaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnli-
chen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), bestehend aus einund-
dreißigtausend (31.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine
Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung erhöht oder
herabgesetzt werden.
5.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt dem/den bestehenden Aktionär/en
angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden diese Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der
von ihnen am Gesellschaftskapital jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Vorstand bestimmt den Zeitraum, in dem
36887
L
U X E M B O U R G
dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welcher nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung
eines an den/die Aktionär/e gesendeten Einschreibens, welches die Eröffnung der Zeichnungsfrist ankündigt, beträgt. Die
Hauptversammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht des bestehenden Aktionärs/der bestehenden Aktionäre durch
einen Beschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, begrenzen oder
aufheben. Der Vorstand kann dieses Vorzugsrecht im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 6 dieser Satzung
begrenzen oder aufheben.
5.4 Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Art. 6. Genehmigtes Kapital.
6.1 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt ausschließlich des Gesellschaftskapitals viertausendsechshundert-
fünfzig Euro (EUR 6.450), bestehend aus viertausendsechshundertfünfzig (6.450) Aktien mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1). Der Vorstand ist während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung
dieser Satzung oder, soweit anwendbar, eines Beschlusses, das genehmigte Kapital gemäß dieses Artikels zu erneuern
oder zu erhöhen, im Rahmen dieses genehmigten Kapitals ermächtigt, Aktien auszugeben, Aktienbezugsoptionen zu ge-
währen und jedes andere in Aktien umwandelbare Wertpapier auszugeben, wobei die Ausgabe an solche Personen und
unter solchen Bedingungen erfolgt, die der Vorstand für sinnvoll hält und insbesondere ohne dem/den bestehenden
Aktionär/en ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren. Diese Ermächtigung kann
einmal oder mehrmals durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden, welcher in der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, und zwar jeweils für einen Zeitraum, der nicht mehr
als fünf (5) Jahre beträgt.
6.2 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, wel-
cher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 7. Aktien.
7.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
7.2 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
7.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
7.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.
7.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Aktien oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Aktionär(en) oder Vorstandsmitglied(ern) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 8. Aktienregister - Übertragung von Aktien.
8.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.
Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Ei-
gentum an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Aktionärs werden Zertifikate über die Eintragung ausgegeben.
8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
8.3 Die Aktien sind im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes frei übertragbar.
8.4 Jede Übertragung von Namensaktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten wirksam (i) durch Eintragung
einer vom Zedenten und vom Zessionar oder deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung
im Aktienregister, oder (ii) nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder dieser zuge-
stimmt hat.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
9.1 Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig ein-
berufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Haupt-
versammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen
Befugnisse.
9.2 Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung der Aktionäre“ in der
vorliegenden Satzung je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als Bezug auf den „alleinigen Aktionär“ zu verstehen
und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.
36888
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Vorstand, durch den Aufsichtsrat oder, soweit
vorhanden, durch den/die Rechnungsprüfer einberufen werden.
10.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent (10%) des Gesell-
schaftskapitals halten, vom Vorstand, vom Aufsichtsrat oder vom Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern einberufen
werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des
Ersuchens abgehalten werden.
10.3 Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Ta-
gesordnung der Versammlung enthalten und zweimal in Form einer Einberufung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von mindestens acht (8) Tagen und acht (8)
Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einberufungen per Post sind acht (8) Tage vor
dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis der
Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann die
Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung an-
beraumten Datum an jeden Aktionär zu versenden sind.
10.4 Falls alle Aktionäre in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf Ladungsformalitäten verzichtet
haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 11. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.
11.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen
in der Einberufung bestimmten Ort am ersten Mittwoch des Monats Juni um 14.00 Uhr MEZ abgehalten. Ist dieser Tag
ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten.
Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angege-
benen Zeit abgehalten werden.
11.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden,
einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Vorstands sein müssen.
Wenn alle bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre entscheiden, dass eine ordnungsgemäße Abstimmung derart
gewährleisten werden kann, so können sie einstimmig beschließen, lediglich (i) einen Vorsitzenden und einen Schriftführer
oder (ii) eine Person zu ernennen, die die Rolle des Rates der Versammlung übernimmt und in einem solchen Fall ist die
Ernennung eines Stimmzählers nicht erforderlich. Soweit anwendbar und je nach Zusammenhang ist jeder Bezug auf den
„Rat der Versammlung“ in dieser Satzung als Verweis auf den „Vorsitzenden und Schriftführer“ oder gegebenenfalls als
Verweis auf die „Einzelperson, die die Rolle des Rates übernommen hat“, zu verstehen. Der Rat der Versammlung soll
sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor allem im Einklang mit den Regeln betreffend
die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.
11.3 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird eine Anwesenheitsliste geführt.
11.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person durch
ein unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt
wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.
11.5 Aktionäre, die an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und des
Stimmrechts, insofern diese Kommunikationsmittel am Ort der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt werden.
11.6 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch eine unterzeichnete Stimm-
karte abgeben, welche per Post, EMail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft
oder an die in der Einberufung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimmkarten ver-
wenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der
Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem
Aktionären ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten,
indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt.
11.7 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen
den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre
erhalten hat.
11.8 Der Vorstand kann weitere Bedingungen bestimmen, die von den Aktionären eingehalten werden müssen, um an
einer Hauptversammlung teilzunehmen.
Art. 12. Quorum und Stimmrecht.
12.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.
12.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in
einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
36889
L
U X E M B O U R G
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Art. 13. Änderungen dieser Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der
Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3)
der abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist.
Falls die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser
Satzung eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem Anwesenheitsquo-
rum beschlussfähig ist und in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen
gültigen Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 15. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915
kann der Vorstand jede sich im Gange befindliche Hauptversammlung der Aktionäre um vier (4) Wochen vertagen. Der
Vorstand muss eine Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von Aktionären, die mindestens zwanzig
Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals halten, gefordert wird. Durch derartige Vertagung wird jeder bereits gefasste
Beschluss in dieser Versammlung annulliert.
Art. 16. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
16.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches vom Rat der Versammlung sowie
von jedem Aktionär, der darum ersucht, unterzeichnet wird.
16.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht
werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der
die Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Vorstandsvorsitzenden oder von zwei beliebigen
Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 17. Dualistische Führungs- und Aufsichtsstruktur.
17.1 Die Geschäftsführung der Gesellschaft unterliegt den Bestimmungen der Artikel 60bis-1 bis 60bis-19 des Gesetzes
von 1915, es sei denn, in dieser Satzung wird etwas Gegenteiliges bestimmt.
17.2 Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, der seine Funktion unter der Kontrolle eines Aufsichtsrats
ausführt (jeweils der „Vorstand“ und der „Aufsichtsrat“).
Art. 18. Zusammensetzung und Befugnisse des Vorstands.
18.1 Der Vorstand setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen. Sofern die Gesellschaft jedoch von einem
einzigen Aktionär gegründet wurde oder sich bei einer Aktionärsversammlung herausstellt, dass alle von der Gesellschaft
ausgegebenen Aktien von einem alleinigen Aktionär gehalten werden, werden die Funktionen des Vorstands bis zur
nächsten Hauptversammlung der Aktionäre nach der Erhöhung der Anzahl der Aktionäre von einem alleinigen Vorstand
ausgeübt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff „alleiniger Vorstand“ in dieser Satzung nicht aus-
drücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Vorstand“ als Verweis auf den „alleinigen Vorstand“
auszulegen.
18.2 Der Vorstand verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Hand-
lungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch
das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung dem Aufsichtsrat oder der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehal-
tenen Befugnisse.
Art. 19. Tägliche Geschäftsführung.
19.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung
der Gesellschaft einem (1) oder mehreren Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen, aber
nicht Aufsichtsratsmitgliedern, mit gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung,
Abberufung und ihre Befugnisse werden durch einen Beschluss des Vorstands bestimmt.
19.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.
Art. 20. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Vorstandsmitgliedern.
20.1 Vorstandsmitglieder werden durch den Aufsichtsrat gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt. Die ersten
Vorstandsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre gewählt.
20.2 Der Aufsichtsrat kann die Ernennung von Vorstandsmitgliedern zweier (2) unterschiedlicher Kategorien be-
schließen, nämlich Vorstandsmitglieder der Kategorie A und Vorstandsmitglieder der Kategorie B. Eine solche Klassifi-
zierung der Vorstandsmitglieder muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Aufsichtsratsbeschlüsse
festgehalten und die Vorstandsmitglieder der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
20.3 Die Amtszeit eines Vorstandsmitglieds darf fünf (5) Jahre nicht überschreiten und jedes Vorstandsmitglied übt
sein Amt aus, bis sein Nachfolger gewählt ist. Jedes Vorstandsmitglied kann wiedergewählt werden.
36890
L
U X E M B O U R G
20.4 Jedes Vorstandsmitglied kann jederzeit und ohne Grund vom Aufsichtsrat abberufen werden.
20.5 Der Vorstand kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Ein stellvertretender Vorsitzender
kann vom Vorstand unter seinen Mitgliedern mit einfacher Mehrheit gewählt werden. Ist der Vorstandsvorsitzende an
der Ausübung seiner Tätigkeiten verhindert, wird er gegebenenfalls vom stellvertretenden Vorsitzenden vertreten.
20.6 Wird eine juristische Person als Vorstandsmitglied gewählt, so muss diese eine natürliche Person als ihren stän-
digen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische
Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche
Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Vorstandsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Vorstandsmitglied sein.
Eine natürliche Person kann nicht gleichzeitig ständiger Vertreter eines Vorstandsmitglieds und eines Aufsichtsratsmitglied
sein.
Art. 21. Vakanz des Amtes eines Vorstandsmitglieds.
21.1 Scheidet ein Vorstandsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen
Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Vorstandsmitglieder bis zur nächsten Hauptver-
sammlung der Aktionäre vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Vorstandsmitglieds
nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den an-
wendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
21.2 Alternativ kann der Aufsichtsrat vorübergehend eines (1) seiner Mitglieder zur Ausführung der Aufgaben eines
Vorstandsmitglieds ernennen. Sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied ruht für die Zeit seiner Ernennung als Vorstandsmit-
glied.
Art. 22. Einladung zu Vorstandssitzungen.
22.1 Der Vorstand versammelt sich auf Einberufung des Vorstandsvorsitzenden mindestens alle drei (3) Monate. Zu-
sätzliche Vorstandssitzungen werden unverzüglich abgehalten, wenn zwei (2) Vorstandsmitglieder dies ersuchen. Kommt
der Vorstandsvorsitzende dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der stellvertretende Vorsitzende zur Einberufung der
ersuchten Sitzung und zur Vertretung des Vorsitzenden für die Zwecke dieser Sitzung ermächtigt. Die Vorstandssitzungen
finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt, am Sitz der Gesellschaft statt.
22.2 Die Vorstandsmitglieder werden mindestens sieben (7) Tage vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu
jeder Vorstandssitzung schriftlich per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels geladen, außer
in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann
unterbleiben, wenn alle Vorstandsmitglieder schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikati-
onsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein
hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Vorstandssitzungen ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem
vorausgehenden Beschluss des Vorstands bestimmt worden sind.
22.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Vorstandsmitglieder in einer Sitzung anwesend oder vertreten sind
und diese sämtliche Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle
Vorstandsmitglieder diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.
Art. 23. Durchführung von Vorstandssitzungen.
23.1 Vorstandssitzungen werden durch den Vorstandsvorsitzenden geleitet. In dessen Abwesenheit wird die Sitzung
vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Der Vorstand bestimmt eines seiner Mitglieder der Kategorie B als Proto-
kollführer der Vorstandssitzungen.
23.2 Jedes Vorstandsmitglied kann von einem anderen Vorstandsmitglied, welches derselben Kategorie zugehört, für
die Beschlussfassung in Sitzungen vertreten werden. In diesem Fall ist eine schriftliche Vollmacht für die Beschlussfassung
vorzulegen und dem Protokoll beizufügen. Ein Vorstandsmitglied kann mehrere seiner Kollegen innerhalb derselben Ka-
tegorie vertreten.
23.3 Grundsätzlich fasst der Vorstand Beschlüsse in Sitzungen. Beschlüsse des Vorstands können jedoch auch in Form
von schriftlichen Umlaufbeschlüssen durch Fax oder per E-Mail gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied innerhalb
einer (1) Woche nach dem Antrag auf Stimmabgabe im Umlaufverfahren Einspruch gegen dieses Verfahren einlegt. Jedes
Vorstandsmitglied kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die
Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart
gefassten Beschlusses.
23.4 Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Abstimmung
teilnehmenden Vorstandsmitglieder gefasst, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder in einer Gesellschafterversammlung
etwas Gegenteiliges bestimmt.
23.5 Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine (1) Stimme. Der Vorstandsvorsitzende hat im Falle von Stimmgleichheit
die entscheidende Stimme.
23.6 Soweit nicht gesetzlich anders bestimmt muss jedes Vorstandsmitglied, welches an einem Geschäft, das dem
Vorstand zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein Interesse hat, welches den Interessen der Gesellschaft ent-
gegensteht, den Vorstand über diesen Interessenskonflikt informieren; die Erklärung wird im Protokoll der betreffenden
Sitzung aufgenommen. Das betreffende Vorstandsmitglied darf weder an der Beratung über das in Frage stehende Geschäft
36891
L
U X E M B O U R G
teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss von derartigen Interessen-
konflikten informiert werden, bevor Beschlüsse zu anderen Tagesordnungspunkten gefasst werden. Darüber hinaus ist
für eine solche Transaktion die Genehmigung des Aufsichtsrats erforderlich. Diese Bestimmungen finden jedoch keine
Anwendung, wenn sich die Entscheidungen auf gängige Geschäfte im gewöhnlichen Geschäftsgang beziehen.
23.7 Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand beschließen. Der Vorstand hat diese Geschäfts-
ordnung für den Vorstand für alle Rechtsgeschäfte, Aktivitäten und Maßnahmen der Gesellschaft und ihrer direkten und
indirekten Tochtergesellschaften zu berücksichtigen und einzuhalten.
23.8 Der Vorstand hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 23, soweit gesetzlich möglich, auf die
gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt oder
indirekt, gegenwärtig oder künftig, eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 24. Protokoll von Vorstandssitzungen.
24.1 Vorstandssitzungen und die darin gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten, welches vom
Vorstandsvorsitzenden oder von einem beliebigen Vorstandsmitglied, dem eine solche Befugnis übertragen worden ist,
unterzeichnet wird.
24.2 Das Protokoll wird allen Vorstandsmitgliedern unmittelbar nach der Erstellung übermittelt und am Sitz der Ge-
sellschaft in Luxemburg hinterlegt. Das Protokoll gilt als angenommen, wenn kein Vorstandsmitglied schriftlich innerhalb
von vier (4) Wochen nach Erhalt Widerspruch einlegt. Ein solcher Widerspruch ist an den Vorstandsvorsitzenden wei-
terzuleiten und in der folgenden Vorstandssitzung abzuhandeln. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden alleine oder gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied der Kategorie A und einem Vorstandsmitglied der Kategorie B oder von einem beliebigen Vorstandsmit-
glied, dem eine solche Befugnis übertragen worden ist, unterzeichnet.
Art. 25. Geschäfte mit Dritten.
25.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des einzigen Vor-
standsmitglieds, (ii) durch die gemeinsame Unterschrift eines (1) Mitglieds der Kategorie A und eines (1) Mitglieds der
Kategorie B (einschließlich deren Vertreter), oder (iii) durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine solche Befugnis durch den Vorstand übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.
25.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder
Einzelunterschrift der Person(en), der/denen diese Befugnis übertragen wurde, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.
Art. 26. Befugnisse des Aufsichtsrats.
26.1 Der Aufsichtsrat ist mit der laufenden Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung der Gesellschaft durch
den Vorstand betraut. Der Aufsichtsrat greift in keinem Fall in die Geschäftsführung ein.
26.2 Der Aufsichtsrat hat ein uneingeschränktes Informationsrecht über alle Tätigkeiten der Gesellschaft und darf in
jedes Dokument der Gesellschaft einsehen. Er darf vom Vorstand verlangen, ihm jegliche Information zur Verfügung zu
stellen, die für die Ausübung seiner Funktion erforderlich ist und kann direkt oder indirekt jegliche Überprüfung vorneh-
men, die er zur Ausübung seiner Funktion für erforderlich hält.
26.3 Der Vorstand erstellt mindestens alle drei (3) Monate einen schriftlichen Bericht an den Aufsichtsrat über die
Geschäfte der Gesellschaft und die vorhersehbare zukünftige Entwicklung. Der Vorstand unterrichtet außerdem den
Aufsichtsrat unverzüglich über jedes Ereignis, das wahrscheinlich einen spürbaren Einfluss auf die Situation der Gesellschaft
hat.
Art. 27. Zusammensetzung des Aufsichtsrats.
27.1 Der Aufsichtsrat setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen.
27.2 Der Aufsichtsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Aufsichtsratsvorsitzenden. Er kann auch einen Schriftführer
ernennen, der weder Aktionär, noch Aufsichtsratsmitglied sein muss.
27.3 Ein Vorstandsmitglied kann nicht gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied sein.
Art. 28. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Aufsichtsratsmitgliedern.
28.1 Aufsichtsratsmitglieder werden durch einstimmige Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt,
die ihre Bezahlung und Amtszeit festlegt. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann die Anzahl der Aufsichtsratsmit-
glieder mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien erhöhen oder herabsetzen.
28.2 Die Amtszeit eines Aufsichtsratsmitglieds darf drei (3) Jahre nicht überschreiten und jedes Aufsichtsratsmitglied
übt sein Amt aus, bis sein Nachfolger gewählt ist. Jedes Aufsichtsratsmitglieds kann wiedergewählt werden.
28.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund durch die Hauptversammlung der Aktionäre mit
einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien abberufen werden.
28.4 Wenn eine juristische Person als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft gewählt wird, muss diese eine natürliche
Person als ständigen Vertreter benennen, welche diese Rolle im Namen und für Rechnung der juristischen Person ausübt.
Die betreffende juristische Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen
Nachfolger ernennt. Eine natürliche Person kann der ständige Vertreter nur eines (1) Aufsichtsratsmitglieds sein und kann
36892
L
U X E M B O U R G
nicht gleichzeitig auch selbst Aufsichtsratsmitglied sein. Eine natürliche Person kann nicht gleichzeitig der ständige Ver-
treter eines Aufsichtsratsmitglieds und eines Vorstandsmitglieds sein.
Art. 29. Vakanz des Amtes eines Aufsichtsratsmitglieds.
29.1 Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen
Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Aufsichtsratsmitglieder vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Aufsichtsratsmitglieds nicht übersteigenden Zeitraum ausgefüllt werden,
bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen
über eine endgültige Neubesetzung entscheidet.
29.2 Wenn die Gesamtanzahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei (3) oder unter eine sich eventuell aus dieser
Satzung ergebende höhere Mindestzahl fällt, so muss diese freie Stelle unverzüglich entweder durch die Hauptversamm-
lung der Aktionäre oder im Einklang mit Artikel 29.1 besetzt werden.
Art. 30. Einladung zu Aufsichtsratssitzungen.
30.1 Der Aufsichtsrat versammelt sich auf Einberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden mindestens alle drei (3) Monate.
Zusätzliche Aufsichtsratssitzungen werden unverzüglich abgehalten, wenn zwei (2) Aufsichtsratsmitglieder dies ersuchen.
Kommt der Aufsichtsratsvorsitzende dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der stellvertretende Vorsitzende zur Einbe-
rufung der ersuchten Sitzung und zur Vertretung des Aufsichtsratsvorsitzenden für die Zwecke dieser Sitzung ermächtigt.
Die Aufsichtsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt, am Sitz der Gesellschaft statt.
30.2 Die Aufsichtsratsmitglieder werden mindestens sieben (7) Tage vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu
jeder Aufsichtsratssitzung schriftlich per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels geladen,
außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung
kann unterbleiben, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kom-
munikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein
hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Aufsichtsratssitzungen ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem
vorausgehenden Beschluss des Aufsichtsrats bestimmt worden sind.
30.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder in einer Sitzung anwesend oder vertreten
sind und diese sämtliche Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn
alle Aufsichtsratsmitglieder diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.
Art. 31. Durchführung von Aufsichtsratssitzungen. Die Bestimmungen des Artikels 23 dieser Satzung gelten sinngemäß
für die Durchführung von Aufsichtsratssitzungen.
Art. 32. Protokoll von Aufsichtsratssitzungen.
32.1 Der Schriftführer oder, sofern ein solcher nicht ernannt worden ist, der Aufsichtsratsvorsitzende soll ein Protokoll
über jede Aufsichtsratssitzung aufnehmen, welches vom Aufsichtsratsvorsitzenden und vom Schriftführer, sofern vor-
handen, unterzeichnet wird. In seiner Abwesenheit wird das Protokoll gemeinsam von zwei beliebigen Aufsichtsratsmit-
gliedern unterzeichnet.
32.2 Jede Kopie und jeder Auszug solcher Originalprotokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet oder die
Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sind vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von zwei (2) beliebigen Aufsichts-
ratsmitgliedern zu unterzeichnen.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 33. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
33.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire
(s)). Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, bei der es sich um
eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, die den Jahresabschluss des entsprech-
enden Geschäftsjahres verabschiedet, handelt.
33.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen wer-
den.
33.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
33.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsund Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen
in seiner geänderten Fassung einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) er-
nennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.
33.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 34. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
36893
L
U X E M B O U R G
Art. 35. Jahresabschluss und Gewinne.
35.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Vorstand erstellt im Einklang mit den
gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.
35.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
35.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der
gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
35.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
35.5 Auf Vorschlag des Vorstands bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit dem Gesetz von
1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.
35.6 Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen
Aktien.
Art. 36. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
36.1 Der Vorstand kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Abschlagsdividenden auszahlen.
36.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 37. Liquidation.
37.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die
über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
37.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 38. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember 2015.
2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahr 2016 abgehalten werden.
3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die einunddreißigtausend (31.000) ausgegebenen Aktien wurden von Rocket Internet AG, vorbenannt, zu einem Preis
von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) gezeichnet.
Die Einlage für die so gezeichneten Aktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ab sofort ein
Betrag in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) zur Verfügung steht, was der unterzeichnenden Notarin
nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Erklärungi>
Die unterzeichnende Notarin erklärt hiermit, dass sie die Einhaltung der Vorschriften, die in Artikel 26, 26-3 und 26-5
des Gesetzes von 1915 aufgeführt sind und auf die verwiesen wird, geprüft hat und erklärt, dass diese erfüllt sind.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,-geschätzt.
<i>Beschlüsse des Aktionärsi>
Der Gründer, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf sämtliche Einberufungsforma-
litäten verzichtet hat, hat folgende Beschlüsse gefasst:
36894
L
U X E M B O U R G
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden als Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft, bis zur Hauptversammlung der Akti-
onäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet, ernannt:
(i) Herr Oliver Samwer, geboren am 9. August 1972 in Köln, geschäftsansässig in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland;
(ii) Herr Alexander Kudlich, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, geschäftsansässig in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland; und
(iii) Herr Arnt Jeschke, geboren am 23. April 1971 in Köln, geschäftsansässig in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.
3. Die folgende Person wird als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, bis zur Hauptversammlung der Ak-
tionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet, ernannt:
Ernst and Young Services S.A., réviseur d’entreprises agréé, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L -5365 Munsbach,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B69847.
4. Die folgende Person wird als Vorstandsmitglied der Gesellschaft, bis zur Hauptversammlung der Aktionäre, die den
Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet ernannt:
Herr Ralf Wenzel, geboren am 8. August 1979 in Berlin, geschäftsansässig in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutsch-
land.
Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.
Die beurkundende Notarin, welche die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde
auf Ersuchen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersu-
chen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welcher der Notarin
mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit der Notarin
unterzeichnet.
Gezeichnet: K. DE WAEL und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 28 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2585. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 13. Februar 2015.
Référence de publication: 2015025857/947.
(150029765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Dream International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 121.181.
L'an deux mille quinze, le quatre février;
Pardevant la notaire Maître Carlo WERSANDT, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
S'est réunit
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée “DREAM INTERNA-
TIONAL S.A.”, ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 121181, constituée suivant acte reçu pardevant le notaire
Henry HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 23 octobre 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2344 du 15 décembre 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roberto PIATTI, expert-comptable, demeurant professionnel-
lement à I-20121 Milan, 49, Corso Giuseppe Garibaldi (Italie).
Le président désigne Madame Nathalie MAGER, employée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg,
45-47, route d'Arlon, comme secrétaire et l'assemblée choisit Madame Regina ROCHA-MELANDA, employée, demeu-
rant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, comme scrutatrice.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires dûment représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
36895
L
U X E M B O U R G
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 110 (cents dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,-
(cent euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale et effective de la
société de L-1140 Luxembourg, 45-47 Route d'Arlon à I-20121 Milan, Corso Garibaldi 49, et adoption par la société
anonyme de la nationalité italienne sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises (“Registro
Imprese”) de Milan;
2. Approbation des comptes sociaux, bilans et comptes économiques;
3. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 4 février 2015 sur base des lois italiennes;
4. Changement de la dénomination de la société de “DREAM INTERNATIONAL S.A.” en “DREAM INTERNATIONAL
S.r.l.”;
5. Modification de l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts en langue italienne;
6. Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050;
7. Démission des gérants actuellement en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à
la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en Italie;
8. Nomination d'un nouvel administrateur unique;
9. Refonte complète des statuts pour le mettre en concordance avec la législation italienne;
10. Délégation de pouvoirs;
11. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite
auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Milan;
12. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de transférer le siège statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de
direction effective de la société de L-1140 Luxembourg, 45-47 Route d'Arlon à I-20121 Milan, Corso Garibaldi 49, Italie,
et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien, le tout
sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Milan.
L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des
obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.
Elle constate en outre aucune action sans droit de vote n'a été émise par la société.
Elle constate également:
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévus par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet,
ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution
est prise en conformité avec l'article 67.1 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été
modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50
du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée examine et approuve, les comptes sociaux à savoir les bilans, les comptes de pertes et profits arrêtés en
dates des 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 tels que ces comptes sont soumis à l'assemblée par le conseil d'ad-
ministration.
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la Société arrêtée au 4 février 2015, telle qu'elle
a été établie par le conseil d'administration en fonction, avant le transfert du siège social de la société.
Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée “ne varietur” par les membres du bureau, restera
annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en “DREAM INTERNATIONAL S.r.l.”.
36896
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article deux des nouveaux statuts
en langue italienne ci-après.
<i>Sixième résolution:i>
L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
<i>Septième résolution:i>
L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs actuellement en fonction et de leur accorder décharge
pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.
<i>Huitième résolution:i>
L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique, en conformité avec la législation italienne, avec pouvoirs
d'ordinaire et extraordinaire administration et sauf révocation ou démission:
Monsieur Brunello DONATI, né à Lugano (CH) le 26 août 1947, demeurant à Ponte Capriasca (CH), Via Nogo 3,
code fiscal: DNT BNL 47M26 Z133W.
<i>Neuvième résolution:i>
L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation
italienne, et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire
adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:
STATUTO
Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione
“DREAM INTERNATIONAL S.r.l.”
Art. 2. Oggetto. La società ha per oggetto:
a) - l'assunzione di partecipazioni in genere, comprensiva dell'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti,
rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese e di coordinamento gestionale, tecnico e finanziario delle
imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni; il finanziamento, da esercitarsi in via non esclusiva a favore e nei
confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile o comunque all'interno del
gruppo e anche nei confronti di terzi, comprensiva detta attività della concessione di crediti inclusi il rilascio di garanzie
accessorie del credito e di impegni di firma nonché le operazioni di acquisto di crediti, di rilascio di fidejussioni, avalli,
aperture di credito; la gestione di patrimoni; il tutto con esclusione delle attività riservate per legge.
b) - l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta nonché la gestione e la conduzione di qualsiasi tipo di immobili,
e l'assunzione di partecipazioni comprensiva delle attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati
o meno da titoli, sul capitale di altre imprese aventi per oggetto attività immobiliari.
La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni che l'organo Amministrativo riterrà necessarie od utili per il
raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie.
La società può, quindi, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare
avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di debiti di terzi ed ogni altra disposizione
ritenuta opportuna dall'Organo Amministrativo.
Art. 3. Finanziamento soci. La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanzia-
menti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, ai soci, anche senza il rispetto della proporzionalità delle
quote possedute, nei limiti fissati dalle vigenti norme legislative o regolamentari in materia di raccolta del risparmio.
Tali versamenti saranno considerati improduttivi di interessi salvo diverso patto scritto.
Art. 4. Sede.
A. La sede della società è stabilita nel comune di Milano.
B. E' attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di:
- trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale;
- istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ferma
restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale od all'estero.
Art. 5. Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere
prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche in sede di liquidazione.
Art. 6. Capitale.
A. Il capitale sociale è fissato in Euro 33.000,00 (trentatremila/00) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i
soci.
B. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
36897
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Trasferimento quote. Le quote di partecipazione sono trasmissibili, per atto tra vivi a titolo oneroso, nel rispetto
della seguente clausola di prelazione.
Il socio che intende cedere la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci.
La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo
e le modalità di pagamento.
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio
offerente la propria risposta entro sessanta giorni dall'invio dell'offerta.
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, l'offerta spetterà ai soci interessati in
proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
Se qualcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a
favore di quei soci che hanno manifestato la loro intenzione di acquisire anche le quote inoptate.
Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, da uno qualsiasi dei soci aventi diritto alla prelazione, lo stesso sarà
stabilito da un Arbitro designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo della sede sociale.
In questo caso il socio proponente potrà in ogni momento revocare la proposta di cessione.
Art. 8. Amministrazione. L'amministrazione della società è affidata dai soci ad un Amministratore Unico o ad un Con-
siglio di Amministrazione composto da due o più membri secondo il numero determinato al momento della nomina.
Art. 9. Nomina e revoca amministratori.
A. Gli amministratori sono nominati dai soci e possono essere anche non soci.
B. Salvo diversa delibera all'atto della nomina, essi durano in carica sino a revoca o dimissioni.
C. La revoca degli Amministratori potrà intervenire in ogni momento senza alcun preavviso e senza alcuna pretesa da
parte degli stessi in ordine ad indennità o risarcimento.
D. Anche dopo la scadenza del mandato gli Amministratori rimarranno in carica per gli affari di ordinaria amministra-
zione fino alla accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori.
E. La carica di Amministratore è gratuita.
Agli Amministratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per la società ed in relazione alla carica.
L'atto di nomina, o una decisione dei soci in corso di esercizio in deroga al precedente patto, può fissare un corrispettivo
per l'opera dagli stessi prestata.
Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del
rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.
Art. 10. Consiglio di amministrazione. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, l'attività dello stesso
sarà regolata dalle seguenti norme:
A. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di tanti amministratori pari alla maggioranza del numero
deliberato dall'atto di nomina e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.
In caso di parità prevale il voto di Presidente.
B. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'atto di nomina, elegge tra i propri membri un
Presidente.
C. Esso si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente
da almeno due Amministratori o dai Sindaci se nominati.
D. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo.
E. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza, senza
che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci se nominati nello stesso luogo, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Le modalità di svolgimento della tele conferenza saranno precisate dall'Organo Amministrativo nell'avviso di convo-
cazione oppure in un regolamento appositamente predisposto.
F. In alternativa alla formale riunione le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante
consultazione scritta, in seguito ad invio da parte del Presidente a tutti gli Amministratori del testo integrale della delibera
da assumere.
G. In caso di cessazione dalla carica di almeno la metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e
ciascun socio dovrà, senza indugio, convocare gli altri soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
Art. 11. Poteri dell'organo amministrativo.
A. Agli Amministratori spettano i poteri a loro conferiti con l'atto di nomina.
B. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le sue attribuzioni ad uno o più Amministratori delegati determinando
i limiti della delega.
36898
L
U X E M B O U R G
C. Quando il Consiglio è composto da due membri in caso di disaccordo sulla nomina o revoca degli Amministratori
Delegati, decade dalla carica l'intero consiglio.
Art. 12. Rappresentanza.
A. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico e disgiuntamente a tutti
i componenti del Consiglio di Amministrazione.
B. La rappresentanza in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
C. La rappresentanza della società spetta anche ai Direttori, agli Institori ed ai Procuratori organici, nei limiti dei poteri
loro conferiti dagli amministratori nell'atto di nomina.
D. La rappresentanza della società per determinati atti o categorie di atti, può anche essere attribuita dagli amminis-
tratori a terzi mediante formale procura.
Art. 13. Controllo. Quando obbligatoriamente previsto dalla legge sarà nominato un Organo di Controllo nel rispetto
delle disposizioni in tema di società per azioni.
In questo caso le funzioni di controllo legale dei conti potranno essere attribuite dai soci allo stesso Organo di Controllo
o ad un Revisore Legale, come previsto dagli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.
Art. 14. Decisioni dei soci. Sono riservate alla competenza dei soci:
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- l'eventuale nomina dei Sindaci o del Revisore Contabile;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- la liquidazione, la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori.
Art. 15. Diritto di voto. Hanno diritto di voto tutti i soci risultanti dal Libro Soci istituito a norma dell'art. 21) del
presente Atto Costitutivo.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.
Art. 16. Assemblea. Tutte le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.
Le decisioni sono prese col voto favorevole del 50% del capitale sociale.
Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- la liquidazione e la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
- oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del
capitale sociale;
queste decisioni dei soci devono essere prese con la maggioranza del capitale sociale.
Art. 17. Convocazione e svolgimento dell'assemblea.
A. Ricorrendo le condizioni di legge ogni amministratore può provvedere alla convocazione dell'assemblea.
Ove sussista obbligo di legge di adottare una determinata delibera in caso di inerzia da parte degli Amministratori,
ciascun socio può procedere alla convocazione.
La convocazione è validamente eseguita con l'invio dell'Ordine del Giorno, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della
prima convocazione e delle eventuali convocazioni successive e l'elenco delle materie da trattare, mediante avviso sot-
toscritto dal soggetto convocante consegnato tramite posta o a mano, oppure tramite fax, o email almeno cinque giorni
prima dell'adunanza.
B. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia;
C. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/
video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento
dei soci, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10/E del presente statuto.
D. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa
l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori (Sindaci e Revisore se nominati) sono presenti o informati e nessuno si
oppone alla trattazione dell'argomento.
Gli Amministratori (Sindaci o Revisore) che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita
dichiarazione scritta (in originale, fax od email), da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere
informati su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, di non opporsi alla trattazione degli stessi.
E. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18. Scioglimento. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
36899
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Bilancio ed utili. Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procederanno alla formazione del bilancio sociale e lo presenteranno ai
soci entro il termine ordinario di legge, ovvero entro il maggior termine previsto dalla legge stessa, a condizione che gli
Amministratori segnalino nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile, o nella nota integrativa le ragioni della
dilazione, nel rispetto dell'art. 2364 Codice Civile.
Art. 20. Distribuzione utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata la somma prescritta dall'articolo 2430
Codice Civile per la costituzione del fondo di riserva, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alle partecipazioni
al capitale da ciascuno posseduta, salvo che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.
Art. 21. Libro dei soci e domicilio dei soci. La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori
secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.
In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali
e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, nonché il mutamento
del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli
amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle
imprese eseguito ai sensi di legge.
Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni
inderogabili di legge.
Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato
nel libro dei soci.
A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo
telefax.
Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in
tutti gli altri casi previsti dalla legge.
<i>Dixième résolution:i>
L'assemblée décide de conférer à Monsieur Brunello DONATI, né à Lugano (CH) le 26 septembre 1947, demeurant
à à Ponte Capriasca (CH), Via Nogo 3, code fiscal: DNT BNL 47M26 Z133W tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes
les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue
d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quel-
conque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-
avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.
En outre, Monsieur Brunello DONATI, prénommé, est autorisé à entreprendre toute procédure nécessaire et à
exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés
de Milan, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui
pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et,
d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.
Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la
société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
(“Registro Imprese”) de Milan.
Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être
obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.
<i>Onzième résolution:i>
L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social
de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Milan.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle le français, constate par les présentes qu'à la requête des comparants le
présent acte est rédigé en français suivi d'une version italienne; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre les textes français et italien, la version française fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg; les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présente acte.
Suit la version italienne du texte qui précède:
L'anno duemila quindici, il quattro febbraio.
Davanti al notaio Maître Carlo WERSANDT, residente a Lussemburgo, (Granducato del Lussemburgo), sottoscritto.
36900
L
U X E M B O U R G
Si è riunita
un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della società a responsabilità limitata “DREAM INTERNATIONAL
S.A.”, avente sede legale a L-1140 Lussemburgo, 45-47, Route d'Arlon, iscritta al Registro di Commercio e delle Società
di Lussemburgo, alla sezione B, con il numero 121181, costituita giusto atto rogato dal notaio Henry HELLINCKX, poi
residente a Mersch, (Granducato del Lussemburgo), in data 23 ottobre 2006, pubblicato al Mémorial C, Raccolta delle
Società ed Associazioni, numero 2344 del 15 dicembre 2006.
La seduta si apre sotto la presidenza del Signor Roberto PIATTI, esperto contabile, domiciliato professionalmente a
I-20121 Milano, Corso Giuseppe Garibaldi 49 (Italia).
Il presidente nomina la Signora Nathalie MAGER, impiegata, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussemburgo,
45-47 Route d'Arlon, come segretario e l'assemblea sceglie come scrutatrice la Signora Regina ROCHA-MELANDA,
impiegata, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon.
Il presidente prega il notaio di prendere atto che:
I.- Gli azionisti presenti o rappresentati e il numero delle azioni da essi detenute sono annotati su una lista delle
presenze. Questa lista, insieme alle deleghe, una volta sottoscritte dai comparenti e dal notaio rogante, rimarranno annesse
al presente atto per essere registrare insieme ad esso.
II.- Una volta chiusa, questa lista delle presenze fa emergere che le 110 (centodieci) azioni del valore nominale di EUR
100,- (cento euro) ciascuna, rappresentanti la totalità del capitale sociale ammontante a EUR 33.000,- (trentatremila euro)
sono rappresentate nella presente assemblea generale straordinaria, in maniera che l'assemblea può deliberare valida-
mente su tutti i punti riportati all'ordine del giorno, di cui gli azionisti sono stati preventivamente informati.
III.- L'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:
<i>Ordine del giorno:i>
1. Trasferimento della sede legale statutaria, della sede di direzione effettiva e dell'amministrazione centrale ed effettiva
della società da L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon a I-20121 Milano (Italia), Corso Garibaldi 49, ed adozione da
parte della società della nazionalità italiana con riserva di iscrizione della società presso il Registro Imprese di Milano;
2. Approvazione dei bilanci della società e relativo conto economico;
3. Approvazione di una situazione contabile intermedia chiusa al 15 gennaio 2015 sulla base delle leggi italiane;
4. Cambio della denominazione della società da “DREAM INTERNATIONAL S.A.” a “DREAM INTERNATIONAL
S.r.l.”;
5. Modifica dell'oggetto sociale al fine di attribuirgli il contenuto riportato nei nuovi statuti in lingua italiana;
6. Fissazione della durata della società fino al 31 dicembre 2050;
7. Dimissioni degli amministratori e del sindaco attualmente in carica e scarico a loro dovuto per l'esecuzione del loro
mandato fino alla data della assemblea generale che delibera il trasferimento della sede della società in Italia;
8. Nomina di un nuovo amministratore unico;
9. Riadeguamento completo dello statuto al fine di adattarlo alla legislazione italiana;
10. Delega dei poteri;
11. Cancellazione della Società dal Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo una volta che la stessa verrà
iscritta presso il Registro Imprese di Milano;
12. Varie ed eventuali;
Esposti questi fatti che vengono riconosciuti corretti dall'assemblea, gli azionisti decidono all'unanimità quanto segue:
<i>Prima delibera:i>
L'assemblea decide di trasferire la sede statutaria, l'amministrazione centrale e la sede di direzione effettiva della società
da L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon a I-20121 Milano (Italia), Corso Garibaldi 49, e di farle adottare la nazionalità,
gli statuti e la forma giuridica di una società a responsabilità di diritto italiano, il tutto con riserva di iscrizione della società
presso il Registro Imprese di Milano.
L'assemblea constata inoltre che nessun prestito obbligazionario è stato emesso dalla società e che quindi nessun
accordo degli obbligazionisti è richiesto in relazione alle modifiche previste.
Essa constata inoltre che nessuna azione senza diritto di voto è stata emessa dalla società.
Essa constata ugualmente:
- che la società ha ottemperato a tutte le disposizioni fiscali previste dalla norma lussemburghese;
- che il trasferimento di sede legale in Italia e il cambio della nazionalità della società non daranno luogo, né legalmente
né fiscalmente, alla costituzione di una nuova società e l'assemblea constata che questa delibera è adottata in conformità
all'articolo 67.1 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e alla Direttiva del
Consiglio della CEE del 17 luglio 1969 no. 335 e alle disposizioni degli articoli 4 e 50 del DPR del 26 aprile 1986, numero
131 e alle disposizioni collegate.
36901
L
U X E M B O U R G
<i>Seconda delibera:i>
L'assemblea esamina e approva i conti della società, ovvero i bilanci e i relativi conti economici chiusi alle date del 31
dicembre 2013 e 31 dicembre 2014 così come sottoposti all'assemblea da parte degli amministratori.
<i>Terza delibera:i>
L'assemblea decide di approvare una situazione contabile intermedia della società chiusa alla data del 15 gennaio 2015,
la quale è stata accertata dal consiglio di amministrazione in carica, prima del trasferimento della sede legale della società.
Una copia di questa situazione contabile, dopo essere stata sottoscritta “ne varietur” dai comparenti, rimarrà annessa
al presente atto per farne parte integrante.
<i>Quarta delibera:i>
L'assemblea decide di cambiare la ragione sociale della società in “DREAM INTERNATIONAL S.r.l.”.
<i>Quinta delibera:i>
L'assemblea decide di modificare l'oggetto sociale al fine di attribuirgli il contenuto riportato nei nuovi statuti in lingua
italiana di cui sotto.
<i>Sesta delibera:i>
L'assemblea decide di fissare la durata della società fino al 31 dicembre 2050.
<i>Settima delibera:i>
L'assemblea decide di accettare le dimissioni degli amministratori e del sindaco in carica e di concedere loro ogni e
più ampio scarico per l'esecuzione del loro mandato fino alla revoca.
<i>Ottava delibera:i>
L'assemblea decide di nominare come amministratore unico, in conformità alla legislazione italiana, con poteri di or-
dinaria e straordinaria amministrazione e salvo revoca o dimissioni:
Il Signor Brunello DONATI, nato a Milano (CH) il 26 agosto 1947, domiciliato a Ponte Capriasca (CH), Via Nogo 3,
codice fiscale: DNT BNL 47M26 Z133W.
<i>Nona delibera:i>
L'assemblea decide di procedere ad un adeguamento completo degli statuti al fine di adattarli alla legislazione italiana,
e di attribuirgli il contenuto seguente, inteso che le formalità previste dalla norma italiana al fine di adottare tali nuovi
statuti dovranno essere espletate:
STATUTO
Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione
DREAM INTERNATIONAL S.r.l.”
Art. 2. Oggetto. La società ha per oggetto:
a) - l'assunzione di partecipazioni in genere, comprensiva dell'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti,
rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese e di coordinamento gestionale, tecnico e finanziario delle
imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni; il finanziamento, da esercitarsi in via non esclusiva a favore e nei
confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile o comunque all'interno del
gruppo e anche nei confronti di terzi, comprensiva detta attività della concessione di crediti inclusi il rilascio di garanzie
accessorie del credito e di impegni di firma nonché le operazioni di acquisto di crediti, di rilascio di fidejussioni, avalli,
aperture di credito; la gestione di patrimoni; il tutto con esclusione delle attività riservate per legge.
b) - l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta nonché la gestione e la conduzione di qualsiasi tipo di immobili,
e l'assunzione di partecipazioni comprensiva delle attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati
o meno da titoli, sul capitale di altre imprese aventi per oggetto attività immobiliari.
La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni che l'organo Amministrativo riterrà necessarie od utili per il
raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie.
La società può, quindi, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare
avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di debiti di terzi ed ogni altra disposizione
ritenuta opportuna dall'Organo Amministrativo.
Art. 3. Finanziamento soci. La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanzia-
menti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, ai soci, anche senza il rispetto della proporzionalità delle
quote possedute, nei limiti fissati dalle vigenti norme legislative o regolamentari in materia di raccolta del risparmio.
Tali versamenti saranno considerati improduttivi di interessi salvo diverso patto scritto.
36902
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Sede.
A. La sede della società è stabilita nel comune di Milano.
B. E' attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di:
- trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale;
- istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ferma
restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale od all'estero.
Art. 5. Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere
prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche in sede di liquidazione.
Art. 6. Capitale.
A. Il capitale sociale è fissato in Euro 33.000,00 (trentatremila/00) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i
soci.
B. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Art. 7. Trasferimento quote. Le quote di partecipazione sono trasmissibili, per atto tra vivi a titolo oneroso, nel rispetto
della seguente clausola di prelazione.
Il socio che intende cedere la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci.
La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo
e le modalità di pagamento.
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio
offerente la propria risposta entro sessanta giorni dall'invio dell'offerta.
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, l'offerta spetterà ai soci interessati in
proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
Se qualcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a
favore di quei soci che hanno manifestato la loro intenzione di acquisire anche le quote inoptate.
Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, da uno qualsiasi dei soci aventi diritto alla prelazione, lo stesso sarà
stabilito da un Arbitro designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo della sede sociale.
In questo caso il socio proponente potrà in ogni momento revocare la proposta di cessione.
Art. 8. Amministrazione. L'amministrazione della società è affidata dai soci ad un Amministratore Unico o ad un Con-
siglio di Amministrazione composto da due o più membri secondo il numero determinato al momento della nomina.
Art. 9. Nomina e revoca amministratori.
A. Gli amministratori sono nominati dai soci e possono essere anche non soci.
B. Salvo diversa delibera all'atto della nomina, essi durano in carica sino a revoca o dimissioni.
C. La revoca degli Amministratori potrà intervenire in ogni momento senza alcun preavviso e senza alcuna pretesa da
parte degli stessi in ordine ad indennità o risarcimento.
D. Anche dopo la scadenza del mandato gli Amministratori rimarranno in carica per gli affari di ordinaria amministra-
zione fino alla accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori.
E. La carica di Amministratore è gratuita.
Agli Amministratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per la società ed in relazione alla carica.
L'atto di nomina, o una decisione dei soci in corso di esercizio in deroga al precedente patto, può fissare un corrispettivo
per l'opera dagli stessi prestata.
Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del
rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.
Art. 10. Consiglio di amministrazione. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, l'attività dello stesso
sarà regolata dalle seguenti norme:
A. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di tanti amministratori pari alla maggioranza del numero
deliberato dall'atto di nomina e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.
In caso di parità prevale il voto di Presidente.
B. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'atto di nomina, elegge tra i propri membri un
Presidente.
C. Esso si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente
da almeno due Amministratori o dai Sindaci se nominati.
D. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo.
E. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza, senza
che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci se nominati nello stesso luogo, a condizione
36903
L
U X E M B O U R G
che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Le modalità di svolgimento della tele conferenza saranno precisate dall'Organo Amministrativo nell'avviso di convo-
cazione oppure in un regolamento appositamente predisposto.
F. In alternativa alla formale riunione le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante
consultazione scritta, in seguito ad invio da parte del Presidente a tutti gli Amministratori del testo integrale della delibera
da assumere.
G. In caso di cessazione dalla carica di almeno la metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e
ciascun socio dovrà, senza indugio, convocare gli altri soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
Art. 11. Poteri dell'organo amministrativo.
A. Agli Amministratori spettano i poteri a loro conferiti con l'atto di nomina.
B. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le sue attribuzioni ad uno o più Amministratori delegati determinando
i limiti della delega.
C. Quando il Consiglio è composto da due membri in caso di disaccordo sulla nomina o revoca degli Amministratori
Delegati, decade dalla carica l'intero consiglio.
Art. 12. Rappresentanza.
A. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico e disgiuntamente a tutti
i componenti del Consiglio di Amministrazione.
B. La rappresentanza in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
C. La rappresentanza della società spetta anche ai Direttori, agli Institori ed ai Procuratori organici, nei limiti dei poteri
loro conferiti dagli amministratori nell'atto di nomina.
D. La rappresentanza della società per determinati atti o categorie di atti, può anche essere attribuita dagli amminis-
tratori a terzi mediante formale procura.
Art. 13. Controllo. Quando obbligatoriamente previsto dalla legge sarà nominato un Organo di Controllo nel rispetto
delle disposizioni in tema di società per azioni.
In questo caso le funzioni di controllo legale dei conti potranno essere attribuite dai soci allo stesso Organo di Controllo
o ad un Revisore Legale, come previsto dagli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.
Art. 14. Decisioni dei soci. Sono riservate alla competenza dei soci:
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- l'eventuale nomina dei Sindaci o del Revisore Contabile;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- la liquidazione, la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori.
Art. 15. Diritto di voto. Hanno diritto di voto tutti i soci risultanti dal Libro Soci istituito a norma dell'art. 21) del
presente Atto Costitutivo.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.
Art. 16. Assemblea. Tutte le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.
Le decisioni sono prese col voto favorevole del 50% del capitale sociale.
Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- la liquidazione e la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
- oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del
capitale sociale;
queste decisioni dei soci devono essere prese con la maggioranza del capitale sociale.
Art. 17. Convocazione e svolgimento dell'assemblea.
A. Ricorrendo le condizioni di legge ogni amministratore può provvedere alla convocazione dell'assemblea.
Ove sussista obbligo di legge di adottare una determinata delibera in caso di inerzia da parte degli Amministratori,
ciascun socio può procedere alla convocazione.
La convocazione è validamente eseguita con l'invio dell'Ordine del Giorno, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della
prima convocazione e delle eventuali convocazioni successive e l'elenco delle materie da trattare, mediante avviso sot-
toscritto dal soggetto convocante consegnato tramite posta o a mano, oppure tramite fax, o email almeno cinque giorni
prima dell'adunanza.
36904
L
U X E M B O U R G
B. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia;
C. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/
video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento
dei soci, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10/E del presente statuto.
D. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa
l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori (Sindaci e Revisore se nominati) sono presenti o informati e nessuno si
oppone alla trattazione dell'argomento.
Gli Amministratori (Sindaci o Revisore) che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita
dichiarazione scritta (in originale, fax od email), da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere
informati su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, di non opporsi alla trattazione degli stessi.
E. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18. Scioglimento. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
Art. 19. Bilancio ed utili. Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procederanno alla formazione del bilancio sociale e lo presenteranno ai
soci entro il termine ordinario di legge, ovvero entro il maggior termine previsto dalla legge stessa, a condizione che gli
Amministratori segnalino nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile, o nella nota integrativa le ragioni della
dilazione, nel rispetto dell'art. 2364 Codice Civile.
Art. 20. Distribuzione utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata la somma prescritta dall'articolo 2430
Codice Civile per la costituzione del fondo di riserva, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alle partecipazioni
al capitale da ciascuno posseduta, salvo che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.
Art. 21. Libro dei soci e domicilio dei soci. La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori
secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.
In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali
e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, nonché il mutamento
del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli
amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle
imprese eseguito ai sensi di legge.
Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni
inderogabili di legge.
Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato
nel libro dei soci.
A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo
telefax.
Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in
tutti gli altri casi previsti dalla legge.
<i>Decima delibera:i>
L'assemblea decide di conferire al Signor Brunello DONATI, nato a Lugano (CH) il 26 agosto 1947, domiciliato a Ponte
Capriasca (CH), Via Nogo 3, codice fiscale: DNT BNL 47M26 Z133W, tutti i poteri al fine di espletare tutte le formalità
necessarie e di intraprendere tutte le pratiche che saranno richieste dalle autorità italiane al fine di ottenere l'approvazione
delle delibere adottate nel presente atto e, in generale, di sottoscrivere tutti i documenti e di gestire tutte le pratiche che
le autorità competenti possano richiedere in relazione all'applicazione delle delibere sopra adottate, ivi comprese, all'oc-
correnza, le modifiche che potrebbero essere apportate agli statuti della società.
Inoltre, il Signor Brunello DONATI sopra citato viene autorizzato ad intraprendere tutte le procedure necessarie e a
eseguire e a fornire tutti i documenti necessari al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Registro Imprese di Milano,
così come al Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo e generalmente a qualsiasi amministrazione possa
essere coinvolta, al fine di assicurare, da una parte, la continuità della società in quanto società di diritto italiano e, dall'altra
parte, la cessazione della società in quanto società di diritto lussemburghese.
Tutti i poteri sono inoltre conferiti ai depositari della presente documentazione al fine di cancellare l'iscrizione della
società in Lussemburgo sulla base della prova di iscrizione della società in Italia presso il Registro Imprese di Milano.
Tutti i documenti relativi alla società nel Granducato di Lussemburgo potranno, durante un periodo di cinque anni,
essere ottenuti presso la vecchia sede legale in Lussemburgo.
<i>Undicesima delibera:i>
L'assemblea decide di subordinare le delibere sopra adottate alla condizione sospensiva del trasferimento della sede
legale della società e della sua iscrizione in Italia presso il Registro Imprese di Milano.
36905
L
U X E M B O U R G
Più nulla restando all'ordine del giorno, la seduta è tolta.
<i>Dichiarazione:i>
Il sottoscritto Notaio, che capisce e parla la lingua francese, dichiara che, su richiesta dei comparenti, il presente atto
è stato redatto in lingua francese, seguito da una traduzione in lingua italiana; su richiesta dei comparenti, in caso di
divergenze tra il testo in lingua francese e quello in lingua italiana, la versione in lingua francese sarà prevalente.
IL CUI ATTO, eseguito in Lussemburgo, il giorno, mese ed anno riportati all'inizio del presente atto.
E previa lettura fatta ai comparenti, tutti hanno sottoscritto insieme a me notaio il presente verbale.
Signé: R. PIATTI, N. MAGER, R. ROCHA-MELANDA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 10 février . Relation: 2LAC/2015/2921. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015025841/567.
(150029990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Diners Club Beneflux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 159.270.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of January.
Before us Maître Marc LOESCH, civil law notary, residing in Mondorfles-Bains,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Diners Club Beneflux S.A., a société anonyme (the “Compa-
ny”), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at L-1331
Luxembourg, 33, avenue Grande Duchesse Charlotte, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Re-
gister under number B 159.270, incorporated pursuant to a notarial deed on 28 February 2011, published in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations of 25 May 2011, number 1105.
The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a notarial deed on 11 April 2014, published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 July 2014, number 1897.
The meeting was opened at 9.20 a.m. with Mrs Dorothée CIOLINO, avocat, residing professionally in Luxembourg,
in the chair,
who appointed as secretary Mr Anthony Helbling, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Emilie Macchi, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Dissolution of the Company;
2. Subsequent opening of the liquidation procedure regarding the Company and appointment of the Liquidator Diners
Club AG;
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed
to this deed.
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items of the agenda.
The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
36906
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The general meeting does not wish to continue the activities of the Company, therefore it resolves to dissolve the
Company and to put it into liquidation.
<i>Second resolutioni>
As a consequence, the general meeting resolves to open a liquidation procedure for the Company, and to appoint
liquidator of the Company Diners Club AG, whose registered office is at Diners Club Tower, Alte Jonastrasse 24, 8640
Rapperswil (Switzerland), registered at the Swiss Trade and Commercial Register under the number CH-320.3.066.316-2
(the “Liquidator”).
The general meeting resolves that the Liquidator shall have, within the scope of its mission, all the power provided by
the articles 144 to 148bis of the law of 10 August 1915 as amended from time to time (the “Law”).
The Liquidator may perform the acts provided by article 145 of the Law without authorisation of the general meeting
in the cases where such authorisation is requested.
The Liquidator may dispense the person in charge of the mortgage registrar (le conservateur des hypothèques) with
taking to record a inscription d'office; waive any rights in rem, privilèges, mortgage, actions résolutoires; release, with or
without payment of any recorded privilège or recorded mortgage, transcript, attachment, opposition or other obstruc-
tion.
The Liquidator is dispensed with the inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may under his own liability, delegate part of its power to one or more proxy holders, for determined
and special operations and for the time frame it decides.
The Liquidator may distribute the assets of the Company to the Shareholders in cash or in kind according to its choice
and in consideration of their shareholding.
The general meeting resolves to postpone the determination of the emoluments of the Liquidator as soon as it has
accepted its mandate.
There being no further business, the meeting is closed at 9.30 a.m..
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the above appearing persons, known to the notary, such persons signed together
with the notary this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le treize janvier.
Par devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-lesBains,
s’est réunie
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Diners Club Beneflux S.A. (la «Société»),
société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 33, avenue Grande Duchesse
Charlotte, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.270, constituée
suivant acte notarié en date du 11 avril 2014, acte publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations le 21 juillet
2014, numéro 1897.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié en date du 6 septembre 2012, acte publié au
Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations du 14 novembre 2014, numéro 1897.
L’assemblée est déclarée ouverte à 9.20 heures sous la présidence de Madame Dorothée CIOLINO, avocat, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire M. Anthony Helbling, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Emilie Macchi, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société;
2. Ouverture subséquente de la procédure de liquidation de la Société et nomination du liquidateur Diners Club AG;
3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d’actions
qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
36907
L
U X E M B O U R G
présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront
pareillement annexées aux présentes.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré demande au notaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale ne souhaite pas poursuivre l’activité de la Société, et décide dès lors de dissoudre la Société et
de la mettre en liquidation.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la première résolution adoptée ci-dessus, l’assemblée générale décide de procéder à l’ouverture
de la liquidation de la Société et à cette fin, de nommer comme liquidateur de la Société Diners Club AG, établie et ayant
son siège social à Diners Club Tower, Alte Jonastrasse 24, 8640 Rapperswil (Suisse), enregistrée au Registre du Commerce
et des Sociétés Suisse sous le numéro CH-320.3.066.316-2 (le «Liquidateur»).
L’assemblée générale décide que, dans l’exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus
prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»).
Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 de la Loi, sans devoir recourir à l’autorisation de l’as-
semblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droit
réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le Liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté
en fonction de leur participation au capital.
L’assemblée générale décide de reporter la fixation des émoluments du Liquidateur dès lors qu'il aura accepté sa
mission.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande des comparants, cet acte est rédigé en
anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Ciolino, A. Helbling, E. Macchi, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 janvier 2015. GAC/2015/650. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 13 février 2015.
Référence de publication: 2015025825/136.
(150029868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
CR Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 142.248.
In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.
THERE APPEARED:
36908
L
U X E M B O U R G
DOCS Global Inc., a corporation governed by the laws of United States of America, with registration number
0100619998 and having its principal office address at 2 Grand Central Tower, 140 East 45
th
Street, 12
th
Floor, NY-10017,
New York, USA
hereby represented by Mr Liridon Elshani, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Ireland on 19
th
December 2014
Which proxy, after signature “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated above, is the only shareholder (the “Sole Shareholder”) of “CR Lux Holding
S.à r.l.” a limited liability corporation with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, incorporated
by deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, on September 30
th
, 2008, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2600 of October 24
th
, 2008.
All twelve thousand and five hundred (12.500) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, representing
the entire subscribed capital of the Company amounting to twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12.500) are
duly present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items
of the agenda. The Sole Shareholder present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly
informed of the agenda prior to the Meeting.
The agenda of the meeting is the following:
1) Change of the registered office of the Company from 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to 2, Millewee,
L-7257 Walferdange;
2) Subsequent amendment of article 2 of the Articles of Incorporation of the Company;
3) Decision to dissolve the Company and to put it into liquidation
4) Appointment of a liquidator and definition of his powers;
5) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to transfer the registered office of the Company from 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg to 2, Millewee, L-7257 Walferdange.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder decides to subsequently amend the article 2 of the Articles of Incorporation of the Company
as follows:
“ Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in Walferdange.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder decides to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Forth resolutioni>
The Sole Shareholder appoints as liquidator “MAYFAIR TRUST S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée organized
under Luxembourg law, having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 112.769 (the “Liquidator”).
The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on
commercial companies of August 10
th
, 1915 (the “Law”). The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article
145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.
The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend
to the Shareholders, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note(s) in the
possession of the Company to the Sole Shareholder.
The Liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several
proxies parts of its powers which will be defined and for the duration fixed by itself.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-
ments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article
148 of the Law.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
36909
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the mandatory, he signed together with us the notary the present
original deed.
Suit la traduction française
L'an deux mille quatorze, le trente décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
DOCS Global Inc., une société de droit américain, avec le numéro d'enregistrement 0100619998 et ayant son siège
principal au 2 Grand Central Tower, 140 East 45
th
Street, 12
th
Floor, NY-10017, New York, USA, ici représentée par
Monsieur Liridon Elshani, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
en vertu d'un procuration donnée sous seing privé donnée en Irlande le 19 Décembre 2014.
Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
aux présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare être l'unique associé de la société à responsabilité limitée
«CR Lux holding S.à r.l.», avec siège social au, 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2600 du 24 octobre 2008.
Toutes les douze milles cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, repré-
sentant la totalité du capital souscrit de la Société de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500) sont présentes ou
représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre
du jour. L'associé unique présent ou représenté déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre
du jour.
Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la Société de 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à 2, Millewee, L-7257
Walferdange;
2) Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;
3) Décisions sur dissolution et la mise en liquidation de la Société;
4) Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs;
5) Divers.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'associé unique:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société de 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
à 2, Millewee, L-7257 Walferdange.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide en conséquence de modifier le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société pour leur
donner la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège social est établi à Walferdange.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique désigne comme liquidateur «MAYFAIR TRUST S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au
R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 112.769 (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-
merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de
la société des avances sur le produit de la liquidation, lesquelles distributions d'avances pourront être réalisées par
l'endossement de billets à ordre détenus par la Société au profit de son associé unique.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
36910
L
U X E M B O U R G
L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, il a signé
avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/628. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-.
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015025814/134.
(150029857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Pelican S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 112.790.
L'an deux mille quatorze, le trente décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PELICAN S.A.(ci-après «la Société»), société anonyme régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2633 Sennningerberg, 6B, route de Trèves, inscrite
au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous la section B numéro 112.790, constituée par acte reçu
par Maître Paul Decker, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 17 novembre 2005, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 537 du 14 mars 2006. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu en
dernier lieu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 2011, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 381 du 13 février 2012.
L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas Léonard, demeurant professionnellement à Bertrange.
Le président a nommé en qualité de secrétaire et l’assemblée a désigné comme scrutateur Madame Aline Dalenconte,
demeurant professionnellement à Bertrange.
Le président requiert le notaire d'acter ce que:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux est indiqué
sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social à L-8070 Bertrange, 31, rue du Puits Romain et modification afférente de l’article 2 des
statuts.
2. Divers.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de transférer le siège social à L-8070 Bertrange, 31, rue du Puits Romain de sorte que le premier
alinéa de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Bertrange.»
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge relativement au présent acte ont été estimés à environ EUR 700.-
36911
L
U X E M B O U R G
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: N. LÉONARD, A. DALENCONTE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/330. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015025380/47.
(150028953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Frontier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 136.011.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 11 février 2015i>
Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège
social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.
Luxembourg, le 11 FEV. 2015.
Signatures.
Référence de publication: 2015025904/12.
(150029911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Exclusive Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 59.430.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 11 février 2015i>
Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège
social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.
Luxembourg, le 11 FEV. 2015.
Signatures.
Référence de publication: 2015025874/12.
(150029908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Cadogan Capital Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 160.013.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026484/9.
(150030706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Alpine Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 136.912.
Les comptes annuels au 30.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026399/9.
(150029299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
36912
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Alpine Finance S.à r.l.
Aool S.A.
Argenta Fund of Funds
Cadogan Capital Partners S.C.A.
CR Lux Holding S.à r.l.
Cybea Cyber Asset Managers S.A.
DB Platinum
DB Platinum III
Digital Services Holding I S.à r.l.
Diners Club Beneflux S.A.
Dream International S.A.
ECommerce Holding S.A.
Ernst & Young International Pension Scheme
EURO DIRECT MARKETING S.à r.l.
Euroteam S.A., SPF
Exclusive Real Estate S.A.
F&B International S.A.
F&B International S.A.
Frontier S.A.
GDL Asset Management S.à r.l.
GeoVille Environmental Services S.à r.l.
GP Lux HoldCo S.à r.l.
GSC S.à r.l.
Hallard Investments Limited S.A.
Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A.
Kwong S.A.
Les Aubépines
Levia Holding S.A.
Malouvag S.A.,
N. Hypothek Lux S.à r.l.
Pelican S.A.
Petercam L Fund
Pictet International Capital Management
Raik Property S.à r.l.
Robiontex S.A.
Rosenberg S.A.
Saint Aubin Développement S.A.
Savings & Investments S.A., SPF
Seapoint
SGI Ingénierie S.A. Luxembourg
SM - IMMO g.m.b.h.
Société Internationale de Participation dans l'Acier
Société Internationale de Participation dans l'Acier
Société Internationale de Participation dans l'Acier
Solar S.A.
Suo Tempore AG
Swiss Park Hotel S.A.
Telefónica Luxembourg Holding S.à r.l.