logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 768

20 mars 2015

SOMMAIRE

Allianz European Pension Investments  . . .

36861

alpha3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36828

Amadeus Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36818

Argenta Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36830

ASSETS Generation Fund UI  . . . . . . . . . . .

36829

Baumann and Partners - Premium Select

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36826

BNP Paribas L1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36827

Carlesian & Matandrea S.A.  . . . . . . . . . . . . .

36820

CBK Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36824

Cherrilux Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

36851

Christali S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36818

Darter Holdings II S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

36824

DB Platinum II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36860

DB Platinum IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36863

De Kéisplateau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36829

EPIC I GP, S.à rl.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36827

Fisabelle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36819

Fondation Thierry Van Werveke  . . . . . . . .

36830

Généralpart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36821

Granny's S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36856

Granny's S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36858

I.C.C.Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

36864

Imprimerie Centrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36825

Interfund Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36823

International Food Retail Capital S.A. . . . .

36831

Investissements Mobiliers Européens et In-

ternationaux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36826

Jarcam Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36859

Kalinde S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36823

Kibu S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36825

Managed Funds Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . .

36823

Nikkei Invest Corporation S.A., SPF  . . . . .

36822

PAM L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36829

Patron Reform C.E. Servicing S.à r.l. . . . . .

36864

Peacock European Alpha Builder UI  . . . . .

36828

Petercam Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36828

Pusan S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36826

Secundus Aktien Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . .

36827

Secure Industries S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36854

Secure Industries S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36847

S.I.P. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36818

Solroc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36830

Staminvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36822

Subsea 7 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36859

Tareno Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36821

Tovic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36819

UBS ETF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36820

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36824

Wenkelhiel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36822

WestGlobal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36825

Zoetheo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36819

36817

L

U X E M B O U R G

Amadeus Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 49.827.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>9 avril 2015 à 17.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 30 novembre 2014,

2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015043304/833/18.

S.I.P. Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 57.856.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>9 avril 2015 à 10.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015043303/833/18.

Christali S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 180.034.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>1er avril 2015 à 10.30 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015038952/833/18.

36818

L

U X E M B O U R G

Fisabelle S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 180.036.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>1er avril 2015 à 16.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015038953/833/18.

Tovic S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 178.203.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>1er avril 2015 à 15.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015038961/833/18.

Zoetheo S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 178.357.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>1er avril 2015 à 15.30 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015038962/833/18.

36819

L

U X E M B O U R G

Carlesian &amp; Matandrea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 178.356.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>1er avril 2015 à 11.30 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2015038951/833/18.

UBS ETF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 83.626.

Notice is hereby given to the shareholders of UBS ETF (the "Company") that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg on <i>15 April 2015 at 11.30 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors;
2. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 31 December 2014;
3. Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company;
4. Discharge to the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended

31 December 2014;

5. Statutory Elections:

i Re-election of Mr. Andreas Haberzeth until the annual general meeting of shareholders to be held in 2019;
ii Re-appointment of PricewaterhouseCoopers Société Coopérative as Independent Auditor of the Company until
the next annual general meeting of shareholders to the held in 2016;

6. Miscellaneous
Copies  of  the  latest  version  of  the  Annual  Report  are  available  free  of  charge  during  normal  office  hours  at  the

registered office of the Company in Luxembourg or on the Internet website of the Company (www.ubs.com/etf) as of
April 1st, 2015.

In order to be admitted to the meeting, shareholders must deposit their shares at least five (5) days before the date

of the general meeting with State Street Bank Luxembourg S.A.

There will be no requirement as to the quorum in order for the general meeting to validly deliberate and decide on

the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented
at the meeting. At the annual shareholders' meeting, each share entitles to one vote.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to State

Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax followed by mail until 13 April 2015
to  the  attention  of  Mrs.  Caroline  Dejardin,  fax  number  +352  46  40  10  413  or  by  e-mail  at  :  Luxembourg-
Domiciliarygroup@statestreet.com.

Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Luxembourg, March 20th, 2015
<i>By Order of the Board of Directors
Référence de publication: 2015043307/755/36.

36820

L

U X E M B O U R G

Tareno Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.903.

The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office on <i>8 April 2015 at 2.00 p.m. with the following agenda :

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Authorised Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2014
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors
5. Appointment of the Authorised Auditor
6. Statutory Elections
The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the

votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. The Shareholders who wish to attend the Meeting
must inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting.

Référence de publication: 2015043305/755/19.

Généralpart, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 31.958.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE

se tiendra mercredi <i>15 avril 2015, à 11:00 du matin, dans les locaux de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,

bâtiment H2O, bloc A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise ;
2. Approbation des comptes annuels pour la période close au 31 Décembre 2014 et de l'affectation des résultats ;
3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Conformément à la Loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

les droits de vote attachés aux actions au porteur non immobilisées avant le 18 février 2015 seront automatiquement
suspendus, comme décrit dans l'avis publié le 23 janvier 2015. Les détenteurs de ces actions ne seront plus admis aux
assemblées générales jusqu'à ce que ces actions soient immobilisées, ni pris en compte pour le calcul du quorum et de la
majorité.

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée sont invités à déposer

leurs actions auprès des agents chargés du service financier, comme indiqué dans le prospectus, au moins cinq jours francs
à l'avance.

Les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée seront admis sur

justification de leur identité, à condition de faire connaître leur intention de prendre part à l'assemblée au moins cinq
jours francs à l'avance.

L'assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées et les résolutions seront

adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées, les abstentions n'étant pas prises en compte. Chaque
action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix. Les fractions d'actions ne conférant aucun droit de vote.

Les comptes annuels ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise et le rapport de gestion sont disponibles au siège

social de GENERALPART. Les actionnaires peuvent demander que ces documents leur soient envoyés. Ils doivent en
faire la demande par courrier à l'adresse suivante : BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, ou par e-mail à fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015043311/755/35.

36821

L

U X E M B O U R G

Staminvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 111.462.

Les actionnaires sont convoqués, par la présente, à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

des actionnaires de STAMINVEST S.A. qui se tiendra extraordinairement le <i>30 mars 2015 à 15.00 heures au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2014.
3. Décharge aux administrateurs et commissaire.
4. Décision concernant la continuation de la société en conformité avec l'article 100 de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015038948/17.

Wenkelhiel, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 123-125, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 105.149.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le <i>3 avril 2015 à 16.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises
Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés d'informer le Conseil d'Administration cinq jours

au moins avant l'assemblée de leur intention d'y assister.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015021485/17.

Nikkei Invest Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 44.354.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>10 avril 2015 à 15.00 heures au siège social avec pour :

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales,

- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015043309/755/20.

36822

L

U X E M B O U R G

Managed Funds Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 81.144.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING Investment Management Luxembourg au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg,

le <i>9 avril 2015 à 10 H 00 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises indépendant de la Société ;
2. Approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 ;
3. Affectation des résultats de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 ;
4. Décharge  des  administrateurs de  la  Société  pour  l'exécution de leur  mandat pendant l'exercice clôturé au  31

décembre 2014 ;

5. Nominations statutaires (démission(s) et ou nomination(s)).
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015043310/755/20.

Interfund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 8.074.

Notice is hereby given to the shareholders of INTERFUND that the

ANNUAL ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

will be held in Luxembourg at the registered office of the Company, 9-11 rue Goethe, on <i>March 31st, 2015 at 10.00

am Luxembourg time with the following agenda:

<i>Agenda:

• * Board of Directors and External Auditors' Reports.
• * Approval of Sub-Fund's Financial Statements as at 31st December, 2014.

Presentation and approval of the SICAV's consolidated Financial Statements as at December 31st, 2014.

• * Director's legal responsibilities discharge for activities rendered during 2014 Financial Year.
• * Statutory Nominations.

The Shareholders wishing to attend the Meeting may request admission ticket to the following Banks :
- Fideuram Bank (Luxembourg)
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
- Kredietbank Luxembourgeoise, Luxembourg
- BGL BNP Paribas Luxembourg, Luxembourg
Référence de publication: 2015037494/21.

Kalinde S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 91.517.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 février 2015 que la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015025152/13.
(150028261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36823

L

U X E M B O U R G

CBK Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 137.309.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Meeting") of CBK SICAV (the " Company ") will be held at the registered office office of the

Company, as set out above, on Wednesday, <i>1st April 2015 at 11 a.m., in order to deliberate and vote on the following
agenda :

<i>Agenda:

1. Presentation of the management report of the Board of Directors and of the authorized auditors' report for the

accounting year ended on 31 December 2014 ;

2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended on 31 December 2014;
3. Allocation of the results ;
4. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended on 31

December 2014;

5. Statutory appointments :

a. Board of Directors ;
b. Authorised auditors ;

6. Miscellaneous.
The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the

shares present or represented at the Meeting.

The shareholders who would like to be present or represented at the Meeting are kindly required to deposit their

share certificates five clear days before the Meeting at the office of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, where forms of proxy are available.

The annual report as at 31 December 2014 will be available upon request at the registered office.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015038357/755/29.

Universal-Investment-Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 75.014.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds ASSETS NB Global welcher von der Universal-Investment-Luxem-

bourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 20. März 2015.

<i>Für den ASSETS NB Global
Universal-Investment-Luxembourg S. A.
Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015040726/14.
(150046195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Darter Holdings II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 193.074.

Les statuts coordonnés au 13 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015025819/11.
(150029734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

36824

L

U X E M B O U R G

Imprimerie Centrale, Société Anonyme.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 15, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 104.983.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le <i>3 avril 2015 à 17.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises
Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés d'informer le Conseil d'Administration cinq jours

au moins avant l'assemblée de leur intention d'y assister.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015021484/17.

WestGlobal, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.504.

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à

capital variable) WestGlobal findet die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am <i>9. April 2015 um 10.00 Uhr am Sitz der Zentralverwaltungsstelle LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel

Lippmann, L-5365 Munsbach statt.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016.
7. Verschiedenes.
Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden

oder die Anteile bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung
der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im März 2015
Référence de publication: 2015043295/2501/24.

Kibu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 84.024.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 février 2015 que la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015025159/13.
(150028263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36825

L

U X E M B O U R G

Investissements Mobiliers Européens et Internationaux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 27.765.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9.04.2015 à 11H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour :

<i>Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2014
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015043294/560/16.

Baumann and Partners - Premium Select, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.708.

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à

capital variable) Baumann &amp; Partners - Premium Select findet die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am <i>8. April 2015 um 10.00 Uhr am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel

Lippmann, L-5365 Munsbach statt.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016.
7. Sonstiges.
Die Zulassung zur Generalversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden oder

die Anteile bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung
der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im März 2015
Référence de publication: 2015043306/2501/24.

Pusan S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 54.027.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 9 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de désigner FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., Cabinet d'expertise-comptable, ayant

son siège social au 18a boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, comme dépositaire des actions au porteur de la Société,
conformément à l'article 42 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pierre SCHILL
<i>Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015025396/14.
(150029243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36826

L

U X E M B O U R G

BNP Paribas L1, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 32.327.

THE STATUTORY GENERAL MEETING

will be held on Friday <i>April 17, 2015 at 2.30 pm at the premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,

Building H2O, block A, ground floor, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to delib-
erate on the following agenda :

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor ;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2014 and allocation of the

results;

3. Discharge to the directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
Pursuant to the Luxembourg Law of 28 July 2014 regarding immobilisation of bearer shares, the voting rights attached

to bearer shares that have not been immobilised as at 18 February 2015 as described in the notice published on 23 January
2015 will automatically be suspended and the holders of these shares will no longer be admitted to the General Meeting,
nor included when calculating the quorum or voting majorities, until such time as the shares are immobilised.

The shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity,

subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five business days before the Meeting.
Furthermore, the shareholders shall present a blocking certificate of shares before the Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will

be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.

Annual accounts, as well as the report of the Auditor and the management report are available at the Registered Office

of the Company. Shareholders may request that these documents are sent to them. They have to send their request,
either by post to the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826
Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015043312/755/32.

Secundus Aktien Fonds, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds Secundus Aktien Fonds welcher von der Universal-Investment-Lu-

xembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 20. März 2015.

<i>Für den Secundus Aktien Fonds
Universal-Investment-Luxembourg S. A.
Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015040723/12.
(150046192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

EPIC I GP, S.à rl., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 186.222.

Die Koordinierten Statuten vom 12. Februar 2014 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg

hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024963/10.
(150028831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36827

L

U X E M B O U R G

Petercam Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 176.339.

Le conseil d'administration de la SICAV (ci-après le "Conseil d'Administration") invite, par la présente, les actionnaires

à participer à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(ci-après l'"AGO") qui se tiendra le <i>8 avril 2015 , à 14.30 heures au siège social de la SICAV, allée Scheffer 5 - L-2520

Luxembourg et qui aura, à l'ordre du jour, les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs;
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé; et
6. Nominations statutaires.

<i>PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'AGO n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement (quel que soit le nombre d'actionnaires participant à la

réunion, en personne, par procuration ou par correspondance). Les résolutions seront valablement adoptées à la majorité
simple des voix exprimées, conformément à l'article 28, alinéa 2 des statuts de la SICAV (ci-après les "Statuts").

Conformément à l'article 25, alinéa 4 des Statuts, la majorité requise sera déterminée par référence aux actions émises

et en circulation à la date du 2 avril 2015 (ci-après la "Date Butoir"), étant entendu que le droit d'un actionnaire de
participer à l'AGO et d'exercer le droit de vote attaché à son/ses action(s) sera déterminé en fonction du nombre d'actions
détenues par l'actionnaire à la Date Butoir

Une brochure explicative, reprenant les modalités de participation à la présente AGO, est disponible, sans frais et sur

simple demande, au siège social de la SICAV (dont les coordonnées sont reprises plus haut).

Les formulaires de vote et de procuration sont disponibles au siège social de la SICAV et peuvent être obtenus, sans

frais, sur simple demande.

Référence de publication: 2015040109/30.

Peacock European Alpha Builder UI, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds Peacock European Alpha Builder UI welcher von der Universal-

Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 20. März 2015.

<i>Für den Peacock European Alpha Builder UI
Universal-Investment-Luxembourg S. A.
Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015040724/12.
(150046193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

alpha3, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds alpha3 welcher von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. ver-

waltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 20. März 2015.

<i>Für den alpha3
Universal-Investment-Luxembourg S. A.
Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015040722/12.
(150046191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

36828

L

U X E M B O U R G

ASSETS Generation Fund UI, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds ASSETS Generation Fund UI welcher von der Universal-Investment-

Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 20. März 2015.

<i>Für den ASSETS Generation Fund UI
Universal-Investment-Luxembourg S. A.
Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015040725/12.
(150046194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

PAM L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.579.

Le conseil d'administration de la SICAV (ci-après le "Conseil d'Administration") invite, par la présente, les actionnaires

à participer à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(ci-après l'"AGO") qui se tiendra le <i>8 avril 2015 , à 11.00 heures au siège social de la SICAV, Boulevard Royal 14, L-2449

Luxembourg et qui aura, à l'ordre du jour, les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé; et
6. Nominations statutaires.

<i>PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'AGO n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement (quel que soit le nombre d'actionnaires participant à la

réunion, en personne, par procuration ou par correspondance). Les résolutions seront valablement adoptées à la majorité
simple des voix exprimées, conformément à l'article 28, alinéa 2 des statuts de la SICAV (ci-après les "Statuts").

Conformément à l'article 25, alinéa 4 des Statuts, la majorité requise sera déterminée par référence aux actions émises

et en circulation à la date du 2 avril 2015 (ci-après la "Date Butoir ), étant entendu que le droit d'un actionnaire de
participer à l'AGO et d'exercer le droit de vote attaché à son/ses action(s) sera déterminé en fonction du nombre d'actions
détenues par l'actionnaire à la Date Butoir.

Une brochure explicative, reprenant les modalités de participation à la présente AGO, est disponible, sans frais et sur

simple demande, au siège social de la SICAV (dont les coordonnées sont reprises plus haut).

Les formulaires de vote et de procuration sont disponibles au siège social de la SICAV et peuvent être obtenus, sans

frais, sur simple demande.

Référence de publication: 2015040111/30.

De Kéisplateau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1865 Luxembourg, 8, rue J.P. Koenig.

R.C.S. Luxembourg B 170.756.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour De Kéisplateau S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015024908/12.
(150028965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36829

L

U X E M B O U R G

Argenta Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 26.881.

Le conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") de la Sicav Argenta-Fund (ci-après dénommée le "Fonds")

a le plaisir d'inviter les actionnaires et les administrateurs ainsi que le réviseur d'entreprises agréé du Fonds à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 avril 2015 à 14.00 heures au siège social du Fonds.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du Fonds (l'"Assemblée") est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Communication et discussion du rapport annuel du conseil d'administration du Fonds (le "Rapport De Gestion")

concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014;

2. Communication et discussion du rapport annuel du réviseur d'entreprises agréé du Fonds sur les comptes annuels

pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014;

3. Communication et approbation des comptes annuels du Fonds pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014

et affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration;

4. Décharge et nomination d'administrateurs et d'administrateurs-délégués;
5. Nomination du réviseur d'entreprises agréé et fixation de sa rémunération;
6. Divers.
Pour être admis à l'Assemblée, les actionnaires doivent faire bloquer leurs actions au plus tard le 09 avril 2015 au siège

social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (Argenta Spaarbank nv) à B-2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 (qui assure le service
financier en Belgique) ou au siège social d'Argenta Asset Management S.A. à L-1724 Luxembourg, 29, Boulevard du Prince
Henri.

Les actionnaires peuvent obtenir la version française des statuts et du rapport annuel, ainsi que les versions françaises

et néerlandaises du prospectus du Fonds actuellement en vigueur et des KIIDs des différents compartiments du Fonds
gratuitement auprès des adresses mentionnées ci-dessus. Vous pouvez consulter ces documents sur www.argenta.be.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015038940/29.

Solroc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».

R.C.S. Luxembourg B 77.755.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement du 12 mars 2015, la sixième section du tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société SOLROC S.A., avec siège
social au Centre d'Affaires "le 2000", L - 3378, Livange, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B77755.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2015.

Maître Robert Kayser
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015042598/16.
(150048751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Fondation Thierry Van Werveke, Fondation.

Siège social: L-3737 Rumelange, 19, rue Henri Luck.

R.C.S. Luxembourg G 206.

Je me vois obligé de démissionner de mon poste d’administrateur de votre Fondation au numéro RC G206.

Belvaux, le 10 janvier 2011.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2015040975/9.
(150047007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

36830

L

U X E M B O U R G

International Food Retail Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 195.316.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of March,
Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of IFR CAPITAL PLC, a public limited company governed by the

laws of Cyprus, with registered office at 30, Tempon Street, Engomi 2408, 2090 Nicosia, Cyprus with registration number
HE 185534, and in the process of deregistration in Cyprus (the "Company").

The meeting was declared open at 11.00 a.m. by Mr Holger Schmitt, in the chair,
who appointed as secretary Mr Philipp Graf.
The meeting elected as scrutineer Me Manfred Müller.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i)  That  the  issued  share  capital  of  the  Company  is  currently  fixed  at  fourteen  million  nine  hundred  ninety-three

thousand eight hundred and twelve euro and seventy-nine cent (EUR 14,993,812.79) represented by one billion four
hundred ninety-nine million three hundred eighty-one thousand two hundred and seventy-nine (1,499,381,279) shares
with a nominal value of one cent (EUR 0,01) each, entirely paid-in.

(ii) That the board of directors and the extraordinary general meeting of the Company have taken the necessary

resolutions  in  Cyprus  regarding  the  transfer  of  the  domicile,  registered  office  and  central  administrative  seat  of  the
Company, without dissolution or discontinuity of the Company’s legal personality, from Cyprus to the Grand-Duchy of
Luxembourg, with effect as at the date of the present extraordinary general meeting of shareholders.

(iii) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 Adoption of the Luxembourg nationality, by transfer of the domicile, registered office and central administrative seat

of the Company without dissolution from Cyprus to the Grand Duchy of Luxembourg, and submission of the Company
to Luxembourg laws, adoption of the legal form of a “société anonyme” and change of the Company’s name to “Inter-
national Food Retail Capital S.A.“, all as from the date of the present extraordinary general meeting of shareholders.

2 Complete restatement of the Company’s articles of association in order to comply with the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg in this respect, including the following corporate object clause:

“ Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/

or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants

or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.”

3  Confirmation  that  a  report  prepared  by  PricewaterhouseCoopers,  réviseur  d’entreprises,  attesting  that  the

Company’s net asset value corresponds to at least the Company’s issued share capital, being fourteen million nine hundred
ninety-three thousand eight hundred and twelve euro and seventy-nine cent (EUR 14,993,812.79) represented by one
billion four hundred ninety-nine million three hundred eighty-one thousand two hundred and seventy-nine (1,499,381,279)
shares with a nominal value of one cent (EUR 0,01) each, has been submitted to the shareholders’ meeting.

4 Determination of the address of the registered office in the Grand Duchy of Luxembourg, which shall be the following:

2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

5 Acknowledgement of the resignation of Mr. Heiner Kamps, Mr. Volkhard Otto Mett, Mr. Michalis Ioannou and Mr.

Christos Theodoulou from their office as directors of the Company and granting of provisional discharge to them for the
performance of their duties as far as legally possible.

6 Setting of the number of directors of the Company at three (3) and appointment of the following directors of the

Company for a period of six years:

- Mr. Heiner Kamps;

36831

L

U X E M B O U R G

- Mr. Ronald Kers; and
- Dr. Henrik Bauwens.
7 Appointment of PricewaterhouseCoopers, société coopérative de droit luxembourgeois, with registered office at

2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as statutory auditor (commissaire
aux comptes) of the Company.

8 Delegation of powers to any lawyer at Linklaters LLP, Luxembourg, to take all actions and do such things that are

necessary or desirable for the Company to take or to do in order for the above resolutions to be implemented and for
the Company to be registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

(iv) That the meeting has been convened by a convening notice sent to all shareholders on 11 February 2015;
(v) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders
or the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(vi) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(vii) That more than half of the corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or

represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

(viii) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(ix) That the general meeting of shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved that the Company shall adopt the Luxembourg nationality by transfer

of the domicile, registered office and central administrative seat of the Company without dissolution from Cyprus to the
Grand Duchy of Luxembourg, that the Company shall be submitted to Luxembourg laws, and that the Company shall
adopt the legal form of a “société anonyme” and change its name to “International Food Retail Capital S.A.“, all as from
the date of the present extraordinary general meeting of shareholders.

Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Refusal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Abstention

/

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to proceed with a complete restatement of the Company’s articles of

association, including the object clause mentioned under item 2 of the above agenda, in order to comply with the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg in this respect and that the articles of association of the Company shall henceforth
read as follows:

“Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société anonyme (the "Company") governed by the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders.
The Company will exist under the name of “International Food Retail Capital S.A.”

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or

in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants

or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

36832

L

U X E M B O U R G

It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and

majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to
article 31 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at fourteen million nine hundred ninety-three thousand

eight hundred and twelve euro and seventy-nine cent (EUR 14,993,812.79) represented by one billion four hundred ninety-
nine million three hundred eighty-one thousand two hundred and seventy-nine (1,499,381,279) shares with a nominal
value of one cent (EUR 0,01) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
The shares will be in the form of registered shares only.
The shares are freely transferable.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

A shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class (if any) of shares held,
the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder
will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely
for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from
the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders’ register may be
delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.

Any transfer of shares will be registered in the shareholders’ register by a declaration of transfer entered into the

shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in
accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore,
the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or
other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the general meeting of shareholders.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority
rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of
Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30)
days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority

rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of
Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right.

Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own

shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

Chapter III.- Board of directors, Auditors

Art. 9. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three

members, who need not be shareholders themselves (the "Board of Directors"). If and as long as the Company has only
one (1) shareholder, the Board of Directors may comprise one (1) member only.

The members of the Board of Directors will be appointed by the general meeting of shareholders, who will determine

their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for reappointment
and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed members of the Board of Directors as class

A director (the “Class A Director”) or class B director (the “Class B Director”).

36833

L

U X E M B O U R G

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by

co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-
optation or elect a new member of the Board of Directors instead.

The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all

acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of share-

holders or to the auditor(s) are in the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the daily

management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more
persons or committees of its choice.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or

temporary functions to persons or committees of its choice.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted

must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Director or by the joint

signatures of any two (2) members of the Board of Directors.

However, if the shareholders have qualified the Directors as Class A Directors or as Class B Directors, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to

whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within
the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman

(the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors himself and who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the “Secretary”).

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors

may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’

written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors

may from time to time determine.

Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing,

transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board
of Directors as his proxy. Any member of the Board of Directors may represent one or several members of the Board
of Directors.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the members

of the Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board
of Directors present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or

any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously commu-
nicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board
of Directors may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.

A written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been

adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented
in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
members of the Board of Directors.

Art. 13. Resolutions of the Board of Directors. The resolutions of the Directors shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

36834

L

U X E M B O U R G

Copies or extracts of written resolutions adopted by the Directors as well as of the minutes of the general meeting

of shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Director or by any two
(2) Directors acting jointly.

The resolutions adopted by the single Director shall be documented in writing and signed by the single Director.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the general meeting of shareholders, the members of

the Board of Directors may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company
and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors
in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company’s corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal

interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors
and shall not consider or vote on any such transaction.

Such transaction and such Director's interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting

of shareholders before any vote by the latter on any other resolution.

If the Board of Directors only comprises one (1) member it suffices that the transactions between the Company and

its director, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or
is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Directors’ Liability - Indemnification. No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his

functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settle-
ment as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Confidentiality. Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as

well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the
Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required
(i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or (ii) for the public benefit.

Art. 18. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including more
in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders
themselves.

The statutory or approved statutory auditor(s), if any, will be appointed by the general meeting of shareholders, which

will  determine  their  number  and  the  duration  of  their  mandate.  They  are  eligible  for  re-appointment.  They  may  be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders, save in such cases
where the approved statutory auditor may, as a matter of Luxembourg law, only be removed for serious causes or by
mutual agreement.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall have such powers

as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single
shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held on the second Wednesday

of June at 11.00 a.m. at the registered office of the Company.

36835

L

U X E M B O U R G

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 21. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general

meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened
if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 22. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication)

of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 23. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder
to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visioconference or any other similar means of

telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority
computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation
in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

Art. 24. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

Art. 25. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4)

weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent
(20%) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly

deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 26. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they

vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt

another voting procedure.

At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles

of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requi-
rements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of
shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least
one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting
may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted,
and save as otherwise provided by the Laws, a two thirds (2/3rds) majority of the votes cast by the shareholders present
or represented is required at any such general meeting.

Art. 27. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau

present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

36836

L

U X E M B O U R G

Chapter V.- Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 28. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 29. Adoption of Financial Statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders,

annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

Art. 30. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the

annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by
carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distri-
butable reserves or share premium, to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons

(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their
powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.”

Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Refusal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Abstention

/

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders confirmed that a report (the “Report”) prepared on March 9.2015 by Pricewa-

terhouseCoopers,  réviseur  d’entreprises,  attesting  that  the  Company’s  net  asset  value  corresponds  to  at  least  the
Company’s issued share capital, being fourteen million nine hundred ninety-three thousand eight hundred and twelve
euro and seventy-nine cent (EUR 14,993,812.79) represented by one billion four hundred ninety-nine million three hun-
dred eighty-one thousand two hundred and seventy-nine (1,499,381,279) shares with a nominal value of one cent (EUR
0,01) each, has been submitted to the shareholders’ meeting.

The conclusions of the Report read as follows:
“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net assets of the Company

as at 31 December 2014 do not correspond at least to an amount of EUR 399,804,064.”

The report will remain attached to the present deed and will be filed together with it.

Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Refusal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Abstention

/

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolved to establish the address of the registered office of the Company at 2b,

rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Refusal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Abstention

/

36837

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolved to acknowledge the resignation of Mr. Heiner Kamps, Mr. Volkhard

Otto Mett, Mr. Michalis Ioannou and Mr. Christos Theodoulou from their office as directors of the Company and to
grant them provisional discharge for the performance of their duties as far as legally possible.

Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Refusal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Abstention

/

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolved to set the number of directors of the Company at three (3) and to

appoint the following directors of the Company for a period of six years:

- Mr. Heiner Kamps;
- Mr. Ronald Kers; and
- Dr. Henrik Bauwens.

Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Refusal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Abstention

/

<i>Seventh resolution

The  general  meeting  of  shareholders  resolved  to  appoint  PricewaterhouseCoopers,  société  coopérative  de  droit

luxembourgeois, with registered office at 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, as statutory auditor (commissaire) of the Company.

Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Refusal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Abstention

/

<i>Eighth resolution

The general meeting of shareholders resolved to delegate to any lawyer at the law firm Linklaters LLP, Luxembourg,

each of them acting individually with full power of substitution, all powers to take all actions and do such things that are
necessary or desirable for the Company to take or to do in order for the above resolutions to be implemented and for
the Company to be registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Refusal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Abstention

/

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residences, the said persons signed together with the notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden textes:

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am neunten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit dem Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxem-

burg,

wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der IFR Capital plc, einer Aktiengesellschaft (public

limited company) zypriotischen Rechts, mit Sitz in der 30, Tempon Street, Engomi 2408, 2090 Nicosia, Zypern, mit der
Registrierungsnummer HE 185534, welche sich im Laufe der De-Registrierung in Zypern befindet (die „Gesellschaft“),
abgehalten.

Die Versammlung wurde um 11.00 Uhr von dem Vorsitzenden Herr Holger Schmitt eröffnet,
welcher Herr Philipp Graf zum Sekretär ernannt hat.
Die Versammlung hat Maître Manfred Müller zum Stimmzähler ernannt.
Die Versammlungsleitung ist demnach ernannt, und der Vorsitzende, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat

den unterzeichnenden Notar ersucht Folgendes schriftlich festzustellen:

36838

L

U X E M B O U R G

(i) dass das gesamte ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft sich zu diesem Zeitpunkt auf vierzehn Millionen neun-

hundertdreiundneunzigtausendachthundertzwölf Euro und neunundsiebzig Eurocent (EUR 14.993.812,79) beläuft, wel-
ches in eine Milliarde, vierhundertneunundneunzig Millionen dreihunderteinundachtzigtausendzweihundertneunundsieb-
zig  (1.499.381.279)  Aktien  mit  einem  Nennwert  von  jeweils  einem  Eurocent  (EUR  0,01)  aufgeteilt  und  vollständig
eingezahlt ist.

(ii) dass der Verwaltungsrat sowie die Aktionäre die in Zypern notwendigen Beschlüsse verabschiedet haben, um den

Gesellschaftssitz und den Sitz der zentralen Geschäftsführung der Gesellschaft ohne Unterbrechung der körperschaftli-
chen Existenz mit Wirkung zum Tage der heutigen außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre von Zypern
in das Großherzogtum Luxemburg zu verlegen.

(iii) dass die Tagesordnung der Versammlung die folgende ist:

<i>Tagesordnung

1 Annahme der Luxemburgischen Staatsbürgerschaft durch die Verlegung des Gesellschaftssitzes und des Sitzes der

zentralen Geschäftsführung der Gesellschaft ohne Unterbrechung der körperschaftlichen Existenz von Zypern in das
Großherzogtum Luxemburg, Unterwerfung der Gesellschaft unter das luxemburgische Recht, Annahme der Form einer
Aktiengesellschaft (société anonyme) und Änderung des Namens der Gesellschaft in „International Food Retail Capital
S.A.“, alles mit Wirkung zum Datum dieser außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft.

2 Völlige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, inklusive der folgenden Klausel bezüglich des Gesellschaftszweckes

der Gesellschaft, um den Anforderungen des luxemburgischen Rechts zu entsprechen:

„ Art. 3. gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst den Erwerb, den Besitz und die Veräußerung von Betei-

ligungen an luxemburgischen und/oder ausländischen Gesellschaften und Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwick-
lung und Unternehmensführung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften und Unternehmen, die der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle

Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und
Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen

Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und Anleihen, Schuldtitel oder jegliche Art von

Schuldverschreibungen und Optionsscheinen oder andere Titel ausgeben, die das Recht auf Zeichnung von Aktien bein-
halten.

Generell kann die Gesellschaft jede Tätigkeit ausführen, die für die Erfüllung und Entwicklung ihres Unternehmens-

zweckes dienlich oder notwendig erscheint.“

3 Bestätigung, dass ein von PricewaterhouseCoopers, Abschlussprüfer (réviseur d’entreprises), vorbereiteter Bericht,

welcher  bescheinigt,  dass  das  Reinvermögen  der  Gesellschaft  mindestens  dem  Stammkapital  von  vierzehn  Millionen
neunhundertdreiundneunzigtausendachthundertzwölf  Euro  und  neunundsiebzig  Eurocent  (EUR  14.993.812,79)  ent-
spricht, welches in eine Milliarde, vierhundertneunundneunzig Millionen dreihunderteinundachtzigtausendzweihundert-
neunundsiebzig (1.499.381.279) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einem Eurocent (EUR 0,01) aufgeteilt ist, der
Generalversammlung vorgelegt wurde.

4 Bestimmung der folgenden Adresse als Gesellschaftssitz der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg: 2b, rue

Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

5 Kenntnisnahme der Rücktritte von Herrn Heiner Kamps, Herrn Volkhard Otto Mett, Herrn Michalis Ioannou und

Herrn Christos Theodoulou von ihren Positionen als Direktoren der Gesellschaft, und vorläufige Entlastung dieser Per-
sonen bezüglich der Ausübung ihrer Pflichten, soweit dies rechtlich möglich ist.

6 Einstellung eines Verwaltungsrates bestehend aus drei (3) Mitgliedern und Ernennung der folgenden Verwaltungs-

ratsmitglieder für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren:

- Herr Heiner Kamps;
- Herr Ronald Kers; und
- Herr Dr. Henrik Bauwens.
7 Ernennung von PricewaterhouseCoopers, Genossenschaft luxemburgischen Rechts (société coopérative de droit

luxembourgeois), mit Sitz in der 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxembourg,
als Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) der Gesellschaft.

8 Befugnisübertragung an jeden Rechtsanwalt der Kanzlei Linklaters LLP, Luxemburg, alle Maßnahmen zu ergreifen und

Handlungen durchzuführen, deren Durchführung durch die Gesellschaft notwendig oder wünschenswert sind, um die
obenstehenden Beschlüsse umzusetzen und um die Gesellschaft beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
einzutragen.

(iv) dass die Versammlung per Einberufungsschreiben an alle Aktionäre am 11. Februar 2015 einberufen wurde.
(v) dass die Aktionäre, ihre Vertretungsbevollmächtigten und die Anzahl der Aktien, die vertreten sind, sich aus einer

Anwesenheitsliste ergeben, die nachdem sie "ne varietur" von den Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen

36839

L

U X E M B O U R G

Aktionäre und den Mitgliedern der Versammlungsleitung sowie durch den unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde,
als Bestandteil dieser Urkunde in deren Anhang verbleibt, um zusammen mit dieser beim Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister eingereicht zu werden.

(vi) dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche von den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und

den Mitgliedern der Versammlungsleitung sowie durch den unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurden, bleiben dieser
Urkunde ebenfalls im Anhang beigefügt.

(vii) dass mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft bei dieser Generalversammlung vertreten ist und alle

anwesenden oder vertretenen Aktionäre rechtzeitig über die Tagesordnung informiert wurden und vor der Generalver-
sammlung ausreichende Kenntnis über diese Tagesordnung besaßen.

(viii) dass diese Generalversammlung somit rechtmäßig zusammengetreten ist und in der Lage ist, wirksam über alle

Tagesordnungspunkte zu beraten und zu beschließen.

(ix) dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse verabschiedet hat:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschloss, dass die Gesellschaft die luxemburgische Staatsbürgerschaft durch die Verlegung

des Gesellschaftssitzes und des Sitzes der zentralen Geschäftsführung der Gesellschaft ohne Unterbrechung der körper-
schaftlichen Existenz von Zypern in das Großherzogtum Luxemburg annimmt, die Gesellschaft dem luxemburgischen
Recht zu unterwerfen, dass die Gesellschaft die Form einer Aktiengesellschaft annimmt und dass der Name der Gesell-
schaft in „International Food Retail Capital S.A.“ geändert wird, alles mit Wirkung zum Datum dieser außerordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft.

Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Enthaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschloss, die Satzung der Gesellschaft, inklusive der Klausel bezüglich des Gesellschafts-

zweckes welcher unter Punkt 2 der oben angeführten Tagesordnung steht, völlig neu zu fassen welche nun in Überein-
stimmung mit dem luxemburgischen Recht wie folgt lautet:

Kapitel I.- Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") gegründet, die den Gesetzen des

Großherzogtums Luxemburg und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die „Satzung“) unterliegt.

Die Aktien der Gesellschaft können von einem einzelnen Aktionär oder von mehreren Aktionären gehalten werden.
Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen „International Food Retail Capital S.A.“

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst den Erwerb, den Besitz und die Veräußerung von Betei-

ligungen an luxemburgischen und/oder ausländischen Gesellschaften und Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwick-
lung und Unternehmensführung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften und Unternehmen, die der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle

Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und
Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen

Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und Anleihen, Schuldtitel oder jegliche Art von

Schuldverschreibungen und Optionsscheinen oder andere Titel ausgeben, die das Recht auf Zeichnung von Aktien bein-
halten.

Generell kann die Gesellschaft jede Tätigkeit ausführen, die für die Erfüllung und Entwicklung ihres Unternehmens-

zweckes dienlich oder notwendig erscheint.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann aufgelöst werden durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit dem nach dem

Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen Mehrheiten
und in Übereinstimmung mit Artikel 31 dieser Satzung und zwingender Vorschriften der Gesetze gefasst wird.

Kapitel II.- Kapital, Aktien

Art. 5. Ausgegebenes Kapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt vierzehn Millionen neunhundertdrei-

undneunzigtausendachthundertzwölf Euro und neunundsiebzig Eurocent (EUR 14.993.812,79) und ist in eine Milliarde,

36840

L

U X E M B O U R G

vierhundertneunundneunzig Millionen dreihunderteinundachtzigtausendzweihundertneunundsiebzig (1.499.381.279) Ak-
tien mit einem Nennwert von jeweils einem Eurocent (EUR 0,01) aufgeteilt. Alle Aktien sind vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Aktien mit denselben Rechten und

Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissions-

aufgelder, die auf eine Aktie eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung von
Aktien, die die Gesellschaft von ihrem(n) Aktionär(en) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur
Auszahlung an den/die Aktionär(e) in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage bereitzustellen,
verwendet werden.

Art. 6. Aktien. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.
Die Aktien werden in Form von Namensaktien.
Die Aktien sind frei übertragbar.
Gegenüber der Gesellschaft ist jede Aktie unteilbar.
Die Miteigentümer, die Nießbraucher und die bloßen Eigentümer von Aktien sowie die Pfandgläubiger und die Pfand-

schuldner von Aktien müssen durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden, der unter ihnen ernannt wird oder
nicht.

Hinsichtlich der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz ein Aktienregister geführt, dass von jedem Aktionär einge-

sehen werden kann. Dieses Aktienregister enthält Angaben über die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs und über die
Anzahl und die Kategorie (falls vorhanden) der jeweils gehaltenen Aktien, über die auf jede Aktie geleisteten Zahlungen
sowie über die Daten der Übertragungen von Aktien. Jeder Aktionär muss der Gesellschaft mittels eingeschriebenen
Briefs seine Adresse und jede Änderung derselben mitteilen. Die Gesellschaft darf sich für jegliche Zwecke auf die ihr
zuletzt mitgeteilte Adresse verlassen. Das Eigentum an den Aktien bestimmt sich nach den Eintragungen in dem Aktien-
register. Den Aktionären werden auf Verlangen Zertifikate ausgestellt, die die Eintragungen des Aktienbuches wieder-
geben. Die Gesellschaft kann Namenszertifikate, welche Eintragungen betreffend mehrere Aktien darstellen, ausstellen.

Jede Übertragung von Aktien wird im Aktienregister durch eine datierte und vom Übertragenden und Übertragungs-

empfänger oder seinem Vertreter unterzeichnete Übertragungserklärung sowie in Übereinstimmung mit den in Artikel
1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Luxemburgs über die Forderungsübertragung festgelegten Regeln eingetragen. Ferner
darf die Gesellschaft jede Übertragung, auf die in jeglicher Art in Korrespondenz oder in jedem anderen Dokument Bezug
genommen wird und die die Zustimmung vom Übertragenden und Übertragungsempfänger enthält, zur Kenntnis nehmen
und in das Aktienregister eintragen.

Das Eigentum an einer Aktie beinhaltet zugleich implizit das Einverständnis mit der Satzung und mit den von der

Hauptversammlung wirksam angenommenen Beschlüssen.

Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehr-

fach durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine
Satzungsänderung anwendbaren Gesetzesvorschriften erforderlichen Quorum- und Mehrheitsregeln gefasst wird, erhöht
oder herabgesetzt werden.

Die neuen, mittels Geldeinlage einzuzahlenden Aktien werden den vorhandenen Aktionären in dem Verhältnis, in dem

sie am Gesellschaftskapital beteiligt sind, bevorzugt angeboten. Der Verwaltungsrat wird den Zeitraum bestimmen, in-
nerhalb dessen das Vorzugsrecht bei der Aktienzeichnung ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf dreißig (30) Tage
nicht unterschreiten.

Unbeschadet des Vorstehenden, kann die Hauptversammlung, durch einen in Übereinstimmung mit den satzungsge-

mäss beziehungsweise gesetzlich vorgeschriebenen Regeln bezüglich Quorum und Mehrheit getroffenen Hauptversamm-
lungsbeschluss das Vorzugsrecht bei der Aktienzeichnung begrenzen oder ausschließen oder den Verwaltungsrat hierzu
ermächtigen.

Art. 8. Erwerb von eigenen Aktien. Die Gesellschaft darf ihre eigenen Aktien erwerben. Der Erwerb und der Besitz

der eigenen Aktien vollzieht sich in Übereinstimmung mit den durch die Gesetze festgelegten Bedingungen und Begren-
zungen.

Kapitel III.- Verwaltungsrat, Revisoren

Art. 9. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat verwaltet, der aus nicht weniger als drei (3)

Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, besteht (der „Verwaltungsrat“). Wenn und solange die Gesellschaft nur
einen (1) Aktionär hat kann der Verwaltungsrat aus einem einzelnen Mitglied bestehen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Hauptversammlung ernannt, die ihre Anzahl und ihre Amtsdauer

festlegt, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Sie können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder
ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden.

Die Hauptversammlung kann beschließen, die ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates als Verwaltungsratsmitglied

der Kategorie A („Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A“) oder als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B („Ver-
waltungsratsmitglied der Kategorie B“) zu qualifizieren.

36841

L

U X E M B O U R G

Wird im Verwaltungsrat ein Sitz frei, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates in Kooptation

einen neues Mitglied des Verwaltungsrates zur Ausfüllung dieser freien Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung nennen,
die die Kooptation ratifizieren oder stattdessen ein neues Mitglied des Verwaltungsrates wählen muss.

Die Aktionäre dürfen weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle zur Errei-

chung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die die
Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich der Hauptversammlung oder dem/den Revisoren übertragen haben, fallen
in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Art. 11. Vertretung der Gesellschaft - Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäfts-

führung  der Gesellschaft  und die Vertretung  der  Gesellschaft  innerhalb  der täglichen Geschäftsführung  an eine oder
mehrere Personen oder Gremien seiner Wahl übertragen.

Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen oder Gremien seiner Wahl andere spezielle Befugnisse oder

Vollmachten übertragen oder diese mit dauernden oder zeitweisen Funktionen ausstatten.

Der Verwaltungsrat muss jährlich der Hauptversammlung Bericht erstatten über die Bezahlung oder Zuweisung von

anderen Vergünstigungen an die Person(en), denen die tägliche Geschäftsführung übertragen wurde.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die Unterschrift des einzigen Mitglieds des Verwaltungsrates oder

durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Mitgliedern des Verwaltungsrates vertreten.

Falls die Hauptversammlung die Verwaltungsratsmitglieder als Verwaltungsratsmitglieder der Klasse A oder Verwal-

tungsratsmitglieder der Klasse B qualifiziert haben, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber nur durch die gemeinsame
Unterschrift von einem (1) Verwaltungsratsmitglied der Klasse A und einem (1) Verwaltungsratsmitglied der Klasse B
vertreten.

Die Gesellschaft wird außerdem gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift oder durch die alleinige Un-

terschrift derjenigen Person vertreten, der die tägliche Verwaltung der Gesellschaft übertragen worden ist, oder durch
die gemeinschaftliche oder die alleinige Unterschrift derjenigen Person, denen von dem Verwaltungsrat eine besondere
Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht.

Art. 12. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ernennt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der

„Vorsitzende“). Der Verwaltungsrat kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats
sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Verwaltungsrats verantwortlich ist (der „Schrift-
führer“).

Der Verwaltungsrat tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Sitzung des Verwaltungsrates muss

auf Wunsch zweier (2) seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Verwaltungsrates vor, es sei denn, dass der Verwaltungsrat wegen der

Abwesenheit des Vorsitzenden ein anderes Mitglied als Vorsitzenden auf Zeit durch Mehrheitswahl durch die anwesenden
oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates in dieser Sitzung ernannt hat.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorher erteilter Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen

des Verwaltungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und Zeit der Sitzung
sowie die Tagesordnung und die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mitglied des Verwal-
tungsrates kann schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium auf die Benachrichti-
gung  verzichten.  Für  Sitzungen,  deren  Ort  und  Zeit  in  einem  zuvor  angenommenen  Beschluss  des  Verwaltungsrates
festgelegt worden sind, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Die Verwaltungsratssitzungen finden in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Verwaltungsrat hierfür be-

stimmt hat, statt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei den Sitzungen des Verwaltungsrates durch ein anderes
Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen, indem es dieses hierzu schriftlich bevollmächtigt; die Bevollmächtigung kann
durch jedes die Schriftlichkeit gewährleistende Kommunikationsmedium übertragen werden. Jedes Verwaltungsratsmit-
glied kann ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Anzahl der

Verwaltungsratsmitglieder. Beschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen
Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung, Visio-

konferenz oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende
Mittel teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der tatsächlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleich gestellt. Der Ver-
waltungsrat kann weitere Regeln in dieser Hinsicht in seinem internen Reglement festlegen.

Eine  von  allen  Verwaltungsratsmitgliedern  unterzeichnete  Entscheidung  steht  einem  Beschluss  gleich,  der  in  einer

ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung gefasst worden wäre. Diese Entscheidung kann
in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts festgehalten sein die jeweils
von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Art. 13. Beschlüsse des Verwaltungsrats. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden schriftlich festgehalten.

36842

L

U X E M B O U R G

Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden von dem Vorsitzenden und gegebenenfalls dem Schriftführer

unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse der Verwaltungsratsmitglieder oder Sitzungsprotokolle der Haupt-

versammlungen, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, werden durch das einzige Mitglied
des Verwaltungsrates oder durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates gemeinsam unterzeichnet.

Beschlüsse die durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied gefasst werden, müssen schriftlich gefasst werden und durch

das einzige Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.

Art. 14. Geschäftführungsbezüge und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung, können

die Mitglieder des Verwaltungsrates eine Vergütung hinsichtlich ihrer Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber
hinaus können ihnen sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des Gesell-
schaftszweckes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

Art. 15. Interessenkonflikte-Entschädigungen. Wenn ein Mitglied des Verwaltungsrates ein persönliches Interesse an

einer Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hat, soll dieses Mitglied dies dem Verwaltungsrat bekannt machen und nicht über
diese Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beraten oder abstimmen.

Diese Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds ist der nächsten

Hauptversammlung in einem speziellen Bericht und vor der Fassung irgendeines Beschlusses durch die Hauptversammlung
zu berichten.

Wenn der Verwaltungsrat nur ein (1) Mitglied hat genügt es dass die Geschäftstätigkeit zwischen der Gesellschaft und

dem Verwaltungsratsmitglied, das ein entgegen gesetztes persönliches Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.

Die obigen Abschnitte dieses Artikels finden keine Anwendung wenn (i) die jeweilige Transaktion unter den üblichen

Marktbedingungen abgeschlossen wird und (ii) in den Bereich der ordentlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft fällt.

Kein  Vertrag  oder  sonstiges  Rechtsgeschäft  zwischen  der  Gesellschaft  und  einer  anderen  Gesellschaft  oder  einer

anderen Firma wird in seiner Wirksamkeit durch die bloβe Tatsache beeinflusst, dass ein Mitglied des Verwaltungsrates
oder ein Angestellter oder Arbeitnehmer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an der anderen Gesellschaft oder
Firma haben oder ein Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Mitglied, Anteilseigner, Angestellter oder Arbeitnehmer der
anderen Gesellschaft oder Firma ist. Jede Person, die in der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft oder einer
Firma verbunden ist und mit denen die Gesellschaft vertraglich oder in anderer Weise in Geschäftsbeziehungen treten
wird, soll nicht alleine wegen dieser Verbindung an der Abstimmung oder der Vornahme anderer Handlungen in Bezug
auf einen solchen Vertrag oder sonstigen Geschäftstätigkeit gehindert sein.

Art. 16. Haftung der Verwaltungsratsmitglieder - Entschädigungen.
Ein Mitglied des Verwaltungsrates trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich der aufgrund seiner Funktion für die

Gesellschaft eingegangen Verpflichtungen.

Mitglieder des Verwaltungsrates sind nur für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jedes Mitglied des Verwaltungsrates, Handlungsbevollmächtigten und seine Erben, Nachlassver-

walter  und  Vermögensverwalter,  von  Ausgaben  frei,  die  ihm  im  Zusammenhang  mit  einem  Rechtsstreit  oder  einem
Prozess, an dem er aufgrund seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied, oder früheres Verwaltungsratsmitglied oder als
Bevollmächtigter der Gesellschaft als Partei teilnimmt, angefallen sind. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesell-
schaft für eine andere Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt
und der gegenüber er nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er endgültig wegen grober
Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt werden soll. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich
umfasste Fragen gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass die
freizustellende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht zur Freistellung schließt keine ande-
ren Rechte aus zu denen die gemäß diesem Artikel zu entschädigenden Personen berechtigt sind.

Art. 17. Vertraulichkeit. Auch nach Beendigung ihres Mandates oder ihrer Tätigkeit dürfen die Mitglieder des Verwal-

tungsrates sowie alle Personen, die eingeladen sind, an einer Verwaltungsratssitzung teilzunehmen, Informationen über
die  Gesellschaft,  die  schädliche  Folgen  für  die  Gesellschaft  haben  könnten,  nicht  offenlegen,  außer  wenn  eine  solche
Offenlegung (i) aus auf Aktiengesellschaften anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen Vorschriften oder (ii) aus
Gründen des öffentlichen Wohls notwendig ist.

Art. 18. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-

schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten, durch statutorische Wirtschafts-
prüfer, welche nicht Aktionär zu sein brauchen, geprüft.

Die statutorischen oder, gegebenenfalls, die zugelassenen Wirtschaftsprüfer werden durch die Hauptversammlung

ernannt, die deren Anzahl und die Dauer ihres Mandates festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden
und können jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss der Hauptversammlung abberufen
werden außer in Fällen, in denen der zugelassene Wirtschaftsprüfer aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften nur
aus schwerwiegendem Grund oder in gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.

36843

L

U X E M B O U R G

Kapitel IV.- Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 19. Befugnisse der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung besitzt die ihr nach der Satzung und nach den

Gesetzen zukommenden Befugnisse. Der alleinige Aktionär übt die Befugnisse der Hauptversammlung aus.

Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre.

Art. 20. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird am Sitz der Gesellschaft am zwei-

ten Mittwoch des Monats Juni um 11.00 Uhr morgens abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen Tag, an dem Banken in Luxemburg allgemein nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am

nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 21. Weitere Hauptversammlungen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der/die statutorische(n) Wirtschafts-

prüfer können zusätzlich zu der Jahreshauptversammlung weitere Hauptversammlungen einberufen. Diese Versammlung
ist einzuberufen, wenn es eine Anzahl von Aktionären, die mindestens ein Zehntel (10%) des Gesellschaftskapitals ver-
treten, so verlangt.

Hauptversammlungen sowie die Jahreshauptversammlung werden am Gesellschaftssitz oder an einem anderen Ort im

Großherzogtum Luxemburg abgehalten.

Art. 22. Einberufungsschreiben zur Hauptversammlungen. Die Aktionäre treten auf Einberufungsschreiben, (das er-

forderlichenfalls auch veröffentlicht wird) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung oder den Gesetzen
zusammen.

Das an die Aktionäre versandte Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit sowie die Tagesordnung und die Art

der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Hauptversammlung an. Die Tagesordnung einer Hauptversammlung
muss, sofern angebracht, die vorzunehmenden Änderungen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den
Wortlaut der Änderungen ausführen, die Auswirkungen auf Gesellschaftszweck und -form der Gesellschaft haben.

Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Tagesordnung

der Versammlung ordnungsgemäss unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.

Art. 23. Teilnahme und Vertretung. Alle Aktionäre besitzen bei jeder Hauptversammlung ein Teilnahme- und Rede-

recht.

Ein Aktionär kann sich durch schriftlich erteilte Vollmacht, die durch eine die Schriftlichkeit wahrende Übertragungs-

weise übermittelt wurde, bei jeder Hauptversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Aktionär sein muss,
vertreten lassen. Der Verwaltungsrat kann alle Bedingungen, die zur Teilnahme eines Aktionärs an einer Hauptversamm-
lung erfüllt sein müssen, aufstellen.

Aktionäre, die an einer Generalversammlung durch Videokonferenz oder ähnliche Telekommunikationsmedien, die

ihre Identifizierung erlauben, teilnehmen, werden für die Feststellung des Quorums und der Mehrheitsverhältnisse als
anwesend angesehen. Solche Telekommunikationsmethoden müssen alle technischen Erfordernisse erfüllen, die konti-
nuierlich die tatsächliche Teilnahme an der Versammlung und ihrer Beratung sicherstellen.

Art. 24. Verfahren. Der Vorsitzende oder eine von dem Verwaltungsrat, oder in dessen Abwesenheit von der Haupt-

versammlung, bestimmte Person steht jeder Hauptversammlung vor.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung ernennt einen (1) Schriftführer.
Die Hauptversammlung wird aus den anwesenden oder vertretenen Aktionären einen Stimmenzähler wählen.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden zusammen den Vorstand der Hauptversammlung.

Art. 25. Vertagung. Der Verwaltungsrat kann jede Hauptversammlung für vier Wochen vertagen. Der Verwaltungsrat

ist zur Vertagung verpflichtet, wenn es die Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des von der Gesellschaft
ausgegebenen Kapitals vertreten, so verlangen.

Eine derartige Vertagung macht automatisch jeden zuvor angenommenen Beschluss gegenstandslos.
Die so vertagte Hauptversammlung hat dieselbe Tagesordnung wie die ursprünglich angesetzte. Die im Hinblick auf

die  ursprünglich  einberufene  Hauptversammlung  ordnungsgemäß  hinterlegten  Aktien  und  Vollmachten  behalten  ihre
Gültigkeit auch für die vertagte Versammlung.

Art. 26. Abstimmung. Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Aktionäre und die Anzahl ihrer zur Abstimmung

berechtigenden Aktien angibt, wird von den Aktionären oder von ihren Vertretern vor der Eröffnung der Hauptver-
sammlung unterzeichnet.

Die Hauptversammlung darf nur über solche Punkte beraten und abstimmen, die auf der Tagesordnung aufgeführt sind.
Die Abstimmungen finden per Handzeichen oder durch Namensaufruf statt, falls nicht die Hauptversammlung be-

schlossen hat, ein anderes Abstimmungsverfahren anzunehmen.

Bei jeder Hauptversammlung, mit Ausnahme der Hauptversammlungen, die zum Zwecke der Satzungsänderung oder

zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Satzungsänderung

36844

L

U X E M B O U R G

unterliegt, einberufen wurde, werden die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit und ungeachtet der Anzahl der vertretenen
Aktien angenommen.

Bei jeder Hauptversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz zum Zwecke der Satzungs-

änderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer
Satzungsänderung unterliegt, einberufen wurde, entspricht das Quorum mindestens der Hälfte (1/2) aller ausgegebenen
und noch ausstehenden Aktien.

Sollte dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht werden, kann eine zweite Versammlung einberufen

werden, welche keinem Quorumserfordernis unterliegt. In jeder Hauptversammlung ist zur Annahme eines vorgeschla-
genen Beschlusses eine Zwei-Drittel Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre
erforderlich, es sei denn, dass das Gesetz etwas anderes vorschreibt.

Art. 27. Protokoll. Das Sitzungsprotokoll der Hauptversammlung wird vom Vorstand der Hauptversammlung unter-

zeichnet. Es kann auf Verlangen von jedem Aktionär oder Bevollmächtigtem eines Aktionärs unterzeichnet werden.

Kapitel V.- Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung

Art. 28. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 29. Annahme der Finanzberichte. Der Verwaltungsrat bereitet in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestim-

mungen den Jahresabschluss und/oder den konsolidierten Jahresabschluss zur Feststellung durch die Aktionäre vor. Der
Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss wird/werden der Hauptversammlung zur Feststellung vorge-
legt.

Art. 30. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der

gesetzlich vorgesehenen Rücklage (die „gesetzliche Rücklage“) zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die ge-
setzliche Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmt die Hauptversammlung wie der verbleibende jährliche Rein-

gewinn verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zuweist, auf
das nächste Geschäftsjahr vorträgt oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Aus-
gabeprämien  an  die  Aktionäre  ausschüttet,  wobei  jede  Aktie  in  gleichem  Verhältnis  zur  Teilnahme  an  einer  solchen
Ausschüttung berechtigt.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmun-

gen, kann der Verwaltungsrat eine Abschlagsdividende an die Aktionäre auszahlen. Der Verwaltungsrat legt die Summe
und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI.- Auflösung, Abwicklung

Art. 31. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstim-

mung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzen erforderlichen Quorum und
Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von dem Verwaltungsrat oder jeder anderen von der Hauptver-

sammlung ernannten (natürlichen oder juristischen) Person ausgeführt werden, deren Befugnisse und Vergütung von der
Hauptversammlung festgelegt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-

quidationskosten wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

Kapitel VII.- Anwendbares recht

Art. 32. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-

stimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915,
in seiner zuletzt geltenden Fassung.

Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Enthaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung bestätigte, dass ein am 9. März 2015 vorbereiteter Bericht von PricewaterhouseCoopers,

Abschlussprüfer (réviseur d’entreprises), bescheinigt, dass das Reinvermögen der Gesellschaft mindestens dem Stamm-
kapital von vierzehn Millionen neunhundertdreiundneunzigtausendachthundertzwölf Euro und neunundsiebzig Eurocent
(EUR 14.993.812,79) entspricht, welches in eine Milliarde, vierhundertneunundneunzig Millionen dreihunderteinundacht-
zigtausendzweihundertneunundsiebzig (1.499.381.279) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einem Eurocent (EUR
0,01) aufgeteilt ist, der Generalversammlung vorgelegt wurde.

Die Schlussfolgerung des Berichts lautet wie folgt:

36845

L

U X E M B O U R G

“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net assets of the Company

as at 31 December 2014 do not correspond at least to an amount of EUR 399,804,064.”

Der Bericht bleibt dieser Urkunde beigefügt, um gemeinsam mit ihr beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsre-

gister eingereicht zu werden.

Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Enthaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschloss, den Gesellschaftssitz der Gesellschaft in der 2b, rue Albert Borschette, L-1246

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Enthaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung nahm die Rücktritte von Herrn Heiner Kamps, Herrn Volkhard Otto Mett, Herrn Michalis

Ioannou und Herrn Christos Theodoulou von ihren Positionen als Direktoren der Gesellschaft zur Kenntnis, und erteilte
ihnen vorläufige Entlastung bezüglich der Ausübung ihrer Pflichten, soweit dies rechtlich möglich ist.

Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Enthaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschloss, die Anzahl der Mitglieder der Verwaltungsrates auf drei (3) festzulegen und be-

schloss folgende Personen für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu ernennen:

- Herr Heiner Kamps;
- Herr Ronald Kers; und..
- Herr Dr. Henrik Bauwens.

Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Enthaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschloss, PricewaterhouseCoopers, Genossenschaft luxemburgischen Rechts (société coo-

pérative de droit luxembourgeois), mit Sitz in der 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzog-
tum Luxembourg, als Rechnungsprüfer (commissaire) der Gesellschaft zu ernennen.

Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Enthaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschloss, alle Befugnisse an jeden Rechtsanwalt der Kanzlei Linklaters LLP, Luxemburg,

alleine handelnd und mit voller Substitutionsvollmacht, zu erteilen, alle Maßnahmen zu ergreifen und Handlungen durch-
zuführen,  deren  Durchführung  durch  die  Gesellschaft  notwendig  oder  wünschenswert  sind,  um  die  obenstehenden
Beschlüsse umzusetzen und um die Gesellschaft beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister einzutragen.

Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.019.686
Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805.158

Enthaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde ent-

stehen werden auf ungefähr sechstausend fünfhundert Euro (EUR 6.500) geschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am eingangs erwähnten Datum.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben

genannten erschienenen Parteien, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst
ist; auf Anfrage der gleichen Parteien und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes,
wird der englische Text vorwiegen.

36846

L

U X E M B O U R G

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar unterzeichnet.

Signé: H. Schmitt, P. Graf, M. Müller, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 10 mars 2015. GAC/2015/1972. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015041661/893.
(150047227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Secure Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 180.439.

In the year two thousand and fifteen, the fourth day of March, before Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in

Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Secure Industries SA, a Luxembourg public

limited liability company (société anonyme), having its registered office at 7, val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register under registration number B
180.439 (the Company).

The Company was incorporated on 13 September 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2470 of 5 October 2013. The articles of association of the
Company (the Articles) have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 27 February
2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Maître Serge Zeien, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Maître Paul Weber Avocat, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting
(the Secretary). The Meeting elects Maître Paul Weber as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the
Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders of the Company (the Shareholders and each a Shareholder) represented at the Meeting and the

number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after
having been signed by the proxyholder of the Shareholders, the members of the Bureau and the undersigned notary.

The proxies from the Shareholders represented at the Meeting, after having been initialled ne varietur by the proxy-

holder acting on behalf of the Shareholders, the members of the Bureau and the undersigned notary, shall also remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
(1) The agenda of the Meeting is as follows:
(a) (i) reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 40,000 (forty thousand euro) in order to

bring the share capital of the Company from an amount of EUR 353,597,000 (three hundred fifty-three million five hundred
ninety-seven thousand euro) to an amount of EUR 353,557,000 (three hundred fifty-three million five hundred fifty-seven
thousand euro) by way of cancellation of 40 (forty) class A shares (the Cancelled Shares), and (ii) the payment of an
aggregate redemption price (including premium) of EUR 47,483.60 (forty-seven thousand four hundred eighty-three euro
and sixty cent) to the holder of the Cancelled Shares;

(b) amendment of article 5 of the Articles, in order to reflect the change mentioned in item (a) above;
(c) authorisation to the board of directors of the Company (the Board) pursuant to article 49-2 of the act dated 10

August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act);

(d) amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, and grant of authority in

connection thereto; and

(e) miscellaneous.
(2) It appears that the Shareholders, represented as stated above, waive any convening notice and consider themselves

as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda, which has been communicated to them in advance.

(3) The Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda of the Meeting.
After deliberation, the Chairman submitted to the vote of the Meeting the following resolutions:

36847

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 40,000 (forty thousand euro)

in order to bring the share capital of the Company from an amount of EUR 353,597,000 (three hundred fifty-three million
five hundred ninety-seven thousand euro) to an amount of EUR 353,557,000 (three hundred fifty-three million five hun-
dred fifty-seven thousand euro) by way of cancellation of 40 (forty) class A shares (the Share Capital Decrease).

As a result of such Share Capital Decrease, Guardian Segur S.A., acting in respect of its compartment called “Com-

partment 1”, as the holder of the Cancelled Shares shall be entitled to the payment of an aggregate redemption price
(including premium) of EUR 47,483.60 (forty-seven thousand four hundred eighty-three euro and sixty cent).

<i>Second resolution

The Meeting subsequently resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles, in order to reflect the

Share Capital Decrease, which shall now read as follows:

“The share capital is set at EUR 353,557,000 (three hundred fifty-three million five hundred fifty-seven thousand euro)

represented by 53,557 (fifty-three thousand five hundred fifty-seven) class A shares (the A Shares) and 300,000 (three
hundred thousand) class B shares (the B Shares), having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro) each, which
are fully paid up (the A Shares and the B Shares are collectively referred to as the shares).”

<i>Third resolution

The Meeting subsequently resolves to authorise the Board, for a period starting on the year and day first above written

and ceasing on the fifth anniversary of such date, to redeem shares of the Company pursuant to the terms and conditions
set out below. This authorisation is granted to the Board pursuant to article 49-2 of the Companies Act.

The Board is authorised to redeem shares of the Company by any means, including without limitation under share

redemption agreements, option agreements, and exchange agreements, against a cash consideration or a consideration
in kind, on the terms and conditions to be set out by the Board, provided that:

(i) the maximum number of shares of the Company that can be redeemed from time to time under this authorisation

shall be equal to the number of shares of the Company outstanding from time to time less the number of shares of the
Company representing the minimum share capital required by the Companies Act for a public limited liability company
(société anonyme);

(ii) the share redemption price whether it is paid in cash or in kind shall be (a) minimum the nominal value of a share

and (b) maximum the aggregate amount of available funds for distribution in accordance with article 20 of the Articles
divided through the number of shares to be redeemed; and

(iii) any repurchased shares shall be fully paid up.
In any event, share redemptions shall be made out of the distributable reserves (including share premium and capital

surplus) and profits available to that effect in accordance with article 49-2 of the Companies Act.

Redeemed shares of the Company may (or may not) be cancelled by a resolution made by a general meeting of the

Shareholders in accordance with the requirements set out in the Companies Act.

Once redeemed and for so long as the shares of the Company are kept in treasury by the Company, the shares of the

Company shall bear no voting rights and the rights to receive dividends or liquidation proceeds shall be suspended.

The Board shall take or authorise any person to take any necessary steps resulting from the redemption of the shares

of the Company, including but not limited to the recording of such redemption in the share register of the Company.

<i>Fourth resolution

The Meeting subsequently resolves to empower and authorise any director of the Company, each one of them acting

individually and on behalf of the Company, with full power of substitution in order (i) to register the Share Capital Decrease
in the share register of the Company and to sign such share register, (ii) to accomplish the filing of the relevant documents
regarding the Share Capital Decrease and the authorisation given in accordance with article 49-2 of the Companies Act
with the Luxembourg trade and companies register and (iii) to see to any formalities in connection therewith (including
for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated to be approximately at one thousand five hundred euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the
proxyholder of the above appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

36848

L

U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le quatre mars, par devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch, au

Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de Secure Industries SA, une société anonyme

régie par le droit luxembourgeois et ayant son siège social au 7, val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro d’imma-
triculation B180439 (la Société).

La  Société  a  été  constituée  le  13  septembre  2013  conformément  à  un  acte  reçu  du  notaire  soussigné,  publié  au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2470 du 5 octobre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 27 février 2015 et pas encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est présidée par Maître Serge Zeien, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg (le

Président). Le Président nomme Maître Paul Weber, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que
secrétaire de l’Assemblée (le Secrétaire). L’Assemblée élit Maître Paul Weber comme scrutateur de l’Assemblée (le
Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après par le Bureau.

Les actionnaires de la Société (les Actionnaires et chacun l’Actionnaire) représentés à l’Assemblée et le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été
signée par le mandataire des Actionnaires, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

Les procurations des Actionnaires représentés à l’Assemblée, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire

de Actionnaires, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexée au présent acte pour être
soumises en même temps aux autorités compétentes.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire de noter que:
(1) L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
(a) (i) réduction du capital social de la Société d’un montant de EUR 40.000 (quarante mille euros) à l’effet de porter

le capital social de la Société d’un montant de EUR 353.597.000 (trois cent cinquante-trois millions cinq cent quatre-vingt-
dix-sept mille euros) à un nouveau montant de EUR 353.557.000 (trois cent cinquante-trois millions cinq cent cinquante-
sept mille euros), par le biais d’une annulation de 40 (quarante) actions de catégorie A (les Actions annulées), et (ii)
paiement d’un prix de rachat total (y compris prime) de EUR 47.483,60 (quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-
trois euros et soixante centimes) au détenteur des Actions annulées;

(b) modification du premier paragraphe de l’article 5 des Statuts afin de refléter les modifications visées aux points (a)

ci-dessus;

(c) l’autorisation au conseil d'administration de la Société (le Conseil) conformément à l’article 49-2 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés);

(d) modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, et octroi de

pouvoirs à cet égard; et

(e) divers.
(2) Les Actionnaires sont dûment représentées à l’Assemblée. L’Assemblée renonce aux formalités de convocation,

les Actionnaires se considérant comme dûment convoqués et ayant une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur
a été communiqué à l’avance.

(3) L’Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points inscrits à l’ordre du

jour de l’Assemblée.

Après délibération, le Président a soumis au vote de l’Assemblée les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de EUR 40.000 (quarante mille euros) afin

de porter le capital social de la Société d’un montant de EUR 353.597.000 (trois cent cinquante-trois millions cinq cent
quatre-vingt-dix-sept mille euros) à un montant de EUR 353.557.000 (trois cent cinquante-trois millions cinq cent cin-
quante-sept mille euros) par le biais de l’annulation de 40 (quarante) actions de catégorie A (la Réduction du Capital
Social).

Suite à cette Réduction du Capital Social, Guardian Segur S.A., agissant pour son compartiment avec le nom «Com-

partment 1», en tant que détenteur des Actions Annulées aura droit au paiement d’un prix de rachat total (y compris
prime) de EUR 47.483,60 (quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et soixante centimes).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des Statuts, afin de refléter la Réduction du Capital

Social, qui doit dorénavant être lu comme suit:

36849

L

U X E M B O U R G

«Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  est  fixé  à  EUR  353.557.000  (trois  cent  cinquante-trois  millions  cinq  cent

cinquante-sept mille euros) représenté par 53.557 (cinquante-trois mille cinq cent cinquante-sept) Actions de catégorie
A (les Actions A) et 300.000 (trois cent mille) actions de catégorie B (les Actions B), ayant une valeur nominale de EUR
1.000 (mille euros) chacune, entièrement souscrites (les Actions A et les Actions B sont collectivement dénommées les
actions)».

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide ensuite d'autoriser le Conseil, pour une période commençant l’année et le jour susmentionnés et

se terminant le cinquième anniversaire de cette date, à racheter des actions de la Société conformément aux modalités
énoncées ci-dessous. Cette autorisation est conférée au Conseil en vertu de l’article 49-2 de la Loi sur les Sociétés.

Le Conseil est autorisé à racheter des actions de la Société par tous moyens, y compris, et sans limitation, en concluant

des contrats de rachat d’actions, des contrats d'options et des contrats d’échange, contre un paiement en numéraire ou
d’un paiement en nature, suivant les conditions devant être définies par le Conseil, à condition que:

(i) le nombre maximal d'actions de la Société pouvant être rachetées en vertu de la présente autorisation soit égal au

nombre d'actions de la Société en circulation de temps à autre, moins le nombre d'actions de la Société représentant le
capital social minimum requis par la Loi sur les Sociétés pour une société anonyme;

(ii) le prix de rachat des actions de la Société, qu’il soit payé en numéraire ou en nature soit de (a) au minimum la

valeur nominale d’une action et (b) au maximum le montant total des fonds disponibles pour la distribution conformément
à l’article 20 des Statuts divisé par le nombre d'actions devant être rachetées; et

(iii) les actions rachetées soient entièrement libérées.
Les rachats d'actions seront effectués au moyen des réserves distribuables (y inclus la prime d'émission et le capital

surplus) ainsi que sur les bénéfices disponibles à cet effet, conformément à l’article 49-2 de la Loi sur les Sociétés.

Les actions de la Société rachetées peuvent ou non être annulées par une résolution de l’assemblée générale des

Actionnaires prise conformément aux dispositions de la Loi sur les Sociétés.

Une fois rachetées et tant que les actions de la Société sont détenues en portefeuille par la Société, les actions n'auront

aucun droit de vote et les droits aux dividendes ou au boni de liquidation seront suspendus.

Le Conseil prendra toutes les mesures nécessaires ou autorisera toute personne à prendre les mesures nécessaires

en conséquence du rachat des actions de la Société, y compris, entre autres, l’inscription dudit rachat dans le registres
des actionnaires de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de donner par la présente pouvoir et autorité à tout gérant de la Société avec plein pouvoir de

substitution, chacun d’eux agissant individuellement et dans l’intérêt de la Société, de procéder (i) à l’enregistrement de
la Réduction du Capital Social dans le registre de parts sociales de la Société et de pourvoir aux formalités y relatives, (ii)
à l’accomplissement du dépôt des documents pertinents concernant la Réduction du Capital Social et l’autorisation ac-
cordée conformément à l’article 49-2 de la Loi sur les Sociétés dans le Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
et (iii) de procéder à toute autre formalité nécessaire, exigée, désirée ou utile à l’accomplissement et à la mise en oeuvre
des résolutions ci-dessus (y compris le dépôt de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à mille cinq cents
euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française; à la requête des parties comparantes, et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l’original

du présent acte.

Signé: Zeien, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 05 mars 2015. Relation: DAC/2015/3878. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 13 mars 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015041934/208.
(150048162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

36850

L

U X E M B O U R G

Cherrilux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.013.050,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.032.

In the year two thousand and fifteen, on the tenth day of March,
before the undersigned, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was weld

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Cherrilux Investments S.à r.l., a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée) with its registered office at 6, rue Eug.ne Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 167.032 and having a share capital of EUR 3,013,050 (the Company). The Company has been incorporated
on 19 January 2012 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial C) on 4 April 2012 under number 887.
The articles of associations of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed by Maître
Jean Seckler on 13 June 2012, published in the Mémorial C on 23 August 2012 under number 2093.

THERE APPEARED:

GAME Digital Holdings Limited (formerly Capitex Holdings Limited), a private limited liability company, governed by

the laws of England and Wales, having its registered office at Unity House, Telford Road, Basingstoke, Hampshire RG21
6YJ, United Kingdom, registered with the Companies House of England and Wales under number 7893832 (the Sole
Shareholder),

here represented by Peggy Simon, employee, whose professional address is at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue

of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
(i) the Sole Shareholder holds all of the shares in the Company;
(ii) the agenda of the Meeting is as follows:
1. presentation and acknowledgment of the draft terms of the cross border merger providing for the absorption by

the Sole Shareholder of the Company (the Draft Terms of the Cross Border Merger and the Merger). The Sole Share-
holder and the Company are hereafter together referred to as the Merging Companies;

2. acknowledgement that, in accordance with articles 267 and 278 of the law on commercial companies dated 10

August 1915, as amended (the Law), the relevant documents, unless waived, have been deposited at the Company's
registered office or made available at its website for due inspection by the Sole Shareholder at least one month before
the date of the holding of the general meeting of the Sole Shareholder to approve the Draft Terms of the Cross Border
Merger and the Merger;

3. confirmation that the requirements provided for under article 265 (1) and (2) of the Law have been, in accordance

with article 265 (3) of the Law, waived by the Sole Shareholder;

4. approval of the Draft Terms of the Cross Border Merger and to carry out the Merger;
5. acknowledgment of the effectiveness of the Merger from an accounting, tax and legal point of view;
6. granting of all powers to any member of the Company's board of managers and to any employee of or any lawyer

at Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting individually, with full power of substitution, to execute any documents
and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Merger; and

7. miscellaneous.
(iii) that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that the board of managers of the Company has presented to it the

Draft Terms of the Cross Border Merger, as published in the Mémorial C on December 15, 2014 under number 3881
in accordance with articles 262 (1) and 9 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law)
and providing for the Merger.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that (i) the documents that must, pursuant to articles 267 and 278 of

the Law, and which have not been waived, be deposited at the registered office of the Company or made available at its
website, i.e. a copy of the (a) Draft Terms of the Cross Border Merger, (b) annual accounts and annual reports of the
Merging Companies for the last three financial years, (c) the interim financial statements of the Merging Companies and

36851

L

U X E M B O U R G

(d) the directors' report of the Sole Shareholder have been deposited at the Company's registered office for due ins-
pection by the Sole Shareholder at least one month before the date hereof, and (ii) a certificate attesting the deposit of
said documents, duly signed by the board of managers of the Company, has been provided to the notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder further confirms that the Sole Shareholder has waived the requirements provided for under

article 265 (1) and (2) of the Law in accordance with article 265 (3) of the Law.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to carry out the Merger in accordance with the conditions detailed in the Draft Terms

of the Cross Border Merger. The Sole Shareholder acknowledges in this respect (i) the dissolution without liquidation
of the Company on the Completion Date (as defined below) and the transfer of all the assets and liabilities (including all
property, rights and powers of any description) of the Company at net book value at the Completion Date to the Sole
Shareholder in accordance with the Draft Terms of the Cross Border Merger and (ii) as a consequence of the Merger,
the cancellation, of the shares held by the Sole Shareholder in the Company.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that the Merger shall, pursuant to regulation 17(2) of the UK Regula-

tions and from a Luxembourg legal, accounting and tax standpoint, become effective at the time and date fixed by the
High Court in its order approving completion of the Merger in accordance with the scrutiny process (the Completion
Date), which Completion Date the Merging Companies intend to request the High Court to fix in the order approving
completion of the Merger by the end of March 2015.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to grant all powers to any member of the Company's board of managers and to any

employee of or any lawyer at Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting individually, with full power of substitution,
to  execute  any  documents  and  perform  any  actions  and  formalities  necessary,  appropriate,  required  or  desirable  in
connection with the Merger.

<i>Declaration

The undersigned notary declares, in accordance with the provisions of article 271 (2) of the Law, having verified and

certified  the  existence  and  the  validity  under  Luxembourg  law  of  the  legal  acts  and  formalities  incumbent  upon  the
Company including the Draft Terms of the Cross Border Merger, the legality of the Merger under Luxembourg law.

There being no further business, the Meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.

WHEREOF, this deed is drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dixième jour de mars,
par devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Cherrilux Investments S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 6, rue Eug.ne Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 167.032 et disposant d'un capital social de EUR 3.013.050 (la Société). La Société a été constituée le 19 janvier
2012 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (le Mémorial C) le 4 avril 2012, numéro 887. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Jean Seckler le 13 juin 2012, publié
au Mémorial C le 23 août 2012 numéro 2093.

A COMPARU:

GAME Digital Holdings Limited (anciennement connu sous la dénomination de Capitex Holdings Limited), une société

à responsabilité limitée (private limited liability company), régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galle, dont le siège
social est établi au Unity House, Telford Road, Basingstoke, Hampshire RG21 6YJ, Royaume-Uni, immatriculée au Registre
des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 7893832 (l'Associé Unique),

ici représenté par Peggy Simon, employée, dont l'adresse professionnelle se situe à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en

vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après signature ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, ladite procuration

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

36852

L

U X E M B O U R G

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
(i) l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans la Société;
(ii) l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. présentation et prise d'acte du projet de fusion transfrontalière prévoyant l'absorption par l'Associé Unique de la

Société (le Projet de Fusion Transfrontalière et la Fusion). L'Associé Unique et la Société sont ci-après désignés ensemble
comme les Sociétés qui Fusionnent;

2. prise d'acte que les documents requis par les articles 267 et 278 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août

1915, telle que modifiée (la Loi), sauf renonciation à ceux-ci, ont été déposés au siège social de la Société ou mis à
disposition sur son site internet pour examen par l'Associé Unique au moins un mois avant la date de la tenue de l'as-
semblée générale de l'Associé Unique pour l'approbation du Projet de Fusion Transfrontalière et de la Fusion;

3. confirmation que l'Associé Unique de la Société a renoncé aux exigences prévues par l'article 265 (1) et (2) de la

Loi conformément à l'article 265 (3) de la Loi;

4. approbation du Projet de Fusion Transfrontalière et de la réalisation de la Fusion;
5. prise d'acte de la prise d'effet de la Fusion d'un point de vue comptable, fiscal et juridique;
6. octroi de tous les pouvoirs à tout membre du conseil de gérance de la Société et à tout employé ou tout avocat de

Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour exécuter
tous les documents et accomplir toutes les actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en
relation avec la Fusion; et

7. divers.
(iii) que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte que le conseil de gérance de la Société lui a présenté le Projet de Fusion

Transfrontalière, tel que publié au Mémorial C, le 15 décembre 2014 numéro 3881 conformément aux articles 262 (1)
et 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et prévoyant la Fusion.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte que (i) les documents qui, en vertu des articles 267 et 278 de la Loi, doivent

être déposés au siège social de la Société ou mis à disposition sur son site internet, et auxquels il n'a pas été renoncé,
i.e. copie (a) du Projet de Fusion Transfrontalière, (ii) des comptes annuels et des rapports annuels des Sociétés qui
Fusionnent pour les trois derniers exercices sociaux, (iii) des états financiers intérimaires des Sociétés qui Fusionnent et
(iv) du rapport du dirigeant de l'Associé Unique ont été déposés au siège social de la Société pour examen par l'Associé
Unique au moins un moins avant la date des présentes, et (ii) un certificat attestant du dépôt desdits documents, dûment
signé par le conseil de gérance de la Société, a été fourni au notaire.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique confirme en outre que l'Associé Unique a renoncé aux exigences prévues par l'article 265 (1) et (2)

de la Loi conformément à l'article 265 (3) de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de réaliser la Fusion conformément aux conditions détaillées dans le Projet de Fusion Trans-

frontalière. L'Associé Unique prend acte à cet effet (i) de la dissolution sans liquidation de la Société à la Date de Réalisation
(telle que définie ci-dessous) et du transfert de tous les actifs et passifs de la Société à la valeur comptable (y compris
tous les biens, droits et pouvoirs de toute sorte) à la Date de Réalisation à l'Associé Unique conformément au Projet de
Fusion Transfrontalière et (ii) de l'annulation, en conséquence de la Fusion, des parts sociales détenues par l'Associé
Unique dans la Société.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte que la Fusion, en vertu du règlement 17(2) de la réglementation britannique

(UK Regulations) et d'un point de vue juridique, comptable et fiscal luxembourgeois, prend effet au moment et à la date
fixés dans l'ordonnance de la Haute Cour approuvant la réalisation de la Fusion conformément au processus d'examen
(la Date de Réalisation), laquelle Date de Réalisation les Sociétés qui Fusionnent ont l'intention de demander à la Haute
Cour de faire figurer dans l'ordonnance approuvant la Fusion avant la fin mars 2015.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide d'accorder tous les pouvoirs à tout membre du conseil de gérance de la Société et à tout

employé ou avocat de Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de sub-
stitution,  pour  exécuter  tous  les  documents  et  accomplir  toutes  les  actions  et  formalités  nécessaires,  appropriées,
requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

36853

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, avoir vérifié et certifié

l'existence et la validité, en vertu du droit luxembourgeois, des actes juridiques et des formalités incombant à la Société,
y compris le Projet de Fusion Transfrontalière, la conformité de la Fusion en vertu du droit luxembourgeois.

Aucun point ne restant à traiter, l'Assemblée est ajournée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences, le texte anglais prévaut.

EN FOI DE QUOI, le présent acte est passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des

présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 mars 2015. Relation: GAC/2015/2008. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015041462/181.
(150047961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Secure Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 180.439.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of February.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

Allen &amp; Overy, société en commandite simple, société d’avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, acting

as the representative of the board of directors of Secure Industries SA (the Board) pursuant to the resolutions of the
Board dated 23 February 2015 (the Resolutions),

Allen &amp; Overy, société en commandite simple, itself represented by Maître Serge ZEIEN, avocat à la Cour residing

professionally in Luxembourg-City, by virtue of a power of attorney given under private seal on 26 January 2015 by Maître
Henri WAGNER, avocat à la Cour, acting on behalf of Allen &amp; Overy GP, société coopérative organisée comme société
anonyme, société d’avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, itself acting in its capacity as general partner
(associé commandité) of Allen &amp; Overy, société en commandite simple.

An excerpt of the minutes of the Resolutions and the above-mentioned power of attorney signed ne varietur by the

appearing person and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The appearing person has requested the undersigned notary to record the following statements:
1. Secure Industries SA (the Company) has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 13

September 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2470 of 5 October 2013.
The articles of association of the Company (the Articles) have been modified for the last time by a deed of the undersigned
notary on 8 January 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Pursuant to article 5 of the Articles, the authorised share capital of the Company is set at EUR 700,000,000 (seven

hundred million euro) represented by a maximum of 100,000 (one hundred thousand) A Shares, and a maximum of
600,000 (six hundred thousand) B Shares, each having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro).

3. Pursuant to the Resolutions and in accordance with the Articles, the Board has resolved (i) to increase the share

capital of the Company by EUR 1,292,000 (one million two hundred ninety-two thousand euro) in order to raise it from
its current amount of EUR 352,305,000 (three hundred fifty-two million three hundred five thousand euro) to EUR
353,597,000 (three hundred fifty-three million five hundred ninety-seven thousand euro); and (ii) to cancel the preferential
subscription right of the existing shareholder(s) of the Company.

4. The share capital increase of the Company has been subscribed and paid up as follows:
Guardian Segur S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9B, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under num-
ber B 168.659, qualifying as a securitisation vehicle (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg act
dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended, acting in respect of its compartment called "Compartment

36854

L

U X E M B O U R G

1", has subscribed to 1,292 (one thousand two hundred ninety-two) A Shares which have been fully paid up by way of a
cash payment in an aggregate amount of EUR 1,535,848.78 (one million five hundred thirty-five thousand eight hundred
forty-eight euro and seventy-eight cent) (the Cash Payment).

The Cash Payment has been allocated as follows:
(i) the amount of EUR 1,292,000 (one million two hundred ninety-two thousand euro) has been allocated to the nominal

share capital of the Company; and

(ii) the amount of EUR 243,848.78 (two hundred forty-three thousand eight hundred forty-eight euro and seventy-

eight cent) has been allocated to the share premium account of the Company.

The aggregate amount of EUR 1,535,848.78 (one million five hundred thirty-five thousand eight hundred forty-eight

euro and seventy-eight cent) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary, and the notary expressly bears witness to it.

5. As a consequence of the above share capital increase the first paragraph of article 5 of the Articles shall read from

now on as follows:

"The share capital is set at EUR 353,597,000 (three hundred fifty-three million five hundred ninety-seven thousand

euro) represented by 53,597 (fifty-three thousand five hundred ninety-seven) class A shares (the A Shares) and 300,000
(three hundred thousand) class B shares (the B Shares), having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro) each,
which are fully paid up (the A Shares and the B Shares are collectively referred to as the shares)."

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of deviations between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, the said appearing person signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

Allen &amp; Overy, société en commandite simple, société d’avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, agissant

en tant que représentant du conseil d'administration de Secure Industries SA (le Conseil d'Administration) conformément
aux résolutions du Conseil d'Administration en date du 23 février 2015 (les Résolutions), Allen &amp; Overy, société en
commandite simple, elle-même représentée par Maître Serge ZEIEN, avocat à la Cour, de résidence professionnelle à
Luxembourg-Ville, en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 26 janvier 2015 conférée par Maître Henri
WAGNER, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Allen &amp; Overy GP, société coopérative organisée comme société
anonyme, société d’avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, cette dernière agissant en tant qu’associé
commandité de Allen &amp; Overy, société en commandite simple.

Un extrait du procès-verbal des Résolutions et la procuration sous seing privé susmentionnée signés ne varietur par

le comparant et le notaire resteront annexés au présent acte et seront présentés au même moment aux autorités de
l’enregistrement.

Le comparant, agissant en la qualité susmentionnée, prie le notaire d'acter ce qui suit:
1. Secure Industries SA (la Société) a été constituée le 13 septembre 2013 par un acte du notaire soussigné, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2470 du 5 octobre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné du 8 janvier 2015, modifications non publiées au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à ce jour.

2. En application de l’article 5 des Statuts le capital autorisé de la Société est établi à EUR700.000.000 (sept cent millions

d’euros) représenté par un maximum de 100.000 (cent mille) Actions A, et un maximum de 600.000 (six cent mille)
Actions B, chacune ayant une valeur nominale de EUR1.000 (mille euros).

3. Suite aux Résolutions et en conformité avec les Statuts, le Conseil d'Administration a décidé (i) d’augmenter le

capital social de la Société de EUR 1.292.000 (un million deux cent quatre-vingt-douze mille euros) de sorte à ce qu’il soit
augmenté de sa valeur actuelle de EUR 352.305.000 (trois cent cinquante-deux millions trois cent cinq mille euros) à EUR
353.597.000 (trois cent cinquante-trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille euros); et (ii) de supprimer les droits
préférentiels de souscription des actionnaires existants de la Société.

4. L'augmentation du capital social de la Société est souscrite et payée comme suit:
Guardian Segur S.A., une société anonyme constituée et existant d’après les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son adresse au 9B, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 168.659, qualifiée de société de titrisation au sens de la loi luxembourgeoise du
22 Mars 2004 sur la titrisation, telle que modifiée, agissant pour le compte de son compartiment appelé "Compartiment
1", a souscrit à 1.292 (mille deux cent quatre-vingt-douze) Actions A, entièrement libérées par voie de paiement en

36855

L

U X E M B O U R G

espèces du montant de EUR 1.535.848,78 (un million cinq cent trente-cinq mille huit cent quarante-huit euros et soixante-
dix-huit centimes) (le Paiement en Espèces).

Le Paiement en Espèces a été alloué comme suit:
(i) le montant de EUR 1.292.000 (un million deux cent quatre-vingt-douze mille euros) a été alloué au capital social

souscrit de la Société; et

(ii) le montant de EUR 243.848,78 (deux cent quarante-trois mille huit cent quarante-huit euros et soixante-dix-huit

centimes) a été alloué au compte de la prime d’émission de la Société.

Le montant de EUR 1.535.848,78 (un million cinq cent trente-cinq mille huit cent quarante-huit euros et soixante-dix-

huit  centimes)  est  à  la  disposition  de  la  Société,  ainsi  qu’il  a  été  prouvé  au  notaire  instrumentant  qui  le  constate
expressément.

5. En conséquence de l’augmentation du capital social, le premier paragraphe de l’article 5 des Statuts est modifié

comme suit:

"Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 353.597.000 (trois cent cinquante-trois millions cinq cent quatre-

vingt-dix-sept  mille  euros)  représenté  par  53.597  (cinquante-trois  mille  cinq  cent  quatre-vingt-dix-sept)  actions  de
catégorie A (les Actions A) et 300.000 (trois cent mille) actions de catégorie B (les Actions B), ayant une valeur nominale
de EUR1.000 (mille euros) chacune, entièrement souscrites (les Actions A et les Actions B sont collectivement dénom-
mées les actions)."

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d'une version française. A la requête du même comparant, et en cas de divergences entre les versions
anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire l’original du présent acte.
Signé: Zeien, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 05 mars 2015. Relation: DAC/2015/3810. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 13 mars 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015041933/125.
(150047383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Granny's S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 38, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 194.479.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le six février.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Annick WEIMERSKIRCH, esthéticienne, née le 18 décembre 1982 à Luxembourg, demeurant à L-1655

Luxembourg, 7, am Grendchen,

2.- Madame Jill WEBER, restauratrice, née le 20 mars 1981 à Luxembourg, demeurant à L-4982 Reckange-sur-Mess,

23, rue Kleesenberg.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'elles constituent entre elles:

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de «GRANNY'S S.à r.l.».

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un établissement avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques,

ainsi que de petite restauration.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

36856

L

U X E M B O U R G

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Differdange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

36857

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales comme

suit:

- Madame Annick WEIMERSKIRCH, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

- Madame Jill WEBER, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-4530 Differdange, 38, avenue Charlotte.
2.- L'assemblée désigne comme gérantes de la société pour une durée indéterminée:
- Madame Annick WEIMERSKIRCH, esthéticienne, née le 18 décembre 1982 à Luxembourg, demeurant à L-1655

Luxembourg, 7, am Grendchen,

- Madame Jill WEBER, restauratrice, née le 20 mars 1981 à Luxembourg, demeurant à L-4982 Reckange-sur-Mess, 23,

rue Kleesenberg.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérantes.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Annick WEIMERSKIRCH, Jill WEBER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 février 2015. Relation GAC/2015/1103. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015025057/111.
(150029007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Granny's S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 38, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 194.479.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés

Il résulte d'une réunion en date du 11 février 2015, des associés de la société à responsabilité limitée «GRANNY'S S.à

r.l.», avec siège social à L-4530 Differdange, 38, avenue Charlotte, en cours d'immatriculation auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg:

1) - que Madame Annick WEIMERSKIRCH, esthéticienne, née le 18 décembre 1982 à Luxembourg, demeurant à L-1655

Luxembourg, 7, am Grendchen, est nommée à la fonction de gérante administrative pour une durée indéterminée, et

- que Madame Jill WEBER, restauratrice, née le 20 mars 1981 à Luxembourg, demeurant à L-4982 Reckange-sur-Mess,

23, rue Kleesenberg, est nommée à la fonction de gérante technique pour une durée indéterminée,

2) que le pouvoir de signature suivant est adopté:

36858

L

U X E M B O U R G

La société est engagée en toutes circonstances par la signature d'une gérante jusqu 'à concurrence de mille deux cent

cinquante euros (1.250,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe de la gérante
technique et de la gérante administrative est nécessaire.

Differdange, le 11 février 2015.

Annick WEIMERSKIRCH / Jill WEBER.

Référence de publication: 2015025058/20.
(150029007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Jarcam Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 72.678.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2015026004/12.
(150029708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Subsea 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 43.172.

You are hereby convened to the

ANNUAL GENERAL MEETING (the "AGM") AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (THE "EGM")

of Shareholders of Subsea 7 S.A. (the "Company"), RCS Luxembourg N° B 43172, having its registered office at 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg, both held at its registered office on <i>17 April, 2015 , the AGM to be held at 15:00 pm
(local time), and the EGM to be held immediately thereafter.

<i>Agenda for the AGM of Subsea 7 S.A:

1. To approve the convening of the AGM of the Company on 17 April 2015, by deviation from the date set forth in

Article 24 of the Company's Articles of Incorporation.

2. To consider (i) the management reports of the Board of Directors of the Company in respect of the statutory and

consolidated financial statements of the Company and (ii) the reports of Ernst &amp; Young S.A., Luxembourg, author-
ised statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") on the statutory financial statements and the consolidated
financial statements of the Company, for the fiscal year ended December 31, 2014, as published on 11 March, 2015
and as are available on the Company's website at www.subsea7.com.

3. To approve the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2014, as

published on 11 March, 2015 and as are available on the Company's website at www.subsea7.com.

4. To approve the consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2014, as

published on 11 March, 2015 and as are available on the Company's website at www.subsea7.com.

5. To approve the allocation of results of the Company, without the payment of a dividend, for the fiscal year ended

December 31, 2014, as recommended by the Board of Directors of the Company.

6. To discharge the Directors of the Company in respect of the proper performance of their duties for the fiscal year

ended December 31, 2014.

7. To elect Ernst &amp; Young S.A., Luxembourg, as authorised statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") to audit

the statutory and consolidated financial statements of the Company, for a term to expire at the next Annual General
Meeting of Shareholders.

8. To re-elect Mr Dod Fraser as an Independent Director of the Company to hold office until the Annual General

Meeting of Shareholders to be held in 2017 or until his successor has been duly elected.

9. To re-elect Mr Allen Stevens as an Independent Director of the Company to hold office until the Annual General

Meeting of Shareholders to be held in 2017 or until his successor has been duly elected.

10. To re-elect Mr Robert Long as an Independent Director of the Company to hold office until the Annual General

Meeting of Shareholders to be held in 2017 or until his successor has been duly elected.

<i>Agenda for the EGM of Subsea 7 S.A:

1. Renewal of authorisation for a period of three years to the Board of Directors to issue new shares to include

authority for the Board of Directors to limit or suppress preferential subscription rights, for up to 10% of the issued
share capital.

36859

L

U X E M B O U R G

Renewal and extension of the authorised share capital (including the issued share capital) of the Company to nine
hundred  million  United  States  Dollars  (U.S.$900,000,000)  represented  by  four  hundred  and  fifty  million
(450,000,000) Common Shares, par value two United States Dollars (U.S.$ 2.00) per share, authorisation to the
Board of Directors (i) to issue Common Shares (or any securities or rights giving rights to Common Shares) within
the authorised unissued share capital against contributions in cash, in kind or by way of incorporation of available
premium or reserves or in lieu of dividends or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the
Board of Directors or its delegate(s), and (ii) with the right to waive, suppress or limit any preferential subscription
rights of existing shareholders within the limit of the authorised unissued share capital for a maximum of 33,216,706
Common Shares (representing 10% of the issued capital as at 28 February 2015), during a period of three (3) years
starting on the day of the Extraordinary General Meeting of Shareholders approving the present authorisation and
ending on the third (3) anniversary of the day of publication of the deed recording the minutes of the said general
meeting in the Mémorial C; and Amendment of article 5 of the Articles of Association of the Company to reflect
such resolution.

***********************

The AGM shall validly deliberate on its agenda without any quorum requirement. The resolutions at the AGM shall

be adopted by a simple majority of the votes validly cast.

The EGM shall validly deliberate on its agenda provided a quorum of half of the issued share capital of the Company

is represented. If the quorum is not reached at the first extraordinary general meeting for the purpose of resolving on
the agenda thereof, a second extraordinary general meeting of shareholders may be convened with the same agenda at
which no quorum requirement shall apply. The resolutions concerning the agenda of the EGM shall be adopted by a
majority of two-thirds of the votes validly cast.

The full text of the proposed amended Articles of Incorporation, the report of the Board with respect to the requested

authorisation to waive, limit and suppress the preferential subscription rights of existing shareholders, and other material
relating to the AGM and EGM is available online at: www.subsea7.com and can also be obtained from the Company
Secretary, Subsea 7 S.A., 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg.

17 March 2015
Mr. Kristian Siem
Chairman

To assure their representation at the Annual General Meeting, as well as the Extraordinary General Meeting, share-

holders are hereby requested to fill in, sign, date and return the Proxy Card(s) in the return envelope provided for such
purpose to the address indicated therein. The deadline for submission of votes for American Depositary Receipt holders
is 8 April 2015 and for holders of Common Shares is 10 April 2015.

The giving of such Proxy will not affect the right of the shareholders to revoke such Proxy or vote in person should

they later decide to attend the meeting.

Référence de publication: 2015043296/795/74.

DB Platinum II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 99.199.

Shareholders of DB Platinum II the "Company"), are hereby invited to participate in the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "AGM"), which will be held on <i>16 April 2015 at 11:00 a.m. (Luxembourg time)

at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member

individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for
the fiscal year ended 31 January 2015;

2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2015;
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2015 and ratification of the distribution of dividends,

if any, in respect of the shares of distributing share classes of the sub-funds of the Company where shares of such
distributing share classes have been issued;

4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year

ended 31 January 2015;

5. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Alexander McKenna and Freddy Brausch as Directors

of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual
accounts for the fiscal year ending on 31 January 2016;

36860

L

U X E M B O U R G

6. Election of Ben O'Bryan and Philippe Ah-Sun as Directors of the Company, subject to the approval of the Com-

mission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg, until the next annual general meeting of shareholders
of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending 31 January 2016.

7. Re-election of Ernst &amp; Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company

until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for
the fiscal year ending on 31 January 2016;

8. Miscellaneous.
Voting Arrangements for the AGM
A shareholder may act at the AGM by person or by proxy.
Shareholders who wish to participate in person at the AGM, are kindly asked to inform RBC Investor Services Bank

S.A. hereof, no later than 13 April 2015, 5:00 p.m. (Luxembourg time).

Shareholders who are not able to participate personally in the AGM, are permitted to have themselves represented.

A proxy form for the AGM may be obtained at the registered office of the Company or from the Company's website
www.funds.db.com  and  has  to  be  returned,  completed  and  duly  signed,  to  RBC  Investor  Services  Bank  S.A.,  to  the
attention of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 13 April 2015, 5:00 p.m. (Luxembourg time) at the
latest.

Shareholders who are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, should note

that:

- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward trans-

mission to the Company by 13 April 2015; and

- if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on the shareholders behalf, it may

not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained
in the prospectus of the Company).

Specific Rules of Voting at the AGM
The shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the AGM and that the

resolutions will be taken at the majority vote of the shareholders present or represented at the AGM and voting. Each
share is entitled to one vote.

Audited Annual Report
The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company

(including the audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2015
will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website www.funds.db.com as
of 31 March 2015.

Further information can be obtained from RBC Investor Services Bank S.A., acting in its capacity as Registrar and

Transfer Agent (tel.: +352 2605 9815, fax: +352 2460 9500, attn. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com) or from
the local representative of the Company or from the relevant financial intermediary through whom the shares of the
Company have been purchased.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015043298/755/61.

Allianz European Pension Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 117.986.

Notice is hereby given that the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of Allianz European Pension Investments ("the Company") will be held at the registered office of the

Company at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at 14.30 on  <i>9 April 2015 for the purpose of
considering and voting upon the following matters on the amendment of the Articles of Incorporation of the Company
dated 21 July 2007 with effect from 29 May 2015:

<i>Agenda:

1. Investment policies and restrictions

The mechanism of calculating the net assets of the Company in the case of one Subfund of the Company investing
into another Subfund of the Company shall be added in order to describe more precisely and fully reflect the
applicable legal requirements. Article 18.1.b of the Articles of Incorporation shall be amended accordingly.

2. Risk diversification

The list of parties which issue securities / instruments that Subfunds of the Company may invest up to 100 % of
their assets into (for the purpose of risk diversification and under the condition that such securities / instruments

36861

L

U X E M B O U R G

are in at least six different issues and of one and the same issue not to exceed 30% of a Subfund's net assets) shall
be extended to cover Hong Kong, Brazil, India, Indonesia, Russia, South Africa, Singapore or any other non-EU
member states subject to the approval of the CSSF and disclosure within the Prospectus of the Company. Article
18.3.f of the Articles of Incorporation shall be amended accordingly.

3. Conversion into feeder funds

The Board of Directors of the Company shall be granted the right to turn Subfunds of the Company into or create
Subfunds of the Company as feeder funds. Article 18.3.g of the Articles of Incorporation shall be amended accord-
ingly in order to reflect the requirements of Article 77 of the Law of 17 December 2010 on Undertakings for
Collective Investment which provide the regulatory provisions of feeder funds (e.g. minimum investment limit (85%)
of a feeder fund in a master fund; a feeder fund may hold up to 15% of its assets in other assets such as ancillary
liquid assets.)

4. Closures of Subfunds and share classes of the Company

The powers and processes of liquidating Subfunds of the Company or liquidating share classes of such Subfunds
shall be defined more precisely under Article 24.1 and Article 24.2. Article 24.1 empowers the Board of Directors
and Article 24.2 empowers the general meeting of shareholders to force redemption of all shares in any share class
or any sub-fund and the wordings in these two clauses are amended in order to describe this more precisely. In
addition, it has been clarified in Article 24.1 of the Articles of Incorporation that the Board of Directors may liquidate
a Subfund or share class if the assets of a Subfund or share class fall below the amount that the Board of Directors
considers to be the minimum amount for economically efficient management of the Subfund or share class. The
circumstances stated in Article 24.1 apply to sub-funds as well as share classes.

5. Mergers of Subfunds and share classes of the Company

The powers, notification timeline and processes of merging of one or all share classes issued in a Subfund (1) with
another Subfund of the Company, (2) with another share class of the same Subfund of the Company, (3)with another
UCITS , or (4) with another Subfund or share class of such UCITS shall be amended. Article 24.5 and 24.6 of the
Articles of Incorporation shall be amended accordingly.
In case the merger of a Subfund would lead to the liquidation of the Company, the respective stipulations of Article
28 of the Articles shall be amended accordingly.

6. Caisse de Consignation

For clarification purposes Article 24.3 of the Articles of Incorporation is updated by referring to the Luxembourg
regulation for the handling of the unclaimed proceeds (where will it be deposited and when will be forfeited).

7. Articles language

Choice  of  English  as  the  official  language  of  the  Articles  of  Association  as  authorised  by  Article  26  (2)  of  the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment.

8. Changes of housekeeping nature

Definitions and usage of terms as well as the spelling of key terminology shall be amended so as to be more concise
and to be in line with the definitions and spelling rules applied in the Prospectus of the Company. All Articles of
the Company (if applicable) shall be amended accordingly.
The text of the proposed amendments to the Articles of Incorporation is accessible or available free of charge for
the Shareholders at the registered office of the Company.
The effective date of the revised Articles of Incorporation would be 29 May 2015 if resolutions are passed at the
Extraordinary General Meeting.

Voting :
Resolutions on the Agenda may be passed by at least two thirds of the votes cast thereon at the Meeting whereby to

have a quorum at least one half of the capital must be represented.

The quorum and majority requirements will be determined in accordance to the outstanding shares on 4 April 2015

midnight CEST (the "Record Date"). The voting rights of Shareholders shall be determined by the number of shares held
at the Record Date.

Should the quorum not be met at this Meeting, a second extraordinary general meeting will be reconvened which may

pass resolutions on the same Agenda without a quorum by at least two thirds of the votes cast thereon at that Meeting.

Voting Arrangements:
Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their

depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder as per the Record Date, to the
Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Lux-
embourg to arrive in Luxembourg by no later than 11:00 CET on 7 April 2015.

Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her

behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/
her attorney or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer,
and sent to the Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-
sur-Alzette, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by no later than 11:00 CET on 7 April 2015.

36862

L

U X E M B O U R G

Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the Transfer Agent RBC Investor Services Bank

S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. A person appointed a proxy need
not be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending the
meeting.

Senningerberg, March 2015

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015043302/755/84.

DB Platinum IV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 85.828.

Shareholders of DB Platinum IV (the "Company"), are hereby invited to participate in the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "AGM"), which will be held on <i>16 April 2015 at 11:00 a.m. (Luxembourg time)

at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member

individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for
the fiscal year ended 31 January 2015;

2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2015;
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2015 and ratification of the distribution of dividends,

if any, in respect of the shares of distributing share classes of the sub-funds of the Company where shares of such
distributing share classes have been issued;

4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year

ended 31 January 2015;

5. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Alexander McKenna and Freddy Brausch as Directors

of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual
accounts for the fiscal year ending on 31 January 2016;

6. Election of Ben O'Bryan and Philippe Ah-Sun as Directors of the Company, subject to the approval of the Com-

mission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg, until the next annual general meeting of shareholders
of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending 31 January 2016.

7. Re-election of Ernst &amp; Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company

until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for
the fiscal year ending on 31 January 2016;

8. Miscellaneous.
Voting Arrangements for the AGM
A shareholder may act at the AGM by person or by proxy.
Shareholders who wish to participate in person at the AGM, are kindly asked to inform RBC Investor Services Bank

S.A. hereof, no later than 13 April 2015, 5:00 p.m. (Luxembourg time).

Shareholders who are not able to participate personally in the AGM, are permitted to have themselves represented.

A proxy form for the AGM may be obtained at the registered office of the Company or from the Company's website
www.funds.db.com  and  has  to  be  returned,  completed  and  duly  signed,  to  RBC  Investor  Services  Bank  S.A.,  to  the
attention of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 13 April 2015, 5:00 p.m. (Luxembourg time) at the
latest.

Shareholders who are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, should note

that:

- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward trans-

mission to the Company by 13 April 2015; and

- if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on the shareholders behalf, it may

not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained
in the prospectus of the Company).

Specific Rules of Voting at the AGM
The shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the AGM and that the

resolutions will be taken at the majority vote of the shareholders present or represented at the AGM and voting. Each
share is entitled to one vote.

36863

L

U X E M B O U R G

Audited Annual Report
The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company

(including the audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2015
will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website www.funds.db.com as
of 31 March 2015.

Further information can be obtained from RBC Investor Services Bank S.A., acting in its capacity as Registrar and

Transfer Agent (tel.: +352 2605 9815, fax: +352 2460 9500, attn. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com) or from
the local representative of the Company or from the relevant financial intermediary through whom the shares of the
Company have been purchased.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015043301/755/61.

I.C.C.Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 93.292.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2015

Les associés présents et représentant comme seuls associés l'intégralité du capital social, ont décidé de se réunir en

Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la susdite société à laquelle, ils se considèrent comme dûment con-
voqués et d'un commun accord, ils ont pris la décision suivante:

Nomination à partir du 16 janvier 2015 comme cogérante supplémentaire , la société de droit Belge dénommée: S.A.

Rudy H Finold (en abrégé KHI) Chaussée de Ninove 534 à B-1070 BRUXELLES,

Représentée par son administrateur délégué, Monsieur Claude DEHENAIN, pour une durée de six ans.
La société sera dorénavant valablement engagée par la signature conjointe de la société de droit Belge S.A. Rudy H

Finold (en abrégé RHF) Chaussée de Ninove 534 à B- 1070 Bruxelles, soit avec Monsieur Jean Kies, né le 23.04.1934 ou
soit avec Madame Françoise Galerne, née le 04.12.1939.

Ainsi arrêté et convenu de commun accord le 16 janvier 2015 au siège sociale de la Société.

<i>Pour la société de droit Belge S.A. Rudy H Finold (en abrégé RHF) / - / -
Claude DEHENAIN / Monsieur Jean Kies / Madame Françoise Galerne
<i>L'administrateur délégué / - / -

Référence de publication: 2015025962/21.
(150029516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Patron Reform C.E. Servicing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: PLN 59.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 100.714.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société du 31 décembre 2014

Les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.
- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant

professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet immédiat pour
une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Martin Drázský, gérant, résidant professionnellement Betlémské námestí, 110 00 Prague 1, République Tchèque.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2015026167/20.
(150029339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

36864


Document Outline

Allianz European Pension Investments

alpha3

Amadeus Holding S.A.

Argenta Fund

ASSETS Generation Fund UI

Baumann and Partners - Premium Select

BNP Paribas L1

Carlesian &amp; Matandrea S.A.

CBK Sicav

Cherrilux Investments S.à r.l.

Christali S.A.

Darter Holdings II S.à.r.l.

DB Platinum II

DB Platinum IV

De Kéisplateau S.à r.l.

EPIC I GP, S.à rl.

Fisabelle S.A.

Fondation Thierry Van Werveke

Généralpart

Granny's S.à.r.l.

Granny's S.à.r.l.

I.C.C.Luxembourg S.à r.l.

Imprimerie Centrale

Interfund Sicav

International Food Retail Capital S.A.

Investissements Mobiliers Européens et Internationaux S.A.

Jarcam Soparfi S.A.

Kalinde S.A.

Kibu S.A.

Managed Funds Portfolio

Nikkei Invest Corporation S.A., SPF

PAM L

Patron Reform C.E. Servicing S.à r.l.

Peacock European Alpha Builder UI

Petercam Capital

Pusan S.A. SPF

Secundus Aktien Fonds

Secure Industries S.A.

Secure Industries S.A.

S.I.P. Investments S.A.

Solroc S.A.

Staminvest S.A.

Subsea 7 S.A.

Tareno Funds

Tovic S.A.

UBS ETF

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Wenkelhiel

WestGlobal

Zoetheo S.A.