This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 754
19 mars 2015
SOMMAIRE
Aberdeen Indirect Property Partners Acti-
ve Soparfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36192
Bezons Parc (Lux) S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
36192
Biergerinitiative Liewensqualitéit Gemeng
Stengefort a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36190
BlackRock Asia Property Fund IV Feeder
S.A. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36167
Cage Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36155
EUR-ASIA Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36146
European News Exchange S.A. . . . . . . . . . .
36146
F&B International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36146
F.E. Luxfinco Services . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36146
Luxadeck S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36147
Luxcellence Management Company S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36189
Lux Mas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36147
Macka S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36152
Magical S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36153
Major Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36153
Malaka International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36153
Malderen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36152
Mallen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36151
Mamola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36152
Mantera S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36152
Maptaq Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36178
Mare Giallo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36146
MARENS Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . .
36147
M.A.R. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36154
MDI A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36149
Meadows Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36148
Meadows Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36149
MEDITERRANEAN REGIONAL TRANS-
PORT COMPANY S.A., société de ges-
tion de patrimoine familial . . . . . . . . . . . . .
36147
Mellow S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36149
Merles S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36148
Metro Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36148
MGE Vernon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36181
M&G Real Estate (Luxembourg) S.A. . . . .
36154
Millepore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36148
Mine Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36149
MMS Transports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36150
Moineau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36150
Monier Holdings GP S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36154
MONTAIGNE Long Now Funding S.A. . . .
36151
MONTAIGNE Long Now Funding S.A. . . .
36150
Moog International Financial Services Cen-
ter S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36153
Next Estate Income Fund II S.à r.l. . . . . . .
36151
Nieuw Amsterdam Receivables Corpora-
tion S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36151
Nobeltex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36150
Orion Engineered Carbons S.A. . . . . . . . . .
36187
Parlux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36184
Seris Security S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36184
Seris Security S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36184
Titex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36151
36145
L
U X E M B O U R G
F.E. Luxfinco Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 179.753.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015024979/11.
(150028783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
F&B International S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare.
R.C.S. Luxembourg B 82.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024984/10.
(150028617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
European News Exchange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 46.116.
EXTRAIT
Le Conseil d'administration prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Jérôme Bureau avec
effet au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024977/11.
(150028188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
EUR-ASIA Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 146.240.
EASIT SA, Expert-comptable OEC, RC Luxembourg n°B107817, 60 Grand-rue L-1660 Luxembourg est désigné comme
dépositaire des titres au porteur de la société.
Référence de publication: 2015024971/9.
(150028060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Mare Giallo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 164.737.
Le bilan rectificatif en remplacement du bilan arrêté au 31/12/2013, déposé le 16 janvier 2015 sous la référence
L150009984 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015025239/13.
(150028286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36146
L
U X E M B O U R G
Luxadeck S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 185.148.
<i>Extrait de l'AGE du 20.01.2015i>
A l'unanimité et par vote spécial, l'Assemblée décide de révoquer l'administrateur Monsieur Thierry Tordeurs né à
Balen (Belgique) le 14 février 1965 demeurant au 80 Grand-rue à L-9711 Clervaux.
M. Denis Charlier
<i>Le Présidenti>
Référence de publication: 2015025224/12.
(150028604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Lux Mas SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 26, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 185.806.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinairei>
S'est réunie le 2 janvier 2015
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la résolution suivante:
- transfert du siège de la société du 4 chemin des douaniers L-9647 Doncols au 26 route de Bastogne L-9638 Pom-
merloch avec effet immédiat
Signature.
Référence de publication: 2015025222/13.
(150028493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
MARENS Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 117.453.
EXTRAIT
Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 12 février 2015 que la société FIDUCENTER
S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2015025264/13.
(150029084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
MEDITERRANEAN REGIONAL TRANSPORT COMPANY S.A., société de gestion de patrimoine fami-
lial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 36.284.
Par décision de l'assemblée générale annuelle du 15 janvier 2015, le siège social a été transféré du 180, rue des Au-
bépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, avec effet immédiat. En outre, le siège social
du commissaire aux Comptes Audit Trust S.A. a également été transféré du 243, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Luxembourg, le 10.02.2015.
<i>Pour: MEDITERRANEAN REGIONAL TRANSPORT COMPANY S.A., société de gestion de patrimoine familial
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015025276/16.
(150028607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36147
L
U X E M B O U R G
Merles S.C.I., Société Civile.
Siège social: L-3631 Kayl, 63, rue de Dudelange.
R.C.S. Luxembourg E 2.742.
An enger assemblée hunn mer decideiert den Artikel 4 am Memorial folgendermossen ze aenneren:
MERLES SCI
Numéro d'immatriculation: E2742
Forme juridique: Societé civile
Art. 4. Le siège de la société est établi à Kayl. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché par
simple décision des gérants.
Le 11/02/2015.
GILLE A.
Référence de publication: 2015025278/14.
(150028513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Millepore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 83.730.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions adoptées par le Conseil d'Administration en date du 31 janvier 2015 que ce dernier a décidé
de désigner Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, demeurant professionnellement à 12, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg, en tant que dépositaire agréé des certificats représentatifs d'actions au porteur émis par la Société,
par application des dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur
portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée
du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015025280/17.
(150029126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Metro Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 55.383.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015i>
«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société Metro
Investments SA la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140
Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025279/12.
(150028941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Meadows Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 132.616.
Je soussigné, Giovanni VITTORE, ai décidé de démissionner de mes fonctions de Président du Conseil d'Administration
et d'Administrateur de votre société Meadows Properties S.A. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 132 616 avec effet immédiat.
Le 16 janvier 2015.
Giovanni VITTORE.
Référence de publication: 2015025274/11.
(150029003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36148
L
U X E M B O U R G
Mellow S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 74.411.
EXTRAIT
Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 février 2015 que la société FIDUCENTER
S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2015025277/13.
(150028260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Meadows Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 132.616.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 15 janvier 2015:i>
«L'assemblée prend acte de la démission de M. Giovanni VITTORE des fonctions de président du Conseil d'Adminis-
tration et d'administrateur. L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur et de président du Conseil
d'Administration, Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né le 27 mars 1973, demeurant professionnellement
au 4547, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée Générale
qui se tiendra en 2017».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MEADOWS PROPERTIES S.A.
Référence de publication: 2015025275/15.
(150029250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Mine Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 76.332.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 janvier 2015i>
Il résulte de ce Conseil d'administration:
Conformément à l'article 42 des Lois Coordonnées sur les Sociétés commerciales du 10 août 1915 tel que modifié
par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration décide,
à l'unanimité, de nommer comme dépositaire des actions au porteur, la société «Fiduciaire Internationale SA», ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
34813 et représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Stéphan MOREAUX.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015025281/15.
(150029110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
MDI A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 172.885.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MDI A.G.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015025273/11.
(150028179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36149
L
U X E M B O U R G
Moineau, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 179.008.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 décembre 2014 à Luxembourgi>
Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET
INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015025285/12.
(150028119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
MMS Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7793 Bissen, 25, rue Jean Engel.
R.C.S. Luxembourg B 163.290.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025284/9.
(150028848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
MONTAIGNE Long Now Funding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 163.558.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société MONTAIGNE Long Now Funding S.A. (la
«Société») datée du 4 novembre 2014, ce qui suit:
- La ré-nomination de la société AMG G.m.b.H., Allgemeine Management Gesellschaft G.m.b.H., inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.145.584 en tant que commissaire aux comptes de la
Société avec effet immédiat et se terminant lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant les
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015025287/17.
(150029232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Nobeltex, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 187.204.
EXTRAIT
Il est à noter que les associés et gérantes de la Société Mesdames Laila Mohammed Hussein EL GAMMAL et Nayla
Salah El Din EL TAWIL résident désormais au 15, rue de la Forêt, L-3354 Leudelange.
En outre, en date du 1
er
janvier 2015, Madame Laila Mohammed Hussein EL GAMMAL, associée de la Société a cédé
5.000 parts sociales de la Société à Madame Nayla Salah El Din EL TAWIL, associée de la Société.
En conséquence, Madame Laila Mohammed Hussein EL GAMMAL détient 1.250 parts sociales de la Société et Madame
Nayla Salah El Din EL TAWIL détient 11.250 parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025296/16.
(150028279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36150
L
U X E M B O U R G
Next Estate Income Fund II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 187.624.
Il résulte des résolutions circulaires de l'associé unique de la Société en date du 19 décembre 2014 que les décisions
suivantes ont été prises:
- de prendre note de la démission de Monsieur Sven Rein aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 31
décembre 2014.
- de nommer aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier 2015, et ceci pour une durée indéterminée:
* Madame Elena Toshkova, née le 23 décembre 1976 à Razlog (Bulgarie), demeurant professionnellement au 44, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
* Monsieur Abed Khaldi, né le 29 août 1977 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 44, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Next Estate Income Fund II S. à r.l.
i>BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. en abrégé «BNPP REIM Lux S.A.»
Référence de publication: 2015025294/22.
(150028866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Nieuw Amsterdam Receivables Corporation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 193.213.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 2552 du 28 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015025295/12.
(150028342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
MONTAIGNE Long Now Funding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 163.558.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015025286/10.
(150028612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Mallen S.A., Société Anonyme,
(anc. Titex S.A.).
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 23.278.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015025259/10.
(150028747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36151
L
U X E M B O U R G
Mantera S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 55.647.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015i>
Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,
avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B - 81.933 dépositaire des titres au porteur de la Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015025261/12.
(150028153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Mamola S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 161.045.
EXTRAIT
Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 12 février 2015 que la société FIDUCENTER
S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2015025260/13.
(150029080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Malderen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 61.058.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 11 février 2015 à 16.00i>
Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège
social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Signatures
<i>Le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015025257/14.
(150028883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Macka S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 180.174.
Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 11/02/2015:
Il est décidé nommer la société à responsabilité limité UNCOS, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,
immatriculée au RCSL sous le numéro B141298, en tant que dépositaire légal des actions au porteur de la société MACKA
S.A., SPF (B180174) et ceci en vertu de la loi du 28 juillet 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2015.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015025252/15.
(150028352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36152
L
U X E M B O U R G
Major Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8715 Everlange, 33, rue Hiel.
R.C.S. Luxembourg B 109.928.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 janvier 2015i>
<i>Conseil d'administrationi>
L'Assemblée Générale accepte la démission de monsieur Manuel MARTINOT né à Wassy, Haute-Marne (France) le
22 Mai 1963, demeurant 1B, rue Jean de Beck, L-7308 HEISDORF du poste d'administrateur et du poste d'administrateur-
délégué de la société avec effet au 2 février 2015 minuit.
L'Assemblée Générale accepte la nomination de monsieur Hacène Harazi né à MONT-SAINT-MARTIN, meurthe-et-
moselle (France) le 17 août 1976, demeurant F-54135 MEXY, 4, rue mozart (France), au poste d'administrateur délégué
de la société avec effet au 3 février 2015.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra tenue le 15 juin 2018.
Everlange, le 3 février 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015025254/19.
(150028182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Malaka International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 57.025.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 11 février 2015 à 17.00i>
Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège
social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Signatures
<i>Le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015025256/14.
(150028884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Magical S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 34.821.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015i>
Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,
avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B - 81.933 dépositaire des titres au porteur de la Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015025253/12.
(150028154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Moog International Financial Services Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3290 Bettembourg, 1, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff.
R.C.S. Luxembourg B 177.940.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025247/9.
(150029047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36153
L
U X E M B O U R G
M&G Real Estate (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 170.483.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle de la Société du 14 mai 2014:i>
<i>Conseil d'administration:i>
Les actionnaires ont décidé de renommer les personnes suivantes aux potes d'administrateurs de la Société pour une
durée d'un an s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015:
1. Monsieur Peter Baxter
2. Madame Bronwyn Salvat-Winter
3. Madame Jennifer Trayner
<i>Réviseur d'entreprisesi>
Les actionnaires ont décidé de renommer KPMG en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée d'un
an s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
<i>Extrait des résolutions des administrateurs restants adoptées le 3 novembre 2014:i>
Les administrateurs restants ont décidé d'accepter la démission de Madame Jennifer Trayner de son poste d'adminis-
tratrice avec effet au 31 octobre 2014.
Les administrateurs restants ont décidé d'accepter la nomination de Monsieur Chris Brierley née le 21 janvier 1975 à
Ashton under Lyne (Royaume-Uni) et résidant professionnellement au City Place House, 55 Basinghall Street, London,
EC2V 5DU, Royaume-Uni, au poste d'administrateur, pour une durée déterminée, à compter du 1
er
novembre et jusqu'à
la prochaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015025237/26.
(150029052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
M.A.R. International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 39.557.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 février 2015i>
Le Conseil d'administration nomme Orangefield (Luxembourg) S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à
L-2163 Luxembourg, en tant qu'agent dépositaire.
Luxembourg, le 10 février 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015025235/14.
(150028809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Monier Holdings GP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.537.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration de la Société en date du 3 février 2015i>
En date du 3 février 2015, le conseil d'administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Fabrice NOTTIN de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué
de la Société avec effet au 3 février 2015;
- de nommer Monsieur Gareth TURNER, né le 11 février 1964 à Winnipeg, Manitoba, Canada, résidant profession-
nellement à l'adresse suivante: 25, St. George Street, W1S 1FS Londres, Royaume-Uni en tant que nouvel administrateur
et administrateur-délégué de la Société avec effet au 3 février 2015 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée
générale des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
36154
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 11 février 2015.
Monier Holdings GP S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015024452/19.
(150027913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Cage Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 194.384.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of December.
Before Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
- FSN Capital III Limited Partnership, a Jersey limited partnership with registered office at 11-15 Seaton Place, St Helier,
Jersey JE4 0QH, registered under LP number 990, duly represented by FSN Capital GP III Limited Partnership registered
under LP number 998, in its capacity as general partner, which is itself represented by FSN Capital Holding Jersey III
Limited, registration number 99523, in its capacity as general partner of FSN Capital GP III Limited partnership,
here duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authoritie.
Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of a
“société à responsabilité limitée” which such party declares to incorporate.
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed
by the present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law
of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28
December 1992 on “sociétés à responsabilité limitée” (the “Commercial Companies Law”).
Art. 2. The Company’s name is “Cage Holding S.à r.l.”.
Art. 3. The Company’s purpose is:
1. To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Lu-
xembourg or foreign companies or enterprises;
2. To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other
way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;
3. Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the
Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;
4. To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
5. To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same
group of companies than the Company (the “Affiliates”) any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case,
even in favor of a third-party lender of the Affiliates);
6. To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and
7. Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment
of the above objects or any of them.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of Niederanven by decision of the board of managers
or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in the Grand Duchy
of Luxembourg and abroad.
36155
L
U X E M B O U R G
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owners or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Shares
Art. 8. The share capital of the Company is set at EUR 25,000 (twenty-five thousand Euros) represented by 25,000
(twenty-five thousand) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, divided into (i) 12,500 (twelve thousand
five hundred) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and (ii) 10 (ten) classes of shares having a nominal value of EUR 1
(one Euro) each as follows:
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class A shares (the “Class A Shares”);
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class B shares (the “Class B Shares”);
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class C shares (the “Class C Shares”);
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class D shares (the “Class D Shares”);
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class E shares (the “Class E Shares”);
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class F shares (the “Class F Shares”);
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class G shares (the “Class G Shares”);
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class H shares (the “Class H Shares”);
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class I shares (the “Class I Shares”); and
- 1,250 (one thousand two hundred and fifty) class J shares (the “Class J Shares”);
All the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F
Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares will be collectively referred to
as the “Classes of Shares” as the case may be, or individually as a “Class of Shares”. All the Ordinary Shares and the
Classes of Shares will be collectively referred to as the “shares” as the case may be, or individually as a “share”.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred “inter vivos” to non-shareholders unless shareholders representing at least three quar-
ters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. Redemption of the Classes of Shares
The Company shall have power to redeem one or more entire Class(es) of Shares through the redemption and
cancellation of all the shares in issue in such Class(es) of Shares.
Such redeemed Class(es) of Shares shall be cancelled through a reduction of the share capital.
The Redemption and cancellation of shares shall (i) be made in the reverse alphabetical order of the Classes of Shares
in issuance (starting with Class J Shares) and (ii) always be made on all the shares of the Class of Shares concerned.
Such redemption of Class(es) of Shares shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for
amendment of the Articles.
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (i) such
Class of Shares gives right to the Total Cancellation Amount (as defined below) to the holders thereof pro rata to their
holding in such class (with the limitation however to the Available Amount (as defined below)) and (ii) the holders of
shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Can-
cellation Value Per Share (as defined below) for each share of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.
36156
L
U X E M B O U R G
Upon redemption and cancellation of the shares of the relevant Class of Shares, the Cancellation Value Per Share will
become due and payable by the Company.
Available Amount
means (i) the total amount of net profits of the Company, including profits made
since the end of the last financial year, for which the annual accounts have been
approved, increased by (ii) any freely distributable share premium and other freely
distributable reserves including all funds available for distribution plus any profits
carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, (iii) the
amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
Class(es) of Shares to be cancelled, knowing that the amount to be distributed may
not exceed the total available sums for distribution as calculated in accordance with
Article 72.2 b) of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as
amended, but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any
sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the
Articles, each as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance
of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L+ LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits), including profits made since the
end of the last financial year, for which the annual accounts have been approved
P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating
to the Class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or
of the Articles.
Cancellation Value Per Share
means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the
number of Shares in issue in the Class of Shares to be repaid and cancelled.
Interim Accounts
means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date
means the date no earlier than 8 (eight) days before the date of the redemption and
cancellation of the relevant Class of Shares.
Total Cancellation Amount
shall be an amount determined by the sole manager or the managers (as the case
may be) in accordance with article 72.2 b) of the law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies, as amended, and approved by the general meeting of the
shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) on the basis of the
relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each Class of Shares
shall be the Available Amount of such class as at the time of its cancellation.
Nevertheless the sole manager or the managers (as the case may be) may provide
for a Total Cancellation Amount different from the Available Amount provided ho-
wever that (i) the Total Cancellation Amount shall never be higher than such
Available Amount, (ii) such different Total Cancellation Amount shall be notified by
sole manager or the managers (as the case may be) to all the shareholders of the
Company through written notice and that (iii) this Total Cancellation Amount has
not been disputed in writing by any shareholders of the Company within 3 (three)
days following receipt of the written notice from the sole manager or the managers
(as the case may be).
Redemption of the Ordinary Shares
Subject to the prior redemption of all Classes of Shares, the Company may redeem the Ordinary Shares.
The redemption of the Ordinary Shares shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for
amendment of the Articles.
If the redemption price for the Ordinary Shares is in excess of the nominal value of the Ordinary Shares to be redeemed,
such redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess
purchase price.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and of one or several category B
manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.
36157
L
U X E M B O U R G
The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and her/his/its/their
remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders, or of the sole shareholder (as the case
may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and “ad nutum”,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of one category A manager and one category B manager.
The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time subdelegate her/his/its powers
for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a
casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers may be convened by any of its managers.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the agenda of the meeting.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his/her/its proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,
including at least one category A manager and one category B manager.
Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly
represented thereto, including at least one category A manager and one category B manager.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by at least two
managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by at least two managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers’ meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
36158
L
U X E M B O U R G
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the number of shareholders is less than 25 (twenty-
five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted
in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each sha-
reholder shall vote in writing.
If the number of shareholders exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of
the shareholders. In such a case 1 (one) general meeting shall be held at least annually in the Grand Duchy of Luxembourg
within 6 (six) months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the
Grand-Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half
of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company’s financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders’ number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)
days preceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If the number of shareholders exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted
to one or more statutory auditor(s) (“commissaires”), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies
Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (“réviseurs
d’entreprises agréés”) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be)
36159
L
U X E M B O U R G
amongst the qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission (“Commission de Surveillance
du Secteur Financier”)’s public register.
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/her/its/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2014.
<i>Subscription - Paymenti>
FSN Capital III Limited Partnership, here represented as mentioned above, declare to subscribe to the 25,000 (twenty-
five thousand) shares issued by a contribution in cash, so that the amount of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euros)
is at the disposal of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about 1,500.- euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of
the subscribed capital, passed the following resolutions:
1) are appointed as category A managers:
- Mr. Peter Möller, born in Österhaninge, Sweden, on 19 December 1972, with professional address at Skeppargatan
39, 11452 Stockholm, Sweden;
- Mr. Marcus Egelstig, born in Österhaninge, Sweden, on 19 July 1978, with professional address at Ljusslingan 32,
12064 Stockholm, Sweden.
are appointed as category B managers:
- Mrs. Dalia Bleyer, born in Alytus, Lithuania, on 17 June 1983, with professional address at 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel;
36160
L
U X E M B O U R G
- Mr. James Lees, born in Belfast, United Kingdom, on 31 January 1978, with professional address at 7 rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel.
The managers shall serve for an indefinite duration.
According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,
in case of plurality of managers, by the joint signature of one category A manager and one category B manager.
2) The Company shall have its registered office at 7 Rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le douzième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
- FSN Capital III Limited Partnership, un limited partnership de Jersey, avec siege social au 11-15 Seaton Place, St Helier,
Jersey JE4 0QH, immatriculée sous le numéro LP 990, dument representé par FSN Capital GP III Limited Partnership,
immatriculé sous le numéro LP 998, agissant en sa qualité de general partner, lui meme représenté par FSN Capital Holding
Jersey III Limited, immatriculé sous le numéro 99523, agissant en sa qualité de general partner de FSN Capital GP III
Limited partnership;
ici dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée
au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire de dresser les statuts suivants d'une société à
responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts
(les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et celle du 28 décembre
1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
Art. 2. La dénomination de la société est «Cage Holding S.à r.l.».
Art. 3. L'objet de la Société est:
(1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;
(2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation
et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et
intérêts, comme la Société le jugera utile;
(3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix
que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
(4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
(5) D'octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou
à toute société appartenant au même groupe de sociétés (les «Affiliées»), tous concours, prêts, avances ou garanties (dans
ce dernier cas, même en faveur d'un tiers-prêteur des Affiliées);
(6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée; et
(7) De manière générale, de faire toute chose que la Société juge circonstanciel ou favorable à la réalisation des objets
ci-dessus décrits ou à l’un quelconque d'entre eux.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
36161
L
U X E M B O U R G
Art. 4. La Société a son siège social établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de Niederanven par décision du conseil de gérance ou du gérant
unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises par la Loi.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil
de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des associés ou de l’associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à EUR 25.000 (vingt-cinq mille Euros) représenté par 12.500 (douze mille
cinq cent) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune, divisées en (i) 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et (ii) 10 (dix) classes de parts sociales ayant une valeur
nominale de EUR 1 (un Euro) chacune, tel que suit:
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»);
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»);
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»);
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»);
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»);
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»);
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»);
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»);
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»); et
- 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»).
L'ensemble des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts
Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des
Parts Sociales de Classe H, des Parts Sociales de Classe I et des Parts Sociales de Classe J sont dénommées collectivement
les «Classes de Parts Sociales» selon le cas, ou individuellement une «Classe de Parts Sociales». L'ensemble des Parts
Sociales Ordinaires et des Classes de Parts Sociales seront collectivement dénommées les «parts sociales» selon le cas,
et individuellement une «part sociale».
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel aux
nombres de parts qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Pour le reste, il est référé aux
dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. Rachat des Classes de Parts Sociales
La Société a le pouvoir de racheter en entier une ou plusieurs Classe(s) de Parts Sociales au moyen du rachat et de
l’annulation de l’ensemble des parts sociales émises dans une(de) telle(s) Classe(s) de Parts Sociales.
Une(De) telle(s) Classe(s) de Parts Sociales rachetée(s) sera(ont) annulée(s) au moyen d'une réduction du capital social.
Le rachat et l’annulation des parts sociales (i) sera fait dans l’ordre alphabétique inversé des Classes de Parts Sociales
36162
L
U X E M B O U R G
émises (en démarrant par les Parts Sociales de Classe J) et (ii) portera toujours sur l’intégralité des parts sociales de la
Classe de Parts Sociales concernée.
Un(De) tel(s) rachat(s) de Classe(s) de Parts Sociales sera décidé par une résolution de l’assemblée générale extraor-
dinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas), adoptée dans les conditions requises pour la modification des
Statuts.
En cas de réduction du capital social par le rachat et l’annulation d'une Classe de Parts Sociales (i) cette Classe de Parts
Sociales donnera droit au Montant Total d'Annulation (tel que défini ci-dessous) aux détenteurs au prorata de leur
détention dans une telle classe (limité toutefois au Montant Disponible (tel que défini ci-dessous)) et (ii) les détenteurs
de parts sociales de la Classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur
d'Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chaque part sociale de la Classe de Parts Sociales cor-
respondante détenue par eux et annulée.
En cas de rachat et d'annulation des parts sociales de la Classe de Parts Sociales correspondante, la Valeur d'Annulation
par Part Sociale deviendra due et payable par la Société.
Montant Disponible
Signifie (i) le montant total des bénéfices nets de la Société incluant les bénéfices
réalisés depuis la fin de la dernière année sociale pour laquelle les comptes annuels
ont été approuvés, augmenté de (ii) toutes prime d'émission librement distribuable
et autres réserves distribuables incluant tous les fonds disponibles pour la distribution
ainsi que tous bénéfices reportés et prélèvement effectués sur les réserves
disponibles à cet effet, (iii) le montant de la réduction du capital social et de la
réduction de la réserve légale en relation avec la/les Classe(s) de Parts Sociales à
annuler, sachant que le montant à distribuer ne peut excéder la totalité des sommes
disponibles pour la distribution telle que calculée conformément à l’article 72-2 b)
de la Loi, mais diminué de (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées) et (ii)
toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu d’une obligation légale ou statutaire,
tel que décrits dans les Comptes Intérimaires afférents (pour lever tout doute, sans
double calcul) de sorte que:
MD = (PN + R + RC) - (P + RL)
où:
MD = Montant Disponible
PN = bénéfices nets (incluant les profits reportés), incluant les profits/bénéfices
réalisés depuis la fin de la dernière année sociale pour laquelle les comptes annuels
ont été approuvés
R = toute prime d’émission librement distribuable et autres réserves distribuables.
RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale
en relation avec la Classe de Parts Sociales devant être annulée
P = pertes (incluant les pertes reportées)
RL = toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de
la loi ou des Statuts.
Montant d’Annulation par Part
Sociale
Sera le montant calculé en divisant le Montant Total d’Annulation par le nombre de
Parts Sociales émises dans une Classe de Parts Sociales devant être rachetée et
annulée.
Comptes Intérimaires
Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires
concernés.
Date des Comptes Intérimaires Signifie la date qui n'étant pas inférieure à huit (8) jours avant la date de rachat et
d'annulation de la Classe de Parts Sociales concernée.
Montant Total d’Annulation
Sera le montant déterminé par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon
le cas) en conformité avec l’article 72.2 b) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, et approuvé par l’assemblée générale des associés
ou l’associé unique (selon le cas) sur la base des Comptes Intérimaires afférents. Le
Montant Total d’Annulation pour chaque Classe de Parts Sociales sera le Montant
Disponible de ladite classe au moment de son annulation.
Néanmoins, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut envisager/
fournir un Montant Total d’Annulation différent du Montant Disponible à condition
que (i) le Montant Total d’Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible,
(ii) un tel Montant Total d’Annulation différent devra être notifié par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas) à tous les associés de la Société par une
notice écrite et que (iii) le Montant Total d’Annulation n’a pas été contesté par écrit
par un associé de la Société dans les 3 (trois) jours suivant la réception de la notice
écrite du conseil de gérance ou du gérant unique (le cas échéant).
Rachat des Parts Sociales Ordinaires
36163
L
U X E M B O U R G
Moyennant le rachat préalable de l’ensemble des Classes de Parts Sociales, la Société peut racheter les Parts Sociales
Ordinaires.
Le rachat des Parts Sociales Ordinaires sera décidé par une résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire
des associés ou par l’associé unique (selon le cas), adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.
Si le prix de rachat des Parts Sociales Ordinaires excède la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires devant être
rachetées, ce rachat pourra seulement être décidé dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles
eu égard à ce prix de rachat excédentaire.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant
(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) comme gérant(s) de catégorie A ou gérant(s) de catégorie B, et sa/
leur rémunération est fixée par résolution de l’assemblée générale des associés ou par décision de l’associé unique (selon
le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée dans les mêmes conditions.
L'assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas) peut, «ad nutum» et à tout moment, révoquer ou
remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou à l’associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec
l’objet social de la Société dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) «ad hoc» qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé
(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération
(s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, n’aura pas de vote
prépondérant. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil
de gérance sera présidé par un gérant présent et nommé à cette fonction. Il peut également choisir un secrétaire, lequel
n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de rédiger les procès verbaux des réunions du conseil de gérance
ou de l’exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra être convoqué par tout gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)
jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans
le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.
Toute convocation devra spécifier l’heure et le lieu de la réunion et l’ordre du jour de la réunion.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
La réunion du conseil de gérance se tiendra valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou dûment
représentés.
Une convocation spécifique n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance qui se tiendront à l’heure et au
lieu précisés dans d'une précédente résolution du conseil de gérance. Tout gérant peut prendre part aux réunions du
conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant
pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen
de communication approprié permettant à l’ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer
simultanément, sous réserve qu’une majorité de gérants ne pourra pas participer à une réunion en étant situé dans la
même juridiction étrangère.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
36164
L
U X E M B O U R G
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité des gérants y est présente ou re-
présentée, dont au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant au conseil ou y étant représentés,
incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par au moins deux gérants.
Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par au moins deux gérants.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans de tels cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul et même document, soit dans
plusieurs documents ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, téléfax, câble, télégramme, télex, moyens élec-
troniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié.
Art. 14. Aucun gérant ne contracte en raison de ses fonctions d'obligation personnelle quant aux engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l’exécution de
son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou
par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Cha-
que associé émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des
associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue au Grand Duché de Luxembourg dans les 6 (six) mois
de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de
Luxembourg à l’heure et au jour fixé dans la convocation à l’assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d'associés sont proposées
par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.
Une convocation écrite convoquant une assemblée générale et indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la
Loi et est adressée à chaque associé au moins 2 (deux) jours avant l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle
pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l’assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l’assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l’associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui
contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la société. Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits
et pertes qui sera soumis à l’assemblée générale des associés avec le bilan.
36165
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)
jours précédant l’assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale
annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l’approbation des comptes annuels.
A l’expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront
être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés ou de l’associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l’ap-
probation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront
atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommés
par l’assemblée générale des associées ou l’associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au registre public
des réviseurs d'entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent
être nommés par résolution de l’assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d'un dixième.
L'assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l’associé unique (selon le cas) peut décider à tout moment
que l’excédent sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de
la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’assemblée générale des associés de la Société ou l’associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l’associé
unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l’approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts
du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils
détiennent.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2014.
<i>Souscription - Paiementi>
FSN Capital III Limited Partnership, ici représenté comme mentionné ci-dessus, déclare souscrire les 25.000 (vingt-
cinq mille) parts sociales émises au moyen d'un apport en numéraire, de sorte que le montant de EUR 25.000 (vingt-cinq
mille Euros) est à la disposition de la Société.
36166
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.500 euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé de la Société, représentant la totalité du capital social
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
<i>1) Est nommé gérant de catégorie A:i>
- M. Peter Möller, né à Österhaninge, Suède, le 19 décembre 1972, avec adresse professionnelle à Skeppargatan 39,
11452 Stockholm, Suède;
- M. Marcus Egelstig, né à Österhaninge, Suède, le 19 juillet 1978, avec adresse professionnelle à Ljusslingan 32, 12064
Stockholm, Suède.
<i>2) Sont nommés gérants de catégorie B:i>
- Mme Dalia Bleyer, née à Alytus, Lithuanie, le 17 juin 1983, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel;
- M. James Lees, né à Belfast, Royaume Uni, le 31 Janvier 1978, avec adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de
pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
2) Le siège social de la Société est établi au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duché de Luxem-
bourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare que sur demande de la personne comparante, la présent
acte de constitution a été rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg à la date figurant au commencement de ce
document.
Le document ayant été lu au mandataire, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17584. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015022399/691.
(150026642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
BlackRock Asia Property Fund IV Feeder S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 194.455.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of December.
Before the undersigned notary Maître Marc Loesch, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
APPEARED:
BlackRock UK 4 LLP, a limited liability partnership incorporated under the laws of England and Wales, with registered
office at 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, and registered with the Companies House of England and Wales
under number OC371088,
here represented by Me Mariama Sene, lawyer, professionally domiciled in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney under private seal given on December 17, 2014, that will be initialled as “ne varietur”
by the proxyholder and the notary, attached to the present deed and simultaneously filed with the registration authority.
The appearing party, represented as stated above, has mandated the notary with the preparation of the following
articles of association (“Articles of Association”) of a public limited company (société anonyme) qualifying as Fonds d’In-
36167
L
U X E M B O U R G
vestissement Spécialisé (SIF) with variable capital (SICAV) pursuant to the Act on Specialised Investment Funds dated 13
February 2007, as amended and which the persons appearing declaredly wish to establish:
Art. 1. Name. Between the undersigned and all persons that may become shareholders there exists a company in the
legal form of a public limited company under the name of "BlackRock Asia Property Fund IV Feeder S.A. SICAV-SIF" (the
“Fund") qualifying as an “investment company with variable capital - specialised investment fund“.
All terms not defined in these Articles of Association shall have the meaning given to such terms in the PPM (as defined
below).
Art. 2. Duration. The Fund is established for a limited duration and will be terminated at the termination of the Master
Fund (as defined below) as set forth in the confidential private placement memorandum of the Fund (the “PPM”).
The Fund may be dissolved at any time upon resolution of the Fund’s shareholders, provided that the resolution has
been passed in the form required for amendments to the Articles of Association.
Art. 3. Corporate Object. The Fund’s exclusive object is to carry out the business of a specialised investment fund
pursuant to the Law on Specialised Investment Funds dated 13 February 2007, as amended (“2007 Law“) and to achieve
the investment strategy laid down in the PPM.
The Fund will invest substantially all of its assets in BlackRock Asia Property Fund IV S.à r.l. SICAV-SIF (the “Master
Fund”).
Within the framework of the 2007 Law, the Fund may take all measures and carry out all business activities it deems
helpful to fulfil and to promote its company purpose.
Art. 4. Registered Office. The Fund’s registered office is in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of
directors (the “Board”). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that events of force majeure have occurred or are imminent that would interfere
with the normal activities of the Fund at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ab-
normal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Fund which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 5. Capital. The capital of the Fund, expressed in U.S. Dollars, shall be represented by fully paid-up shares (the
“Shares”) of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Fund pursuant to Articles 27 and
28 hereof.
The initial capital of the Fund is the U.S. Dollar equivalent of thirty-one thousand euro (EUR 31,000).
The minimum capital shall be as provided by the 2007 Law i.e., the U.S. Dollar equivalent of one million two hundred
and fifty thousand euro (EUR 1,250,000). The minimum capital of the Fund must be achieved within 12 months after the
date on which the Fund has been authorised under the 2007 Law.
Art. 6. Issue of Shares. The Board is entitled, within the limits set out in these Articles, to issue an unlimited number
of fully paid up Shares at any time and at such value as shall be determined in the PPM, without being required to grant
existing shareholders a preferential right of subscription.
The Board may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued. The Board may, in particular,
decide that Shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other periods as determined by
the Board and in accordance with the PPM.
The Board is authorised to issue different classes of Shares (each a “Share Class”) which may differ, inter alia, as regards
the fee structure, distribution policy, hedging strategies, minimum investment capital, shareholders’ qualifications, payment
structures or other specific features and that can be denominated in different currencies, as may be determined by the
Board and laid down in the PPM from time to time. The Board may decide if and when Shares of such Share Classes are
to be offered for subscription, as well as the conditions of such issuance.
Shares will be issued after the acceptance of the subscription and subject to payment of the issue price, pursuant to
Articles 7 and 8 hereof. Upon acceptance of the subscription and receipt of the issue price, the shareholder will receive
a confirmation of its shareholding, within a period customary in financial affairs.
Fractions of Shares may be issued. In the event that a shareholder becomes entitled to a shareholding, such shareholding
shall be registered in the share register with up to four (4) decimals. Fractional Shares do not grant any voting rights:
however, the shareholder is entitled to distributions pro rata to its shareholding.
The proceeds from the issuance of Shares will be invested in securities and/or other permitted assets pursuant to
Article 3 hereof.
The shareholders of all issued Shares will be listed in the share register that is kept by the Fund or by one or more
entities to whom the Board has delegated such task. The share register shall contain the names of all shareholders, their
address as well as the number of Shares held in the Fund and in each Share Class, if applicable. Ownership of a Share is
evidenced prima facie by the registration of the holder of such Share in the share register.
36168
L
U X E M B O U R G
Every shareholder registered in the share register must provide the Fund with an address for the reception of notifi-
cations and announcements by the Fund. This address will be listed in the share register. A shareholder may at all times
change its registered address by written notice sent to the Fund’s registered office or such other address as may be
indicated by the Fund from time to time.
Subject to the consent of the shareholders and if permitted by the PPM and permitted by law, notifications and an-
nouncements by the Fund can be sent electronically to the shareholders.
The registration of a person as a shareholder of the Fund in the share register is subject to the shareholder’s qualifi-
cation as an Eligible Investor as defined in Article 10. For that purpose, the Fund may request evidence that the acquirer
qualifies as an Eligible Investor within the meaning of the 2007 Law. If need be, the Fund may request additional documents
it deems necessary for the registration in the share register.
Art. 7. Subscription of Shares / Capital Commitments. The Board or duly authorised persons may - at their sole
discretion - accept or reject subscriptions and payments for new Shares as well as issue new Shares to Eligible Investors
(as defined below).
Subscriptions may be made in the form of capital commitments (“Commitments”) and will become due and payable
either immediately in full or in several instalments upon receipt of drawdown notices, as further provided in the following
Article 8.
The Board may allow assets to be contributed in kind, to the extent permitted by Luxembourg law (in particular with
respect to the requirement of a special audit report from the auditors of the Fund, confirming the value of any assets
contributed in kind) and the PPM, and provided that such assets are consistent with the investment strategy of the Fund
and the Master Fund. The costs of such contributiuon in kind shall be borne by the contributing shareholder.
Unless otherwise determined in the PPM, whenever the Fund offers Shares for subscription, the price of the offered
Shares shall be based on the issue price per Share of the relevant Share Class, if applicable, as determined in the PPM.
The Board may, in its sole discretion, accept Commitments, or additional Commitments from existing shareholders,
after the date on which Commitments are first accepted from shareholders of the Master Fund (the “Master Fund Initial
Closing Date”) until the date set forth in the PPM (the “Final Closing Date”). If a shareholder (a “Subsequent Shareholder”)
is admitted to the Fund, or increases its Commitment, on a date after the Master Fund Initial Closing Date (a “Subsequent
Closing Date”), the following provisions shall apply in respect of the first drawdown following such Subsequent Closing
Date:
(i) drawdowns will be of such amounts and in such proportions so as to ensure that following the application of
paragraph (iii) and this paragraph (i) and equivalent provisions of each of the Master Fund Documents and the constitutional
documents of each of the Other Feeders, the aggregate amount drawn down from each shareholder (other than for the
purposes of paying the Additional Amounts (as defined below) and the Base Fee and that portion of the Master Fund Base
Fee calculated by reference to Total Fund Commitments) is in proportion to the shareholders’ respective Total Fund
Commitments as at the date of such drawdown;
(ii) each Subsequent Shareholder shall pay to the Fund and each Other Subsequent Investor (as defined in paragraph
(iii) below) shall pay to the relevant Other Feeder an additional amount equal to interest at a rate equal to 9 per cent
per annum on amounts drawn down from the Subsequent Shareholder and Other Subsequent Investors (other than for
the purpose of paying the Base Fee and that portion of the Master Fund Base Fee calculated by reference to Total Fund
Commitments) from the date that such amounts would have been drawn down from it had such Subsequent Shareholder
or Other Subsequent Investor been admitted on or held its increased commitment on the Master Fund Initial Closing
Date to the date of actual draw down, calculated on a daily basis and compounding annually on the anniversary of the
due date of the prior draw down (“Additional Amount”);
(iii) each shareholder from whom prior drawdowns had been made shall be allocated and paid such amount equal to
the excess of: (a) the amount drawn down from such shareholder and not previously returned (excluding Additional
Amounts and Base Fees); and (b) the amount which would have been drawn down from such shareholder (excluding Base
Fees) had all Subsequent Shareholders and their equivalent in each of the Other Feeders (the “Other Subsequent Inves-
tors” and each an “Other Subsequent Investor”) been admitted to the Fund or the Other Feeders (as the case may be)
or made their increased Commitment on the Master Fund Initial Closing Date. Any amounts so returned to a shareholder
shall be treated as having never been drawn down (and accordingly such shareholder’s undrawn Commitment shall be
increased by such amount);
(iv) each of the shareholders other than the Subsequent Shareholder and each of the Other Feeder Fund Investors
other than the Other Subsequent Investors shall be entitled to receive such proportion of the Additional Amount as
represents the proportion which the amount drawn down from each of them prior to the relevant Subsequent Closing
Date bears to the aggregate amount so drawn down. Additional Amounts are paid in addition to the Commitment of a
shareholder and the shareholder will not receive any Shares in respect of such amounts; and
(v) a further amount shall be drawn down from each Subsequent Shareholder equal to the Base Fee calculated by
reference to the Subsequent Shareholders’ respective Commitments plus that portion of the Master Fund Base Fee
calculated by reference to Total Fund Commitments to be borne by such Subsequent Shareholder each calculated as if
36169
L
U X E M B O U R G
such Subsequent Shareholder had been admitted to the Fund or made its increased Commitment on the Master Fund
Initial Closing Date.
With respect to any rebalancing of Shares to be effected on a Subsequent Closing Date, the Board shall, having regard
to the best interests of the shareholders as a whole, be entitled to effect such rebalancing by:
(a) transferring Shares between the shareholders;
(b) issuing new Shares; and
(c) redeeming and reissuing Shares.
Art. 8. Drawdowns. If subscriptions are made in the form of Commitments, such shareholder’s Commitments will
become due and payable in one or several instalments by subscription of the relevant number of fully paid-up Shares
pursuant to a drawdown (the “Drawdown”). For each Drawdown, the Fund or other authorised person will send a
drawdown notice to the shareholder with the request to arrange for payment of the respective amount via bank transfer.
Pursuant to the payment of the relevant amount in accordance with the PPM, the corresponding number of Shares will
be issued to the respective shareholder.
When Commitments are called in several instalments, except in relation to Drawdowns made following a Subsequent
Closing Date as described in Article 7, each Drawdown will be made on a pro rata basis with respect to the Commitments
made by each shareholder, unless otherwise provided in the PPM. Unless otherwise determined, each Drawdown, shall
amount to a percentage of the relevant shareholder’s total Commitment, determined by the Board in its sole discretion.
The offering period (and any possible extension(s) thereof), as well as the issue price of Shares shall be defined in the
PPM.
Art. 9. Defaulting Investor. Subject to any specific provision in the PPM, a shareholder who fails to comply with a
drawdown notice by the date of its expiry (a “Defaulting Shareholder“) may be requested to pay interest on the amount
it failed to pay in such amount as determined in the PPM.
In addition, the Defaulting Shareholder will also be liable for (i) any additional amount sufficient to reimburse the
Manager, the Portfolio Manager and/or the Fund with respect to any other fees, costs and expenses (including in respect
of borrowings) or Tax incurred by the Manager, the Portfolio Manager and/or the Fund as a result of the shareholder’s
failure to pay the full amount due and (ii) any additional penalties as set forth in the PPM.
Further details with respect to this Article 9 of the Articles of Association are provided in the PPM.
Art. 10. Restrictions on shareholders. Shares shall be issued only to well-informed investors within the meaning of
Article 2 of the 2007 Law (each an "Eligible Investor''), upon verification of such status and upon acceptance of the
subscription and subject to payment of the price as set forth in Articles 7 and 8 hereof. Every shareholder must provide
the Fund with the confirmation or, as the case may be, evidence of its status of Eligible Investor.
The conditions set forth above shall not apply to the directors and other persons who are involved in the management
of specialised investment funds and hence are not applicable to the Directors.
In addition to the above, the Board shall have power (but not the obligation) to refuse to issue or register any transfer
of Shares, or to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as it, in its discretion, may
think necessary for the purpose of ensuring that no Shares are acquired or held by or on behalf of any person, firm or
corporate entity, determined in the sole discretion of the Board as being not entitled to subscribe for or hold Shares,
(i) if in the opinion of the Board such holding may be detrimental to the Fund,
(ii) if as a result thereof the Fund would breach any applicable material law, regulation or interpretation, Luxembourg
or foreign,
(iii) if as a result thereof the Fund or any shareholder may become exposed to disadvantages of a tax, legal, economic
or financial nature that it would not have otherwise incurred, or
(iv) if such person would not comply with the eligibility criteria of the Shares, and notably if such person is a U.S. Person
and not a “qualified purchaser” within the meaning of Section 2(a)(51) of the U.S. Investment Company Act (each indi-
vidually, a "Prohibited Person").
More specifically, the Fund may restrict or prevent the ownership of Shares by any person, firm or corporate body.
For such purposes, the Fund may:
(a) decline to issue any Share, and decline to register any transfer, where it appears to it that such issue or transfer
would or might result in such Share being directly or beneficially owned by a Prohibited Person,
(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares
on the register of shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not the beneficial ownership of Shares rests in Prohibited Person,
(c) request the shareholder to dispose of its Shares pursuant to the transfer provisions contained herein and in the
PPM and to provide evidence of the disposal vis-à-vis the Fund within thirty (30) days of such request if in the Board’s
assessment a Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner
of Shares. Should the respective shareholder fail to comply with this request in due time, the Board may - in its sole
discretion - treat such shareholder as a Defaulting Investor.
36170
L
U X E M B O U R G
(d) where it appears to the Fund that any Prohibited Person, either alone or in conjunction with any other person is
a beneficial or registered owner of Shares, compulsorily redeem from any such shareholder all Shares held by such
shareholder in the following manner:
(i) the Fund shall serve a notice (hereinafter referred to as the "Redemption Notice") upon the shareholder holding
such Shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares
to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as defined
below) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such shareholder by posting
the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known or appearing in the
register of shareholders. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice, such
shareholder shall cease to be a shareholder and the Shares previously held by him shall be cancelled. The said shareholder
shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Fund the Share certificate or certificates (if issued) relating to the
Shares specified in the Redemption Notice;
(ii) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed shall be determined in ac-
cordance with Article 26 hereof (hereinafter referred to as the "Redemption Price");
(iii) payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner of such Shares and will
be deposited by the Fund with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment
to such person upon verifications in accordance with the relevant laws and regulations. Upon deposit of the monies
corresponding to the Redemption Price as aforesaid no person specified in such Redemption Notice shall have any further
interest or claim in such Shares or any of them, or any claim against the Fund or its assets in respect thereof, except the
right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without any interest) from
such bank as aforesaid;
(iv) the exercise by the Fund of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case,
on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of
any Shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any Redemption Notice, provided that in such case
the said powers were exercised by the Fund in good faith; and
(v) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Fund.
Art. 11. Rights and duties attached to the Shares. Each Share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Fund and to one vote at shareholder general meetings, except as may be determined in the PPM.
If the Fund is composed of a single shareholder, that shareholder exercises all those powers granted to all shareholders
by the law of 10 August 1915 on commercial companies (the “1915 Law”) and these Articles.
Ownership of a Share carries implicit acceptance of these Articles and of any decision made by resolution of the
shareholders.
The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event request that a
seal be affixed to the assets and documents of the Fund or an inventory of assets be ordered by court. They must, for
the exercise of their rights, refer to the Fund's inventories and resolutions.
Art. 12. Indivisibility of Shares. Co-owners of Shares must be represented by a common attorney-in-fact, whether or
not jointly appointed.
Art. 13. Transfer of Shares. Shares may only be transferred subject to: (i) the provisions of the 2007 Law according
to which every shareholder must qualify as an Eligible Investor; (ii) these Articles of Association; (iii) the provisions
contained in the PPM and (iv) the prior written consent of the Portfolio Manager.
Transfers of Shares may only be made by any existing shareholder to Eligible Investors.
Art. 14. Incapacity, bankruptcy or insolvency of shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar
event affecting a shareholder will not cause the Fund to go into liquidation.
Art. 15. Director. The Fund is managed and administered by a Board composed of at least four (4) directors who do
not have to be shareholders (each a "Director'').
The Board is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Fund's
corporate object.
All powers not expressly reserved by the Articles or by the 1915 Law to the general meeting of shareholders or to
the auditor(s) are in the competence of the Board.
Each Director is appointed annually by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may
elect to remove, replace or appoint additional Directors to the Board from time to time. Each Director shall be subject
to re-appointment on an annual basis, such reappointment together with the appointment of any new or additional
Directors and any decision not to replace a Director who does not wish to be reappointed, has resigned or has been
removed (provided there are sufficient numbers of Directors remaining to comply with the requirements of this Article
with respect to composition of the Board) shall require the approval of the general meeting of shareholders.
Any Director may be removed at any time, with or without cause, by the general meeting of shareholders taking an
Ordinary Resolution. Any Director may resign at any time on providing advance notice to the Fund.
36171
L
U X E M B O U R G
The general meeting of shareholders shall decide by Ordinary Resolution upon the compensation of each Director.
The Board shall appoint, from among its members, a chairman. The Board shall choose a secretary, who need not be
a Director, who shall be responsible for keeping board meeting minutes and other Fund records.
The Board may also appoint officers of the Fund considered necessary for the operation and management of the Fund.
Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be Directors or shareholders of the
Fund. The officers appointed shall have the powers and duties entrusted to them by the Board.
Art. 16. Meetings of the Board. Meetings of the Board shall be held at the place indicated in the notice of the meeting.
Written notice of any Board meeting shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the time set for
such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in
the notice of the meeting. This notice may be waived with the consent of each Director in writing, by facsimile or e-mail.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted
by resolution of the Board.
The Board will meet upon call by the chairman. A meeting of the Board must be convened if any two (2) of its members
so require.
The chairman will preside at all meetings of the Board, except that in his absence the Board may appoint another
member of the Board as chairman pro tempore by majority vote of the directors present or represented at such meeting.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing, by facsimile or e-mail, another director as
his proxy. Directors may also cast their vote in writing, by facsimile or e-mail. Meetings of the Board may be held by way
of conference call, video conference or any other similar means of communication, in which case the Directors partici-
pating by such means shall be deemed to be present in Luxembourg.
The Board shall act validly only if at least three directors are present or represented at a meeting of the Board. Decisions
shall be taken by a majority vote of the Directors present or represented. The chairman of the Board shall have a casting
vote.
The minutes of any meeting of the Board will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain
attached thereto. Copies or extracts of written resolutions or minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise
may be signed by any two Directors.
Resolutions may also be passed in the form of a written consent resolution. This may be signed jointly or by the use
of counterpart signatures by all the directors.
Art. 17. Powers of representation. In dealing with third parties, any two Directors shall have the power to act jointly
in the name of the Fund in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations. The Fund is bound in
all circumstances by the signature of two Directors. Notwithstanding the foregoing, any one Director shall have the power
to act alone in the name of the Fund in all circumstances, to carry out and authorize all acts and operations, and to bind
the Fund in all circumstances by only such Director's signature, if so authorised by the Board.
Art. 18. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a Director. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency,
resignation, removal or any other similar event affecting a Director will not cause the Fund to go into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a Director may in no event have seals affixed to the assets and documents of the
Fund.
Art. 19. Liability of Director. A Director will not incur any personal liability arising out of the functions performed on
behalf of the Fund. He is only liable for the performance of his mandate.
Art. 20. Conflicts of interest and indemnity. No contract or other transaction between the Fund and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that a Director, officer or employee of the Fund has a personal interest
in, or is a shareholder, director, director, officer or employee of such other company or firm. Any person related, as
described above, to any company or firm with which the Fund shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting or otherwise
acting upon any matters with respect to such contract or business.
Notwithstanding the above, in the event that any Director has or may have any vested interest or personal interest
in any transaction of the Fund, such Director shall make known such personal interest to the Board of Directors and
shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such interest of the Director therein shall
be reported to the next general meeting of shareholders.
The above paragraph of this Article does not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Fund.
The term “vested interest«as used herein does not comprise every interest merely resulting from the fact that the
transaction relates to BlackRock (or a company directly or indirectly associated with BlackRock respectively) or another
company as determined by the Fund.
None of the members of the Investor Advisory Committee (acting solely in their capacity as such), any shareholders
who have appointed a member of the Investor Advisory Committee (solely in relation to the appointment and conduct
of the relevant Investor Advisory Committee member), the Board, the Manager, the manager of the Master Fund, the
36172
L
U X E M B O U R G
Portfolio Manager, the portfolio manager of the Master Fund, the members of the Investment Committee, BlackRock or
any of their respective partners, officers, members, shareholders, directors, employees, agents or affiliates or board
member of any Holding Company or Property Company (each an “Indemnified Person”) will be liable to the Fund or any
of the shareholders for any act or omission performed or omitted by any such Indemnified Person and the Fund shall
indemnify such Indemnified Persons on an after-Tax basis for any loss or damage incurred by any of them, except where
such liability or claim is the result of: (i) in the case of an Indemnified Person other than members of the Investor Advisory
Committee, or any shareholder who has appointed a member of the Investor Advisory Committee, (a) gross negligence,
(b) wilful misfeasance, (c) bad faith, (d) fraud or (e) a knowing breach of the terms of the Lux Documents, which in each
case results in the Fund and/or the shareholders suffering material financial disadvantage; and (ii) in the case of members
of the Investor Advisory Committee, or any shareholder who has appointed a member of the Investor Advisory Com-
mittee, bad faith as determined by the final judgment of a court.
Art. 21. Appointment, powers and removal of the Manager. The Board may appoint an external alternative investment
fund manager (“Manager”) within the meaning of the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund
managers (the “AIFM Law”).
The Manager of the Fund shall be responsible for the portfolio and risk management of the Fund in accordance with
the PPM and subject to ultimate oversight of the Board. The Manager may be allowed to delegate portfolio management
to one or more portfolio managers in accordance with the PPM.
The Board may remove the Manager at any time where it considers it to be in the best interest of the shareholders,
and in accordance with the conditions set forth in the PPM.
The Board shall also remove the Manager under such circumstances and conditions as may be further set forth in the
PPM.
Art. 22. Voting Rights. Each Share will grant one vote, independent from the Net Asset Value of such Share but subject
to limitations, if any, pursuant to applicable law, the Articles of Association and the PPM.
Each shareholder may be represented by another shareholder or another person at any meeting of shareholders by
virtue of a written proxy (including facsimile). Such proxy holder does not need to be a shareholder and may be a Director
or a representative thereof.
Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Fund. Voting forms contain the date, place and
agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution three boxes allowing to (a)
vote in favour, (b) vote against, or (c) abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the
registered office of the Fund. Only voting forms received prior to the meeting of the shareholders are taken into account
for the calculation of the quorum. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions)
nor an abstention are void.
In cases where votes are related to (an) individual Share Class(es), only the shareholders of such relevant Share Class
(es) will be entitled to vote.
The Board may determine further conditions to be fulfilled by the shareholders in order to be admitted to a meeting
of the shareholders.
Should the Fund be requested to exercise voting rights in relation to the Master Fund, the Board shall consult with
the shareholders of the Fund prior to exercising any vote at the Master Fund level, to the extent such consultation is
required by the PPM. Further details of the relevant consultation mechanism may be determined in the PPM.
To the extent permitted by the constitutive documents of the Master Fund, the Board shall exercise a split vote at
the Master Fund level so as to vote the interest of the Fund in the Master Fund in proportion to the responses received
from the shareholders of the Fund. Absent direction from a shareholder, the Board will abstain from voting with respect
to such shareholder's pro rata interest.
Art. 23. General meetings of shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Fund shall
represent the entire body of shareholders of the Fund. Its resolutions shall be binding upon all shareholders regardless
of the Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Fund.
In the event that the Fund is composed of one sole shareholder, the sole shareholder will be vested with all powers
of the general meeting of shareholders.
When the Fund is composed of several shareholders, shareholders’ decisions are taken by resolutions in a general
meeting, the text of which will be sent by the Board to the shareholders by simple letter or by e-mail for a first consultation,
and sent by registered letter for a second consultation. In the latter case, shareholders are under the obligation to cast
their written vote and send it by registered letter to the Fund within 15 days of receiving the text of the resolution to
be decided upon.
When the Fund is composed of several shareholders, unless otherwise specified in these Articles or in the 1915 Law,
shareholder decisions are only validly taken if they are adopted by shareholders representing more than half (50%) of the
corporate capital. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted a
36173
L
U X E M B O U R G
second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes cast validly, regardless of the
portion of capital represented.
However, resolutions to amend these Articles and to liquidate the Fund may only be taken by a majority of shareholders
representing three quarters (75%) of the Fund's corporate capital.
In line with Luxembourg law, the annual general meeting of shareholders will be held at the Fund’s registered office in
Luxembourg or any other place in the municipality of Luxembourg-city as may be indicated in the convening notice, at
midday on the last day on which banks in Luxembourg are open for business in June of each year or, if such day is a public
holiday, on the last preceding Luxembourg bank business day. The annual general meeting of shareholders may be held
abroad should extraordinary circumstances so require in the sole discretion of the Board.
Other shareholders’ meetings of the Fund may be held at such place and date as stated in the respective convening
notice.
Upon the written request of shareholders jointly representing one tenth (1/10) of the share capital, a shareholders’
meeting has to be convened.
Art. 24. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the shareholders will be documented in writing,
recorded in a register and kept at the registered office of the Fund. Shareholder votes and any powers of attorney will
be attached to the minutes of the meeting, if applicable.
Art. 25. Determination of investment policies. The Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have
power to determine the investment policies and the course of conduct of the management and business affairs of the
Fund, within the restriction set forth in the PPM and in compliance with applicable laws and regulations.
Art. 26. Redemption and Compulsory Transfer. The Fund is a closed-ended specialised investment fund. Consequently,
Shares in the Fund shall not be redeemable at the request of a shareholder unless specified otherwise in the PPM.
Shares may be called by the Fund for redemption or may be subject to compulsory transfer to a third party:
(a) in the circumstances listed under Articles 7 and 10 of the Articles of Association;
(b) if such shareholder has materially breached any provision of these Articles or the PPM; or
(c) in such other circumstances as set forth in the PPM or as the Fund may determine where continued ownership
would be materially prejudicial to the interests of the Fund or its shareholders.
Shares which are to be redeemed by the Fund may be redeemed by the Fund upon the Fund giving to the registered
holder of such Shares not less than 30 days' notice in writing of the intention to redeem such Shares specifying the date
of such redemption, which must be any day (other than a Saturday or Sunday) when banks are open in Luxembourg,
London, Hong Kong and New York (a “Business Day”).
The amount payable on such redemption of Shares shall be the Net Asset Value of the Shares on the most recent
Valuation Date, except as otherwise provided in the PPM. Costs associated with the redemption may, if the Fund so
decides, be charged to the shareholder whose Shares are redeemed and such costs may be deducted from the redemption
proceeds payable to the shareholder in circumstances where the Fund has exercised its power to redeem Shares pursuant
to paragraph (a) or (b) of this Article 26.
Any Shares in respect of which a notice of redemption has been given shall not be entitled to participate in the profits
of the Fund in respect of the period after the date of redemption.
No Shares of a relevant Share Class may be converted into Shares of another Share Class upon request of a shareholder,
but the Board may be entitled to proceed to such conversions under the conditions set forth in the PPM.
Art. 27. Valuation and Deposit of assets.
27.1 Calculation method
The net asset value per Share shall be expressed in U.S. Dollar and shall be determined as of each Valuation Date by
dividing (i) the net assets of the Fund, by (ii) the number of outstanding Shares, in accordance with the valuation rules set
forth below, provided that the assets shall be determined in accordance with the rules set forth below (the “Net Asset
Value”).
The Net Asset Value per Share is quoted with up to four (4) decimal places as one amount per Share in the reference
currency. If since the time of determination of the Net Asset Value there has been a material change in relation to a
substantial part of the Investments of the Fund, the Fund may, in order to safeguard the interests of the shareholders and
the Fund, cancel the first valuation and carry out a second valuation with prudence and in good faith.
27.2 Determination of assets and liabilities
Subject to compliance with Lux GAAP, or as may otherwise be agreed with the Auditors, the assets and liabilities of
the Fund shall be determined in the following manner:
27.2.1 The assets of the Fund shall include:
a) shares in the Master Fund;
b) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
36174
L
U X E M B O U R G
c) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of properties, property rights, se-
curities or any other assets sold but not delivered);
d) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-
rants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Fund (provided
that the Manager may make adjustments in a manner with regard to fluctuations in the market value of securities caused
by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
e) stock dividends, cash dividends and cash payments receivable (including drawn but unpaid capital) by the Fund to
the extent information thereon is reasonably available to the Fund;
f) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Fund except to the extent that the same is included
or reflected in the value attributed to such asset;
g) the formation expenses of the Fund, including the cost of issuing and distributing Shares of the Fund, insofar as the
same have not been written off; and
h) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
Subject to compliance with Lux GAAP, or as may otherwise be agreed with the Auditors, the value of such assets shall
be determined as follows:
The value of the Master Fund Investments shall be determined by reference to the net asset value of such Master Fund
Investments as most recently reported by the Master Fund.
The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable (including VAT receivables),
prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the
full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof
is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
All other securities and other assets, including debt securities and securities for which no market quotation is available,
are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by a pricing service approved by the Board or the Manager or,
to the extent such prices are not deemed to be representative of market values, such securities and other assets shall
be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Manager. Money market
instruments held by the Fund with a remaining maturity of 90 days or less will be valued by the amortised cost method,
which approximates market value.
The value of all assets and liabilities not expressed in U.S. Dollar will be converted into such currency at the relevant
rates of exchange ruling on the relevant Valuation Date. If such quotations are not available, the rate of exchange will be
determined with prudence and in good faith by or under procedures established by the Manager.
The Manager may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects
the fair value of any asset of the Fund.
27.2.2:
Subject to compliance with Lux GAAP, or as may otherwise be agreed with the Auditors and subject to Article 27.2.3,
the liabilities of the Fund shall include:
a) all loans and other indebtedness for borrowed money (including convertible debt), bills and accounts payable;
b) all accrued interest on such loans and other indebtedness for borrowed money (including accrued fees for com-
mitment for such loans and other indebtedness);
c) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, advisory fees, custodian fees, and domiciliary
and corporate agents' fees);
d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or in
respect of property, including the amount of any unpaid distributions declared by the Fund, where the Valuation Date
falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
e) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from
time to time by the Board, as well as such amount (if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in
respect of any contingent liabilities of the Fund, provided, for the avoidance of doubt, that such provision shall include
any deferred taxation calculated as if the relevant real estate had been directly or indirectly realised on the relevant
Valuation Date in a manner determined from time to time in the discretion of the Board; and
f) all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law and Lux
GAAP. In determining the amount of such liabilities, the Fund shall take into account all expenses payable by the Fund.
The Fund may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount
rateably for yearly or other periods.
27.2.3 For the purpose of this Article 27:
(i) Shares to be issued by the Fund shall be treated as being in issue as from the date the relevant amount is paid
pursuant to a Drawdown and from such time and until received by the Fund the price therefore shall be deemed to be
a debt due to the Fund;
36175
L
U X E M B O U R G
(ii) All Investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than U.S. Dollar shall be valued after
taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset
Value; and
(iii) Subject to compliance with Lux GAAP, or as may otherwise be agreed with the Auditors, where on any Valuation
Date the Fund has contracted to:
a) purchase unconditionally any asset, the value of the consideration to be paid and any costs associated with such
asset on the relevant Valuation Date shall be shown as a liability of the Fund and the value of the asset to be acquired
less any costs associated with the asset on the relevant Valuation Date shall be shown as an asset of the Fund; or
b) sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Fund
and the asset to be delivered by the Fund shall not be included in the assets of the Fund;
provided, however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Date, then its value shall be estimated by the Manager in good faith.
27.2.4 For the avoidance of doubt, the provisions of this Article 27 (including, in particular, Article 27.2.3 hereof) are
rules for determining the Net Asset Value per Share and are not intended to affect the treatment for accounting or legal
purposes of the assets and liabilities of the Fund or any Shares issued by the Fund.
27.2.5 Subject to any decision of the Board to the contrary, every decision of the Manager with regard to the deter-
mination of the Net Asset Value (and for the avoidance of doubt, the Manager may amend, in its sole discretion, any
decisions made by service providers appointed by the Board or the Manager) will be final and binding on the Fund as well
as for all current, former and future shareholders, provided that there is no violation of the principle of good faith, no
gross negligence or no obvious error at hand.
27.3 Appointment of Depositary
The Fund and the Manager shall appoint a depositary in relation to the supervision, deposit and safekeeping of the
assets of the Fund in accordance with the 2007 Law and the AIFM Law.
Where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and
there are no local entities that are subject to effective prudential regulation and supervision as well as external periodic
audit, the depositary can discharge itself of liability provided that the conditions laid down in the AIFM Law are met and
subject to the terms of the depositary agreement between the Fund, the Manager and the depositary.
Art. 28. Frequency and temporary suspension of calculation of Net Asset Value.
28.1 Frequency of calculation
The Net Asset Value per Share of a respective Share Class shall be calculated by the Central Administration Agent
based on the Net Asset Value as at the Valuation Date. Where the Net Asset Value is calculated at the initiative of the
shareholder, the costs related to such additional calculation of Net Asset Value will be borne by such shareholder.
28.2 Temporary suspension
The Board may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue of Shares:
a) in the event that the determination of the net asset value of the Master Fund has been suspended;
b) during any period when one or more exchanges which provide the basis for valuing a substantial portion of the
assets of the Fund are closed or if dealings therein are restricted or suspended or where trading is restricted or suspended;
c) during any period when, as a result of the political, economic, military, terrorist or monetary events or any cir-
cumstance outside the control, responsibility and power of the Board, disposal of the assets of the Fund is not reasonably
practicable without materially and adversely affecting and prejudicing the interests of shareholders or if, in the opinion of
the Board, a fair price cannot be determined for the assets of the Fund;
d) in the case of a breakdown of the means of communication normally used for valuing any asset of the Fund which
is material or if for any reason the value of any asset of the Fund which is material in relation to the Net Asset Value (as
to which the Board shall have sole discretion) may not be determined as rapidly and accurately as required;
e) if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of
the Fund are rendered impracticable, or if purchases, sales, deposits and withdrawals of the assets of the Fund cannot be
effected at the normal rates of exchange;
f) when the value of a substantial part of the assets of any consolidated subsidiary of the Fund may not be determined
accurately;
g) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of considering a
resolution to wind up the Fund; or
h) when for any other reason, the prices of any Investments or Master Fund Investments cannot be promptly or
accurately determined.
The Board shall give notice of any such suspension to the shareholders.
Art. 29. Issue Price. Shares will be issued at a fixed price of U.S. Dollar 10 (the “Issue Price”).
After the Initial Closing Date, shareholders shall pay for the subscription of new Shares, the Issue Price plus any charges
or fees as may be decided by the Board from time to time and described in Article 7 of these Articles of Association.
36176
L
U X E M B O U R G
Art. 30. Auditor. The shareholders’ meeting of the Fund will appoint an auditor (“réviseur d'entreprise agréé”) who
will perform such duties vis-à-vis the Fund as described in Article 55 of the 2007 Law.
Art. 31. Financial year. The financial year of the Fund shall begin on 1 January of each year and end on 31 December
provided that (i) the first financial year of the Fund, shall commence on the date of incorporation of the Fund and end on
31 December 2015; and (ii) the last financial year of the Fund will end on the date on which the winding up of the Fund
is completed.
The accounts of the Fund shall be expressed in U.S. Dollar. The annual accounts, including the balance sheet and profit
and loss account, the Directors report and the notice of the annual general meeting will be sent and/or published and
made available in accordance with applicable law.
Art. 32. Balance-sheet. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board will produce an
inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the 1915 Law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to each of the shareholders
for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may consult the financial documents at the registered office of the Fund.
Art. 33. Distribution of income. The general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board, subject
to any interim distributions having been declared or paid, determine how the annual net investment income shall be
disposed of.
Interim distributions may, at the discretion of the Board and in accordance with the PPM, be declared subject to such
further conditions as set forth by law, and be paid out on the Shares out of the income of assets upon decision of the
Board.
Distributions may include an allocation from a dividend equalisation account which, in such event, will be credited
upon issue of Shares to such dividend equalisation account and upon redemption of Shares, the amount attributable to
such Share will be debited to an accrued income account.
The distributions declared, if any, will normally be paid in U.S. Dollar, in the currency of the relevant Share Class or
in such other currencies as selected by the Board and may be paid at such places and times as may be determined by the
Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend monies into
the currency of their payment. Stock dividends may be declared.
Distributions may be made in kind to the extent permitted in the PPM.
If and to the extent set forth in the PPM, distributions made to shareholders may be subject to a clawback obligation,
allowing the Board to call back the respectively distributed assets.
Any distributions to shareholders that were declared by the Fund but for any reasons cannot be paid, may not be
claimed after five (5) years and will then be attributed to the respective Share Class or to the Fund. No interest will be
paid on distributions declared by the Fund.
Distributions may not be made if pursuant to such distribution the Fund’s minimum capital would fall below the
statutory minimum capital.
Art. 34. Dissolution and liquidation. The decision to dissolve the Fund may be validly adopted only with the consent
of a majority of shareholders representing three quarters (75%) of the Fund's corporate capital.
Upon dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by the Manager or by one or several other liquidators
(who may be physical persons or legal entities) (together with the Manager the “Liquidators”) named by the meeting of
shareholders resolving to commence such dissolution and which shall determine their powers and theirfees. The net
proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares relating in proportion of their
holding of Shares, and subject to the specifities of each Share Class, as set forth in the PPM.
Moneys available for distribution to shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by shareholders
will at the close of liquidation be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance with the 2007
Law.
If at any time the capital of the Fund falls below two thirds of the minimum capital required by Luxembourg law, the
Board must submit the question of dissolution of the Fund to a general meeting of shareholders acting, without quorum
requirements, by a simple majority decision of the Shares present or represented at such meeting.
Art. 35. General. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with applicable law.
<i>Transitional provisionsi>
The Fund’s first financial year shall begin on the date of the Fund’s incorporation and shall end on 31 December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Shares to be issued have been subscribed and paid-in in cash by BlackRock UK 4 LLP, aforementioned, which has
paid-in fifty thousand U.S. Dollars (USD 50,000.-) and subscribed for five thousand (5,000.-) Share(s).
36177
L
U X E M B O U R G
All the Shares have been entirely paid-in in cash, so fifty thousand U.S. Dollars (USD 50,000.-) is as of now available
to the Fund, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand five hundred Euro (EUR
1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
BlackRock UK 4 LLP, aforementioned, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly conve-
ned, has immediately passed the following resolutions:
1. The number of members of the board of directors is fixed at four (4).
2. The following persons are appointed managers of the Fund with immediate effect and for an unlimited period of
time:
a. Mrs Audrey Jane Lewis, born on 28 August 1968 in Glasgow, United Kingdom, with professional address at 25, rue
du Schlammestee, L-5770 Weiler la Tour, Luxembourg;
b. Mr Hugo Johannes Leopold Neuman, born on 21 October 1960 in Amsterdam, the Netherlands, with professional
address at 16, rue J.B. Fresez, L-1542 Luxembourg, Luxembourg;
c. Mr Gregory John Lapham, born on 12 July 1967 in Brisbane, Australia, with professional address at 2, Queen’s Road
Central, Cheung Kong Centre, Hong Kong, China 1072; and
d. Mr Maxence Philippe Alexis Monot, born on 8 December 1976 in Dijon, France, with professional address at 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Luxembourg.
3. The following entity is appointed as approved auditor of the Fund with immediate effect and for an unlimited period
of time, but may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders:
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 65.477, 2, rue Gerhard Mercator, B.P.
1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4. The address of the Fund’s registered office is set at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
the notary, this original deed.
Signé: M. Sene, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 31 décembre 2014. REM/2014/2913. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 11 février 2015.
Référence de publication: 2015024786/623.
(150028512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Maptaq Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 171.104.
Im Jahre zweitausendfünfzehn am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul MEYERS, mit dem Amtssitz in Rambrouch.
Fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der MAPTAQ Europe
S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Lu-
xemburg gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, und
mit Gesellschaftssitz in 9, rue Enz, L-5532 Remich, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg
unter Nummer B171104 statt.
Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Wei Zhang, beruflich ansässig in Helmsange, welcher Kevin Chaves
beruflich ansässig in Helmsange zum Sekretär bestellt.
Die Generalversammlung bestellt Kevin Chaves beruflich ansässig in Kevin Chaves zum Stimmenzähler.
36178
L
U X E M B O U R G
Da somit der Versammlungsrat bestellt ist, stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Fol-
gendes fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilsverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den
Aktionären bzw. deren Vertretern sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, der Stimmenzähler und dem unterzeich-
neten Notar unterschrieben.
Die von den Aktionären ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert
beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
II. Der Versammlungsrat und dessen Stimmenzähler stellen fest dass sämtliche einunddreißig tausend (31.000) Aktien,
welche das gesamte Gesellschaftskapital (100%) darstellen sind in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten. Die so
anwesenden Aktionäre erklären sich ordnungsgemäß zu der gegenwärtigen Versammlung eingeladen und verzichten auf
die Einhaltung weiterer Formalitäten. Somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
III. Die TAGESORDNUNG der Generalversammlung ist folgende:
1. Abänderung der Gesellschaftssatzung zwecks Einräumung der Möglichkeit eines einzigen Aktionärs welcher alle
Aktien besitzt, und dass somit die Gesellschaft in diesem Fall durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden kann.
2. Dementsprechende Umgestaltung des Artikels 4 der Gesellschaftssatzung wie folgt:
Art. 4. Wenn und solange ein Aktionär alle Aktien besitzt, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter
(hiernach anhaltend auch „der Verwaltungsrat“) verwaltet werden, der kein Aktionär sein muss, welcher von dem allei-
nigen Aktionär für eine Dauer ernannt wird, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, und der von dem alleinigen Aktionär
jederzeit abberufen werden kann.
Wenn und solange zwei oder mehrere Aktionäre alle Aktien besitzen, wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat
verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalver-
sammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten
verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige
Wahl durch die nächste Generalversammlung.“
3. Dementsprechende Umgestaltung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung wie folgt:
„ Art. 5. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, alle Handlungen vor-
zunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem
anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder ferns-
chriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung
sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder (Delegierte des
Verwaltungsrates), Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Ak-
tionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des einzigen Verwalters oder durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der
ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch
die Einzelunterschrift eines Verwalters des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Die oder der Delegierte können/kann zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt werden, welche unmit-
telbar nach der Gründung stattfindet.“
4. Verlegung des Gesellschaftssitzes.
5. Verschiedenes.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
36179
L
U X E M B O U R G
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 4 der Gesellschaftssatzung abzuändern und welcher demnach fortan fol-
genden Wortlaut haben wird:
„ Art. 4. Wenn und solange ein Aktionär alle Aktien besitzt, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter
(hiernach anhaltend auch „der Verwaltungsrat“) verwaltet werden, der kein Aktionär sein muss, welcher von dem allei-
nigen Aktionär für eine Dauer ernannt wird, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, und der von dem alleinigen Aktionär
jederzeit abberufen werden kann.
Wenn und solange zwei oder mehrere Aktionäre alle Aktien besitzen, wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat
verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalver-
sammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten
verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige
Wahl durch die nächste Generalversammlung.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5 der Gesellschaftssatzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
Art. 5. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzu-
nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des
Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem
anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder ferns-
chriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung
sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder (Delegierte des
Verwaltungsrates), Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Ak-
tionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des einzigen Verwalters oder durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der
ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch
die Einzelunterschrift eines Verwalters des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Die oder der Delegierte können/kann zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt werden, welche unmit-
telbar nach der Gründung stattfindet.“
Die übrigen Artikel der Gesellschaftssatzung bleiben unberührt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft an folgende Adresse zu verlegen: 16a, route de l’Europe
L-5531 Remich.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen zu Helmsange, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung des Vorgeschehenen an die Komparenten, welche dem unterzeichneten Notar durch
Familiennamen, Vornamen, Zivilstatus und Wohnort bekannt sind, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegen-
wärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: Zhang, Chaves, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1501. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
36180
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 09 février 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015024460/129.
(150027896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
MGE Vernon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 121.951.
In the year two thousand and fifteen, the thirteenth day of January.
The undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED
MGE Vernon LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at
1209 Orange Street, Wilmington, county of New Castle, Delaware 19801, (United States of America), registered in the
Division of Corporations in the State of Delaware under number 4214405,
here represented by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally in Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of the attached proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, through its proxy-holder, declared and requested the notary to act:
that the appearing party is the sole partner of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
MGE Vernon S.à r.l., having its registered office at L-2453 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), 19, rue Eugène
Ruppert, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 121.951 (the Company),
incorporated by deed of the undersigned notary, on November 3, 2006, published in the Mémorial C number 31 of
January 23, 2007 and whose articles of association have been amended by deed of Maître Francis KESSELER, notary
residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), on March 2, 2011, published in the Mémorial C number 1084
of May 23, 2011,
and that the appearing party has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present meeting, the meeting waives the convening
notices, the partner represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
Article 12 of the articles of association of the Company is amended and will have henceforth the following wording:
" Art. 12. The Company shall be managed by one or more managers. The managers need not be partners. If several
managers are appointed, they shall constitute the board of managers consisting of A managers and of B managers unless
agreed otherwise by the partners.
In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The managers are ap-
pointed by the partners who fix the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the partners.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
Company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the Company shall be validly bound towards third parties in all other matters by the
joint signatures of A manager together with B manager.".
<i>Third resolutioni>
The mandates of manager and chairman of the board of managers of Mr. Richard Michael LEE for an unlimited period
are confirmed and the class A is attributed to the latter.
<i>Fourth resolutioni>
The mandate of manager of Mr. John RALSTON for an unlimited period is confirmed and the class A is attributed to
the latter.
36181
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The mandate of manager of Mr. Marc BAUWENS for an unlimited period is confirmed and the class A is attributed to
the latter.
<i>Sixth resolutioni>
The following persons are appointed, for an unlimited period, as B managers:
<i>B managers:i>
- Mr. Ludovic TROGLIERO, born on June 8, 1979 in Clichy-la-Garenne (France), residing professionally at L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert;
- Mr. David CATALA, born on January 19, 1979 in Ghent (Belgium), residing professionally at L-2453 Luxembourg, 6,
rue Eugène Ruppert;
- Mr. Hugo FROMENT, born on February 22, 1974 in Laxou (France), residing professionally at L-2453 Luxembourg,
6, rue Eugène Ruppert;
- Mr. Joé GREIS, born on January 26, 1986 in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), residing professionally at
L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert;
- Mr. Robert HESSING, born on August 14, 1966 in Apeldoorn (The Netherlands), residing professionally at L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert;
- Ms. Miroslava JASSOVA, born on July 15, 1988 in Dolny Kubin (Slovakia), residing professionally at L-2453 Luxem-
bourg, 6, rue Eugène Ruppert.
<i>Seventh resolutioni>
The number of managers is increased from 3 (three) to 9 (nine).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately EUR 950.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, the proxy-holder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois du janvier.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU
MGE Vernon LLC, une société régie par les lois du Delaware, dont le siège social se situe au 1209 Orange Street,
Wilmington, county of New Castle, Delaware 19801, (Etats-Unis d’Amérique), enregistrée auprès de la «Division of
Corporations» de l’Etat de Delaware sous le numéro 4214405,
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d’une procuration attachée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
que la comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée MGE Vernon S.à r.l. ayant son siège à
L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 19, rue Eugène Ruppert, et enregistrée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.951 (la Société), constituée par acte du notaire ins-
trumentant, le 3 novembre 2006, publié au Mémorial C n° 31 du 23 janvier 2007 et dont les statuts ont été modifiés par
acte de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Eschsur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 2 mars 2011,
publié au Mémorial C n° 1084 du 23 mai 2011,
et que la comparante a pris les résolutions suivantes:
36182
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant représenté à l’assemblée, l’assemblée renonce aux convocations d’usage, l’associée
se considère valablement convoquée et déclare avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué en
avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’article 12 des statuts de la Société se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance composé de gérants de classe A et de gérants
de classe B, sauf s’il en a été convenu autrement par les associés.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par les
associés, fixant la durée de leur mandate. Ils sont librement et à tout moment révocables par les associés.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la Société sera
valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagé envers les tiers en toutes circonstances par la signature
conjointe d’un gérant de classe A ensemble avec un gérant de classe B.».
<i>Troisième résolutioni>
Les mandats de gérant et de président du conseil de gérance de Monsieur Richard Michael LEE pour une durée
indéterminée sont confirmés et la classe A est attribué à ce dernier.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat de gérant de Monsieur John RALSTON pour une durée indéterminée est confirmé et la classe A est attribué
à ce dernier.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat de gérant de Monsieur Marc BAUWENS pour une durée indéterminée est confirmé et la classe A est
attribué à ce dernier.
<i>Sixième résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées, pour une durée indéterminée, comme gérants de classe B:
<i>Gérants de classe B:i>
- Monsieur Ludovic TROGLIERO, né le 8 juin 1979 à Clichy-la-Garenne (France), demeurant professionnellement à
L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert;
- Monsieur David CATALA, né le 19 janvier 1979 à Gand (Belgique), demeurant professionnellement à L-2453 Lu-
xembourg, 6, rue Eugène Ruppert;
- Monsieur Hugo FROMENT, né le 22 février 1974 à Laxou (France), demeurant professionnellement à L-2453 Lu-
xembourg, 6, rue Eugène Ruppert;
- Monsieur Joé GREIS, né le 26 janvier 1986 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant profession-
nellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert;
- Monsieur Robert HESSING, né le 14 août 1966 à Apeldoorn (Pays-Bas), demeurant professionnellement à L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert;
- Madame Miroslava JASSOVA, née le 15 juillet 1988 à Dolny Kubin (Slovaquie), demeurant professionnellement à
L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert;
<i>Septième résolutioni>
Le nombre des gérants est augmenté de 3 (trois) à 9 (neuf).
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ 950,- EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
36183
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, le mandataire de la comparante a signé
avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 janvier 2015. Relation GAC/2015/481. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015024471/154.
(150027545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Seris Security S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Seris Security S.A.).
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 173.216.
Parlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 192.594.
L’an deux mille quinze, le vingt février.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
(1) Le conseil de gérance de Parlux S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.594 (la «Société Absorbée»), et
(2) Le conseil de gérance de Seris Security S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.216 (la «Société Absorbante»),
Tous deux représentés par M. Guy Tempereau, administrateur de sociétés, demeurant au 220 rue du jardin secret,
Domaine Juan Flore, 06160 Juan Les Pins (France), agissant en sa qualité de gérant de la Société Absorbée et de la Société
Absorbante.
La Société Absorbée et la Société Absorbante sont désignées ci-après collectivement comme les Sociétés.
ATTENDU QUE
(A) La Société Absorbante est détenue entièrement par la Société Absorbée, qui est ellemême détenue par SoNoux
Sprl, Kyazi Sprl, Keneva Sprl et CoSb Sprl, quatre sociétés privées à responsabilité limitée de droit belge, ayant leur siège
social à rue Père Eudore Devroye 43, 1040 Bruxelles (Belgique) (les «BelCos»).
(B) Les Sociétés proposent que la Société Absorbée fusionne dans la Société Absorbante par le biais d’une fusion par
absorption ayant pour effet le transfert ipso jure de l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée à la Société
Absorbante (la «Fusion»).
(C) Le conseil de gérance de la Société Absorbée et le conseil de gérance de la Société Absorbante (ensemble les
«Organes de Gestion») ont décidé d’établir un projet commun de fusion (le «Projet de Fusion»). Le Projet de Fusion
propose de soumettre la Fusion aux dispositions des articles 261 et suivants (les «Articles de la Loi») de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée («la Loi»).
(D) Le conseil de gérance de la Société Absorbée a approuvé le Projet de Fusion le 20 février 2015.
(E) Le conseil de gérance de la Société Absorbante a approuvé le Projet de Fusion le 20 février 2015.
SUR CE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
1. Caractéristiques des Sociétés: article 261 de la Loi.
(a) La Société Absorbée est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 192.594.
La Société Absorbée a été constituée pour une durée illimitée le 18 novembre 2014, en vertu d’un acte de Maître
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 9 du 2 janvier 2015. Les statuts de la Société Absorbée ont été
modifiés une fois par un acte notarié du notaire instrumentant, le 20 février 2015, lequel acte n’a pas encore été publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le capital social de la Société Absorbée s’élève actuellement à deux millions trois cent quarante et un mille neuf cents
euros (EUR 2.341.900), représenté par vingt-trois mille quatre cent dix-neuf (23.419) parts sociales, d'une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
36184
L
U X E M B O U R G
Les parts sociales de la Société Absorbée sont toutes souscrites et entièrement libérées.
(b) La Société Absorbante est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 173.216.
La Société Absorbante a été constituée pour une durée illimitée le 9 novembre 2012, en vertu d’un acte de Maître
Martine Schaeffer, précitée, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
115 du 17 janvier 2013. Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par
un acte notarié du notaire instrumentant, le 20 février 2015, lequel acte n’a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
Le capital social de la Société Absorbante s’élève actuellement à cinq cent mille euros (EUR 500.000.-), représenté par
cinq mille (5.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.
Les parts sociales de la Société Absorbante sont toutes souscrites et entièrement libérées.
2. Transfert universel des actifs et passifs: article 259 de la Loi.
- Conformément aux Articles de la Loi, la Société Absorbée transfèrera la totalité de ses actifs et passifs (connus ou
inconnus) (les «Actifs et Passifs») à titre universel à la Société Absorbante, par effet de la loi et sans aucune exception ou
réserve de manière à ce qu’à la Date d’Effet (tel que définie ci-dessous) i) tous les actifs de la Société Absorbée soient
acquis par la Société Absorbante et soient la propriété de la Société Absorbante, ii) la Société Absorbante assumera tous
les passifs et obligations de la Société Absorbée, sous réserve toutefois, nonobstant ce qui précède, que (a) les montants
dus entre la Société Absorbée et la Société Absorbante seront annulés sans contrepartie, (b) les parts sociales dans la
Société Absorbante détenues par la Société Absorbée immédiatement avant la Fusion, soit toutes les parts sociales émises
et en circulation de la Société Absorbante, seront annulées en conformité avec la clause 4 ci-dessous et (c) la Société
Absorbée cessera d’exister sans liquidation. Les Actifs et Passifs de la Société Absorbée seront évalués à leur valeur
comptable.
- Pour éviter tout doute, il est confirmé que les activités de la Société Absorbée transférées à la Société Absorbante
seront poursuivies par la Société Absorbante.
3. Date d’effet de l'Apport: articles 272 et 273 de la Loi.
- Sur le plan comptable, la Fusion aura un effet rétroactif au 1
er
janvier 2015 (la «Date d’Effet Comptable»).
- Vis-à-vis des Sociétés, la Fusion prendra effet à la date de la notarisation du procès-verbal de la dernière des assemblées
générales des associés de la Société Absorbée et de l'associé unique de la Société Absorbante, devant se tenir par-devant
notaire au Luxembourg, conformément à l'article 272 de la Loi, durant le mois de mars 2015 ou à toute date ultérieure
de l'année 2015 (la «Date d’Effet»).
- A la Date d’Effet, mais sans porter préjudice à la Date d’Effet Comptable, le transfert des Actifs et Passifs de la Société
Absorbée à la Société Absorbante devrait s’opérer par application de la loi, tel que décrit à la clause 2 ci-dessus.
- Vis-à-vis des tiers, la Fusion produira effet à la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du procès-verbal de la dernière des assemblées générales des associés de la Société Absorbée et de l'associé unique de
la Société Absorbante, devant se tenir par-devant notaire au Luxembourg, conformément à l'article 272 de la Loi, durant
le mois de mars 2015 ou à toute date ultérieure de l'année 2015 (les «Assemblées») (article 273 de la Loi).
4. Rapport d’échange des parts sociales: article 261 (2) b) de la Loi.
Les Organes de Gestion de chacune des Sociétés se sont basés sur les bilans intérimaires au 31 décembre 2014 et les
écritures qui s’en sont suivies évaluant les actifs nets des Sociétés à leur valeur comptable comme suit:
- Société Absorbée: deux millions trois cent trente-sept mille huit cent cinq euros et quatorze cents (EUR 2.337.805,14)
au moment de la signature du Projet de Fusion; et
- Société Absorbante: deux cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-sept euros et trente-six cents (EUR
254.967,36).
Sur cette base, le rapport d’échange des parts sociales prévoit qu’en contrepartie de toutes les vingt-trois mille quatre
cent dix-neuf (23.419) parts sociales émises et en circulation ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune
dans le capital social de la Société Absorbée détenues par les BelCos avant la Date d’Effet, vingt-trois mille quatre cent
dix-neuf (23.419) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune seront émises
par la Société Absorbante et attribuées aux Belcos (les «Nouvelles Parts Sociales»), comme suit:
(i) deux mille trois cent quarante-quatre (2.344) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune, seront émises par la Société Absorbante et attribuées à SoNoux Sprl;
(ii) sept mille vingt-cinq (7.025) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, seront
émises par la Société Absorbante et attribuées à Kyazi Sprl;
(iii) sept mille vingt-cinq (7.025) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, seront
émises par la Société Absorbante et attribuées à Keneva Sprl;
(iv) sept mille vingt-cinq (7.025) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, seront
émises par la Société Absorbante et attribuées à CoSb Sprl;
36185
L
U X E M B O U R G
ensemble avec une réserve libre totale de trois cent vingt mille euros (EUR 320.000) (le «Rapport d’Echange des
Parts»).
A la Date d’Effet, (i) les parts sociales émises et en circulation dans le capital social de la Société Absorbée seront
automatiquement annulées par l'effet de la Fusion, (ii) les BelCos deviendront les associés de la Société Absorbante par
la détention des Nouvelles Parts Sociales et (iii) les parts sociales de la Société Absorbante détenues par la Société
Absorbée immédiatement avant la Fusion seront automatiquement annulées par l'effet de la Fusion et par conséquent
aucune contrepartie ne sera émise au profit de la Société Absorbée à cet égard.
5. Rémunération de la Fusion: article 261 (2) c), d) et f) de la Loi. Les Nouvelles Parts Sociales seront émises lors de
la Date d’Effet.
Les Nouvelles Parts Sociales seront considérées comme étant remises aux BelCos à la Date d’Effet et permettront à
leurs détenteurs de bénéficier des distributions de dividendes dans les conditions prévues par les statuts de la Société
Absorbante à compter de la Date d’Effet.
Les Nouvelles Parts Sociales seront soumises aux dispositions des statuts de la Société Absorbante.
Aucun droit spécial n’est attaché aux Nouvelles Parts Sociales et il n’y a aucun détenteur d’obligations autres que des
parts sociales ou de tout autre droit dans la Société Absorbée et dans la Société Absorbante.
6. Jouissance des Actifs et Passifs.
(a) Jouissance La Société Absorbante deviendra la détentrice et prendra possession des Actifs et Passifs et des droits
et obligations liés qui lui sont cédés dans le cadre de la Fusion à compter de la Date d’Effet.
Jusqu’à la Date d’Effet, la Société Absorbée accepte de gérer les Actifs et Passifs selon les mêmes principes, règles et
dans les mêmes conditions que précédemment, sans contracter d’engagement substantiel susceptible d’augmenter le passif
de façon significative ni d’engagements susceptibles de nuire à la propriété ou à la cessibilité des éléments d’actifs.
(b) Conditions générales La Fusion est acceptée sous réserve des conditions générales suivantes:
(i) La Société Absorbante prendra les Actifs et Passifs de la Société Absorbée dans leur consistance et leur état lors
de la Date d’Effet, sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit, pour quelque cause que ce soit, contre la Société
Absorbée.
(ii) La Société Absorbante se substituera purement et simplement à la Société Absorbée dans tous les droits et obli-
gations.
(iii) La Société Absorbante supportera tous impôts, contributions ainsi que toutes les charges quelconques, dues ou
dont pourrait être redevable la Société Absorbée.
(iv) A la Date d’Effet, la Société Absorbante disposera de tous pouvoirs à la place de la Société Absorbée, afin d’initier
des procédures judiciaires et d’arbitrage, et d’approuver, recevoir et payer tous montants relatifs à de telles procédures.
(v) La Société Absorbante assumera le règlement des dettes de la Société Absorbée, conformément aux conditions
stipulant leurs modalités de remboursement, ainsi qu’au paiement de tous intérêts et plus généralement au respect des
conditions de tout emprunt ou autres instruments de dette pouvant exister.
(vi) La Société Absorbante bénéficiera de tout paiement effectué en vertu de créances dont la Société Absorbée était
titulaire, conformément aux conditions stipulant leurs modalités de remboursement, et plus généralement la Société
Absorbante s’engage à respecter les conditions de toute créance détenue par la Société Absorbée pouvant exister.
(vii) La Société Absorbante se conformera à toutes lois, règlements et usages applicables aux Actifs et Passifs.
(c) Remise de la documentation
A la Date d’Effet, tous actes, toute modification, tous contrats/conventions de quelque nature que ce soit, ainsi que
tous livres comptables et archives y relatives et tous autres documents comptables, titres de propriété ou acte justificatifs
de propriété de tous les éléments d’actif, documents justificatifs des opérations réalisées, valeur mobilière ainsi que tous
contrats, archives, bons et autres documents quelconques relatifs aux éléments d’actifs et droits apportés relatifs aux
Actifs et Passifs cédés seront remis à la Société Absorbante.
7. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 266 de la Loi, aux membres des organes de gestion
ainsi qu’aux commissaires aux comptes des Sociétés (article 261 (2) g) de la Loi).
- Aucun avantage particulier n’est accordé aux gérants des Sociétés en relation avec la Fusion.
- Aucun avantage particulier n’est attribué au réviseur d’entreprises agréé des Sociétés en relation avec la Fusion.
- Comme détaillé à la clause 8, aucun expert n’est impliqué dans la Fusion.
8. Rapport détaillé d’expert (article 266 de la Loi).
- Conformément à l'article 266 (5) de la Loi, les associés de la Société Absorbée et l'associé unique de la Société
Absorbante ont décidé le 20 février 2015 (i) que le Projet de Fusion ne fera pas l'objet d’un examen par des experts
indépendants et (ii) que le rapport d’expert mentionné à l'article 266 de la Loi ne sera pas requis.
36186
L
U X E M B O U R G
9. Consultation des documents. Conformément à l'article 267 (1) b) et c) de la Loi, les documents suivants sont
disponibles gratuitement aux associés de la Société Absorbée et à l'associé unique de la Société Absorbante au siège social
respectif des Sociétés à compter de la date des présentes et au minimum un mois avant la date des Assemblées:
(a) le Projet de Fusion;
(b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la Société Absorbante;
(c) les bilans intérimaires au 31 décembre 2014;
(d) les rapports rédigés par les Organes de Gestion expliquant et justifiant d’un point de vue juridique et économique
la Fusion, mentionnés à l'article 265 de la Loi.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné certifie la légalité du présent Projet de Fusion.
<i>Frais et dépensesi>
Tous frais, droits et honoraires qui résultent de l'Apport seront pris en charge par la Société Absorbante.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date mentionnée qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état civil et demeure, ils ont
signé avec Nous, notaire, le présent acte original.
Signé: Tempereau, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 février 2015. Relation: EAC/2015/4482. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015041936/180.
(150047230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Orion Engineered Carbons S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 160.558.
The Board of Directors (the “Board of Directors”) of Orion Engineered Carbons S.A., a société anonyme with a
registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 160.558, and with a total number of 59,365,126
shares (the “Common Shares”), of which all are entitled to vote (the “Company”), hereby convenes, in accordance with
the provisions of article 10 of the articles of association of the Company, two general meetings of Shareholders (the
“General Meetings”):
The ANNUAL GENERAL MEETING
of the Shareholders (first general meeting) will be held through private deed and convene on Wednesday <i>April 15,i>
<i>2015i> at 10:00 A.M. CET, at the offices of Arendt & Medernach SA at:
8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and will have the following agenda (the “Annual General Meeting”):
<i>Agenda of the Annual General Meeting:i>
1. Presentation of the management report by the Board of Directors and the reports of the independent auditor of
the Company in relation to the annual accounts and the consolidated financial statements of the Company for the
financial year ended on December 31, 2014.
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended on December 31, 2014.
3. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December 31,
2014.
4. Allocation of results, approval of the payment by the Company on December 22, 2014 of the interim dividend in
the amount of EUR 40 million and approval of a distribution of a dividend in the aggregate amount of EUR 10 million
in the second quarter of 2015.
5. Discharge of the Board of Directors and of the independent auditor of the Company for the financial year ended
on December 31, 2014.
6. Appointment of an independent auditor of the Company (Réviseur d'Entreprises) for the purposes of the annual
accounts and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December 31,
2015.
7. Decisions on the compensation that shall be paid to the Board of Directors for the time period until the next annual
general meeting.
36187
L
U X E M B O U R G
The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Shareholders (second general meeting) will be held through notary deed and convene on Wednesday <i>April 15,i>
<i>2015i> at 1:30 P.M. CET, at the offices of
Arendt & Medernach SA at
8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and will have the following agenda (the “Extraordinary General Meeting”):
<i>Agenda of the Extraordinary General Meeting:i>
1. Change of the Company's registered office from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Nie-
deranven, Grand Duchy of Luxembourg.
2. Amendment of article four of the articles of association of the Company to effect the change in the location of the
Company's registered office.
<i>Important information concerning procedures for attendance and voting at the General Meetings, the record date for the Generali>
<i>Meetings and other relevant matters relating to the General Meetings is set forth in this convening notice below. You are urged to
read the following pages carefully and to follow the procedures set forth herein for casting your vote at the General Meetings.i>
Orion Engineered Carbons S.A.
<i>The Board of Directorsi>
Procedures for Voting and Attendance at the General Meetings
The Company urges you to cast your vote at the General Meetings by completing, signing, dating and returning the
proxies made available by the Company for use at the General Meetings in accordance with the instructions below.
Only holders of record of the Common Shares outstanding on March 9, 2015 (the “Record Date”) at 11:59 P.M. CET
are entitled to attend and vote at the General Meetings.
Each Shareholder is entitled to one vote per share for each Common Share held of record by such Shareholder as of
the Record Date, on each matter submitted to a vote at the General Meetings. All Common Shares represented by
proxies duly executed and received by 11:59 P.M. CET on April 10, 2015 (the “Voter Deadline”) will be voted at the
applicable General Meeting in accordance with the terms of the proxies. If no choice is indicated on the proxy, the
proxyholders will vote in favour of all proposals described in this convening notice. If any other item is properly brought
on the Agenda on the Annual General Meeting and/or Extraordinary General Meeting under our Articles of Association
or Luxembourg law, the proxies will be voted in accordance with the best judgment of the proxyholders. In general, only
those items appearing on this convening notice and agenda for the Annual General Meeting can be voted on at the Annual
General Meeting. A Shareholder may revoke a proxy by submitting a document revoking it prior to the Voter Deadline,
by submitting a duly executed proxy bearing a later date prior to the Voter Deadline or by attending the applicable General
Meeting and voting in person.
If you hold your Common Shares through a bank, brokerage firm or other agent and do not give instructions to your
bank, brokerage firm or other agent as to how your shares should be voted at the General Meetings, the Common Shares
that you hold through a bank, brokerage firm or other agent will not be voted at the applicable General Meeting. We
therefore urge all Shareholders who hold their shares through a bank, brokerage firm or other agent to promptly vote
their Common Shares in accordance with the instructions provided by their bank, brokerage firm or other agent. You
may cast your vote at the General Meetings by marking, signing and dating the applicable proxy card and returning them
in the envelope we have provided or returning them in another envelope, postage prepaid, to American Stock Transfer
& Trust Company, LLC, 6201 15th Avenue, Brooklyn, New York 11219-9821 U.S.A. Proxy cards that are mailed must
be received by American Stock Transfer & Trust Company, LLC at the above address by no later than the Voter Deadline.
No postage is required for mailing of the enclosed envelope in the United States. We will bear the cost of soliciting
proxies in relation to the matters to be voted on at the General Meetings.
Some of our directors, executive officers and employees may solicit proxies in person or by mail, telephone, fax or
email, but will not receive any additional compensation for these services. We may reimburse brokers and others for
their reasonable expenses in forwarding proxy solicitation material to the beneficial owners of our Common Shares. We
may retain a proxy solicitation firm to assist in the solicitation of proxies for the General Meetings.
Each Shareholder of record who holds one or more Common Shares on the Record Date shall be admitted to par-
ticipate and vote in the General Meetings. A holder of Common Shares held through an operator of a securities settlement
system or recorded as book-entry interests in the accounts of a professional depositary, who wishes to attend the General
Meetings should receive from such operator or depositary a certificate certifying (i) the number of Common Shares
recorded in the relevant account on the Record Date and (ii) that such Common Shares are blocked until the closing of
the applicable General Meeting. The certificate should be submitted to the Company no later than the Voter Deadline.
If you plan to attend one or both General Meetings, you are kindly requested to notify the Company thereof before the
Voter Deadline in writing by post to the registered office of the Company located at 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, or by fax to +1-832-445-3335, or by email to investor-
36188
L
U X E M B O U R G
relations@orioncarbons.com. The Shareholders are kindly requested to provide their name, address and telephone
number and any other necessary materials.
Admittance of Shareholders and acceptance of written voting proxies shall be governed by Luxembourg law.
Right to Put Items on the Agendas of the General Meetings and to Table Draft Resolutions
One or more Shareholders of record holding at least 10% of the Common Shares may put items on the agenda of the
General Meetings, provided that each such item is accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted in
the General Meetings. If you plan to put items on the agenda of a General Meeting, you must notify the Company thereof
before April 8, 2015 in writing by post to Orion Engineered Carbons S.A. 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, or by fax to +1-832-445-3335, or by email to investor-relations@orioncarbons.com.
Shareholders are kindly requested to provide their name, address and telephone number.
Quorum/Majority
The Annual General Meeting will deliberate validly regardless of the number of Common Shares present or represented
by proxy.
Resolutions will be adopted by a simple majority of the votes validly cast at the Annual General Meeting.
The Extraordinary General Meeting will only deliberate validly if at least half of the share capital is present or repre-
sented. Should the quorum of half of the share capital not be met, then in accordance with article 67-1 of the Luxembourg
law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, a second extraordinary general meeting of Shareholders
may be convened, by means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and with the second notice
to be published fifteen (15) days before the meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the pro-
portion of the capital represented.
Resolutions will be adopted by a majority of at least two-thirds of the votes validly cast at the Extraordinary General
Meeting.
Documents
Copies of the full and unabridged text of the documents to be submitted to the General Meetings together with draft
resolutions proposed pursuant to agendas of the General Meetings, will be made available on the Company's website or
may be requested in writing by post to Orion Engineered Carbons S.A. 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, or by fax to +1-832-445-3335, or by email to investor-relations@orioncarbons.com.
Référence de publication: 2015037518/117.
Luxcellence Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 46.546.
L'an deux mille quatorze, le cinq décembre
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Alexandra SCHMITT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme
"LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
en vertu d'une résolution circulaire du Conseil d'Administration en date du 12 novembre 2014.
La résolution restera, après avoir été paraphée "ne varietur" par la comparante et le notaire, annexée aux présentes
pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
l) La société anonyme LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A., a été constituée suivant acte reçu par Maître
Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 31 janvier 1994, publié au Mémorial C Recueil de
Sociétés et Association (le «Mémorial», numéro 83 en date du 7 mars 1994, et don les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juillet 2014, publié au Mémorial numéro 2850 du 10
octobre 2014.
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à fixé à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), représenté par
cinq mille (5.000) actions ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
3) Conformément à l'article 5 des statuts, le capital social souscrit pourra être porté jusqu'à dix millions d'Euros (EUR
10.000.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites
du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera.
4) Par le biais de la résolution circulaire du 12 novembre 2014, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le
capital social à concurrence de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent
mille Euros (EUR 500.000,-) à un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) par la création et l'émission de cinq mille (5.000)
36189
L
U X E M B O U R G
actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
Les cinq mille (5.000) actions nouvelles ont été souscrites par l'actionnaire unique et ont été entièrement libérées en
espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), a été mise à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Les documents justificatifs de cette nouvelle souscription de l'actionnaire unique ont été présentés au notaire soussigné.
5) A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, les premier et troisième alinéas de l'article 5 des statuts sont
modifié comme suit:
" Art. 5. Capital - premier alinéa. Le capital social émis est fixé à un million d'Euros (EUR 1.000.000,-), représenté par
dix mille (10.000) actions ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées."
" Art. 5. Capital - troisième alinéa. Le capital social autorisé non émis s'élève à neuf millions cinq cent mille euros (EUR
9.500.000,-) représenté par quatre-vingt quinze mille (95.000) actions ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR
100,-) chacune."
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital sont estimés à approximativement EUR 2.800,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. SCHMITT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60090. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 février 2015.
Référence de publication: 2015026763/55.
(150030716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.
Biergerinitiative Liewensqualitéit Gemeng Stengefort a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-8366 Hagen, 5, rue Teschwaasser.
R.C.S. Luxembourg F 10.280.
STATUTS
Art. 1
er
. Nom et siège. L'association est dénommée «Biergerinitiative Liewensqualitéit Gemeng Stengefort a.s.b.l.».
Le siège social est établi actuellement à Hagen, 5 rue Teschwaaser décision de l'Assemblée Générale, être transféré en
tout autre endroit de la commune de Steinfort ou du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2. Objet et durée. L'association a pour but d'oeuvrer pour:
- le maintien et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la commune de Steinfort;
- la protection de l'environnement de la commune de Steinfort;
- un développement raisonnable d'un point de vue dimensionnement et infrastructures subséquentes de la commune
de Steinfort;
- un développement responsable d'un point de vue social et financier de la commune de Steinfort;
- l'empêchement de tout projet nuisant aux objectifs des points précités.
L'association est indépendante d'un point de vue politique et religieux.
L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps.
Art. 3. Membres. Peut devenir membre ou adhérer toute personne qui veut soutenir l'association dans la réalisation
de son objet. Le nombre de membres est illimité sans toutefois pouvoir être inférieur à trois. La qualité de membre
s'acquiert par une demande écrite d'adhésion adressée au conseil d'administration de l'association qui se réserve le droit
de refuser toute candidature sans fournir de justification.
Les membres s'engagent à observer les principes contenus dans les présents statuts. Après leur admission sont con-
sidérés comme membres effectifs tous ceux qui ont réglé le montant de la cotisation annuelle dont le montant est fixé
par l'assemblée générale.
Le taux de la cotisation ne pourra dépasser 100 euros.
L'association peut avoir en outre des membres honoraires et donateurs.
36190
L
U X E M B O U R G
- Tout membre a la faculté de sortir de l'association en présentant sa démission par écrit au conseil d'administration.
Cependant, la qualité de membre se perd de plein droit par le non-respect des conditions d'affiliation;
- par le défaut de paiement, pendant trois mois à compter de l'échéance de la cotisation fixée par l'assemblée générale;
- par l'exclusion pour motifs graves prononcée par décision du conseil d'administration.
La liste des membres est complétée chaque année par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se
sont produites parmi les membres et qui ont été portées à l'attention de l'association.
Les organes de l'association sont:
- l'assemblée générale des membres;
- le conseil d'administration.
Art. 4. Le conseil d'administration. Le conseil d'administration se compose de trois membres au moins, et de dix au
plus, tous élus par l'assemblée générale à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. La durée du
mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans avec la possibilité de reconduction.
Pour garantir l'indépendance politique de l'association, aucun mandataire d'un parti politique ne peut faire partie du
conseil d'administration. Toutefois un mandataire d'un parti politique peut être entendu en son avis par le conseil d'ad-
ministration.
Est considéré comme mandataire d'un parti politique au sens du présent article toute personne qui a été élue au
suffrage universel (qu'elle soit membre d'un parti ou non) ou qui assume un mandat politique en tant que membre d'un
organe de direction d'un parti au niveau national, régional ou local.
Le conseil d'administration désigne en son sein un président, un trésorier, et un secrétaire. Le conseil d'administration
a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts. L'annexe
1 mentionne les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs à la date du dépôt des présents
statuts.
Le conseil d'administration ne peut statuer valablement que si au moins trois de ses membres sont présents ou re-
présentés physiquement ou par voie électronique. Un administrateur ne saurait représenter plus d'un membre du conseil
d'administration. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents ou
représentés. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou sur la demande de deux au moins de ses
membres.
Les actes engageant l'association sont signés par deux membres du conseil d'administration.
L'association est représentée en justice et à l'égard des autorités publiques par le président du conseil d'administration
ou par deux administrateurs.
Si un siège de membre du conseil d'administration devient vacant, le conseil d'administration peut coopter un nouveau
membre pour terminer le mandat avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil.
L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par le trésorier, selon les règles de la bonne
gestion financière et en accord avec les directives émanant des organes de l'association.
Art. 5. L'assemblée générale. L'assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an. Elle sera convoquée
par le conseil d'administration. La convocation écrite par lettre simple se fait au moins cinq jours avant la réunion.
Une assemblée extraordinaire doit être convoquée si la majorité du conseil d'administration ou un cinquième des
membres de l'association le demandent.
L'ordre du jour sera joint à la lettre de convocation adressée à chacun des membres au moins cinq jours avant l'as-
semblée. Des résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour. Les décisions seront prises à la majorité
simple des voix des membres présents ou représentés.
L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents à l'exception des cas
prévus par la loi. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
Chaque membre dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale. Les membres ne pourront se faire représenter
que par un autre membre par voie d'un mandat écrit.
Les résolutions de l'assemblée sont consignées dans un registre spécial conservé au siège de l'association où tous les
membres pourront en prendre connaissance sans déplacement du registre. Les tiers qui justifient d'un intérêt pourront
avoir connaissance des résolutions sur demande écrite, motivée et adressée au conseil d'administration.
Les pouvoirs de l'assemblée générale sont ceux énumérés par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations
sans but lucratif. Les pouvoirs incluent:
- La nomination et la révocation des membres du conseil d'administration;
- L'approbation des budgets et des comptes;
- La désignation de deux réviseurs de caisse non membres du conseil d'administration;
- La modification des statuts;
- La dissolution volontaire de l'association.
36191
L
U X E M B O U R G
Si l'assemblée générale le décide, le compte rendu de l'assemblée générale est envoyé à l'adresse des membres de
l'association.
Art. 6. Fonds Social. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. Par exception, la première
année sociale a commencé à la date des statuts initiaux et a fini le 31 décembre 2015. Chaque année, le conseil d'admi-
nistration soumettra à l'approbation de l'assemblée générale le bilan ainsi que le compte des recettes et dépenses de
l'année écoulée. L'excédent favorable des comptes sera versé à la réserve.
Art. 7. Ressources de l'association. Les ressources de l'association se composent de:
- des cotisations des membres qui sont fixées par décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'ad-
ministration, et qui ne dépassent le taux maximum de EUR 100 par membre;
- des subventions publiques ou privées, incluant les dons, legs, subsides et subventions de toutes sortes, dans les limites
autorisées par la loi;
- des sommes perçues en contrepartie de prestations fournies par l'association;
- des revenus de fonds placés et de toutes ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.
En cas de dissolution, l'actif de l'association, après acquittement des dettes, sera attribué à une oeuvre à but similaire
ou, à défaut, à une oeuvre de bienfaisance, désignée par l'assemblée générale.
La loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée, est applicable
à tous les cas non prévus par les présents statuts.
Art. 8. Modifications aux statuts et dissolution. Les modifications de statuts se feront d'après les règles établies par la
loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
La dissolution de l'association peut être prononcée par l'assemblée générale en se conformant à l'article 20 de la loi
du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. L'assemblée générale pourra désigner par la même
délibération un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation.
Art. 9. Associés fondateurs. Lors de la constitution les membres suivants étaient présents:
Nom
Prénom(s)
Domicile
Nationalité
Kraus
Léon
58, rue de Luxembourg L-8440 Steinfort
Luxembourgeoise
Schank
Romain Michel Nico
7, rue Teschwasser L-8366 Hagen
Luxembourgeoise
Spiraux
Bruce
5, rue Teschwasser L-8366 Hagen
Luxembourgeoise
Zanette
Mauro
4, rue Teschwasser L-8366 Hagen
Luxembourgeoise
Zwick
Marco Victor
9, rue Teschwasser L-8366 Hagen
Luxembourgeoise
KRAUS Léon / ZWICK Marco / ZANETTE Mauro / SPIROUX Bruce / SCHANK Romain.
Référence de publication: 2015024784/115.
(150028925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Aberdeen Indirect Property Partners Active Soparfi, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 124.153.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015024716/10.
(150028688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Bezons Parc (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 63.482.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Référence de publication: 2015024783/10.
(150028062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
36192
Aberdeen Indirect Property Partners Active Soparfi
Bezons Parc (Lux) S.à.r.l.
Biergerinitiative Liewensqualitéit Gemeng Stengefort a.s.b.l.
BlackRock Asia Property Fund IV Feeder S.A. SICAV-SIF
Cage Holding S.à r.l.
EUR-ASIA Invest S.A.
European News Exchange S.A.
F&B International S.A.
F.E. Luxfinco Services
Luxadeck S.A.
Luxcellence Management Company S.A.
Lux Mas SA
Macka S.A., SPF
Magical S.A., SPF
Major Investment S.A.
Malaka International S.A.
Malderen S.A.
Mallen S.A.
Mamola S.A.
Mantera S.A., SPF
Maptaq Europe S.A.
Mare Giallo S.à r.l.
MARENS Immobilière S.A.
M.A.R. International S.A.
MDI A.G.
Meadows Properties S.A.
Meadows Properties S.A.
MEDITERRANEAN REGIONAL TRANSPORT COMPANY S.A., société de gestion de patrimoine familial
Mellow S.A.
Merles S.C.I.
Metro Investments S.A.
MGE Vernon S.à r.l.
M&G Real Estate (Luxembourg) S.A.
Millepore S.A.
Mine Holding S.A.
MMS Transports S.à r.l.
Moineau
Monier Holdings GP S.A.
MONTAIGNE Long Now Funding S.A.
MONTAIGNE Long Now Funding S.A.
Moog International Financial Services Center S.à r.l.
Next Estate Income Fund II S.à r.l.
Nieuw Amsterdam Receivables Corporation S.à.r.l.
Nobeltex
Orion Engineered Carbons S.A.
Parlux S.à r.l.
Seris Security S.A.
Seris Security S.à r.l.
Titex S.A.