This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 753
19 mars 2015
SOMMAIRE
Asia III Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36139
Asia Investment Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . .
36103
BlackRock Asia Property Fund IV S.à r.l.
SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36108
CF Equities HAIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36102
Clement Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36099
Digital Services L S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
36119
Espirito Santo Health Care Investments
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36103
EuroRidge Capital Partners CAT 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36102
Gain Capital Participations SA, SICAR . . .
36103
GMPS Operations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36102
Grevlin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36098
H.G.E. Chemical Company S.A. . . . . . . . . .
36099
Holding de Financements et d'Investisse-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36100
Invesco Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36101
Janeiro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36098
K.A.M. Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .
36100
KPI Investment Property 59 S.à r.l. . . . . . .
36143
LaSalle REDS (D-2013) . . . . . . . . . . . . . . . . .
36105
Likipi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36104
Lineapiu International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
36104
Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . .
36104
LIPI Société Luxembourgeoise d'Ingénie-
rie et de Participation S.A. . . . . . . . . . . . . .
36104
Lululemon LU Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
36105
Luxcontrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36107
Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36105
Luxhope A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36107
Luxury Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
36107
Maas International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36105
Makland S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36106
Mc Millan Information Technology S.A. . .
36106
Memora 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36106
Menuiserie GAUL et CLEES s.à.r.l. . . . . . .
36143
M.I.D. Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36107
Mull Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36106
OpCapita Red Bidco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
36102
Origin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36130
Orion Engineered Carbons S.A. . . . . . . . . .
36102
Padilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36143
Paro S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36099
Pervinage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36135
Private Equity Plus OP . . . . . . . . . . . . . . . . .
36144
RM, SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36139
Royal Flush S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36100
Sam Production Europe S.A. . . . . . . . . . . . .
36099
Sapientiae S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36144
Tourist Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36098
Vis Europe Finance S.à r.l. société de ges-
tion de patrimoine familial . . . . . . . . . . . . .
36103
36097
L
U X E M B O U R G
Grevlin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 40.426.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>8 avril 2015i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Ratification de la nomination de Jean-Charles Thouand, Administrateur
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015042672/755/19.
Tourist Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 40.784.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 mars 2015i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2013.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015038960/1023/18.
Janeiro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 110.234.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 mars 2015i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2014, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2014.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015038956/1023/17.
36098
L
U X E M B O U R G
H.G.E. Chemical Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2bis, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 105.001.
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on <i>April 7th, 2015i> at 11.00 o'clock with the following
<i>Agenda:i>
1. Management Report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and the allocation of the results as at 31.12.2014
3. Discharge to the Directors and Statutory Auditor
4. Resolution whether to continue or not the company's activities, with respect to article 100 of the law as at August
10, 1915
5. Miscellaneous
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015042674/788/17.
Paro S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 45.366.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le mercredi <i>8 avril 2015i> à 10.00 hrs au siège social de la société à L -
9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy, avec
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice
clôturé au 31.12.2014 ;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2014 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société ;
5. Elections statutaires ;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015042673/19.
Sam Production Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 15, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 24.310.
Le bilan au 31/12/13 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024593/9.
(150027350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Clement Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.108.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024129/9.
(150028093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
36099
L
U X E M B O U R G
Holding de Financements et d'Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 37.746.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 10, rue Nicolas Adames L-1114 Luxembourg, le <i>27 mars 2015i> à 10.00 heures avec l'ordre
du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du liquidateur;
2. Présentation du bilan et du compte de profits et pertes (i) au 31 décembre 2011, (ii) du bilan et compte de profits
et pertes au 31 décembre 2012, (iii) du bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2013 et (iv) du bilan
et compte de profits et pertes au 31 décembre 2014;
3. Décharge à donner au liquidateur;
4. Démission du liquidateur;
5. Divers.
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2015038333/317/19.
K.A.M. Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 22.382.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>8 avril 2015i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015042675/755/19.
Royal Flush S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 104.446.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social en date du 11
février 2015 que:
L'Etude DURO & GOEBEL, établie à L-1325 Luxembourg 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) a été
nommée dépositaire des actions au porteur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015025432/16.
(150028914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36100
L
U X E M B O U R G
Invesco Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 34.457.
Notice is hereby given that the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of Invesco Funds will be held at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg on <i>March 27th, 2015i> at
2:00 PM with the following agenda:
<i>Agenda:i>
• Sole Resolution
1. Full restatement of the articles of incorporation of the Company and more particularly to amend some Articles as
follows:
• - Amendment to Article 1 (Form, Name) to clarify that the Company is harmonized under the European Union
Council Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to
undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), which has been implemented under the
law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment or any legislative replacements or
amendments thereof.
• - Amendment to Article 4 (Purpose) to use term "2010 Law" as defined under the Article 1
• - Amendment to Article 7 (Issue of Shares) for clarification purposes, to add further information on the power of
the board of directors to wholly or partially reject any subscription application or to suspend the issue of shares
in one or more or all of the Sub-Funds at any time and without prior notification and clarify the process in case of
rejection.
• - Amendment to Article 9 (Conversion of Shares) to extend the right of the board of directors to switch share-
holders who cease to satisfy the eligibility requirements applicable to the classes of shares as described in the
prospectus of the Company.
• - Amendment to Article 11 (Calculation of Net Asset Value per Share) to clarify the mechanism of fair value and
swing pricing which may apply in order to ensure that the relevant Sub-Fund's investments will be valued at their
fair value as determined in good faith by the Board.
• - Amendment to Article 12 (Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share,
of Issue, Redemption and Conversion of Shares) to protect further the investors in case of emergency situations
affecting the valuation of assets (paragraph b) and to clarify in which circumstances the net asset value of feeder
funds could be suspended (paragraph f).
Shareholders are advised that decisions taken are valid only if at least half of the shares issued by the company are
represented and the passing of the resolution requires the consent of two thirds of the votes cast. If the resolutions are
duly passed, the changes to the Articles will take effect as from the date of this first meeting.
Shareholders may request a copy of the proposed text of the restated articles, free of charge, from the registered
office of the Company.
Shareholders may vote in person or by proxy.
Shareholders who cannot attend the meeting may vote by returning the form of proxy sent to them, to Capita Asset
Services, Shareholder solutions (Ireland), P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland (if delivered by post) or Capita Asset Services,
Shareholder solutions (Ireland), 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (if delivered by hand during normal business
hours) not later than 25 March, 2015. Alternatively, the appointment of a proxy may be submitted by telefax to + 353 1
224 0700, provided it is received in legible form and unencumbered.
The bearer Shareholders wishing to attend this Meeting are required to block their shares at the depositary one day
prior to the Meeting and to provide the registered office of the Company with the related certificate, stating that these
shares remain blocked until the end of the Meeting.
For organisational reasons, those shareholders who intend to attend the meeting in person are requested to register
with Invesco Funds, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to the attention of Yann Foll - Fax (+352) 24 524 204
by 18 March 2015 at the latest.
Shareholders in Hong Kong may contact Invesco Funds Hong Kong Sub-Distributor and Representative, Invesco Asset
Management Asia Limited on telephone number (+852) 3191 8282 for any questions.
<i>The Board of Directorsi>
Référence de publication: 2015038955/755/54.
36101
L
U X E M B O U R G
GMPS Operations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 127A, rue de Leudelange.
R.C.S. Luxembourg B 192.898.
RECTIFICATIF de l'acte numéro 2014203239 déposé le 19 décembre 2014 sous le numéro 140227477
Il y a lieu de corriger dans le Mémorial C n° 94 du 13 janvier 2015, page 4493, le nom de la société dans l'entête de
la publication des statuts:
lire: "GMPS Operations S.A., Société Anonyme"
au lieu de "GMPS Operarions S.A., Société Anonyme."
Référence de publication: 2015043293/11.
CF Equities HAIG, Fonds Commun de Placement.
Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 25. Februar 2015 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement
wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 25. Februar 2015.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2015035745/11.
(150040044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
EuroRidge Capital Partners CAT 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 103.723.
RECTIFICATIF
Dans la publication dans le Mémorial C n° 3717 du 4 décembre 2014, le titre suivant n'a pas lieu d'être :
au lieu de: "CLÔTURE DE LIQUIDATION",
lire: "".
Référence de publication: 2015042668/11.
Orion Engineered Carbons S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 160.558.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015025328/10.
(150028722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
OpCapita Red Bidco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 183.497.
Les comptes annuels pour la période du 20 novembre 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Référence de publication: 2015025326/11.
(150028579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36102
L
U X E M B O U R G
Vis Europe Finance S.à r.l. société de gestion de patrimoine familial, Société à responsabilité limitée -
Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 1.007.000,00.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 172.872.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de corriger comme suit la première ligne de l'en-tête de l'acte publié dans le Mémorial C no 57 du 10 janvier
2013, page 2719:
au lieu de : "Vis Europe Finance S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial, Société Coopérative organisée comme
une Société Anonyme.",
lire: "Vis Europe Finance S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial, Société à responsabilité limitée - Société de
gestion de patrimoine familial.".
Référence de publication: 2015042669/15.
Asia Investment Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 158.093.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015024730/10.
(150028714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Espirito Santo Health Care Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 172.560.
<i>Extrait de la décision sur la nomination d'un dépositaire des actions et parts sociales au porteur du 06.02.2015i>
Le Conseil d'Administration de la société ESPIRITO SANTO HEALTHCARE INVESTMENTS S.A.
décide de nommer
FIDUCIAIRE GLACIS SARL, experts comptables, demeurant au
18 A, boulevard de la Foire L -1528 Luxembourg
comme dépositaire des actions et parts sociales au porteur.
Junglinster, le 11 février 2015.
POUR EXTRAIT CONFORME
Paul LAPLUME
Référence de publication: 2015024966/16.
(150028498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Gain Capital Participations SA, SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 128.091.
Monsieur Gert Reinhard JONKE a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
<i>Pour GAIN CAPITAL PARTICIPATIONS S.A., SICAR
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015025038/13.
(150029045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36103
L
U X E M B O U R G
Likipi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 72.806.
<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires en date du 21 Novembre 2014i>
Les Actionnaires notifient le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg du changement des données du
Commissaire aux Comptes comme suit:
Grant Thornton Weber & Bontemps, Société Anonyme, ayant son siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 183.690.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025210/13.
(150028398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Lineapiu International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 70.466.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015i>
«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société Lineapiu'
International SA la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140
Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025211/12.
(150028946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
LIPI Société Luxembourgeoise d'Ingénierie et de Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 76.887.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015i>
«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société LIPI
Société Luxembourgeoise d'Ingénierie et de Participation SA la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son
siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de
Luxembourg».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025212/13.
(150028942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.656.603,75.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 156.509.
Modification des 3,060,100 parts sociales C2 de l'associé Frozen Finances, une société française constituée et régie
selon les lois françaises, enregistrée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 525 286 159, ayant son siège
social au 20bis, rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine, France.
Les 3,060,100 parts sociales C2 sont des parts sociales préférentielles C2.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015025181/16.
(150028975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36104
L
U X E M B O U R G
Lululemon LU Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.501,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 170.553.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 2 février 2015 que:
- La démission de Monsieur John Edward Currie de son poste de gérant de catégorie A, a été acceptée avec effet
immédiat.
- Monsieur Stuart Haselden, né le 9 juillet 1969 à South Carolina, Etats-Unis d'Amérique, et résidant professionnelle-
ment au 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, V6J 1C7, Canada, a été nommé gérant de catégorie A de la Société avec
effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
Madame Kristy Maynes, gérant de catégorie A;
Monsieur Stuart Haselden, gérant de catégorie A;
Monsieur Damian Warde, gérant de catégorie B;
Monsieur Marc Chong Kan, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2015.
Référence de publication: 2015025184/22.
(150028525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 111.928.
Veuillez noter que l'associé unique EMEA HOSPITALITY INVESTMENT HOLDING COMPANY (LUXEMBOURG)
S.A. a désormais son siège social au 64 Rue Principale, L-5367 Schuttrange, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015025226/12.
(150028243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Maas International, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.186.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015025251/10.
(150029162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
LaSalle REDS (D-2013), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 182.210.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Référence de publication: 2015025173/10.
(150028280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36105
L
U X E M B O U R G
Mull Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 52.190,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.194.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 janvier 2015i>
1. Mme Katia CAMBON a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
2. Mlle Virginie GUILLAUME a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
3. M. Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant pro-
fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une
durée indéterminée.
4. Mme Mariateresa BATTAGLIA, administrateur de sociétés, née à Cropani (Italie), le 1
er
janvier 1963, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante de catégorie B pour
une durée indéterminée.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Mull Property S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015025249/21.
(150029266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Mc Millan Information Technology S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 56.516.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 10 juin 2014.i>
Les mandats d'administrateur de Monsieur Carlo DAX (demeurant 16, Rue de Kehlen L-8394 Olm) et Messieurs Joeri
STEEMAN et Kris GOORTS (demeurant tous les deux professionnellement: 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg)
sont renouvelés pour une période de six ans.
Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Régis PIVA (demeurant professionnellement: 24, rue Saint Ma-
thieu L-2138 Luxembourg) est renouvelé pour une période de six ans.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015025242/14.
(150029216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Memora 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 161.411.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Référence de publication: 2015025243/10.
(150028049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Makland S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 112.011.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025255/9.
(150029023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36106
L
U X E M B O U R G
Luxury Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 121.274.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société LUXURY INVESTMENTS S.A.i>
Lors de sa réunion du 11 février 2015, le conseil d'administration a pris la décision suivante:
- Me Lex THIELEN, avocat à la Cour, né le 21 juillet 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1636
Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, est nommé comme dépositaire des actions au porteur de la société, conformément
à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre
des actions nominatives et du registre des actions au porteur.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015025229/14.
(150028824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Luxhope A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 155.656.
Aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 11/02/2015, welche am Gesellschaftssitz abgehalten wurde, gehen
folgende Beschlüsse hervor:
Der alleinige Verwalter beschließt AD CONSULT SARL, 67, Gruuss Strooss L-9991 WEISWAMPACH als Treuhänder
der Inhaberaktien zu ernennen.
KLINGENSTIJN Johannes
<i>Alleiniger Verwalteri>
Référence de publication: 2015025228/13.
(150029172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Luxcontrade, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8076 Bertrange, 4B, an Ditert.
R.C.S. Luxembourg B 114.919.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 12 février 2015.
<i>Pour la société
i>Me Martine DECKER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015025225/13.
(150028832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
M.I.D. Services S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 114.593.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 05 février 2015i>
NOMINATION D'UN AGENT DEPOSITAIRE
En vertu de l'article premier de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à
la tenue du registre des actions au porteur, le conseil d'administration décide de nommer Dandois & Meynial, 23 rue Jean
Jaurès, L-1836 Luxembourg comme agent dépositaire portant sur la totalité de actions au porteur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2015025236/14.
(150028660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36107
L
U X E M B O U R G
BlackRock Asia Property Fund IV S.à r.l. SICAV-SIF, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une
SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 194.434.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of December.
Before the undersigned notary Maître Marc Loesch, residing in Mondorfles-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
APPEARED:
BlackRock UK 4 LLP, a limited liability partnership incorporated under the laws of England and Wales, with registered
office at 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, and registered with the Companies House of England and Wales
under number OC371088,
here represented by Me Mariama Sene, lawyer, professionally domiciled in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney under private seal given on December17, 2014, that will be initialled as “ne varietur”
by the proxyholder and the notary, attached to the present deed and simultaneously filed with the registration authority.
The appearing party, represented as stated above, has mandated the notary with the preparation of the following
articles of association (“Articles of Association”) of a private limited company (société à responsabilité limitée) qualifying
as Fonds d’Investissement Spécialisé (SIF) with variable capital (SICAV) pursuant to the Act on Specialised Investment
Funds dated 13 February 2007, as amended and which the persons appearing declaredly wish to establish:
Art. 1. Name. Between the undersigned and all persons that may become shareholders there exists a company in the
legal form of a private limited company under the name of "BlackRock Asia Property Fund IV S.à r.l. SICAV-SIF" (the
“Fund") qualifying as an “investment company with variable capital - specialised investment fund“.
All terms not defined in these Articles of Association shall have the meaning given to such terms in the PPM (as defined
below).
Art. 2. Duration. The Fund is established for a limited duration.
The Fund will terminate five years after the end of the Investment Period (as defined below) or at such time as all
investments have been realised and the proceeds thereof have been distributed (whichever is earlier).
The board of directors (the “Board”) may, with the consent of the Investor Advisory Committee, extend the term of
the Fund for up to two consecutive one-year periods from the fifth anniversary of the end of the Investment Period. In
addition, the Board may, upon recommendation of the Manager, extend the term of the Fund for up to two additional
years in order to effect an orderly dissolution and winding up of the Fund.
Art. 3. Corporate Object. The Fund’s exclusive object is to carry out the business of a specialised investment fund
pursuant to the Law on Specialised Investment Funds dated 13 February 2007, as amended (“2007 Law“) and to achieve
the investment strategy laid down in the confidential private placement memorandum (the “PPM”).
Within the framework of the 2007 Law, the Fund may take all measures and carry out all business activities it deems
helpful to fulfil and to promote its company purpose.
Art. 4. Registered Office. The Fund’s registered office is in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the Board.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board.
In the event that the Board determines that events of force majeure have occurred or are imminent that would interfere
with the normal activities of the Fund at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ab-
normal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Fund which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 5. Capital. The capital of the Fund, expressed in U.S. Dollars, shall be represented by fully paid-up shares (the
“Shares”) of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Fund pursuant to Articles 27 and
28 hereof. The minimum capital shall be as provided by the 2007 Law i.e., the U.S. Dollar equivalent of one million two
hundred and fifty thousand euro (EUR 1,250,000). The minimum capital of the Fund must be achieved within 12 months
after the date on which the Fund has been authorised under the 2007 Law.
Art. 6. Issue of Shares. The Board is entitled, within the limits set out in these Articles, to issue an unlimited number
of fully paid up Shares at any time and at such value as shall be determined in the PPM, without being required to grant
existing shareholders a preferential right of subscription.
The Board may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued. The Board may, in particular,
decide that Shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other periods as determined by
the Board and in accordance with the PPM.
36108
L
U X E M B O U R G
The Board is authorised to issue different classes of Shares (each a “Share Class”) which may differ, inter alia, as regards
the fee structure, distribution policy, hedging strategies, minimum investment capital, shareholders’ qualifications, payment
structures or other specific features and that can be denominated in different currencies, as may be determined by the
Board and laid down in the PPM from time to time. The Board may decide if and when Shares of such Share Classes are
to be offered for subscription, as well as the conditions of such issuance.
Shares will be issued after the acceptance of the subscription and subject to payment of the issue price, pursuant to
Articles 7 and 8 hereof. Upon acceptance of the subscription and receipt of the issue price, the shareholder will receive
a confirmation of its shareholding, within a period customary in financial affairs.
Fractions of Shares may be issued. In the event that a shareholder becomes entitled to a shareholding, such shareholding
shall be registered in the share register with up to four (4) decimals. Fractional Shares do not grant any voting rights:
however, the shareholder is entitled to distributions pro rata to its shareholding.
The proceeds from the issuance of Shares will be invested in securities and/or other permitted assets pursuant to
Article 3 hereof.
The shareholders of all issued Shares will be listed in the share register that is kept by the Fund or by one or more
entities to whom the Board has delegated such task. The share register shall contain the names of all shareholders, their
address as well as the number of Shares held in the Fund and in each Share Class, if applicable. Ownership of a Share is
evidenced prima facie by the registration of the holder of such Share in the share register.
Every shareholder registered in the share register must provide the Fund with an address for the reception of notifi-
cations and announcements by the Fund. This address will be listed in the share register. A shareholder may at all times
change its registered address by written notice sent to the Fund’s registered office or such other address as may be
indicated by the Fund from time to time.
Subject to the consent of the shareholders and if permitted by the PPM and permitted by law, notifications and an-
nouncements by the Fund can be sent electronically to the shareholders.
The registration of a person as a shareholder of the Fund in the share register is subject to the shareholder’s qualifi-
cation as an Eligible Investor as defined in Article 10. For that purpose, the Fund may request evidence that the acquirer
qualifies as an Eligible Investor within the meaning of the 2007 Law. If need be, the Fund may request additional documents
it deems necessary for the registration in the share register.
Art. 7. Subscription of Shares / Capital Commitments. The Board or duly authorised persons may - at their sole
discretion - accept or reject subscriptions and payments for new Shares as well as issue new Shares to Eligible Investors
(as defined below).
Subscriptions may be made in the form of capital commitments (“Commitments”) and will become due and payable
either immediately in full or in several instalments upon receipt of drawdown notices, as further provided in the following
Article 8.
The Board may allow assets to be contributed in kind, to the extent permitted by Luxembourg law (in particular with
respect to the requirement of a special audit report from the auditors of the Fund, confirming the value of any assets
contributed in kind) and the PPM, and provided that such assets are consistent with the investment strategy of the Fund.
The costs of such contributiuon in kind shall be borne by the contributing shareholder.
Unless otherwise determined in the PPM, whenever the Fund offers Shares for subscription, the price of the offered
Shares shall be based on the issue price per Share of the relevant Share Class, if applicable, as determined in the PPM.
The Board may, in its sole discretion, accept Commitments, or additional Commitments from existing Class A Sha-
reholders, after the date on which Commitments are first accepted from Class A Shareholders (the “Initial Closing Date”)
until the date which is 18 months from the Initial Closing Date or such later date as may be agreed by the Investor
Advisory Committee (the “Final Closing Date”). If Class A Shareholders (a “Subsequent Shareholder”) are admitted to
the Fund, or increase their Commitment, on a date after the Initial Closing Date (a “Subsequent Closing Date”), the
following provisions shall apply in respect of the first drawdown following such Subsequent Closing Date:
(i) drawdowns will be of such amounts and in such proportions so as to ensure that following the application of
paragraph (iii) and this paragraph (i), the aggregate amount drawn down from each Class A Shareholder (other than for
the purposes of paying the Additional Amounts (as defined below) and that portion of the Base Fee calculated by reference
to Total Commitments is in proportion to the Class A Shareholders’ respective Commitments as at the date of such
drawdown;
(ii) each Subsequent Shareholder shall pay to the Fund an additional amount equal to interest at a rate equal to 9 per
cent per annum on amounts drawn down from the Subsequent Shareholder (other than for the purpose of paying the
Base Fee calculated by reference to Total Commitments) from the date that such amounts would have been drawn down
from it had such Subsequent Shareholder been admitted on or held its increased Commitment on the Initial Closing Date
to the date of actual draw down, calculated on a daily basis and compounding annually on the anniversary of the due date
of the prior draw down (the “Additional Amount”);
(iii) out of the amounts drawn down pursuant to paragraph (i) above, each Class A Shareholder from whom prior
drawdowns had been made shall be allocated and paid such amount equal to the excess of: (a) the amount drawn down
from such Class A Shareholder and not previously returned (excluding Additional Amounts and that portion of the Base
36109
L
U X E M B O U R G
Fee calculated by reference to Total Commitments); and (b) the amount which would have been drawn down from such
Class A Shareholder (excluding that portion of the Base Fee calculated by reference to Total Commitments) had all
Subsequent Shareholders been admitted to the Fund or made their increased Commitment on the Initial Closing Date.
Any amounts so returned to a Class A Shareholder shall be treated as having never been drawn down (and accordingly
such Class A Shareholder’s undrawn Commitment shall be increased by such amount);
(iv) any Additional Amount shall be distributed to Class A Shareholders other than the Subsequent Shareholder, pro
rata to the relative amounts drawn down from them prior to the relevant Subsequent Closing Date. Additional Amounts
are paid in addition to the Commitment of a Class A Shareholder and the Class A Shareholder will not receive any Class
A Shares in respect of such amounts; and
(v) the portion of the Base Fee calculated by reference to Total Commitments paid by a Subsequent Shareholder shall
be paid in the amount that would have been paid to date if such Subsequent Shareholder had been admitted to the Fund
or made its increased Commitment on the Initial Closing Date.
With respect to any rebalancing of Class A Shares to be effected on a Subsequent Closing Date, the Board shall, having
regard to the best interests of the Class A Shareholders as a whole, be entitled to effect such rebalancing by:
(a) transferring Class A Shares between the Class A Shareholders;
(b) issuing new Class A Shares; and
(c) redeeming and reissuing Class A Shares.
Art. 8. Drawdowns. If subscriptions are made in the form of Commitments, such shareholder’s Commitments will
become due and payable in one or several instalments by subscription of the relevant number of fully paid-up Shares
pursuant to a drawdown (the “Drawdown”). For each Drawdown, the Fund or other authorised person will send a
drawdown notice to the shareholder with the request to arrange for payment of the respective amount via bank transfer.
Pursuant to the payment of the relevant amount in accordance with the PPM, the corresponding number of Shares will
be issued to the respective shareholder.
When Commitments are called in several instalments, except in relation to Drawdowns made following a Subsequent
Closing Date as described in Article 7, each Drawdown will be made on a pro rata basis with respect to the Commitments
made by each shareholder, unless otherwise provided in the PPM. Unless otherwise determined, each Drawdown, shall
amount to a percentage of the relevant shareholder’s total Commitment, determined by the Board in its sole discretion.
The offering period (and any possible extension(s) thereof), as well as the issue price of Shares shall be defined in the
PPM.
The Fund’s investment period (the “Investment Period”) will commence on the Initial Closing Date. The Investment
Period will end on the earlier of (i) the date that is three and a half years after the Initial Closing Date; (ii) such date as
the Portfolio Manager may determine (in its sole discretion) and notify to Class A Shareholders provided that not less
than 80% of Total Commitments have been invested, called for investment or committed or reserved for investment or
for reasonably anticipated fees, costs, expenses (or other liquditity reserves; and (iii) unless otherwise approved by
Ordinary Resolution, 12 months after the commencement of a Suspension Period which has not been lifted.
If at the end of the Investment Period, Class A Shareholders have undrawn Commitments, such undrawn Commitments
may thereafter be drawn down only to: (i) pay amounts owing or which may be due under any existing indebtedness; (ii)
pay the Fund’s fees, costs and expenses (including, without limitation, the Base Fee) and indemnification obligations; (iii)
make Follow-On Investments in, or related to, existing Investments; and/or (iv) complete Investments with respect to
which the Fund or any BlackRock entity has, prior to the end of the Investment Period, entered into a binding commitment,
letter of intent, or other similar agreement, or to discharge any obligations, whether contractual or otherwise, entered
into in respect of Investments prior to the end of the Investment Period.
Art. 9. Defaulting Investor. Subject to any specific provision in the PPM, a Class A Shareholder who fails, as a result of
a default of one or more of its own investors (the “Defaulting Ultimate Investor”), to comply with a drawdown notice
by the date of its expiry (a “Defaulting Shareholder“) may be requested to pay interest on the amount it failed to pay in
such amount as determined in the PPM.
In addition, the Defaulting Shareholder will also be liable for (i) any additional amount sufficient to reimburse the
Manager, the Portfolio Manager and/or the Fund with respect to any other fees, costs and expenses (including in respect
of borrowings) or Tax incurred by the Manager, the Portfolio Manager and/or the Fund as a result of the Class A
Shareholder’s failure to pay the full amount due and (ii) any additional penalties as set forth in the PPM.
In addition, the Portfolio Manager may, subject to the conditions set forth in the PPM, exercise one or more of the
following rights and remedies against the Defaulting Shareholders:
(i) cause all or part of the undrawn Commitments attributable to the Defaulting Ultimate Investor (the “Attributable
Commitments”) to be fortfeited and all or part of the Class A Shares attributable to the Defaulting Ultimate Investor
(the “Attributable Shares”) to be redeemed on liquidation of the Fund, at such price and terms determined in accordance
with the PPM; and
(ii) sell, under the conditions set forth in the PPM, all or part of the Attributable Shares together with all or part of
the Attributable Commitments.
36110
L
U X E M B O U R G
Such measures must comply with Luxembourg legislation but do not exclude other legal remedies provided by Lu-
xembourg law so that the Fund may - in consideration of the interests of the other shareholders - also enact legal remedies
against a Defaulting Investor.
Further details with respect to this Article 9 of the Articles of Association are provided in the PPM.
Art. 10. Restrictions on shareholders. Shares shall be issued only to well-informed investors within the meaning of
Article 2 of the 2007 Law (each an "Eligible Investor''), upon verification of such status and upon acceptance of the
subscription and subject to payment of the price as set forth in Articles 7 and 8 hereof. Every shareholder must provide
the Fund with the confirmation or, as the case may be, evidence of its status of Eligible Investor.
The conditions set forth above shall not apply to the directors and other persons who are involved in the management
of specialised investment funds and hence are not applicable to the Directors.
In addition to the above, the Board shall have power (but not the obligation) to refuse to issue or register any transfer
of Shares, or to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as it, in its discretion, may
think necessary for the purpose of ensuring that no Shares are acquired or held by or on behalf of any person, firm or
corporate entity, determined in the sole discretion of the Board as being not entitled to subscribe for or hold Shares,
(i) if in the opinion of the Board such holding may be detrimental to the Fund,
(ii) if as a result thereof the Fund would breach any applicable material law, regulation or interpretation, Luxembourg
or foreign,
(iii) if as a result thereof the Fund or any shareholder may become exposed to disadvantages of a tax, legal, economic
or financial nature that it would not have otherwise incurred, or
(iv) if such person would not comply with the eligibility criteria of the Shares, and notably if such person is a U.S. Person
and not a “qualified purchaser” within the meaning of Section 2(a)(51) of the U.S. Investment Company Act (each indi-
vidually, a "Prohibited Person").
More specifically, the Fund may restrict or prevent the ownership of Shares by any person, firm or corporate body.
For such purposes, the Fund may:
(a) decline to issue any Share, and decline to register any transfer, where it appears to it that such issue or transfer
would or might result in such Share being directly or beneficially owned by a Prohibited Person,
(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares
on the register of shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not the beneficial ownership of Shares rests in Prohibited Person,
(c) request the shareholder to dispose of its Shares pursuant to the transfer provisions contained herein and in the
PPM and to provide evidence of the disposal vis-à-vis the Fund within thirty (30) days of such request if in the Board’s
assessment a Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner
of Shares. Should the respective shareholder fail to comply with this request in due time, the Board may - in its sole
discretion - treat such shareholder as a Defaulting Investor.
(d) where it appears to the Fund that any Prohibited Person, either alone or in conjunction with any other person is
a beneficial or registered owner of Shares, compulsorily redeem from any such shareholder all Shares held by such
shareholder in the following manner:
(i) the Fund shall serve a notice (hereinafter referred to as the "Redemption Notice") upon the shareholder holding
such Shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares
to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as defined
below) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such shareholder by posting
the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known or appearing in the
register of shareholders. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice, such
shareholder shall cease to be a shareholder and the Shares previously held by him shall be cancelled. The said shareholder
shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Fund the Share certificate or certificates (if issued) relating to the
Shares specified in the Redemption Notice;
(ii) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed shall be determined in ac-
cordance with Article 26 hereof (hereinafter referred to as the "Redemption Price");
(iii) payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner of such Shares and will
be deposited by the Fund with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment
to such person upon verifications in accordance with the relevant laws and regulations. Upon deposit of the monies
corresponding to the Redemption Price as aforesaid no person specified in such Redemption Notice shall have any further
interest or claim in such Shares or any of them, or any claim against the Fund or its assets in respect thereof, except the
right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without any interest) from
such bank as aforesaid;
(iv) the exercise by the Fund of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case,
on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of
any Shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any Redemption Notice, provided that in such case
the said powers were exercised by the Fund in good faith; and
36111
L
U X E M B O U R G
(v) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Fund.
Art. 11. Rights and duties attached to the Shares. Each Share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Fund and to one vote at shareholder general meetings, except as may be determined in the PPM.
If the Fund is composed of a single shareholder, that shareholder exercises all those powers granted to all shareholders
by the law of 10 August 1915 on commercial companies (the “1915 Law”) and these Articles.
Ownership of a Share carries implicit acceptance of these Articles and of any decision made by resolution of the
shareholders.
The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event request that a
seal be affixed to the assets and documents of the Fund or an inventory of assets be ordered by court. They must, for
the exercise of their rights, refer to the Fund's inventories and resolutions.
Art. 12. Indivisibility of Shares. Co-owners of Shares must be represented by a common attorney-in-fact, whether or
not jointly appointed.
Art. 13. Transfer of Shares. Where the Fund is composed of a single shareholder, that single shareholder may freely
transfer the Shares owned, subject to the restrictions in these Articles.
Where the Fund is composed of more than one shareholder, no shareholder may transfer, or otherwise dispose of
any of its Shares without the consent of the Board and each of the other shareholders.
Transfer of Shares may only be made by any existing shareholder to Eligible Investors.
Art. 14. Incapacity, bankruptcy or insolvency of shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar
event affecting a shareholder will not cause the Fund to go into liquidation.
Art. 15. Director. The Fund is managed and administered by a Board composed of at least four (4) directors who do
not have to be shareholders (each a "Director'').
Each Director is appointed annually by the single shareholder owning the entire issued Share capital or by a resolution
of the shareholders. Shareholders may elect to remove, replace or appoint additional Directors to the Board from time
to time. Each Director shall be subject to re-appointment on an annual basis, such re-appointment together with the
appointment of any new or additional Directors and any decision not to replace a Director who does not wish to be re-
appointed, has resigned or has been removed (provided there are sufficient numbers of Directors remaining to comply
with the requirements of this Article with respect to composition of the Board) shall require the approval of the single
shareholder owning the entire issued Share capital or by a resolution of the shareholders.
Any Director may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder holding the entire issued
share capital, or by a resolution of the shareholders. Any Director may resign at any time on providing advance notice
to the Fund.
The single shareholder holding the entire issued share capital or a resolution of the shareholders shall decide upon
the compensation of each Director.
The Board shall appoint, from among its members, a chairman. The Board shall choose a secretary, who need not be
a Director, who shall be responsible for keeping board meeting minutes and other Fund records.
The Board may also appoint officers of the Fund considered necessary for the operation and management of the Fund.
Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be Directors or shareholders of the
Fund. The officers appointed shall have the powers and duties entrusted to them by the Board.
Art. 16. Meetings of the Board. Meetings of the Board shall be held at the place indicated in the notice of the meeting.
Written notice of any Board meeting shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the time set for
such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in
the notice of the meeting. This notice may be waived with the consent of each Director in writing, by facsimile or e-mail.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing, by facsimile or e-mail, another director as
his proxy. Directors may also cast their vote in writing, by facsimile or e-mail. Meetings of the Board may be held by way
of conference call, video conference or any other similar means of communication, in which case the Directors partici-
pating by such means shall be deemed to be present in Luxembourg.
The Board shall act validly only if at least three directors are present or represented at a meeting of the Board. Decisions
shall be taken by a majority vote of the Directors present or represented. The chairman of the Board shall have a casting
vote.
The minutes of any meeting of the Board will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain
attached thereto. Copies or extracts of written resolutions or minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise
may be signed by any two Directors.
Resolutions may also be passed in the form of a written consent resolution. This may be signed jointly or by the use
of counterpart signatures by all the directors.
Art. 17. Powers of representation. In dealing with third parties, any two Directors shall have the power to act jointly
in the name of the Fund in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations. The Fund is bound in
36112
L
U X E M B O U R G
all circumstances by the signature of two Directors. Notwithstanding the foregoing, any one Director shall have the power
to act alone in the name of the Fund in all circumstances, to carry out and authorize all acts and operations, and to bind
the Fund in all circumstances by only such Director's signature, if so authorised by the Board.
Art. 18. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a Director. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency,
resignation, removal or any other similar event affecting a Director will not cause the Fund to go into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a Director may in no event have seals affixed to the assets and documents of the
Fund.
Art. 19. Liability of Director. A Director will not incur any personal liability arising out of the functions performed on
behalf of the Fund. He is only liable for the performance of his mandate.
Art. 20. Conflicts of interest and indemnity. No contract or other transaction between the Fund and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that a Director, officer or employee of the Fund has a personal interest
in, or is a shareholder, director, director, officer or employee of such other company or firm. Any person related, as
described above, to any company or firm with which the Fund shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting or otherwise
acting upon any matters with respect to such contract or business.
Notwithstanding the above, in the event that any Director has or may have any vested interest or personal interest
in any transaction of the Fund, such Director shall make known such personal interest to the Board of Directors and
shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such interest of the Director therein shall
be reported to the next general meeting of shareholders.
The above paragraph of this Article does not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Fund.
The term “vested interest“ as used herein does not comprise every interest merely resulting from the fact that the
transaction relates to BlackRock (or a company directly or indirectly associated with BlackRock respectively) or another
company as determined by the Fund.
None of the members of the Investor Advisory Committee (acting solely in their capacity as such), any Ultimate
Investors who have appointed a member of the Investor Advisory Committee (solely in relation to the appointment and
conduct of the relevant Investor Advisory Committee member), the Board, the Manager, the Portfolio Manager, the
members of the Investment Committee, BlackRock or any of their respective partners, officers, members, shareholders,
directors, employees, agents or affiliates or board member of any Holding Company or Property Company (each an
“Indemnified Person”) will be liable to the Fund or any of the shareholders or Ultimate Investors for any act or omission
performed or omitted by any such Indemnified Person and the Fund shall indemnify such Indemnified Persons on an after-
Tax basis for any loss or damage incurred by any of them, except where such liability or claim is the result of: (i) in the
case of an Indemnified Person other than members of the Investor Advisory Committee, or any Ultimate Investor who
has appointed a member of the Investor Advisory Committee, (a) gross negligence, (b) wilful misfeasance, (c) bad faith
(d) fraud or (e) a knowing breach of the terms of the Fund Documents, which in each case results in the Fund and/or the
shareholders suffering material financial disadvantage; and (ii) in the case of members of the Investor Advisory Committee,
or any Ultimate Investor who has appointed a member of the Investor Advisory Committee, bad faith as determined by
the final judgment of a court.
Art. 21. Appointment, powers and removal of the Manager. The Board may appoint an external alternative investment
fund manager (“Manager”) within the meaning of the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund
managers (the “AIFM Law”).
The Manager of the Fund shall be responsible for the portfolio and risk management of the Fund in accordance with
the PPM and subject to ultimate oversight of the Board. The Manager may be allowed to delegate portfolio management
to one or more portfolio managers in accordance with the PPM.
The Board may remove the Manager at any time where it considers it to be in the best interest of the shareholders,
and in accordance with the conditions set forth in the PPM.
The Board shall also remove the Manager if requested to do so by a decision of shareholders in respect of all the
Shares held by them with the majority required under the PPM, and subject to any additional condition set forth in the
PPM.
Art. 22. Voting Rights. Each Share will grant one vote, independent from the Net Asset Value of such Share but subject
to limitations, if any, pursuant to applicable law, the Articles of Association and the PPM.
Each shareholder may be represented by another shareholder or another person at any meeting of shareholders by
virtue of a written proxy (including facsimile). Such proxy holder does not need to be a shareholder and may be a Director
or a representative thereof.
Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Fund. Voting forms contain the date, place and
agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution three boxes allowing to (a)
vote in favour, (b) vote against, or (c) abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the
registered office of the Fund. Only voting forms received prior to the meeting of the shareholders are taken into account
36113
L
U X E M B O U R G
for the calculation of the quorum. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions)
nor an abstention are void.
In cases where votes are related to (an) individual Share Class(es), only the shareholders of such relevant Share Class
(es) will be entitled to vote.
The Board may determine further conditions to be fulfilled by the shareholders in order to be admitted to a meeting
of the shareholders.
Art. 23. General meetings of shareholders. When the Fund is composed of one single shareholder, that shareholder
exercises the powers granted by the 1915 Law to shareholders at a general meeting. Articles 194 to 196 and 199 of the
1915 Law are not applicable to this situation.
When the Fund is composed of several shareholders, shareholders’ decisions are taken in a general meeting or by
written resolution, the text of which will be sent by the Board to the shareholders by simple letter or by e-mail for a first
consultation, and sent by registered letter for a second consultation. In the latter case, shareholders are under the
obligation to cast their written vote and send it by registered letter to the Fund within 15 days of receiving the text of
the resolution to be decided upon.
When the Fund is composed of several shareholders, unless otherwise specified in these Articles or in the 1915 Law,
shareholder decisions are only validly taken if they are adopted by shareholders representing more than half (50%) of the
corporate capital. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted a
second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes cast validly, regardless of the
portion of capital represented.
However, resolutions to amend these Articles and to liquidate the Fund may only be taken by a majority of shareholders
representing three quarters (75%) of the Fund's corporate capital.
In line with Luxembourg law, the annual general meeting of shareholders will be held at the Fund’s registered office in
Luxembourg or any other place in the municipality of Luxembourg-city as may be indicated in the convening notice, at
midday on the last day on which banks in Luxembourg are open for business in June of each year or, if such day is a public
holiday, on the last preceding Luxembourg bank business day. The annual general meeting of shareholders may be held
abroad should extraordinary circumstances so require in the sole discretion of the Board.
Other shareholders’ meetings of the Fund may be held at such place and date as stated in the respective convening
notice.
Art. 24. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the shareholders will be documented in writing,
recorded in a register and kept at the registered office of the Fund. Shareholder votes and any powers of attorney will
be attached to the minutes of the meeting, if applicable.
Art. 25. Determination of investment policies. The Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have
power to determine the investment policies and the course of conduct of the management and business affairs of the
Fund, within the restriction set forth in the PPM and in compliance with applicable laws and regulations.
Art. 26. Redemption. The Fund is a closed-ended specialised investment fund. Consequently, Shares in the Fund shall
not be redeemable at the request of a shareholder unless specified otherwise in the PPM.
Shares may be called by the Fund for redemption:
(a) in the circumstances listed under Articles 7 and 10 of the Articles of Association;
(b) if such shareholder has materially breached any provision of these Articles or the PPM; or
(c) in such other circumstances as set forth in the PPM or as the Fund may determine where continued ownership
would be materially prejudicial to the interests of the Fund or its shareholders.
Shares which are to be redeemed by the Fund may be redeemed by the Fund upon the Fund giving to the registered
holder of such Shares not less than 30 days' notice in writing of the intention to redeem such Shares specifying the date
of such redemption, which must be any day (other than a Saturday or Sunday) when banks are open in Luxembourg,
London,Hong Kong and New York (a “Business Day”).
The amount payable on such redemption of Shares shall be the Net Asset Value of the Shares on the most recent
Valuation Date. Costs associated with the redemption may, if the Fund so decides, be charged to the shareholder whose
Shares are redeemed and such costs may be deducted from the redemption proceeds payable to the shareholder in
circumstances where the Fund has exercised its power to redeem Shares pursuant to paragraph (a) or (b) of this Article
26.
Any Shares in respect of which a notice of redemption has been given shall not be entitled to participate in the profits
of the Fund in respect of the period after the date of redemption.
No Shares of a relevant Share Class may be converted into Shares of another Share Class upon request of a shareholder,
but the Board may be entitled to proceed to such conversions under the conditions set forth in the PPM.
Art. 27. Valuation and Deposit of assets.
27.1 Calculation method
36114
L
U X E M B O U R G
The net asset value per Share of a relevant Share Class shall be expressed in U.S. Dollar and shall be determined as of
each Valuation Date by dividing (i) the net assets of the Fund (composed of the Fund’s net assets attributable to the
respective Share Class less the liabilities attributable to the respective Share Class), by (ii) the number of outstanding
Shares of the respective Share Class, in accordance with the valuation rules set forth below, provided that the assets shall
be determined in accordance with the rules set forth below (the “Net Asset Value”).
The Net Asset Value per Share of a relevant Share Class is quoted with up to four (4) decimal places as one amount
per Share in the reference currency. If since the time of determination of the Net Asset Value there has been a material
change in relation to a substantial part of the real estate of the Fund, the Fund may, in order to safeguard the interests
of the shareholders and the Fund, cancel the first valuation and carry out a second valuation with prudence and in good
faith.
27.2 Determination of assets and liabilities
Subject to compliance with IFRS, or as may otherwise be agreed with the Auditors, the assets and liabilities of the
Fund for these purposes shall be determined in the following manner:
For the purpose of the valuation of real estate, the Board, or the Manager when the Manager is entrusted with the
valuation of the assets of the Fund within the meaning of the AIFM Law, shall appoint an Independent Valuer. The Board
or the Manager may select different Independent Valuers for each local market as circumstances warrant.
27.2.1 The assets of the Fund shall include:
a) real estate;
b) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
c) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of properties, property rights, se-
curities or any other assets sold but not delivered);
d) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-
rants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Fund (provided
that the Manager may make adjustments in a manner with regard to fluctuations in the market value of securities caused
by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
e) stock dividends, cash dividends and cash payments receivable (including drawn but unpaid capital) by the Fund to
the extent information thereon is reasonably available to the Fund;
f) all income accrued on any real estate properties or interest accrued on any interest-bearing assets owned by the
Fund except to the extent that the same is included or reflected in the value attributed to such asset;
g) the formation expenses of the Fund, including the cost of issuing and distributing Shares of the Fund, insofar as the
same have not been written off; and
h) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
Subject to compliance with IFRS, or as may otherwise be agreed with the Auditors, the value of such assets shall be
determined as follows:
Subject as prescribed below, (i) real estate registered in the name of the Fund or any of its subsdiairies, and (ii) (if any)
direct or indirect shareholdings of the Fund in real estate companies mentioned below in which the Fund shall hold an
interest in the outstanding voting stock (assets described under (i) and (ii) above together referred to as “Real Estate”)
will be valued by the Board (or the Manager when the Manager is entrusted with the valuation of the assets of the Fund
within the meaning of the AIFM Law) or the Independent Valuers, as the case may be, as at each Valuation Date. The
Fund’s Real Estate will be valued by the Independent Valuers on the basis of a full valuation with physical inspection at
least annually, except for Investments acquired less than six (6) months prior to financial year-end, in which case the
Board (or the Manager when the Manager is entrusted with the valuation of the assets of the Fund within the meaning
of the AIFM Law) may choose to adopt an internal valuation. Internal valuations will be undertaken by the Board (or the
Manager when the Manager is entrusted with the valuation of the assets of the Fund within the meaning of the AIFM Law)
at the end of each quarter other than the quarter on which Independent Valuers conduct their valuation. In addition,
prior to making or disposing of any Investment, the Portfolio Manager will obtain, when practicable, an independent
valuation of such investment from an Independent Valuer. Where it is not practicable to obtain such valuation prior to
making or disposing of an Investment, such a valuation shall be obtained as soon as possible thereafter. The Portfolio
Manager will be required to justify the reasons for any acquisition price materially higher, or disposal materially lower,
than such valuations, in the Fund’s next annual report.
The securities of real estate companies which are listed on a stock exchange or dealt in on another Regulated Market
will be valued on the basis of the average of the last available 10 Business Days publicised stock exchange or market value.
A Regulated Market is a market which is regulated and supervised by state approved bodies, is held on a regular basis
and is directly or indirectly accessible to the public ("Regulated Market").
Subject as specified below, the securities of real estate companies which are not listed on a stock exchange nor dealt
in on another Regulated Market will be valued on the basis of the probable net realisation value (taking into account any
deferred Taxation) estimated with prudence and in good faith by the Manager using the value of real estate as determined
in accordance with (a) above and as prescribed below.
36115
L
U X E M B O U R G
The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable (including VAT receivables),
prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the
full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof
is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
All other securities and other assets, including debt securities and securities for which no market quotation is available,
are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by a pricing service approved by the Board or the Manager or,
to the extent such prices are not deemed to be representative of market values, such securities and other assets shall
be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Manager. Money market
instruments held by the Fund with a remaining maturity of 90 days or less will be valued by the amortised cost method,
which approximates market value.
The value of all assets and liabilities not expressed in U.S. Dollar will be converted into such currency at the relevant
rates of exchange ruling on the relevant Valuation Date. If such quotations are not available, the rate of exchange will be
determined with prudence and in good faith by or under procedures established by the Manager.
The Manager may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects
the fair value of any asset of the Fund.
27.2.2:
Subject to compliance with IFRS, or as may otherwise be agreed with the Auditors, and subject to Article 27.2.3, the
liabilities of the Fund shall include:
a) all loans and other indebtedness for borrowed money (including convertible debt), bills and accounts payable;
b) all accrued interest on such loans and other indebtedness for borrowed money (including accrued fees for com-
mitment for such loans and other indebtedness);
c) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, advisory fees, custodian fees, and domiciliary
and corporate agents' fees);
d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or in
respect of property, including the amount of any unpaid distributions declared by the Fund, where the Valuation Date
falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
e) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from
time to time by the Board, as well as such amount (if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in
respect of any contingent liabilities of the Fund, provided, for the avoidance of doubt, that such provision shall include
any deferred taxation calculated as if the relevant real estate had been directly or indirectly realised on the relevant
Valuation Date in a manner determined from time to time in the discretion of the Board; and
f) all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law and
IFRS. In determining the amount of such liabilities, the Fund shall take into account all expenses payable by the Fund. The
Fund may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount
rateably for yearly or other periods.
27.2.3 For the purpose of this Article 27:
(i) Shares to be issued by the Fund shall be treated as being in issue as from the date the relevant amount is paid
pursuant to a Drawdown and from such time and until received by the Fund the price therefore shall be deemed to be
a debt due to the Fund;
(ii) All Investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than U.S. Dollar shall be valued after
taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset
Value; and
(iii) Subject to compliance with IFRS, or as may otherwise be agreed with the Auditors, where on any Valuation Date
the Fund has contracted to:
a) purchase unconditionally any asset, the value of the consideration to be paid and any costs associated with such
asset on the relevant Valuation Date shall be shown as a liability of the Fund and the value of the asset to be acquired
less any costs associated with the asset on the relevant Valuation Date shall be shown as an asset of the Fund; or
b) sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Fund
and the asset to be delivered by the Fund shall not be included in the assets of the Fund;
provided, however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Date, then its value shall be estimated by the Manager in good faith.
27.2.4 For the avoidance of doubt, the provisions of this Article 27 (including, in particular, Article 27.2.3 hereof) are
rules for determining the Net Asset Value per Share and are not intended to affect the treatment for accounting or legal
purposes of the assets and liabilities of the Fund or any Shares issued by the Fund.
27.2.5 Subject to any decision of the Board to the contrary, every decision of the Manager with regard to the deter-
mination of the Net Asset Value (and for the avoidance of doubt, the Manager may amend, in its sole discretion, any
decisions made by service providers appointed by the Board or the Manager) will be final and binding on the Fund as well
36116
L
U X E M B O U R G
as for all current, former and future shareholders, provided that there is no violation of the principle of good faith, no
gross negligence or no obvious error at hand.
27.3 Appointment of Depositary
The Fund and the Manager shall appoint a depositary in relation to the supervision, deposit and safekeeping of the
assets of the Fund in accordance with the 2007 Law and the AIFM Law.
Where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and
there are no local entities that are subject to effective prudential regulation and supervision as well as external periodic
audit, the depositary can discharge itself of liability provided that the conditions laid down in the AIFM Law are met and
subject to the terms of the depositary agreement between the Fund, the Manager and the depositary.
Art. 28. Frequency and temporary suspension of calculation of Net Asset Value.
28.1 Frequency of calculation
The Net Asset Value per Share of a respective Share Class shall be calculated by the Central Administration Agent
based on the Net Asset Value as at the Valuation Date. Where the Net Asset Value is calculated at the initiative of the
shareholder, the costs related to such additional calculation of Net Asset Value will be borne by such shareholder.
28.2 Temporary suspension
The Board may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue of Shares:
a) during any period when one or more exchanges which provide the basis for valuing a substantial portion of the
assets of the Fund are closed or if dealings therein are restricted or suspended or where trading is restricted or suspended;
b) during any period when, as a result of the political, economic, military, terrorist or monetary events or any cir-
cumstance outside the control, responsibility and power of the Board, or the existence of any state of affairs in the
property market, disposal of the assets of the Fund is not reasonably practicable without materially and adversely affecting
and prejudicing the interests of shareholders or if, in the opinion of the Board, a fair price cannot be determined for the
assets of the Fund;
c) in the case of a breakdown of the means of communication normally used for valuing any asset of the Fund which
is material or if for any reason the value of any asset of the Fund which is material in relation to the Net Asset Value (as
to which the Board shall have sole discretion) may not be determined as rapidly and accurately as required;
d) if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of
the Fund are rendered impracticable, or if purchases, sales, deposits and withdrawals of the assets of the Fund cannot be
effected at the normal rates of exchange;
e) when the value of a substantial part of the assets of any consolidated subsidiary of the Fund may not be determined
accurately;
f) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of considering a
resolution to wind up the Fund; or
g) when for any other reason, the prices of any investments cannot be promptly or accurately determined.
The Board shall give notice of any such suspension to the shareholders.
Art. 29. Issue Price. Shares will be issued at a fixed price of U.S. Dollar 10 (the “Issue Price”).
After the Initial Closing Date, shareholders shall pay for the subscription of new Shares, the Issue Price plus any charges
or fees as may be decided by the Board from time to time and described in Article 7 of these Articles of Association.
Art. 30. Auditor. The shareholders’ meeting of the Fund will appoint an auditor (“réviseur d'entreprise agréé”) who
will perform such duties vis-à-vis the Fund as described in Article 55 of the 2007 Law.
Art. 31. Financial year. The financial year of the Fund shall begin on 1 January of each year and end on 31 December
provided that, (i) the first financial year of the Fund shall commence on the date of incorporation of the Fund and end on
31 December 2015; and (ii) the last financial year of the Fund will end on the date on which the winding up of the Fund
is completed.
The accounts of the Fund shall be expressed in U.S. Dollar. The annual accounts, including the balance sheet and profit
and loss account, the Directors report and the notice of the annual general meeting will be sent and/or published and
made available in accordance with applicable law.
Art. 32. Balance-sheet. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board will produce an
inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the 1915 Law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to each of the shareholders
for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may consult the financial documents at the registered office of the Fund.
Art. 33. Distribution of income. The general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board, subject
to any interim distributions having been declared or paid, determine how the annual net investment income shall be
disposed of.
36117
L
U X E M B O U R G
Interim distributions may, at the discretion of the Board and in accordance with the PPM, be declared subject to such
further conditions as set forth by law, and be paid out on the Shares out of the income of assets upon decision of the
Board.
Distributions may include an allocation from a dividend equalisation account which, in such event, will be credited
upon issue of Shares to such dividend equalisation account and upon redemption of Shares, the amount attributable to
such Share will be debited to an accrued income account.
The distributions declared, if any, will normally be paid in U.S. Dollar, in the currency of the relevant Share Class or
in such other currencies as selected by the Board and may be paid at such places and times as may be determined by the
Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend monies into
the currency of their payment. Stock dividends may be declared.
Distributions may be made in kind to the extent permitted in the PPM.
If and to the extent set forth in the PPM, distributions made to shareholders may be subject to a clawback obligation,
allowing the Board to call back the respectively distributed assets.
Any distributions to shareholders that were declared by the Fund but for any reasons cannot be paid, may not be
claimed after five (5) years and will then be attributed to the respective Share Class or to the Fund. No interest will be
paid on distributions declared by the Fund.
Distributions may not be made if pursuant to such distribution the Fund’s minimum capital would fall below the
statutory minimum capital.
Art. 34. Dissolution and liquidation. The decision to dissolve the Fund may be validly adopted only with the consent
of a majority of shareholders representing three quarters (75%) of the Fund's corporate capital.
Upon dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by the Manager or by one or several other liquidators
(who may be physical persons or legal entities) (together with the Manager the “Liquidators”) named by the meeting of
shareholders resolving to commence such dissolution and which shall determine their powers and theirfees. The net
proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares relating in proportion of their
holding of Shares, and subject to the specifities of each Share Class, as set forth in the PPM.
Moneys available for distribution to shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by shareholders
will at the close of liquidation be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance with the 2007
Law.
If at any time the capital of the Fund falls below two thirds of the minimum capital required by Luxembourg law, the
Board must submit the question of dissolution of the Fund to a general meeting of shareholders acting, without quorum
requirements, by a simple majority decision of the Shares present or represented at such meeting.
Art. 35. General. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with applicable law.
<i>Transitional provisionsi>
The Fund’s first financial year shall begin on the date of the Fund’s incorporation and shall end on 31 December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Shares to be issued have been subscribed and paid-in in cash by BlackRock 4 UK LLP, aforementioned, which has
paid-in twenty thousand U.S. Dollars (USD 20,000.-) and subscribed for two thousand (2,000.-) Share(s).
All the Shares have been entirely paid-in in cash, so that twenty thousand U.S. Dollars (USD 20,000.-) is as of now
available to the Fund, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand three hundred Euro (EUR
1,300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
BlackRock UK 4 LLP, aforementioned, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly conve-
ned, has immediately passed the following resolutions:
1. The number of members of the board of directors is fixed at four (4).
2. The following persons are appointed managers of the Fund with immediate effect and for an unlimited period of
time:
a. Mrs Joanne Fitzgerald, born on 11 March 1979 in Waterford, Ireland, with professional address at 28, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg;
b. Mrs Audrey Jane Lewis, born on 28 August 1968 in Glasgow, United Kingdom, with professional address at 25, rue
du Schlammestee, L-5770 Weiler la Tour, Luxembourg;
36118
L
U X E M B O U R G
c. Mr Hugo Johannes Leopold Neuman, born on 21 October 1960 in Amsterdam, the Netherlands, with professional
address at 16, rue J.B. Fresez, L-1542 Luxembourg, Luxembourg; and
d. Mr Arnold Louis Spruit, born on 13 October 1971 in London, United Kindgom, with professional address at 15a,
rue Langheck, L-5410 Beyren, Luxembourg.
3. The following entity is appointed as approved auditor of the Fund with immediate effect and for an unlimited period
of time, but may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders:
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 65.477, 2, rue Gerhard Mercator, B.P.
1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4. The address of the Fund’s registered office is set at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
the notary, this original deed.
Signé: M. Sene, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 31 décembre 2014. REM/2014/2912. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 14 janvier 2015.
Référence de publication: 2015024056/649.
(150027998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Digital Services L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.413.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany with its statutory
seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg
(Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany;
here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Berlin on 19 January 2015.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services L S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
36119
L
U X E M B O U R G
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
36120
L
U X E M B O U R G
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
36121
L
U X E M B O U R G
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
36122
L
U X E M B O U R G
E. Audit and supervision
Art. 20 Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
36123
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and paymenti>
The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned, for the
price of fifteen thousand euro (EUR 15,000).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR
15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have
been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg;
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole
shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.
hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 19
Januar 2015, ausgestellt in Berlin.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services L S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
36124
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend
(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
36125
L
U X E M B O U R G
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welc
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich
innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
36126
L
U X E M B O U R G
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro
tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
36127
L
U X E M B O U R G
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
36128
L
U X E M B O U R G
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2015.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet AG, vorbenannt, zum Preis von
fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.800,- geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-
berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.
36129
L
U X E M B O U R G
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-
men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2435. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 11. Februar 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015024155/583.
(150027543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Origin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 194.401.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
La société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “The Strand S.A.”, établie et
ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 185644,
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs, savoir:
- Monsieur Guy LANNERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue
Marie-Thérèse, et
- Monsieur Luc HILGER, expert fiscal, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thé-
rèse.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l’acte
de constitution d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme
suit:
I. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de “ORIGIN S.A.” (la “Société”), laquelle sera régie par les
présents statuts (les “Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la “Loi”).
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et
à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
L'objet de la Société est également l’achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous
concours, prêts, avances ou garanties.
36130
L
U X E M B O U R G
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.
La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-
bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.
La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration ou de l’administrateur unique.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée des action-
naires délibérant comme en matière de modification des statuts.
La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l’étranger par une simple décision du conseil d'administration de la Société ou, dans le cas d'un admi-
nistrateur unique, par une décision de l’administrateur unique.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cents (100)
actions avec une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune et qui ouvrent les mêmes droits à tout égard.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des Statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra les indications prévues à l’article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.
La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les
indications prévues par l’article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul
administrateur, par cet administrateur.
La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l’une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l’acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil
d'administration, sera déposée préalablement conformément à l’article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l’être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier mardi du mois de mai à 14.00 heures au
siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
36131
L
U X E M B O U R G
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique,
par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.
L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommu-
nication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à
voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront
aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication,
étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par
correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le “formulaire”) envoyé par le conseil d'admi-
nistration, l’administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes en langue
anglaise et française:
a) le nom et l’adresse de l’actionnaire;
b) le nombre d'actions qu'il détient;
c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
d) une déclaration par laquelle l’actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote
est requis;
e) une case pour chaque résolution à considérer;
f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l’actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir
de voter;
g) une mention de l’endroit et de la date de signature du formulaire;
h) la signature du formulaire et une mention de l’identité du signataire autorisé selon le cas; et
i) la déclaration suivante: “A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul.”
L'indication de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le
formulaire peut être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance
ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Un
actionnaire ne peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents
parvenaient à la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-
naires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un action-
naire.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
36132
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l’assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
administrateur par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,
par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur
comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visio-conférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du
conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer
le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l’intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont
de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société est valablement engagée (i) par la signature collective de deux administrateurs ou (ii) par la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil
d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes
circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l’administrateur unique.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs
rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
36133
L
U X E M B O U R G
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent
(10%) du capital social.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde
des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d’exercices antérieurs. Les dividendes seront
payés en euros ou par distribution gratuite d’actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des
administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d’administration.
Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l’adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne
sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la Loi.
Toutefois les résolutions décidant une augmentation de capital doivent être prises à l’unanimité des actionnaires.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites par l’actionnaire unique, la
société “The Strand S.A.”, pré-désignée et représentée comme dit ci-avant, et entièrement libérées par la souscriptrice
prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.
<i>Résolutions prises par l’actionnaire uniquei>
La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-
vantes en tant qu'actionnaire unique:
1. Le siège social de la Société est établi à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Les personnes suivantes sont appelées comme administrateurs:
a) Monsieur Guy LANNERS, expert-comptable, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 septembre
1965, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse;
b) Monsieur Luc HILGER, expert fiscal, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 16 novembre 1974,
demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse; et
c) Madame Marie SAINT-ARNOULT, administratrice de société née à Schiltigheim (France), le 20 janvier 1986, de-
meurant à L-2410 Luxembourg, 29, rue de Reckenthal.
36134
L
U X E M B O U R G
4. La société à responsabilité limitée “FIDU-CONCEPT SARL”, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg,
36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
38136, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale annuelle de
l’année 2020.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cinquante euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux représentants de la partie comparante, ès-qualités qu'ils agissent, connus du notaire
par noms, prénoms, états et domiciles, lesdites personnes ont tous signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. LANNERS, L. HILGER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 5 février 2015. 2LAC/2015/2611. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 10 février 2015.
Référence de publication: 2015024522/276.
(150027221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Pervinage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 294.963.500,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 115.755.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CNODC International Holding Limited, a limited company incorporated and organised under the laws of the British
Virgin Islands, having a business office at 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Companies
House under number 618265,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:
I. the appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Pervinage S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 6, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 115.755 and having a share capital of two hundred ninety-four million nine
hundred sixty-four thousand five hundred United States dollars (USD 294,964,500.-), incorporated on April 10, 2006
pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1247 on June 28, 2006 (the Company). The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on February 4, 2014, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations dated June 13, 2014 under number 1532, pages 73510 and seq.
II. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company and is duly represented at this meeting,
which is consequently regularly constituted.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of one thousand United
States dollars (USD 1,000.-) in order to bring it from its present amount of two hundred ninety-four million nine hundred
sixty-four thousand five hundred United States dollars (USD 294,964,500.-) represented by five million eight hundred
ninety-nine thousand two hundred ninety (5,899,290) shares in registered form, having a nominal value of fifty United
States dollars (USD 50.-) each, consisting of (i) five million eight hundred ninety-eight thousand eight hundred ten
(5,898,810) class A1 shares and (ii) twenty (20) class C1 to C3 shares, (iii) twenty (20) class D1 to D3 shares, (iv) twenty
36135
L
U X E M B O U R G
(20) class E1 to E3 shares, (v) twenty (20) class F1 to F3 shares, (vi) twenty (20) class G1 to G3 shares, (vii) twenty (20)
class H1 to H3 shares, (viii) twenty (20) class I1 to I3 shares and (ix) twenty (20) class J1 to J3 shares, to two hundred
ninety-four million nine hundred sixty-three thousand five hundred United States dollars (USD 294,963,500.-) by way of
the redemption and subsequent cancellation by the Company of all of the twenty (20) class C1 shares (each a Redeemed
Share).
The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with article 8. of the Articles, the aggregate amount of three
hundred eighteen million five hundred thousand United States dollars (USD 318,500,000.-) shall be repaid by the Company
to its Sole Shareholder, by way of a payment in cash, which aggregate amount corresponds at a price per Redeemed Share
of fifteen million nine hundred twenty-five thousand United States dollars (USD 15,925,000.-).
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company is set at two hundred ninety-three million nine hundred sixty-three thousand
five hundred United States dollars (USD 294,963,500.-), represented by five million eight hundred ninety-nine thousand
two hundred seventy (5,899,270) shares in registered form, having a nominal value of fifty United States dollars (USD
50.-) each, consisting of:
1. five million eight hundred ninety-eight thousand eight hundred ten (5,898,810) class A1 shares (the Class A1 Shares
and individually, the Class A1 Share);
2. twenty (20) class C2 shares (the Class C2 Shares and individually, the Class C2 Share);
3. twenty (20) class C3 shares (the Class C3 Shares and individually, the Class C3 Share);
4. twenty (20) class D1 shares (the Class D1 Shares and individually, the Class D1 Share);
5. twenty (20) class D2 shares (the Class D2 Shares and individually, the Class D2 Share);
6. twenty (20) class D3 shares (the Class D3 Shares and individually, the Class D3 Share);
7. twenty (20) class E1 shares (the Class E1 Shares and individually, the Class E1 Share);
8. twenty (20) class E2 shares (the Class E2 Shares and individually, the Class E2 Share);
9. twenty (20) class E3 shares (the Class E3 Shares and individually, the Class E3 Share);
10. twenty (20) class F1 shares (the Class F1 Shares and individually, the Class F1 Share);
11. twenty (20) class F2 shares (the Class F2 Shares and individually, the Class F2 Share);
12. twenty (20) class F3 shares (the Class F3 Shares and individually, the Class F3 Share);
13. twenty (20) class G1 shares (the Class G1 Shares and individually, the Class G1 Share);
14. twenty (20) class G2 shares (the Class G2 Shares and individually, the Class G2 Share);
15. twenty (20) class G3 shares (the Class G3 Shares and individually, the Class G3 Share);
16. twenty (20) class H1 shares (the Class H1 Shares and individually, the Class H1 Share);
17. twenty (20) class H2 shares (the Class H2 Shares and individually, the Class H2 Share);
18. twenty (20) class H3 shares (the Class H3 Shares and individually, the Class H3 Share);
19. twenty (20) class I1 shares (the Class I1 Shares and individually, the Class I1 Share);
20. twenty (20) class I2 shares (the Class I2 Shares and individually, the Class I2 Share);
21. twenty (20) class I3 shares (the Class I3 Shares and individually, the Class I3 Share);
22. twenty (20) class J1 shares (the Class J1 Shares and individually, the Class J1 Share);
23. twenty (20) class J2 shares (the Class J2 Shares and individually, the Class J2 Share); and
24. twenty (20) class J3 shares (the Class J3 Shares and individually, the Class J3 Share)”.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders’ register of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority given to any manager of the Company and any lawyer or employee of Loyens & Loeff
Luxembourg S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the shareholders’
register of the Company and to do any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the
filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately EUR 2,000.-
36136
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it with the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour de décembre.
Pardevant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
CNODC International Holding Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon et régie par les lois des
Iles Vierges britanniques, ayant son siège social situé au 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges britanniques, immatriculée
au Registre des Sociétés (Companies House) sous le numéro 618265,
ici représentée par Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. la partie comparante est l’associé unique (l’Associé Unique) de Pervinage S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée selon et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social situé au 6, Rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.755
et disposant d’un capital social de deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-quatre mille cinq cents
dollars américains (USD 294.964.500,-), constituée le 10 avril 2006 suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
1247 en date du 28 juin 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le
4 février 2014 suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association sous le numéro 1532, pages 73510 et suivantes, en date du 13
juin 2014.
II. l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société et est dûment représenté à cette
assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée.
III. l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société par un montant de mille dollars américains (USD
1.000,-) afin de le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-quatre
mille cinq cents dollars américains (USD 294.964.500,-) représenté par cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille
deux cent quatre-vingt-dix (5.899.290) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cinquante
dollars américains (USD 50,-) chacune, consistant en (i) cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent dix
(5.898.810) parts sociales de classe A1, (ii) vingt (20) parts sociales des classe C1 à C3, (iii) vingt (20) parts sociales des
classes D1 à D3, (iv) vingt (20) parts sociales des classes E1 à E3, (v) vingt (20) parts sociales des classes F1 à F3, (vi) vingt
(20) parts sociales des classes G1 à G3, (vii) vingt (20) parts sociales des classes H1 à H3, (viii) vingt (20) parts sociales
des classes I1 à I3 et (ix) vingt (20) parts sociales des classe J1 à J3, à deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent
soixante-trois mille cinq cents dollars américains (USD 294.963.500,-) par le rachat et l’annulation subséquente par la
Société de l’intégralité des vingt (20) parts sociales de classe C1 (chacune une Part Sociale Rachetée).
L’Associé Unique reconnaît que, conformément à l’article 8. des Statuts, le montant total de trois cent dix-huit millions
cinq cent mille dollars américains (USD 318.500.000,-) sera repayé par la Société à son Associé Unique, par un paiement
en numéraire, lequel montant total correspond à un prix par Part Sociale Rachetée de quinze millions neuf cent vingt-
cinq mille dollars américains (USD 15.925.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-trois mille cinq
cents dollars américains (USD 294.963.500,-), représenté par cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent
soixante-dix (5.899.270) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cinquante dollars américains
(USD 50,-) chacune, consistant en:
36137
L
U X E M B O U R G
1. cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent dix (5.898.810) parts sociales de classe A1 (les Parts
Sociales de Classe A1 et individuellement, une Part Sociale de Classe A1);
2. vingt (20) parts sociales de classe C2 (les Parts Sociales de Classe C2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
C2);
3. vingt (20) parts sociales de classe C3 (les Parts Sociales de Classe C3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
C3);
4. vingt (20) parts sociales de classe D1 (les Parts Sociales de Classe D1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
D1);
5. vingt (20) parts sociales de classe D2 (les Parts Sociales de Classe D2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
D2);
6. vingt (20) parts sociales de classe D3 (les Parts Sociales de Classe D3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
D3);
7. vingt (20) parts sociales de classe E1 (les Parts Sociales de Classe E1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
E1);
8. vingt (20) parts sociales de classe E2 (les Parts Sociales de Classe E2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
E2);
9. vingt (20) parts sociales de classe E3 (les Parts Sociales de Classe E3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
E3);
10. vingt (20) parts sociales de classe F1 (les Parts Sociales de Classe F1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
F1);
11. vingt (20) parts sociales de classe F2 (les Parts Sociales de Classe F2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
F2);
12. vingt (20) parts sociales de classe F3 (les Parts Sociales de Classe F3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
F3);
13. vingt (20) parts sociales de classe G1 (les Parts Sociales de Classe G1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
G1);
14. vingt (20) parts sociales de classe G2 (les Parts Sociales de Classe G2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
G2);
15. vingt (20) parts sociales de classe G3 (les Parts Sociales de Classe G3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
G3);
16. vingt (20) parts sociales de classe H1 (les Parts Sociales de Classe H1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
H1);
17. vingt (20) parts sociales de classe H2 (les Parts Sociales de Classe H2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
H2);
18. vingt (20) parts sociales de classe H3 (les Parts Sociales de Classe H3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
H3);
19. vingt (20) parts sociales de classe I1 (les Parts Sociales de Classe I1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
I1;
20. vingt (20) parts sociales de classe I2 (les Parts Sociales de Classe I2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
I2);
21. vingt (20) parts sociales de classe I3 (les Parts Sociales de Classe I3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
I3);
22. vingt (20) parts sociales de classe J1 (les Parts Sociales de Classe J1 et individuellement, une Part Sociale de Classe
J1);
23. vingt (20) parts sociales de classe J2 (les Parts Sociales de Classe J2 et individuellement, une Part Sociale de Classe
J2); et
24. vingt (20) parts sociales de classe J3 (les Parts Sociales de Classe J3 et individuellement, une Part Sociale de Classe
J3).»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff à Luxembourg,
pour procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans les registre
des associés de la Société et d’effectuer toutes formalités y relatives (en ce compris, afin d’éviter toute confusion, le dépôt
et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoise compétentes).
36138
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison du présent acte sont estimés à environ EUR 2.000.-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête de la partie comparante, que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu document au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/269. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 février 2015.
Référence de publication: 2015024527/213.
(150027405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Asia III Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 184.949.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015024732/10.
(150028709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
RM, SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser.
R.C.S. Luxembourg E 4.142.
L'an deux mille quinze, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES, expert-comptable, né à Beyrouth (Liban) le 25 octobre 1965 (numéro
d’identité 1965 10 25 09923), demeurant à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser,
détenteur de quatre vingt-dix-neuf (99) parts sociales.
2.- La société civile “Mouwannes Groupe” (numéro d’identité 2012 70 03 360), ayant son siège social à L-3501 Du-
delange, 38, rue Aloyse Kayser, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro E 4954,
ici représentée par son gérant unique Monsieur Rizk MOUWANNES, préqualifié sub 1.-,
détentrice d’une (1) part sociale.
Les comparants préqualifiés sub 1.- et 2.-, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile "RM, SCI" (numéro
d’identité 2009 70 01 325), avec siège social à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro E 4142, constituée suivant acte sous seing privé daté du 3 septembre 2009, publié au Mémorial C, numéro 1986
du 12 octobre 2009,
ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros
(€ 382.500.-) pour le porter de son montant actuel de deux mille cinq cents euros (€ 2.500.-) à trois cent quatre-vingt-
cinq mille euros (€ 385.000.-) par la création et l’émission de quinze mille trois cents (15.300) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales
existantes.
36139
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription - Libérationi>
Les associés décident d’admettre à la souscription de la prédite augmentation de capital les époux Monsieur Rizk Nagib
MOUWANNES, préqualifié sub 1.- et Madame Paula Michel KALLAS, mère au foyer, née à El Bouchrieh (Liban), le 4
juillet 1968 (numéro d’identité 1968 07 04 46865), demeurant ensemble à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser,
mariés sous le régime luxembourgeois de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire
Anja HOLTZ, de residence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 décembre 2012, transcrit au deuxième bureau des hypo-
thèques à Luxembourg, le 12 février 2013, volume 1942, numéro 93.
Lesquels époux Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES et Madame Paula Michel KALLAS, cette dernière étant ici re-
présentée par Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du
7 janvier 2015, laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, ont déclaré souscrire à la prédite augmentation de
capital et la libérer intégralement par un apport à la société d’une maison d’habitation et de commerce sise à Esch-sur-
Alzette, 63, rue de la Libération, inscrite au cadastre comme suit:
- Commune d’ESCH-SUR-ALZETTE, section A d’ESCH-NORD - numéro 129/8429, lieu-dit «Rue de la Libération»,
place (occupée), bâtiment à habitation, avec une contenance cadastrale de 88 centiares.
<i>Origine de propriétéi>
L’immeuble prédésigné appartient aux époux Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES et Madame Paula Michel KALLAS,
chacun pour la moitié (1/2) indivise, pour l’avoir acquis en vertu d’un acte de vente reçu par le notaire Norbert MULLER,
alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 mai 1999, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxem-
bourg, le 4 juin 1999, volume 1183, numéro 58.
<i>Evaluation de l’apport en naturei>
Les souscripteurs déclarent fixer la valeur vénale en pleine propriété de l’immeuble prédécrit à trois cent quatre-vingt-
deux mille cinq cents euros (€ 382.500.-), sur la base d’un rapport d’évaluation immobilière établi en date du 13 août
2013 par la société «RealCorp Luxembourg S.A.», avec siège social à L-2163 Luxembourg, 22, avenue Monterey.
Le prédit rapport, après avoir été paraphé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera
annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
<i>Conditions de l’apporti>
L’immeuble est apporté tels et ainsi qu'il se comporte, avec toutes les appartenances et dépendances ainsi qu'avec
toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, continues et discontinues pouvant y être attachées, sauf
à la société à faire valoir les unes et se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls et sans recours contre les
apporteurs.
Les indications cadastrales et les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins excédât-elle un
vingtième, fera profit ou perte à la société.
La société a la jouissance et la propriété de l’immeuble apporté à compter de ce jour, à charge d'en payer et d'en
supporter à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de tenir compte de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-cinq mille euros (€ 385.000.-), représenté par quinze mille
quatre cents (15.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune.
Les parts sociales sont réparties comme suit:
1) Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . .
99
2) Les époux Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES et Madame Paula Michel KALLAS, préqualifiés, ensemble
quinze mille trois cents parts sociales, chacun d’eux pour la moitié (1/2) indivise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.300
3) La société «Mouwannes Groupe», préqualifiée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: quinze mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.400»
<i>Certificat de performance énergétiquei>
Les souscripteurs déclarent être en possession de l’original d’un certificat de performance énergétique, ce conformé-
ment aux dispositions du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments
fonctionnels.
Une copie de la première page du prédit certificat, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
36140
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-
mativement à six mille cent euros (€ 6.100.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire qui certifie
l’état civil des époux Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES et Madame Paula Michel KALLAS comme suit:
- celui de Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES, d’après sa carte d’identité luxembourgeoise numéro 715034490388,
- et celui de Madame Paula Michel KALLAS, d’après sa carte d’identité luxembourgeoise numéro 715034490489.
Signé: MOUWANNES, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1640. Reçu deux mille deux cent
quatre-vingt-quinze euros 382.500,00 € à 0,50 % = 1.912,50 € + 2/10 = 382,50 € / 2.295,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
Suit copie de l’annexe:
PROCURATION
La soussignée:
Madame Paula Michel KALLAS, mère au foyer, née à El Bouchrieh (Liban), le 4 juillet 1968 (numéro d’identité 1968
07 04 46865), demeurant à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser
constitue par la présente pour son mandataire spécial son époux Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES, expert-comp-
table, demeurant à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser,
auquel elle donne POUVOIR:
- de la représenter lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société civile "RM, SCI" (numéro d’identité 2009
70 01 325), avec siège social à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro E 4142, à
tenir par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, et ayant la teneur suivante:
«L'an deux mille quinze, le janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES, expert-comptable, né à Beyrouth (Liban) le 25 octobre 1965 (numéro
d’identité 1965 10 25 09923), demeurant à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser,
détenteur de quatre vingt-dix-neuf (99) parts sociales.
2.- La société civile “Mouwannes Groupe” (numéro d’identité 2012 70 03 360), ayant son siège social à L-3501 Du-
delange, 38, rue Aloyse Kayser, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro E 4954,
ici représentée par son gérant unique Monsieur Rizk MOUWANNES, préqualifié sub 1.-,
détentrice d’une (1) part sociale.
Les comparants préqualifiés sub 1.- et 2.-, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile "RM, SCI" (numéro
d’identité 2009 70 01 325), avec siège social à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro E 4142, constituée suivant acte sous seing privé daté du 3 septembre 2009, publié au Mémorial C, numéro 1986
du 12 octobre 2009,
ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros
(€ 382.500.-) pour le porter de son montant actuel de deux mille cinq cents euros (€ 2.500.-) à trois cent quatre-vingt-
cinq mille euros (€ 385.000.-) par la création et l’émission de quinze mille trois cents (15.300) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales
existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les associés décident d’admettre à la souscription de la prédite augmentation de capital les époux Monsieur Rizk Nagib
MOUWANNES, préqualifié sub 1.- et Madame Paula Michel KALLAS, mère au foyer, née à El Bouchrieh (Liban), le 4
juillet 1968 (numéro d’identité 1968 07 04 46865), demeurant ensemble à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser,
mariés sous le régime luxembourgeois de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire
Anja HOLTZ, de residence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 décembre 2012, transcrit au deuxième bureau des hypo-
thèques à Luxembourg, le 12 février 2013, volume 1942, numéro 93.
Lesquels époux Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES et Madame Paula Michel KALLAS, cette dernière étant ici re-
présentée par Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du
36141
L
U X E M B O U R G
7 janvier 2015, laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, ont déclaré souscrire à la prédite augmentation de
capital et la libérer intégralement par un apport à la société d’une maison d’habitation et de commerce sise à Esch-sur-
Alzette, 63, rue de la Libération, inscrite au cadastre comme suit:
- Commune d’ESCH-SUR-ALZETTE, section A d’ESCH-NORD - numéro 129/8429, lieu-dit «Rue de la Libération»,
place (occupée), bâtiment à habitation, avec une contenance cadastrale de 88 centiares.
<i>Origine de propriétéi>
L’immeuble prédésigné appartient aux époux Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES et Madame Paula Michel KALLAS,
chacun pour la moitié (1/2) indivise, pour l’avoir acquis en vertu d’un acte de vente reçu par le notaire Norbert MULLER,
alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 mai 1999, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxem-
bourg, le 4 juin 1999, volume 1183, numéro 58.
<i>Evaluation de l’apport en naturei>
Les souscripteurs déclarent fixer la valeur vénale en pleine propriété de l’immeuble prédécrit à trois cent quatre-vingt-
deux mille cinq cents euros (€ 382.500.-), sur la base d’un rapport d’évaluation immobilière établi en date du 13 août
2013 par la société «RealCorp Luxembourg S.A.», avec siège social à L-2163 Luxembourg, 22, avenue Monterey.
Le prédit rapport, après avoir été paraphé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera
annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
<i>Conditions de l’apporti>
L’immeuble est apporté tels et ainsi qu'il se comporte, avec toutes les appartenances et dépendances ainsi qu'avec
toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, continues et discontinues pouvant y être attachées, sauf
à la société à faire valoir les unes et se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls et sans recours contre les
apporteurs.
Les indications cadastrales et les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins excédât-elle un
vingtième, fera profit ou perte à la société.
La société a la jouissance et la propriété de l’immeuble apporté à compter de ce jour, à charge d'en payer et d'en
supporter à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de tenir compte de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-cinq mille euros (€ 385.000.-), représenté par quinze mille
quatre cents (15.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune.
Les parts sociales sont réparties comme suit:
1) Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . .
99
2) Les époux Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES et Madame Paula Michel KALLAS, préqualifiés, ensemble
quinze mille trois cents parts sociales, chacun d’eux pour la moitié (1/2) indivise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.300
3) La société «Mouwannes Groupe», préqualifiée une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: quinze mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.400»
<i>Certificat de performance énergétiquei>
Les souscripteurs déclarent être en possession de l’original d’un certificat de performance énergétique, ce conformé-
ment aux dispositions du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments
fonctionnels.
Une copie de la première page du prédit certificat, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-
mativement à six mille cent euros (€ 6.100.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire qui certifie
l’état civil des époux Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES et Madame Paula Michel KALLAS comme suit:
- celui de Monsieur Rizk Nagib MOUWANNES, d’après sa carte d’identité luxembourgeoise numéro 715034490388,
- et celui de Madame Paula Michel KALLAS, d’après sa carte d’identité luxembourgeoise numéro 715034490489.”
- de signer aux effets ci-dessus tous actes, procès-verbaux, faire toutes déclarations et en général faire tout le néces-
saire, quoi que non prévu aux présentes, avec droit de substitution.
36142
L
U X E M B O U R G
Donnée le 7 janvier 2015.
bon pour pouvoir (s) KALLAS
Ne varietur (s) MOUWANNES, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1640. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
Pour expedition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 10 février 2015.
Référence de publication: 2015024566/193.
(150027091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
KPI Investment Property 59 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 124.404.
EXTRAIT
Il résulte d'une cession de parts sociales conclue et signée en date du 19 décembre 2014 que:
Babcock & Brown European Investments S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109 507, a cédé l'intégralité des 235 parts sociales qu'il détenait dans le capital
social de la société à Babcock & Brown Investment Holdings Pty Ltd, une responsabilité limitée de droit australien, ayant
son siège social à 12/680 George Street, Sydney NSW 2000, (Australie), immatriculée auprès du Australian Securities and
Investments Commission sous le numéro 110 013 851.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015024395/20.
(150027743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Menuiserie GAUL et CLEES s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 36.
R.C.S. Luxembourg B 94.659.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015024445/10.
(150027322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Padilux S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 49.032.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 8 décembre 2014 que:
- les démissions des administrateurs suivants ont été acceptées:
* Mme Foteini CHANTZIVANGELI-ZERITIS, avec effet immédiat;
* M. Michail SIDERIDIS, avec effet immédiat;
* M. Christos-Spyr CAVALLIS, avec effet au 25 novembre 2014.
<i>- les administrateurs sortants:i>
* M. Panagiotis ZERITIS, également Président du Conseil d'Administration, demeurant au 150, Iera Odos, GR-12242
Athènes, Grèce, Président;
* M. Dimitrios Alexandros ZERITIS, demeurant au 150, Iera Odos, GR-12242 Athènes, Grèce;
ainsi que le Commissaire aux comptes sortant, SG Services S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg, ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour une nouvelle période de six ans.
36143
L
U X E M B O U R G
Tous les mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2020.
- M. George Anastasios ZERITIS, demeurant au Papanastasiou & Malakasi 67 Str., GR-15452 Palaio Psyxiko, Grèce, a
été nommé à la fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.
- le nombre des administrateurs de la société a par conséquent été réduit de cinq à trois.
Il résulte en outre du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration du 8 décembre 2014 que M. Panagiotis
ZERITIS, demeurant au 150, Iera Odos, GR-12242 Athènes, Grèce, a été confirmé dans sa fonction d'administrateur-
délégué pour une nouvelle période de six ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2020.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2015024535/27.
(150027264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Private Equity Plus OP, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 127.652.
Die neue Geschäftsanschrift der Gesellschaft lautet:
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Die neue Berufsanschrift von Alfons KLEIN lautet:
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Diese Änderungen sind wirksam ab dem 1. Januar 2015.
Herr Danial KRÜGER ist mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der
Gesellschaft zurückgetreten.
Herr Max von FRANTZIUS ist mit Wirkung zum 10. September 2014 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft zurückgetreten.
Herr Marco SCHMITZ, geschäftlich ansässig Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln, ist mit Wirkung zum 6. Februar
2015 bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2015 zu einem Mitglied des Verwaltungsrates der
Gesellschaft ernannt worden.
Frau Julia BRAUCKMANN, geschäftlich ansässig 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, ist mit Wirkung
zum 20. Januar 2015 bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2015 zu einem Mitglied des Verwal-
tungsrates der Gesellschaft ernannt worden.
Herr Alfons KLEIN, geschäftlich ansässig 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, ist mit Wirkung zum
16. April 2014 bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2015 zu dem Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates der Gesellschaft ernannt worden
Luxemburg.
Référence de publication: 2015024531/28.
(150027521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Sapientiae S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 178.435.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de démissionner de notre mandat de gérant de catégorie A
de votre société avec effet immédiat à la date du 11 février 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2015.
Maprima Luxembourg S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015025445/13.
(150028834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
36144
Asia III Soparfi S.à r.l.
Asia Investment Soparfi S.à r.l.
BlackRock Asia Property Fund IV S.à r.l. SICAV-SIF
CF Equities HAIG
Clement Invest S.A.
Digital Services L S.à r.l.
Espirito Santo Health Care Investments S.A.
EuroRidge Capital Partners CAT 1 S.à r.l.
Gain Capital Participations SA, SICAR
GMPS Operations S.A.
Grevlin S.A.
H.G.E. Chemical Company S.A.
Holding de Financements et d'Investissements S.A.
Invesco Funds
Janeiro S.A.
K.A.M. Holding S.A., SPF
KPI Investment Property 59 S.à r.l.
LaSalle REDS (D-2013)
Likipi Holding S.A.
Lineapiu International S.A.
Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l.
LIPI Société Luxembourgeoise d'Ingénierie et de Participation S.A.
Lululemon LU Holdings S.à r.l.
Luxcontrade
Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l.
Luxhope A.G.
Luxury Investments S.A.
Maas International
Makland S.à.r.l.
Mc Millan Information Technology S.A.
Memora 2 S.à r.l.
Menuiserie GAUL et CLEES s.à.r.l.
M.I.D. Services S.A.
Mull Property S.à r.l.
OpCapita Red Bidco S.à r.l.
Origin S.A.
Orion Engineered Carbons S.A.
Padilux S.A.
Paro S.A.-SPF
Pervinage S.à r.l.
Private Equity Plus OP
RM, SCI
Royal Flush S.A.
Sam Production Europe S.A.
Sapientiae S.à r.l.
Tourist Investments S.A.
Vis Europe Finance S.à r.l. société de gestion de patrimoine familial