logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 665

11 mars 2015

SOMMAIRE

19 B S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31879

19 B S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31879

Aedes SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31895

Air Valanga S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31894

Auto Klass Concept  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31896

Car Doc S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31899

Deka Rue Cambon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

31900

Ermital Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31901

Fortune Finance Participations (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31893

Futuradent G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31881

Interfinancial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31894

Limalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31874

Lusinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31912

Medima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31897

Oriel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31902

Oriel S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31902

Orion IV European 16 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

31902

Orion IV European 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

31905

Oxford BioChronometrics S.A. . . . . . . . . . .

31905

Samena (Lux) Global Funds  . . . . . . . . . . . . .

31887

Silver Sea Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31920

Société Anonyme Immobilière A.G.  . . . . .

31880

Sofis Baraka S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31880

Solaria S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31880

Startone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31881

Steinweber Aktiengesellschaft A.G. . . . . . .

31881

Terabyte Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31881

Timentaves S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31874

Times Realisations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31875

Toiture C.F.C. S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31875

Toolcarrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31875

Tosal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31876

Toys Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31874

Tricol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31876

Trivium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31874

Tudor Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31877

Twinerg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31877

Twins Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

31877

Urban Capital Lender 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

31877

Usantar Two S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31878

Vallis Sustainable Investments I, G.P., S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31878

Vallis Sustainable Investments I, S.C.A., SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31878

VALORITECH International S.à r.l. . . . . . .

31879

Vauban Strategies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31879

Vaulux International SPF S.A.  . . . . . . . . . . .

31880

VIPdent GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31919

Vistra Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31879

31873

L

U X E M B O U R G

Limalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 85.332.

Société constituée le 17 décembre 2001 par Me Joseph Elvinger, acte publié au Mémorial C n° 613 du 19 avril 2002. Les

statuts ont été modifiés par Me Joseph Elvinger le 24 février 2006, acte publié au Mémorial C n°1209 du 21 juin
2006 et le 30 novembre 2010, acte publié au Mémorial C n°126 du 21 janvier 2011.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée générale tenue le 4 février 2015 que:
Les mandats des administrateurs Monsieur Fons Mangen, Madame Carine Reuter-Bonert et Monsieur Jean-Hugues

Antoine sont révoqués avec effet immédiat.

Monsieur Ives Mergaerts, né le 25 mars 1968 à Leuven, Belgique, demeurant à L-9420 Vianden, 31, rue de la Gare, est

nommé administrateur unique de la société pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2021.

Le mandat du commissaire au compte RAMLUX S.A. est révoqué avec effet immédiat. La société FOP CONSEIL S.A.,

R.C. n° B186074, avec siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, est nommé nouveau commissaire aux comptes de
la société pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2021.

Pour extrait
Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015019806/22.
(150023457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Trivium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 117.845.

Le comptes annuels au 31. Dezember 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015020043/9.
(150023994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Toys Investment S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 77.292.

Il résulte de la décision du liquidateur du 5 février 2015 que:
La Société Finsev SA, ayant son siège social au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg a été nommée agent

dépositaire des actions au porteur émis par la société Toys Investment SA (en liquidation) avec siège social au 5, avenue
Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 février 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour le Liquidateur
Marco Sterzi

Référence de publication: 2015020039/15.
(150023958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Timentaves S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 167.589.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision du Conseil d' Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

31874

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 4 février 2015.

<i>Pour: TIMENTAVES S.A.
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015020034/16.
(150023601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Times Realisations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 49.194.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 février 2015.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2015020035/11.
(150023404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Toiture C.F.C. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7660 Medernach, 5, Gruecht.

R.C.S. Luxembourg B 111.659.

EXTRAIT

Il découle d'un acte de cession de parts sous seing privé en date du 30 janvier 2015 que:
Le capital social de la société «TOITURE C.F.C. S.à r.l.» se trouve actuellement réparti comme suit:
- Monsieur José Carlos VALENTE DA SILVA, employé privé, né à Salreu/Estarreja (Portugal) le 19 novembre 1970,

matricule n° 1970 1119 250 16, demeurant à L- 7660 MEDERNACH, 3, Gruecht- 100 parts sociales,

Total des parts sociales: 100 parts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Medernach, le 30 janvier 2015.

<i>Pour la société
C.F.N. GESTION SA
20,Esplanade-L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P.80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015020036/22.
(150023575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Toolcarrier, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbilig, 38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 155.980.

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.
Den sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung DFS S.à r.l. mit Sitz in L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf, eingetragen

beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 155.977.

Welche Komparentin hier vertreten ist durch Herrn Ralf Peter GREGORI, Buchhalter, beruflich ansässig in L-6637

Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 14. Januar 2015,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

31875

L

U X E M B O U R G

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, dem unterzeichneten Notar erklärte, dass sie die alleinige Anteil-

haberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TOOLCARRIER ist, mit Sitz in L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 155.980 (NIN 2010 2434 596).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem

Amtssitze in Luxemburg, am 22. September 2010, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 2469 vom 16. November 2010 und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch
Notar Joseph ELVINGER, mit dem damaligen Amtssitze in Luxemburg, am 25. Februar 2013, veröffentlicht im Memorial
C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 988 vom 25. April 2013.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert

fünfundzwanzig (125) Anteile von je ein hundert Euro (€ 100.-), alle zugeteilt der Gesellschaft DFS S.à r.l., vorgenannt.

Alsdann ersuchte die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden

wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Senningerberg nach Wasserbillig zu verlegen,

und demgemäss Artikel 5 der Statuten abzuändern wie folgt:

„ Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter

an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.“.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6630 Wasserbillig, 38, Grand-

Rue.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.

Signé: R. P. GREGORI, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 janvier 2015. Relation: GAC/2015/831. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): C. PIERRET.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des

sociétés.

Echternach, den 4. Februar 2015.

Référence de publication: 2015020037/48.
(150023198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Tosal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 18.790.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 174.050.

Monsieur Pascal RAFFY, demeurant désormais au 3a, route de Gimel, CH-1185 Mont-Sur-Rolle canton de Vaud (Suis-

se)

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015020038/11.
(150023876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Tricol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 116.605.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

31876

L

U X E M B O U R G

TRICOL S.A.
Régis DONATI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015020040/12.
(150023933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Tudor Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 133.485.

Le bilan au 31.10.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 février 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015020045/14.
(150023253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Twinerg, Société Anonyme.

Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 201, route d'Ehlerange.

R.C.S. Luxembourg B 64.224.

Le Conseil d'administration, en sa séance du 4 décembre 2014, a:
- pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Wim De Clercq à la date du 4 décembre 2014;
- nommé provisoirement en qualité d'administrateur Monsieur Philip Pouillie, demeurant professionnellement Boule-

vard Simon Bolivar 34 à 1000 Bruxelles (Belgique), pour achever le mandat de Monsieur Wim De Clercq, jusqu'à la
prochaine assemblée générale qui le nommera définitivement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Mark Lauwers.

Référence de publication: 2015020046/14.
(150023641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Twins Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 36, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 191.268.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 19 janvier 2015

L'Assemblée Générale décide avec effet immédiat de transférer le siège social de la société au 36, rue du laboratoire

à L-1911 Luxembourg.

Référence de publication: 2015020047/10.
(150024017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Urban Capital Lender 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 179.135.

Par résolutions signées en date du 29 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Soufia El Mounadi, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant, avec effet au 30 janvier 2015 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission d'Augusto Bessi, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1 882 Lu-

xembourg de son mandat de gérant, avec effet au 30 janvier 2015;

31877

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2015.

Référence de publication: 2015020049/15.
(150023549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Usantar Two S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 126.926.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg, le 4 février 2015

<i>Première résolution

Le conseil d'administration décide de nommer la Société Finsev SA, ayant son siège social au 5, Avenue Gaston Diderich,

L-1420 Luxembourg agent dépositaire des actions au porteur émis par la société Usantar Two SA.

Omissis

Luxembourg, le 5 février 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Francesca Docchio / Xavier Mangiullo
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015020056/17.
(150023677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Vallis Sustainable Investments I, G.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue de Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 159.012.

<i>Extrait des résolutions de gérance

En date du 11 Novembre 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 5, rue de Kiem, L-1857 Luxembourg, et ce avec effet au 17 Novembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 Février 2014.

Salvatore Rosato
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015020058/15.
(150023311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Vallis Sustainable Investments I, S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue de Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 159.018.

<i>Extrait des résolutions de gérance

En date du 11 Novembre 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 5, rue de Kiem, L-1857 Luxembourg, et ce avec effet au 17 Novembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 Février 2014.

Salvatore Rosato
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015020059/16.
(150023288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

31878

L

U X E M B O U R G

Vistra Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 148.920.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015020064/10.
(150024061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

VALORITECH International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 178.243.

OBC by P. Thielen domiciliation, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, avenue Gaston Diderich, 5-11, dénonce

avec effet au 31 janvier 2015 le contrat de bail qui la lie à la société à responsabilité limitée VALORITECH INTERNA-
TIONAL  S.à  r.l.,  inscrite  au  R.C.S.  Luxembourg  sous  le  numéro  B178243,  ainsi  que  le  siège  social  fixé  à  L-1420
Luxembourg, avenue Gaston Diderich, 5-11.

Luxembourg, le 5 février 2015.

Référence de publication: 2015020068/11.
(150023904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Vauban Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 93.825.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 2 février 2015

La société Edmond de Rothschild Europe S.A. inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 19194, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais; L - 2535 Luxembourg a été nommée
comme dépositaire des actions au porteur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un administrateur

Référence de publication: 2015020069/13.
(150023838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

19 B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.062.

Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015020113/10.
(150024005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

19 B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.062.

Le Bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015020112/10.
(150024004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

31879

L

U X E M B O U R G

Vaulux International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 65.828.

<i>Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 29/01/2015

1) L'Assemblée accepte la démission de M. Cathy Bekemans en tant qu'administrateur de la société avec effet au

01/02/2015.

2) L'Assemblée procède avec effet au 01/02/2015 à la nomination en tant qu'administrateur de M. Joseph Treis de-

meurant professionnellement 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg avec pouvoir de signature conjointe.

La durée de son mandat expirera lors l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31/12/2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour VAULUX INTERNATIONAL SPF SA

Référence de publication: 2015020070/16.
(150024011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Société Anonyme Immobilière A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 41.571.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2015.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2015019999/12.
(150023584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Sofis Baraka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 184.198.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision de l'administrateur unique en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 5 février 2015.

<i>Pour: SOFIS BARAKA S.A.
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015020000/16.
(150024086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Solaria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 189.134.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision du Conseil d'Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

31880

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 4 février 2015.

<i>Pour: SOLARIA S.A.
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015020002/16.
(150023605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Startone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 188.186.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision de l'administrateur unique en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 5 février 2015.

<i>Pour: STARTONE S.A.
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015020012/16.
(150024087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Steinweber Aktiengesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 147.222.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 février 2015

L'Assemblée a nommé un nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Stefano GIUFFRA.
L'Assemblée a nommé:
Monsieur Olivier CAUDRON, ayant son adresse professionnelle au 31, Grand-Rue L-1661 Luxembourg, aux fonctions

d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés aux 31 décembre 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AGIF S.A.

Référence de publication: 2015020013/14.
(150023727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Terabyte Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 190.474.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 10 novembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2015020015/11.
(150023271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Futuradent G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3337 Hellange, 26, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 39.551.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten Tag des Monats Februar;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

31881

L

U X E M B O U R G

Herr Claude LESS, Zahntechniker, geboren in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 18. November 1965,

wohnhaft in L-3337 Hellingen, 26, rue de Mondorf, handelnd in seiner Eigenschaft als einzelzeichnungsberechtigter Ge-
schäftsführer  der  nach  dem  Recht  des  Großherzogtums  Luxemburg  gegründete  und  bestehende  Gesellschaft  mit
beschränkter Haftung „FUTURADENT G.M.B.H.“, mit Sitz in L-3337 Hellingen, 26, rue de Mondorf, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 39551 (Matrikelnummer: 1992 24 01
066), (hiernach die „Gesellschaft“).

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht den folgenden Teilspaltungsplan der Gesellschaft zu dokumen-

tieren wie folgt:

I. Beschreibung der zu spaltenden Gesellschaft, sowie der neu zu gründenden Gesellschaft
Die Gesellschaft, hiernach auch als die „zu spaltende Gesellschaft“bezeichnet, ist gegründet worden gemäß Urkunde

aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem damaligen Amtssitz in Wiltz (Großherzogtum Luxemburg), am
11. Februar 1992, veröffentlicht im Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 325 vom 29. Juli
1992,

und deren Satzungen (die „Statuten“) sind abgeändert worden gemäß Urkunden aufgenommen:
- durch Notar Roger ARRENSDORFF, im damaligen Amtssitz in Wiltz (Großherzogtum Luxemburg), am 31. August

1995, veröffentlicht im Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 565 vom 6. November 1995,

- durch Notar Jean-Paul HENCKS, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 25.

September 2003, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1120 vom 28. Oktober
2003,  o  durch  vorgenannten  Notar  Jean-Paul  HENCKS,  am  28.  Juli  2005,  veröffentlicht  im  Memorial  C,  Recueil  des
Sociétés et Associations, Nummer 113 vom 17. Januar 2006, und

- durch Notarin Christine DOERNER, mit dem Amtssitz in Bettemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 26. August

2013, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2744 vom 4. November 2013.

Die zu spaltende Gesellschaft hat ein gezeichnetes und voll eingezahltes Gesellschaftskapital von vierundzwanzigtau-

sendachthundert Euro (24.800,- EUR), aufgeteilt in zweihundert (200) Anteile mit einem Nominalwert von je hundert-
vierundzwanzig Euro (124,- EUR).

Der Geschäftsführer schlägt dem Alleingesellschafter der Gesellschaft eine Spaltung derselben vorschlagen, mit dem

Ziel einen Teil der Aktiva und Passiva derselben an eine neuzugründende Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu über-
tragen (hiernach als „neuzugründende Gesellschaft“ bezeichnet), wobei die zu spaltende Gesellschaft den anderen Teil
der Aktiva und Passiva, das heißt sämtliche nicht ausdrücklich laut dem vorliegenden Entwurf an die neuzugründende
Gesellschaft übertragenen Aktiva und Passiva, behält.

Nach den Anforderungen des Gesetzes wird es demnach notwendig die bestehende Gesellschaft „FUTURADENT

G.M.B.H.“ aufzuspalten, durch Übertragung und Einbringung verschiedener Aktiva und Passiva an die neuzugründende
Gesellschaft, wobei jedoch die bestehende Gesellschaft, auch nach Vollzug und Inkrafttreten des vorliegenden Abspal-
tungsentwurfs, bestehen bleibt.

Die neuzugründende Gesellschaft unter der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zu gründen unter der

Gesellschaftsbezeichnung „ART ORAL LUXEMBOURG S.à r.l.“, wird in 3337 Hellingen, 26, rue de Mondorf, angesiedelt,
wobei das Gesellschaftskapital der neuzugründenden Gesellschaften auf zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR),
eingeteilt in einhundert (100) Anteile, allesamt voll einbezahlt, festgelegt werden, und wovon jeder Anteil einen Nenn-
betrag von hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR) hat.

Die Satzung der neuzugründenden Gesellschaft ist in der Anlage 4 angeführt.
Am Ende der Abspaltung werden die neuzugründende Gesellschaft „ART ORAL LUXEMBOURG S.à r.l.“ folgende

Tätigkeit, in Einklang mit ihrer Satzung ausüben:

„Gegenstand der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf von Basismaterial für Zahnprothesen, Anfertigungen und Repa-

rieren von Zahnersatz jeglicher Art und allen Produkten, Materialien und Dienstleistungen die damit zusammenhängen,
sowie der Einkauf. Verkauf und die Lagerung von Zahnprodukten im In- und Ausland.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen  und  alle  Maßnahmen  zu  treffen,  welche  mit  dem  Gegenstad  der  Gesellschaft  mittelbar  oder  unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen. In diesem Sinnen kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede andere Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, ausüben.

Die Gesellschaft kann Darlehen eingehen mit oder ohne Hypothekenbestellung und alle sonstigen Tätigkeiten ausüben,

finanzieller, industrieller, mobiliarer oder immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck
beziehen oder denselben fördern, und sie kann solidarisch und hypothekarisch gegenüber Drittpersonen als Bürge haften.“

II. Bedingungen der Abspaltung
1. Die Abspaltung fußt auf einer Zwischenbilanz der zu spaltenden Gesellschaft, welche vom 13. Februar 2015 datiert.
2. Die Abspaltung wird unter der bestehenden und zu spaltenden (jedoch bestehenbleibenden) Gesellschaft und der

neuzugründenden Gesellschaft, an dem Datum in Kraft treten an dem dieser Abspaltungsentwurf vor Notar beurkundet
wird, unbeschadet seiner Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Voraussetzung,

31882

L

U X E M B O U R G

dass die gesetzlich dafür vorgesehene Beschlussfassung des Alleingesellschafters der zu spaltenden Gesellschaft den vor-
liegenden Abspaltungsentwurf annehmen wird (das „Datum des Inkrafttretens“).

Ab jenem Datum des Inkrafttretens werden die Aktiva und Passiva, welche laut diesem Abspaltungsentwurf an die

neuzugründende Gesellschaft übertragen werden, übertragen.

Vom buchhalterischen Standpunkt her tritt die Abspaltung am selben Tag in Kraft, unter der alleinigen Voraussetzung,

dass der Alleingesellschafter endgültig über den vorliegenden Abspaltungsentwurf befindet und die Gründung der neu-
zugründenden Gesellschaft beurkundet, wobei die zu spaltende Gesellschaft in jedem Fall bestehen bleibt, also nicht
aufgelöst wird.

3. Die teilweise Übertragung der Aktiva und Passiva, wie diese aus der Zwischenbilanz zum Stichtag 13. Februar 2015

resultieren, sind in den Anlagen 1, 2 und 3 im Einzelnen beschrieben.

4. Zur Entlohnung der Andienung der verschiedenen Aktiva und Passiva an die zu gründende Gesellschaft, werden dem

Alleingesellschafter der zu spaltenden Gesellschaft einhundert (100) Anteile, allesamt voll einbezahlt, mit einen Nennwert
von je hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR) angedient.

5. Die Abspaltung unterliegt auch noch den folgenden Bedingungen:
a)  die  neuzugründende  Gesellschaft  wird  die  ihr  angedienten  Aktiva  und  Passiva  in  dem  Zustand  übernehmen,  in

welchem dieselben sich am Tag des Inkrafttretens der Abspaltung befinden, ohne Regress gegen die zu spaltende Gesell-
schaft aus welchem Grund auch immer.

b) Die neuzugründende Gesellschaft wird ab dem Tag des Inkrafttretens der Abspaltung für jegliche Steuern, Gebühren,

Lasten und Kosten, gleich ob gewöhnlich oder außergewöhnlich, gleich ob zur Zahlung fällig oder noch nicht fällig, welche
die respektiven Aktiva oder die Passiva direkt betreffen, welche ihr durch die vorliegende Spaltung angedient werden,
hierfür zum Schuldner.

c) Die neuzugründende Gesellschaft wird vom Tag des Inkrafttretens der Spaltung jegliche Rechte und Pflichten wahr-

nehmen, welche zu den jeweiligen ihr angedienten Aktiva und Passiva gehören.

d) Die Rechte und Forderungen welche an die neuzugründende Gesellschaft übergehen, werden samt aller Sicherhei-

ten, gleich ob von persönlicher oder sachlicher Natur, die denselben Forderungen anhaften, übertragen. Die neuzugrün-
dende Gesellschaft wird demnach in die Rechte der zu spaltenden Gesellschaft eintreten, ohne Novation und demnach
in jegliche sachlichen und persönlichen Rechte der zu spaltenden Gesellschaft, samt allen Sachwerten und jeglichen For-
derungen  gegen  alle  Schuldner,  ohne  Ausnahme,  das  Ganze  in  Ausführung  der  Auffächerung  der  Bilanz  wie  hierin
beschrieben.

Das Eintreten in die Rechte geschieht spezifischer bei allen Hypothekarrechten, Pfändungsrechten, Pfandrechten, Op-

tionsrechten, sowie Vorkaufsrechten, oder ähnlich gearteten Rechten, ob dieselben sichtbar oder nicht sichtbar sind, und
demnach ist die neuzugründende Gesellschaft dazu ermächtigt, jegliche Zustellungen, Einregistrierungen, Eintragungen,
Erneuerungen, sowie Verzichte auf Hypothekarrechte, auf Pfändungsrechte, auf Pfandrechte, sowie auch andere Rechte,
vorzunehmen.

e) Die neuzugründende Gesellschaft verzichtet ausdrücklich auf jegliche Auflösungsklagen, welche dieselbe gegen die

zu spaltende Gesellschaft oder gegen deren Berechtigten haben könnten, da dieselbe neuzugründende Gesellschaft die
Schulden, Lasten und Verpflichtungen der zu spaltenden Gesellschaft übernehmen.

6. In der Folge der Abspaltung wird die zu spaltende Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern bleibt bestehen und wird

fortgeführt, das Gesellschaftskapital wird jedoch um zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR) herabgesetzt durch
Streichung von einhundert (100) Anteile.

7. Die Annahme der Abspaltung durch Beschlussfassung durch den Alleingesellschafter der zu spaltenden Gesellschaft

wird bei deren Abhaltung dem Geschäftsführer der zu spaltenden Gesellschaft für die Ausübung aller seiner Pflichten bis
zum Tag der besagten Beschlussfassung Entlastung erteilen.

8. Die Abspaltung wird unmittelbar und automatisch mit den rechtlichen Konsequenzen, wie in Artikel 308bis-2, sowie

Artikel 285 bis 308 (außer Artikel 303) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über kommerzielle Gesell-
schaften bestimmt, einhergehen.

9. Die neuzugründende Gesellschaft wird zu allen Formalien schreiten, welche notwendig oder nützlich sind um die

Abspaltung in Kraft zu setzen, sowie die Übertragung aller Werte und Verpflichtungen durch die zu spaltende Gesellschaft
an die neuzugründende Gesellschaft zu gewährleisten.

10. Die Gesellschaftsunterlagen, sowie die Bücher der zu spaltenden Gesellschaft werden weiterhin am Sitz derselben

Gesellschaft aufbewahrt.

11. Der Abspaltungsentwurf wird dem Alleingesellschafter am Sitz der zu spaltenden Gesellschaft zur Einsicht vorliegen,

und dies während einer Dauer von mindestens einem Monat vor der Beschlussfassung des Alleingesellschafters, mitsamt
den Jahresabschlusskonten, und dem Geschäftsbericht der letzten drei Geschäftsjahren, sowie mit dem buchhalterischen
Zwischenabschluss zum 13. Februar 2015.

12. Die Abspaltung hat nicht und wird nicht zur Zahlung von besonderen Vergütungen an den Geschäftsführer der an

der Spaltung beteiligten Gesellschaft, sowie deren etwaigen Wirtschaftsprüfer, führen.

31883

L

U X E M B O U R G

13. In Ausführung von Artikel 308bis-2 des Gesetzes über kommerzielle Gesellschaften unterliegt der vorliegende

Abspaltungsentwurf, und wird die damit einhergehende Abspaltung, den Bestimmungen von Artikel 285 bis 308, außer
Artikel 303, sowie außer Artikel 287 und 288, des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes vom 10.August 1915 unterstellt.

Die Abspaltung bedingt also nicht die Auflösung der zu spaltenden Gesellschaft, sondern im Gegenteil wird dieselbe

in Ausführung von Artikel 308-bis 2 fortbestehen.

<i>Aufschiebende Bedingung

Vorgenannter Teilspaltungsplan muss nach Ablauf der gestzlichen Frist durch eine Versammlung der Gesellschafter

der abzuspaltenden Gesellschaft genehmigt werden.

<i>Anlage 1, 2 und 3:

Aufteilung und Abspaltung der Aktiva und Passiva der „FUTURADENT G.M.B.H.“ (die „zu spaltende Gesellschaft“),

einerseits, und der neuzugründenden Gesellschaft „ART ORAL LUXEMBOURG S.à r.l.“( die „zu neuzugründende Ge-
sellschaft“), andererseits.

Die untenstehende Aufteilung basiert auf einer buchhalterischen Situation zum 13. Februar 2015 der zu spaltenden

Gesellschaft.

1. Der zu spaltenden Gesellschaft bleiben folgende Aktiva und Passiva erhalten, sowie der neuzugründenden Gesell-

schaft  jeweilig  folgende  Aktiva  und  Passiva  übertragen  werden,  welche  die  Gesamtheit  der  Aktiva  und  Passiva  der
Zwischenbilanz der zu spaltenden Gesellschaft zum 13. Februar 2015 darstellt - Anlage 1.

2. Der neuzugründenden Gesellschaft „ART ORAL LUXEMBOURG S.à r.l.“werden folgende Aktiva und Passiva über-

tragen - Anlage 2.

Zu diesen Aktiva gehört ebenfalls eine Immobilie gelegen in L-3337 Hellingen, 26, rue de Mondorf, eingetragen im

Kataster  der  Gemeinde  Frisingen,  Sektion  C  von  Hellingen,  Katasternummer  928/2358,  Ort  genannt:  „Munnerëfers-
trooss“, Platz (besetzt), Wohnhaus, Groß 11,65 Ar.

<i>Eigentumsnachweis

Die zu spaltende Gesellschaft hat vorbezeichnete Immobilie erworben gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar

Edmond SCHROEDER, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch (Großherzogtum Luxemburg), am 10. Dezember 2001,
überschrieben im zweiten Hypothekenamte von und zu Luxemburg, am 31. Dezember 2001, Band 1308, Nummer 3.

3. Der zu spaltenden Gesellschaft bleiben alle anderen Aktiva und Passiva erhalten, welche nicht anders, ausdrücklich

und jeweilig an die neuzugründende Gesellschaft übertragen werden, wie oben beschrieben, und unter anderem die
folgenden Aktiva und Passiva - Anlage 3.

<i>Anlage 4:

Entwurf der Satzung der neuzugründenden Gesellschaft „ART ORAL LUXEMBOURG S.à r.l.

“Kapitel A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „ART ORAL LUXEMBOURG

S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen (die „Statuten“), sowie durch die anwend-
baren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das
„Gesetz von 1915“) geregelt wird.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf von Basismaterial für Zahnprothesen, Anfertigungen und

Reparieren von Zahnersatz jeglicher Art und allen Produkten, Materialien und Dienstleistungen die damit zusammen-
hängen, sowie der Einkauf. Verkauf und die Lagerung von Zahnprodukten im In- und Ausland.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen  und  alle  Maßnahmen  zu  treffen,  welche  mit  dem  Gegenstad  der  Gesellschaft  mittelbar  oder  unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen. In diesem Sinnen kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede andere Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, ausüben.

Die Gesellschaft kann Darlehen eingehen mit oder ohne Hypothekenbestellung und alle sonstigen Tätigkeiten ausüben,

finanzieller, industrieller, mobiliarer oder immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck
beziehen oder denselben fördern, und sie kann solidarisch und hypothekarisch gegenüber Drittpersonen als Bürge haften.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Frisingen, (Großherzogtum Luxemburg).
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann Innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder

des Geschäftsführerrates verlegt werden.

31884

L

U X E M B O U R G

Der Gesellschaftssitz kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen,

die für eine Änderungen der Statuten maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen, Büros oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großher-

zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Kapitel B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile mit einem Nominalwert von je hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR).

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesetzes von

1915 festgelegt ist.

Art. 6. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 7. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaft-

santeile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des restlichen

Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendenten, Deszendenten
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 8. Der Tod, der Verlust der Bürgerrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters wird

nicht die Auflösung der Gesellschaft herbeiführen.

Art. 9. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente

der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen
einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Kapitel C. Verwaltung - Vertretung

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, ernannt durch einen Beschluss

des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, welche die Dauer ihrer Mandate festlegt.

Der (die) Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Im Fall der Ernennung mehrerer Geschäftsführer bilden

diese die Geschäftsführung.

Die Geschäftsführer sind "ad nutum" abrufbar.

Art. 11. Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die vorliegenden Statuten der Gesellschafter-

versammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäfts-
führern in die Zuständigkeit der Geschäftsführung, der/die mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet ist, um alle mit dem
Gesellschaftszweck zu vereinbarenden Handlungen und Geschäfte vorzunehmen und zu genehmigen.

Jeder Geschäftsführer kann beschränkte Sondervollmachten für besondere Aufgaben an einen oder mehrere Bevoll-

mächtigte erteilen, der/die kein(e) Gesellschafter zu sein braucht/brauchen.

Art. 12. Die Geschäftsführung versammelt sich so oft, wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern sowie auf

Einberufung eines der Geschäftsführer an dem in der Einberufung angegebenen Versammlungsort.

Jeder Geschäftsführer erhält für jede Versammlung der Geschäftsführung mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor

dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine mündliche oder schriftliche Mitteilung, außer im Falle einer Drin-
glichkeit; in einem solchen Fall wird die Art dieser Dringlichkeit (und ihre Gründe) in der Einberufung der Versammlung
der Geschäftsführung kurz angegeben.

Die Versammlung kann ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer der

Gesellschaft bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Ver-
sammlung und ihre Tagesordnung informiert worden sind. Auf die Einberufung kann auch verzichtet werden, wenn das
schriftliche Einverständnis jedes Geschäftsführers der Gesellschaft entweder in Urschrift oder als Telegramm, Fax, Telex
oder E-Mail vorliegt.

Jeder Geschäftsführer kann sich durch schriftliche Ernennung eines anderen Geschäftsführers zu seinem Vertreter bei

den Versammlungen der Geschäftsführung vertreten lassen.

Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend

oder vertreten ist. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden rechtsgültig mit der Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Die Protokolle der Versammlungen der Geschäftsführung werden von
allen bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

Jeder Geschäftsführer kann an der Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon-oder Videokonferenz oder

ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, bei denen sämtliche Versammlungsteilnehmer sich hören und miteinander

31885

L

U X E M B O U R G

sprechen können. Die Teilnahme an der Versammlung durch eines dieser Mittel gilt als der persönlichen Teilnahme an
der Versammlung gleichwertig.

Die von allen Geschäftsführern unterzeichneten Umlaufbeschlüsse gelten als rechtsgültig gefasst, als wären sie in einer

ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst worden. Die Unterschriften
der Geschäftsführer können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder Telefax verschickten Kopien
eines identischen Beschlusses angebracht werden.

Art. 13. Die Geschäftsführer übernehmen auf der Grundlage ihres Amtes keine persönliche Haftung für Verpflichtun-

gen, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, soweit diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den
Statuten und den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 eingegangen wurden.

Kapitel D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 15. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Statuten benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 16. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes von 1915 zustehen.

Kapitel E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 18. Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-

resabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinnund Verlustrechnung.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und sonstigen Lasten verbleibende Nettogewinn wird

wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,

bis diese 10% des gezeichneten Kapitals erreicht;

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Statuten vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

Kapitel F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in den Statuten festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes

von 1915 über die Handelsgesellschaften, verwiesen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

31886

L

U X E M B O U R G

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, qualitate qua, dem instrumentierenden

Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat besagter Komparent mit Uns dem
Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. LESS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 février 2015. 2LAC/2015/3523. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 5 mars 2015.

Référence de publication: 2015037852/292.
(150042499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Samena (Lux) Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 178.133.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN, ON THE TWENTY-SEVENTH DAY OF FEBRUARY.
Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders (hereafter referred to as the “Meeting”) of “SAMENA (LUX)

GLOBAL FUNDS” (hereafter referred to as the “Company”), a Société d'investissement à capital variable having its
registered office at 14, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B178133, incorporated pursuant to a deed received by Maître Henri HELLINCKX, notary residing
in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 13 June 2013, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 1558 of 1 

st

 July 2013. The articles of incorporation have never been amended since.

The Meeting is open by Mrs Lydie Moulard, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting.
The chairman appoints Mrs Isabelle Brangbour, residing professionally in Luxembourg, as secretary and the Meeting

elects as scrutineer Mrs Nicole Hoffmann, residing professionally in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

- Change of the corporate name of the SICAV to RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II with effect on 1 

st

 April 2015 and

amendment of Article 1 of the Articles of Association as a consequence.

- Change of the characteristics of bearer shares and amendment of Articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 and 31 of the Articles

of Association as a consequence.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the re-
presented shareholders and by the board, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

III.  The  present  shareholders  meeting  has  been  convened  by  a  letter  to  the  nominative  shareholders  sent  on  11

February 2015 and by announcements containing the above named agenda appeared in:

- “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”, on 11 February 2015 number 363 and on 19 February 2015

number 455;

- “Luxemburger Wort” on 11 February 2015 and on 19 February 2015.
- “Wirtschaftsblatt” on 11 February 2015 and on 19 February 2015.
- “ FOSC” on 11 February 2015 and on 19 February 2015.
- “Fundinfo” on 11 February 2015 and on 19 February 2015.
- “Börsenzeitung” on 11 February 2015 and on 19 February 2015.
- “Svenska Dagbladet” on 11 February 2015 and on 19 February 2015.
- “The Independent” on 11 February 2015 and on 19 February 2015.
IV. It appears from the attendance list that, out of the five hundred and four thousand eight hundred and forty-six point

fourteen (504,846.14) outstanding shares, three hundred and thirty-two thousand eight hundred and thirteen point sixty-
nine (332,813.69) shares are present or represented at the Meeting. The Chairman declares that the present Meeting
was regularly convened, that the quorum required by article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies
as amended is reached, and that the Meeting is therefore regularly constituted and can deliberate on all the items of the
above named agenda.

31887

L

U X E M B O U R G

After deliberation, the shareholders meeting adopts unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to change the corporate name of the SICAV to RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II with effect

on 1 

st

 April 2015 and to amend Article 1 of the Articles of Association to read as follows:

“ Art. 1. Corporate name. There exists between the subscriber(s) and all those who will become shareholders, a

société anonyme in the form of a Société d’investissement à capital variable (SICAV), i.e. an open-ended investment
company, RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II (“Company”).”

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the characteristics of bearer shares and to amend of Articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25

and 31 of the Articles of Association with effect on 1 

st

 April 2015 to read as follows:

“ Art. 7. Form of shares. The shares are issued without par value and are fully paid-up. Any share of any sub-fund and

any class in said sub-fund may be issued:

1. either in registered form in the name of the subscriber, recorded by subscriber’s registration in the shareholders’

register. The subscriber’s registration in the register may be confirmed in writing. No registered share certificate will be
issued.

The shareholders’ register shall be kept by the Company or by one or more individuals or legal entities that the

Company designates for this purpose. The registration must indicate each registered shareholder’s name, their place of
residence or elected domicile, number of registered shares held. All transfers of registered shares between living persons
or as the result of a death will be recorded in the shareholders’ register.

If a named shareholder fails to provide the Company with an address, this may be reported in the shareholders’ register,

and the shareholder’s address shall be presumed to be at the Company’s registered office or at any other address defined
by the Company, until another address has been provided by the shareholder. Shareholders may at any time request that
the address recorded for them in the shareholders’ register be changed by sending a written notice to the Company at
its registered office or any other address indicated by the Company.

The named shareholder must inform the Company of any change in personal information contained in the shareholders

register to allow the Company to update said personal information.

2. either in bearer shares issued only in the form of global certificate held in custody by a clearing and settlement

system.

A shareholder may at any time request to convert his bearer shares to registered shares, or the inverse In this case,

the Company shall be entitled to charge the shareholder for any costs incurred.

As allowed by Luxembourg laws and regulations, the board of directors may decide, at its sole discretion, to require

the exchange of bearer shares to registered shares provided that it publishes a notice in one or several newspapers
determined by the board of directors.

Shares may be issued in fractions of shares, to the extent allowed in the Prospectus. The rights attached to fractions

of shares are exercised in proportion to the fraction held by the shareholder, except for the voting right, which can only
be exercised for a whole number of shares.

The Company only recognises one shareholder per share. If there are several owners of one share, the Company shall

be entitled to suspend the exercise of all the rights attached to it until a single person has been designated as being the
owner in the eyes of the Company.”

“ Art. 8. Issue and subscription of shares. Within each sub-fund, the board of directors is authorised, at any time and

without limitation, to issue additional fully paid-up shares, without reserving a pre-emptive subscription right for existing
shareholders.

If the Company offers shares for subscription, the price per share offered, irrespective of the sub-funds and class in

which the share is issued, shall be equal to the Net Asset Value of the share as determined pursuant to these articles of
incorporation. Subscriptions are accepted on the basis of the price established for the applicable Valuation Day, as specified
in the Prospectus of the Company. This price may be increased by fees and commissions, including a dilution levy, as
stipulated in this Prospectus. The price thus determined will be payable within the normal deadlines as specified more
precisely in the Prospectus and taking effect on the applicable Valuation Day.

Unless specified differently in the Prospectus, subscription requests may be expressed in the number of shares or by

amount.

Subscription requests accepted by the Company are final and commit the subscriber except when the calculation of

the net asset value of the shares for subscription is suspended. The board of directors, however, may but is not required
to do so, agree to a modification or a cancellation of a subscription order when there is an obvious error on the part of
the subscriber on condition that the modification or cancellation is not detrimental to the other shareholders in the
Company. Moreover, the board of directors of the Company may, but is not required to do so, cancel the subscription
request if the depositary has not received the subscription price within the common delays, such as determined in the

31888

L

U X E M B O U R G

Prospectus and starting as from the applicable Valuation Day. Subscription price already received by the depositary at the
time of the cancellation’s decision of subscription request will be returned to the subscribers concerned without appli-
cation of interests.

The board of directors of the Company may also decide, at its own discretion, to cancel the initial offering subscription

of shares for a sub-fund or a share class. In this case subscribers who have already made subscription requests will be
informed in due form and, by way of derogation from the preceding paragraph, subscription requests received will be
cancelled. Any subscription price that has been already received by the depositary will be returned to the subscribers
concerned without application of interests.

In general, in case of refusal of a subscription request by the board of directors, any subscription price that has been

already received by the depositary at the time of the refusal decision will be returned to the subscribers concerned
without application of interests, unless legal or regulatory provisions prevent or prohibit the return of the subscription
price.

Shares are only issued on acceptance of a corresponding subscription order. For the shares issued upon acceptance

of a corresponding subscription order but for which all or part of the subscription price will not have been received by
the Company, the subscription price or the portion of the subscription price not yet received by the Company shall be
considered as a receivable of the Company with respect to the subscriber concerned.

Subscriptions may also be made by contribution of transferable securities and other authorised assets other than cash,

where authorised by the board of directors, which may refuse its authorisation at its sole discretion and without providing
justification. Such securities and other authorised assets must satisfy the investment policy and restrictions defined for
each sub-fund. They are valued according to the valuation principles specified in the Prospectus and these articles of
incorporation. To the extent required by the amended Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies
or by the board of director, such contributions shall be the subject of a report drafted by the Company’s independent
authorised auditor. The expenses related to subscription by in-kind contribution shall not be borne by the Company
unless the board of directors considers that the in-kind subscription is favourable to the Company, in which case all or
part of the costs may be borne by the Company.

The board of directors can delegate to any director or to any other legal person approved by the Company for such

purposes, the tasks of accepting the subscriptions and receiving payments for the new shares to issue.

All subscriptions for new shares must, under pain of being declared null and void, be fully paid up. The issued shares

carry the same rights as the shares existing on the day of issue.

The board of directors may refuse subscription requests, at any time, at its sole discretion and without providing

justification. “

“ Art. 9. Redemption of shares. All shareholders are entitled at any time to request the Company to redeem some or

all of the shares they hold.

The redemption price of a share shall be equal to its net asset value, as determined for each class of shares, according

to these articles of incorporation. Redemptions are based on the prices established for the applicable Valuation Day
determined according to this Prospectus. The redemption price may be reduced by the redemption fees, commissions
and the dilution levy stipulated in this Prospectus. Payment of the redemption must be made in the currency of the class
of shares and is payable in the normal deadlines, as set more precisely in the Prospectus and taking effect on the applicable
Valuation Day.

Neither the Company nor the board of directors may be held liable for a failure to pay or a delay in payment of the

redemption price if such a failure or delay results from the application of foreign exchange restrictions or other circums-
tances beyond the control of the Company and/or the board of directors.

All redemption requests must be submitted by the shareholder (i) in writing to the Company’s registered office or to

another legal entity designated by the Company for the redemption of shares or (ii) by requesting by any electronic means
approved by the Company. The request must specify the name of the investor, the sub-fund, the class, the number of
shares or the amount to be redeemed, and the payment instructions for the redemption price and/or any other infor-
mation specified in the Prospectus or the redemption form available at the registered office of the Company or from
another legal person authorised to process share redemptions.

Subscription requests accepted by the Company are final and commit the shareholder except when the calculation of

the net asset value of the shares for redemption is suspended. However, the board of directors may, but is not required
to do so, agree to modify or cancel a redemption request when there is an obvious error on the part of the shareholder
that requested the redemption, on condition that the modification or cancellation is not detrimental to the other sha-
reholders in the Company.

Shares redeemed by the Company shall be cancelled.
When agreed by the shareholders concerned, the board of directors may, on a case-by-case basis, decide to make in-

kind payments, while complying with the principle of equal treatment of shareholders, by allocating to or for shareholders
that request redemption of their shares, transferable securities or assets other than transferable securities and cash from
the portfolio of the sub-fund concerned, the value of which is equal to the redemption price of the shares. To the extent
required by applicable laws and regulations or by the board of directors, all in-kind payments will be valued in a report

31889

L

U X E M B O U R G

prepared by the Company’s independent authorised auditor and will be equitably conducted. The expenses related to
redemptions by in-kind contribution shall not be borne by the Company unless the board of directors considers that the
in-kind redemption is favourable to the Company, in which case all or part of the costs may be borne by the Company.

The board of directors can delegate to (i) any director or to (ii) any other legal person approved by the Company for

such purposes the tasks of accepting the redemptions and paying the price for shares to redeem.

In the event of redemption and/or conversion in a sub-fund bearing on 10% or more of the net assets of the sub-fund,

this latter may either:

- postpone the payment of the redemption price of such requests to a date at which the Company will have sold the

necessary assets and it will have the proceeds from such sales;

- postpone whole or part of such requests to a later Valuation Day determined by the board of directors, when the

Company will have sold the necessary assets, taking into consideration the interests of all shareholders and when it will
have the proceeds from such sales. These requests shall be treated with priority over any other request.

In addition, the Company can postpone the payment of all requests for redemption and/or conversion for a sub-fund:
- if any one of the stock exchanges and/or other markets on which the sub-fund concerned were broadly exposed, in

the opinion of the board of directors, were closed or;

- if transactions on stock exchanges and/or other markets on which the sub-fund concerned were broadly exposed,

in the opinion of the board of directors, were restricted or suspended.

If,  following  the  acceptance  and  execution  of  a  redemption  order,  the  value  of  the  remaining  shares  held  by  the

shareholder in the sub-fund or in the class of shares falls below a minimum amount as may be determined by the board
of directors for the sub-fund or the class of shares, the board of directors can rightfully believe that the shareholder has
requested the redemption of all of its shares held in that sub-fund or class of shares. The board of directors can, in this
case at its sole discretion, execute a forced redemption of the remaining shares held by the shareholder in the sub-fund
or the class concerned.”

“ Art. 10. Conversion of shares. Subject to any restrictions set by the board of directors, shareholders are entitled to

switch from one sub-fund or one class of shares to another sub-fund or another class of shares and to request conversion
of the shares they hold in one sub-fund or one share class to shares belonging to another sub-fund or share class.

Conversion is based on the net asset values of the class of shares of the relevant sub-fund as determined in accordance

with these articles of incorporation on the common Valuation Day set in accordance with the provisions of the Prospectus,
taking into consideration any prevailing exchange rate between the currencies of the two sub-funds on the Valuation Day.
The board of directors may set the restrictions that it deems necessary for the frequency of conversions. It may impose
payment of conversion fees the amount of which it will reasonably determine.

Conversion requests accepted by the Company are final and commit the shareholder except when the calculation of

the net asset value of the shares for conversion is suspended. The board of directors, however, may but is not required
to do so, agree to a modification or a cancellation of a conversion request when there is an obvious error on the part
of the shareholder that requested the conversion on condition that the modification or cancellation is not detrimental
to the other shareholders in the Company.

All conversion requests must be submitted by the shareholder (i) in writing to the Company’s registered office or to

another legal entity designated by the Company for the conversion of shares or (ii) by requesting by any electronic means
approved by the Company. The request must specify the name of the investor, the sub-fund, the class of shares held, the
number of shares or the amount to convert, as well as the sub-fund and the class of shares to obtain in exchange and/or
any other information specified in the Prospectus or the conversion form available at the registered office of the Company
or from another legal person authorised to process share conversions.

The board of directors can set a minimum threshold for conversion of each class of shares. Such a threshold may be

defined by the number of shares or by the amount.

The board of directors may decide to allocate any fractions of shares generated by the conversion or pay a cash amount

corresponding to these fractions to the shareholders requesting conversion.

Shares which have been converted into other shares shall be cancelled.
The board of directors may delegate to any director or to any other legal person approved by the Company for such

purposes the tasks of accepting the conversions and paying the price for shares to convert.

In the event of redemption and/or conversion in a sub-fund bearing on 10% or more of the net assets of the sub-fund

or a threshold below 10% deemed critical by the board of directors, the board may either:

- postpone the payment of the redemption price of such requests to a date at which the Company will have sold the

necessary assets and it will have the proceeds from such sales;

- postpone whole or part of such requests to a later Valuation Day determined by the board of directors, when the

Company will have sold the necessary assets, taking into consideration the interests of all shareholders and when it will
have the proceeds from such sales. These requests shall be treated with priority over any other request.

In addition, the Company may postpone the payment of all requests for redemption and/or conversion for a sub-fund:

31890

L

U X E M B O U R G

- if any one of the stock exchanges and/or other markets on which the sub-fund concerned were broadly exposed, in

the opinion of the board of directors, were closed or;

- if transactions on stock exchanges and/or other markets on which the sub-fund concerned were broadly exposed,

in the opinion of the board of directors, were restricted or suspended.

The board of directors may reject all conversion request for an amount lower than the minimum conversion amount

as set from time to time by the board of directors and indicated in the Prospectus.

If, following the acceptance and execution of a conversion order, the value of the remaining shares held by the sha-

reholder in the sub-fund or in a class of shares from which the conversion is requested falls below a minimum amount
as may be determined by the board of directors for the sub-fund or the class of shares, the board of directors may
rightfully believe that the shareholder has requested the conversion of all of its shares held in that sub-fund or class of
shares. The board of directors may, in this case at its sole discretion, execute a forced conversion of the remaining shares
held by the shareholder in the sub-fund of the class concerned in which the conversion is requested.”

“ Art. 11. Transfer of shares. All transfers, inter vivos or because of decease, of registered shares will be recorded in

the shareholders’ register.

The transfer of bearer shares, represented by global certificates of shares held in custody by a clearing and settlement

system, will be executed by the registration of the shares transfer with the clearing entity in question.

The transfer of registered shares will be executed by recording in the register following remittance to the Company

of the transfer documents required by the Company including a written declaration of transfer provided to the share-
holders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives.

The Company may, for bearer shares, consider the bearer and, for registered shares, consider the person in whose

name the shares are recorded in the shareholders’ register as the owner of the shares and the Company will incur no
liability toward third parties resulting from transactions on these shares and shall rightfully refuse to acknowledge any
rights, interests or pretentions of any other person on these shares; these provisions, however, do not deprive those
who have the right to request to record registered shares in the shareholders’ register or a change in the record in the
shareholders’ register.”

“ Art. 12. Restrictions on the ownership of shares. The Company may restrict, prevent or prohibit ownership of shares

of the Company by any individual or legal entity, including by persons from the United States of America as defined
hereinafter.

The Company may moreover issue restrictions that it deems necessary in order to make sure that no share of the

Company is acquired or held by (a) a person who has violated the laws or requirements of any country or governmental
authority,  (b)  any  person  whose  situation,  in  the  opinion  of  the  board  of  directors,  could  lead  the  Company  or  its
shareholders to incur a risk of legal, fiscal or financial consequences, that it would not have incurred or that it would not
have otherwise incurred or (c) a person from the United States (each of these persons referred to in (a), (b) and (c) being
defined hereinafter as a “Prohibited Person”).

In this regard:
1. The Company may refuse to issue shares and record shares’ transfer if it appears that this issue or transfer would

or could result in a Prohibited Person being granted share ownership.

2. The Company may request any person included in the shareholders’ register or requesting a shares’ transfer to be

recorded to provide it with all the information and certificates that it deems necessary, accompanied by a sworn statement
if appropriate, in order to determine whether these shares are or will be effectively owned by a Prohibited Person.

3. The Company may carry out a forced redemption if it appears that a Prohibited Person, either acting alone or with

others, has ownership of Company shares or it appears that confirmations given by a shareholder were not exact or have
ceased to be exact. In this case, the following procedure shall be applied:

a) The Company shall send a notice (hereinafter the “redemption notice”) to the shareholder owning the shares or

indicated in the shareholders’ register as being the owner of the shares. The redemption notice shall specify the shares
to be redeemed, the redemption price to be paid and the location where this price is to be paid to the shareholder. The
redemption notice may be sent by registered letter to the shareholder at the shareholder’s last known address or to the
address recorded in the shareholders’ register.

As soon as the offices are closed on the day specified in the redemption notice, the shareholder in question shall cease

to be the owner of the shares specified in the redemption notice; if they are registered shares, the shareholder’s name
shall be removed from the shareholders’ register; if they are bearer shares, the bearer share certificates representing
these shares shall be cancelled in the books of the Company.

b) The price at which the shares specified in the redemption notice shall be repurchased (“redemption price”) shall

be the redemption price based on net asset value of the shares of the Company (appropriately reduced as specified in
these articles of incorporation) immediately preceding the redemption notice. From the date of the redemption notice,
the shareholder in question shall lose all shareholder’s rights.

c) The payment shall be made in the currency determined by the board of directors. The redemption payment will be

deposited by the Company for the shareholder in a bank, in Luxembourg or elsewhere, specified in the redemption notice,

31891

L

U X E M B O U R G

that will send it to the shareholder in question upon remittance of the certificate(s) indicated in the redemption notice.
As soon as the redemption price has been paid under these conditions, no party with an interest in the shares mentioned
in the redemption notice shall have any right over these shares or be able to take any action against the Company or its
assets, with the exception of the right of the shareholder appearing as the owner of the shares to receive the redemption
price (without interests) deposited at the bank upon delivery of the certificate(s) indicated in the redemption notice.

d) The Company’s use of the powers conferred in this article may not, under any circumstances, be contested or

invalidated on the grounds that there is insufficient proof of the ownership of the shares by any person or that a share
belonged to another person who the Company had not recognised when sending out the redemption notice, provided
the Company acts in good faith.

4. The Company may refuse, at any general meeting of the shareholders, the voting right to any Prohibited Person and

to any shareholder to whom a redemption notice has been sent for the shares indicated in the redemption notice.

The term “person from the United States of America”, as used in these articles of incorporation means any expatriate,

citizen or resident of the United States of America or of one of the territories or possessions under its jurisdiction, or
persons who normally reside there (including the succession of any persons or companies or associations established or
organised there). This definition may be amended if necessary by the board of directors and specified in the Prospectus.

If the board of directors is aware or reasonably suspects that a shareholder owns shares and does not meet the

required conditions for ownership stipulated for the sub-fund or the class of shares in question, the Company may:

- either execute a forced redemption of the shares in question in accordance with the procedure for redemption

described above;

- or execute forced conversion of shares to shares in another class within the same sub-fund for which the shareholder

in question meets the conditions of ownership (provided that a class exists with similar characteristics concerning, inter
alia, the investment objective, the investment policy, the currency, the frequency of calculation of the net asset value, the
distribution policy). The Company will inform the shareholder in question on this conversion.”

“ Art. 25. General meetings. All general meetings of the shareholders are convened by the board of directors.
The general meeting of the shareholders is convened in the delays and in accordance with procedures laid down by

law. If any bearer shares are in circulation, the meeting notice shall be published in the forms and the delays prescribed
by law.

In conditions laid down by applicable laws and regulations, the meeting notice for any general meeting of the share-

holders may specify that the conditions of quorum and majority required shall be determined with respect to shares
issued and outstanding as of a certain date and time preceding the meeting (“Date of Registration”), considering that a
shareholder’s right to participate in a general meeting of shareholders and to exercise the right to vote attached to its
share(s) shall be determined according to the number of shares held by said shareholder on the Date of Registration.

The general meeting of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg, at the place indicated in the

meeting notice, on the Third Wednesday of the month of May every year at 4 p.m., and for the first time in May 2014. If
this day is a public holiday, the general meeting of shareholders shall be held on the following bank business day.

The board of directors may in accordance with applicable laws and regulations decide to hold a general meeting of the

shareholders at another date and/or other time or other location than those specified in the preceding paragraph, provided
that the meeting notice indicates this other date, other time or other place.

Other general meetings of shareholders of the Company or of sub-funds may be held at the locations and on the dates

indicated in the respective notices of these meetings. Shareholders’ meetings of sub-funds may be held to deliberate on
any matter relating that concerns only those sub-funds. Two or more sub-funds may be considered as one single sub-
fund if such sub-funds are affected in the same manner by the proposals requiring approval by shareholders of the sub-
funds in question.

Moreover, any general meeting of the shareholders must be convened such that it is held within one month, when

shareholders representing one tenth of the share capital submit a written request to the board of directors indicating
the items to include on the meeting agenda.

One or more shareholders, together owning at least ten percent of the share capital, may request the board of directors

to include one or more items in the meeting agenda of any general meeting of the shareholders. This request must be
sent to the registered office of the Company by registered letter at least five days before the meeting.

Any general meeting of the shareholders may be held abroad if the board of directors, acting on its own authority,

decides that this is warranted by exceptional circumstances.

The business conducted at a general meeting of shareholders shall be limited to the points contained in the agenda

and to matters related to these points.”

“ Art. 31. Expenses borne by the Company. The Company shall be responsible for the payment of all of its operating

expenses, in particular:

- fees and reimbursement of expenses to the board of directors;

31892

L

U X E M B O U R G

- compensation of investment advisors, investment managers, the Management Company, the depositary, its central

administration, authorised representatives of the financial department, paying agents, independent authorised auditor,
legal advisors of the Company as well as other advisors or agents which the Company may call upon;

- brokerage fees;
- the fees for the production, printing and distribution of the Prospectus, the key investor information document, and

the annual and half-year reports;

- fees and expenses incurred in the set-up of the Company;
- taxes and duties, including the subscription tax and governmental rights related to its activity;
- insurance costs of the Company, its directors and managers;
- fees and expenses related to the Company’s registration and continued registration with government organisations

and Luxembourg and foreign stock exchanges;

- expenses for publication of the net asset value and the prices of subscription and redemption or any other document

including the expenses for the preparation and printing in all languages deemed useful in the interest of the shareholders;

- expenses related to the sales and distribution of the shares of the Company including the marketing and advertising

expenses determined in good faith by the board of directors of the Company;

- expenses related to the creation, hosting, maintenance and updating of the Company’s Internet sites;
- legal expenses incurred by the Company or its depositary when acting in the interests of the Company’s shareholders;
- legal expenses of directors, partners, managers, official representatives, employees and agents of the Company in-

curred by themselves in relation with any action, lawsuit or process in which they are involved in consequence of they
are or have been directors, partners, managers, official representatives, employees and agents of the Company.

- all exceptional expenses, including, but without limitation, legal expenses, interests and the total amount of all taxes,

duties, rights or any similar expenses imposed on the Company or its assets.

The Company is a single legal entity. The assets of a given sub-fund shall only be liable for the debts, liabilities and

obligations concerning that sub-fund. Expenses that cannot be directly attributed to a particular sub-fund shall be spread
across all sub-funds in proportion to the net assets of each sub-fund.

The incorporation fees of the Company may be amortised over a maximum of five years starting from the date of

launching of the first sub-fund, in proportion to the number of operational sub-funds, at that time.

If a sub-fund is launched after the launch date of the Company, the setup expenses for the launch of the new sub-fund

shall be charged solely to that sub-fund and may be amortised over a maximum of five years from the sub-fund’s launch
date.”

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present shareholders meeting are estimated at EUR 1.800,-.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil statuses and residences, they signed together with us, the Notary, the present original deed.

Signé: L. MOULARD, I. BRANGBOUR, N. HOFFMANN, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6283. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 mars 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015038211/377.
(150042615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Fortune Finance Participations (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 154.404.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 26 janvier 2015

Le Conseil d'Administration accepte la démission de BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-51.675 en tant que déléguée à la gestion journalière des affaires de la société.

31893

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
FORTUNE FINANCE PARTICIPATIONS (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015018108/12.
(150021535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

Interfinancial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 31.094.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 29 janvier 2015

La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège

social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.

Pour extrait sincère et conforme
INTERFINANCIAL S.A.

Référence de publication: 2015018190/12.
(150022361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

Air Valanga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 173.222.

L'an deux mille quatorze, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AIR VALANGA S.A., avec siège social à

L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 173222,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 novembre 2012, publié au Mémorial

C numéro 143 du 21 janvier 2013.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Solange

Wolter, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille cinq cents

(1.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital de cent cin-
quante mille euros (€ 150.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps

aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Décision de mettre la société en liquidation
2) Nomination de FIDESCO S.A. comme liquidateur.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).
Est nommé liquidateur:
La société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578.

31894

L

U X E M B O U R G

L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et

suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu'il doit recourir à une autorisation particulière de l’as-
semblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs

à un ou plusieurs mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l’actif immobilier de la société, d'encaisser le prix de vente et

de renoncer au privilège du vendeur et à l’action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63745. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Référence de publication: 2015018659/57.
(150022599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Aedes SCI, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2357 Luxembourg, 6, rue des Pins.

R.C.S. Luxembourg E 839.

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. Monsieur Gerd RECHT, né à Hambourg (Allemagne), le 24 mai 1948, demeurant à D-72805 Lichtenstein, 8, Rainweg.
2. Monsieur Olaf RECHT, né à Luxembourg, le 26 mars 1975, demeurant à L-2357 Senningerberg, 6, rue des Pins.
3. Madame Birgit RECHT-GREISZ, née à Hambourg (Allemagne), le 7 mai 1952, demeurant à L-2357 Senningerberg,

6, rue des Pins.

4. Madame Christina RECHT, née à Luxembourg, le 24 novembre 1976, demeurant à Endlhauser straβe 9, D-82064

straβlach-Dinhgarting.

Les comparantes sub 3 et 4 étant ici représentées par Monsieur Gerd RECHT, prénommé, en vertu de deux procu-

rations sous seing privé, lesquelles procurations signées ne varietur par les comparants sub 1 et 2 et le notaire soussigné
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, sont les seuls associés de la société civile immobilière «AEDES SCI», ayant

son siège social à L-2357 Senningerberg, 6, rue des Pins, constituée suivant acte notarié du 10 mars 1988, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 158 du 10 juin 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte notarié du 21 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 104 du
29 février 1996 (la «Société»).

Les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant la totalité du capital social, requièrent le notaire soussigné de

prendre acte de leurs décisions comme suit:

<i>Première résolution:

Les associés décident de convertir le capital social de la Société fixé à un million de francs luxembourgeois (1.000.000

frs.) en euros et d’augmenter celui-ci à concurrence d’un montant de deux cent dix euros soixante-cinq cents (EUR
210,65), pour le porter à un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-) représenté par mille (1.000) parts d’intérêts
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune. Le montant de deux cent dix euros et soixante-cinq cents (EUR
210,65.-) a été intégralement libéré par un versement en espèces, ce qui est reconnu par les associés.

<i>Deuxième résolution:

Les associés déclarent approuver la donation de dix (10) parts d’intérêts appartenant à Monsieur Gerd RECHT à

Madame Franziska BLOCKHAUS née RECHT qui sera documentée par acte du notaire soussigné en date de ce jour.

31895

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution:

Suite aux résolutions qui précèdent et compte tenu de la donation dont question ci-avant qui sera faite concomitam-

ment aux présentes, les associés décident de modifier l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la
teneur suivante:

«  Art. 5.  Le  capital  social  est  fixé  à  VINGT-CINQ  MILLE  euros  (EUR  25.000)  représenté  par  mille  (1.000)  parts

d’intérêts de VINGT-CINQ euros (EUR 25) chacune.

Ces parts sont réparties comme suit:

1.- Madame Birgit RECHT-GREISZ:
Trois cent trente parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

2.- Monsieur Olaf RECHT:
Trois cent trente parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

3.- Madame Christina RECHT:
Trois cent trente parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

4.- Madame Franziska BLOCKHAUS née RECHT:
Dix parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: Mille parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les parts d’intérêts sont entièrement souscrites et libérées.»

<i>Déclaration du gérant

Monsieur Gerd RECHT, agissant en sa qualité de gérant de la Société, déclare se tenir, au nom de la Société, la susdite

donation comme dûment signifiée.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. RECHT, O. RECHT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C, le 30 décembre 2014. LAC / 2014 / 63967. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Référence de publication: 2015018654/63.
(150022910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Auto Klass Concept, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5423 Ersange, 19, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 159.529.

L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois de janvier.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Lionel Jean-Louis GIRAUD-CLAUDE, dirigeant de société, né à Marseille, le 21 juin 1973, demeurant à 144,

Boulevard Charles Simonis, L-2539 Luxembourg-Cents.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d'acter ce qui suit:
I.- Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «AUTO KLASS CONCEPT», avec

siège social à L-5280 Sandweiler, Z.I Rolach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
le numéro B 159.529, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du
25 février 2011, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1183 du 1 

er

 juin 2011, et

dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés la dernière fois par un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire
de résidence à Luxembourg, le 28 octobre 2013 publié au Mémorial C N° 2815 du 11 novembre 2013 (ci-après «la
Société»).

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune, toutes entièrement libérées et appartenant à l’associé unique comme
suit:

- Monsieur Lionel Jean-Louis GIRAUD-CLAUDE, pré-qualifié,
Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

31896

L

U X E M B O U R G

III. L’associé unique, prénommé, représentant l’intégralité du capital social, s’est réuni en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre
sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de l’adresse actuelle à L-5280 Sandweiler, Z.I Rolach à l’adresse suivante L-5423 Ersange,

19, rue du Village;

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société;
3. Divers.
Après en avoir délibéré, le comparant a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société de l’adresse actuelle L-5280 Sandweiler, Z.I Rolach

à l’adresse suivante L-5423 Ersange, 19, rue du Village.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier en

conséquence l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner à la teneur suivante:

Art. 5. «Le siège de la Société est établi dans la commune de Waldbredimus.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du Conseil d’Adminis-

tration, et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en
matière de modification de Statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. J.-L. GIRAUD-CLAUDE, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1813. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 04 février 2015.

Référence de publication: 2015018682/61.
(150023033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Medima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5495 Wintrange, 6, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 72.180.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den fünfzehnten Tag im Monat Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft MEDIMA S.A., mit Sitz in L-5495 Wintrange, 6, Waistrooss, eingetragen im Handelsregister Lu-
xemburg unter der Nummer B 72.180, gegründet durch Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 6. Oktober 1999,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 988 vom 22. Dezember 1999, abgeändert durch Urkunde des Unterzeichnenden
Notars am 17. Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 313 vom 12. Februar 2010 (die „Gesellschaft“).

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Rainer ERZ, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-6793

Grevenmacher, 77, route de Tréves.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Jean-Pierre Dias, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Senningerber.
Die Versammlung erwählt zum Stimmzähler Herrn Rainer ERZ, vorgenannt.

31897

L

U X E M B O U R G

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf

einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem ins-

trumentierenden Notar “ne varietur“ unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Entscheidung, dass die Aktien der Gesellschaft Namensaktien sind und bleiben.
2.- Abänderung von Artikel 5 der Satzung wie folgt:

„ Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

Die Gesellschaftsaktien sind Namensaktien.
Ein Register der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung

steht. Dieses Register enthält alle durch Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgeschriebenen Auskünfte. Das Eigentum
an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet.“

3.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, dass die Aktien der Gesellschaft Namensaktien sind und bleiben.

<i>Zweiter Beschluss

In Folge dessen, beschliesst die Generalversammlung Artikel 5 der Satzung abzuändern wie folgt:

„ Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

Die Gesellschaftsaktien sind Namensaktien.
Ein Register der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung

steht. Dieses Register enthält alle durch Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgeschriebenen Auskünfte. Das Eigentum
an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet.“

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

<i>Kosten

Die  Kosten  welche  der  Gesellschaft  wegen  der  gegenwärtigen  Urkunde  obliegen,  werden  auf  EINTAUSENDEIN-

HUNDERT EURO (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Rainer Erz, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 16 janvier 2015. 1LAC / 2015 / 1334. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Für gleichlautende Kopie - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Senningerberg, den 27. Januar 2015.

Référence de publication: 2015019027/64.
(150023142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

31898

L

U X E M B O U R G

Car Doc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 72-78, rue de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 194.198.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le seize janvier.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- Boban BAN, salarié, demeurant à L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il

déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "CAR DOC S.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.

Art. 3. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, pour compte propre ou pour

compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l’explotation d'une station de services
pour  véhicules  ainsi  que  toutes  opérations  industrielles,  commerciales  ou  financières,  mobilières  ou  immobilières  se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le déve-
loppement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€), représenté par CENT (100) parts

sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- €) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication
de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Boban BAN, sudit, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total : Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que le capital au montant de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès lors à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à sept cent soixante euros (760,- €).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-4025 Esch-sur-Alzette, 72-78, rue de Belvaux.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Est nommé gérant technique, pour une durée illimitée:
* Hélder Agostinho MARTINS PEREIRA, salarié, demeurant à L-4265 Esch-sur-Alzette, 21, rue des Noyers.
- Est nommé gérant administratif, pour une durée illimitée:
* Boban BAN, salarié, demeurant à L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.

31899

L

U X E M B O U R G

La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: BAN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 janvier 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 1969. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 4 février 2015.

Référence de publication: 2015018753/65.
(150023005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Deka Rue Cambon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.100.000,00.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 148.220.

Im Jahre zweitausend und vierzehn, am sechzehnten Dezember,
vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Gesellschafter der Deka Rue Cambon S.à r.l.,

eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg, die am
8. September 2009 durch Urkunde des unterzeichnenden Notars gegründet wurde, welche im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, vom 8. Oktober 2009 mit der Nummer 1966 veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde zuletzt
abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 11. Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Num-
mer 221 vom 2. Februar 2010.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Gerd Kiefer, Bankangestellter, geschäftsansässig in Luxemburg,

eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Annick Braquet, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, zur Protokollfüh-

rerin der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zur Schriftführerin Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxem-

burg.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I. Aus einer durch die Gesellschafter, beziehungsweise deren Bevollmächtigten, gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise die Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlich vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Ak-
tionäre bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

II.  Die  Versammlung  ist demnach  ordnungsgemäß  zusammengesetzt und kann rechtsgültig über  die  Tagesordnung

abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden ist.

III. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 63.000.000,00 EUR um es von seinem jetzigen Betrag von 37.100.000,00 EUR

auf 100.100.000,00 EUR zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 630.000 neuen Anteilen, welche durch die
alleinige Gesellschafterin gezeichnet werden und vollständig in bar eingezahlt werden

2. Zeichnung und Einzahlung der neuen Anteile
3. Entsprechende Änderung von Artikel 6 der Satzung- Kapital der Gesellschaft
Sodann trifft die Generalversammlung nach Beratung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die  außerordentliche  Generalversammlung  beschließt,  das  Gesellschaftskapital  um  dreiundsechzig  Millionen  Euro

(63.000.000,00 EUR) auf einhundert Millionen eintausend Euro (100.100.000,00 EUR) zu bringen, durch die Schaffung und
Ausgabe von sechshundertdreißig Tausend (630.000) neuen Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro
(100,00 EUR).

31900

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

Die sechshundertdreißig Tausend (630.000) neuen Anteile werden sodann durch den alleinigen Gesellschafter der

Deka Rue Cambon S.à r.l., die Deka Immobilien Investment GmbH (in ihrer Funktion als Verwalterin des Fonds Deka-
Immobilien Europa), hier vertreten aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht durch Herrn Gerd Kiefer, vorgenannt,
gezeichnet.

Die Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Die sechshundertdreißig Tausend (630.000) neuen Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag

von dreiundsechzig Millionen Euro (63.000.000,00 EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeich-
neten Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich festgestellt wurde.

<i>Dritter Beschluss

Auf Grund dieser Kapitalerhöhung wird Absatz 1 von Artikel sechs (6) der Satzung wie folgt abgeändert:

„ Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 100.100.000 (einhundert Millionen einhunderttausend Euro), eingeteilt

in 1.001.000 Aktien (eine Million ein Tausend) Gesellschaftsanteile zu je EUR 100 (einhundert Euro)“

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 6.500.-.

Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. KIEFER, A. BRAQUET, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63322. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 3. Februar 2015.

Référence de publication: 2015018790/67.
(150022311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Ermital Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9972 Lieler, 46, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 180.109.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Edouard DELOSCH mit Amtswohnsitz in Diekirch.

Ist erschienen:

Herr Andreas ULFIG, Kaufmann, geboren am 5. Juli 1958 in Berod (Deutschland), wohnhaft in NL-6224 GV Maastricht,

170A, Frankenstraat (Niederlande).

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte, Nachfolgendes zu beurkunden:
I.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „ERMITAL Invest SARL“, mit Sitz in L-9972 Lieler, 46, Hauptstrooss,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B und Nummer 180.109, wurde gegründet
gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Edouard Delosch, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
am 28. August 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2702, vom 29. Oktober
2013. Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert seit der Gründung der Gesellschaft („die Gesellschaft“).

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile

von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), alle den Herrn Andreas ULFIG, vorbenannt, gehörend, und somit
ist das gesamte Kapital hier vertreten.

III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft „ERMITAL Invest SARL“ und ihre Liquidation.
2. Ernennung von Herrn Andreas ULFIG als Liquidator der Gesellschaft, und Festlegung von seinen Befugnissen;
3. Verschiedenes.
IV. Alsdann ersuchen der einzige Gesellschafter den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden:

31901

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft „ERMITAL Invest SARL“ und ihre

Liquidation.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Herr Andreas ULFIG, Kaufmann, geboren am 5. Juli 1958 in Berod (Deuts-

chland), wohnhaft in NL-6224 GV Maastricht, 170A, Frankenstraat (Niederlande) zum Liquidator der Gesellschaft zu
ernennen.

Der Liquidator verfügt über die weitgehendsten durch das Gesetz, und namentlich durch die Artikel 144 bis 148 des

abgeänderten Luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, vorgesehenen Befugnisse
und Vollmachten, sogar ohne vorherige Ermächtigung durch die Generalversammlung im Falle wo diese Ermächtigung
normalerweise erforderlich wäre.

<i>Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf unge-

fähr eintausend zweihundert Euros (EUR 1.200,-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Diekirch, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an der Komparent, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben er selbst mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. ULFIG, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1818. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 04. Februar 2015.

Référence de publication: 2015018847/49.
(150023041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Orion IV European 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 28.913,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 185.272.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 1 

er

 février 2015 et se

trouve désormais au:

- Noordensweg 52, 2421 XZ Nieuwkoop, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Orion IV European 16 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015019072/17.
(150022288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Oriel S.A., Société Anonyme,

(anc. Oriel S.A.-SPF).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 50.771.

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),

s’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «ORIEL S.A.», établie et ayant son

siège social au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 50771, constitué suivant acte de scission par acte notarié en date du 17 mars

31902

L

U X E M B O U R G

1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 337 du 24 juillet 1995. Les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 septembre 2010, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2377 du 05 novembre 2010.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume SCROCCARO, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification du statut fiscal de la Société qui n’aura plus désormais le statut d'une société de gestion de patrimoine

familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification de l’article premier des statuts de la société qui se lira dorénavant comme suit:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de «ORIEL S.A.».
3. Modification de l’article deux des statuts de la société comme suit:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également développer, acquérir, céder et exploiter des marques, brevets et tous autres droits similaires

ou équivalents, à Luxembourg et à l’étranger.

Elle pourra encore employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres, les
réaliser par voie de vente,de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder à d’autres
sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient un participation ou qui font partie du même groupe de sociétés
que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

4. Modification de l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut fiscal de la Société qui n’aura plus désormais le statut

d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts de la société

qui se lira dorénavant comme suit:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de «ORIEL S.A.».

31903

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article deux des statuts de la société comme suit:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également développer, acquérir, céder et exploiter des marques, brevets et tous autres droits similaires

ou équivalents, à Luxembourg et à l’étranger.

Elle pourra encore employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres, les
réaliser par voie de vente,de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder à d’autres
sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient un participation ou qui font partie du même groupe de sociétés
que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à six cent vingt-cinq mille euros (625.000.- EUR) divisé en deux mille cinq cents (2.500)

actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250.-EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire,

selon le cas, répondant aux conditions de l’Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur
sont inscrites au nom de l’actionnaire propriétaire des actions.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société

ou par le dépositaire en cas d’actions au porteur.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. GEURTS, G. SCROCCARO, F. MIGNON, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2014. Relation: EAC/2014/18342. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015019108/113.

(150022865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

31904

L

U X E M B O U R G

Orion IV European 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.250,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 160.706.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 1 

er

 février 2015 et se

trouve désormais au:

- Noordensweg 52, 2421 XZ Nieuwkoop, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Orion IV European 2 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015019073/17.
(150022208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Oxford BioChronometrics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 58, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 183.812.

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of Janaury,
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in [Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Oxford BioChronometrics S.A., a société anonyme (public

company limited by shares), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 58, Boulevard de la Pétrusse, L-2230 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and re-
gistered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number
B 183.812 (the “Company”).

The meeting is opened by Mr Bob PLEIN, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg,

being in the chair, who appoints as secretary Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, 3,
route de Luxembourg,

The meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxem-

bourg.

The notary enacted that:
I. the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list; the attendance list and the proxies, signed by the persons that appeared and the notary, shall remain here annexed
to be registered with the minutes;

II. it appeared from the attendance list that all of the 31,843 issued shares of the Company representing the whole

share capital of the Company were represented so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders had been duly informed; and

III. the agenda of the meeting be the following:

<i>Agenda

1. Waiver of the legal timing requirement for convening notices;
2. Ratification, and to the extent necessary approval, of the issuance of convertible debentures by the Company and

waiver of preferential subscription rights of the shareholders in connection therewith;

3. Removal of the reference to a nominal value of the shares of the Company;
4. Issuance of new shares of the Company without increasing the share capital of the Company;
5. Reintroduction of a nominal value of the shares of the Company;
6. Insertion of an authorized capital clause pursuant to which the board of directors of the Company shall be authorized,

for a period of five years, to increase the share capital of the Company and to limit or to withdraw any of the preferential
subscription rights of the shareholders of the Company in connection therewith, in the articles of association of the
Company;

7. Subsequent amendment to article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect such actions;

and

31905

L

U X E M B O U R G

8. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders of the Company (the “Shareholders”), acting through their

proxy holder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

As noted hereinabove, all of the Shareholders were represented at the meeting, and declared through their proxy

holder, that they had been duly informed of all the items on the agenda, and further thereto, it was resolved to waive the
timing requirement for convening notice as set forth in Article 70 of the law of 10 

th

 August, 1915 concerning commercial

companies, as amended from time to time (the “Law”) and/or the articles of association of the Company, and therefore,
allowing such meeting to be held and to validly decide on all the items of the agenda.

<i>Second resolution

It was reminded that:
- on October 1, 2014, the board of directors of the Company (the “Board”) ratified, and to the extent necessary

approved:

* the issuance of debentures convertible into shares (each a “First Lux Convertible Note” and together the “First Lux

Convertible Notes”) by the Company for an aggregate principal amount of EUR 500,000 (five hundred thousand Euros)
(the “First Lux Convertible Note Issuance”), with the convertible feature being subject to (a) the approval of the ex-
traordinary  general  meeting  of  the  Shareholders  and  (b)  the  waiver  by  all  the  Shareholders  of  their  preferential
subscription rights in connection with the First Lux Convertible Note Issuance; and

* the terms and conditions of such First Lux Convertibles Notes (the “T&amp;Cs of the First Lux Convertible Notes”);
- during the course of November and December 2014, the Company issued further debentures convertible into shares

(together the “Second Lux Convertible Notes” and together with the First Lux Convertible Notes, the “Lux Convertible
Note”) for an aggregate principal amount of EUR 350,000 (three hundred and fifty thousand Euros) (the “Second Lux
Convertible Note Issuance” and together with the First Lux Convertible Note Issuance, the “Lux Convertible Note
Issuances”), with the convertible feature as outlined above and the terms and conditions of such Second Lux Convertibles
Notes, being the same as the First Lux Convertible Notes (the “T&amp;Cs of the Second Lux Convertible Notes” and together
with the T&amp;Cs of the First Lux Convertible Notes, the “T&amp;Cs of the Lux Convertible Notes”).

It was noted that:
- pursuant to the provisions of article 32-3 (5) of the Law, the Board, when convening this extraordinary general

meeting, proposed to the Shareholders to waive any and all of their preferential subscription rights (i) with respect to
the Lux Convertible Note Issuances and (ii) in the event of conversion of the Lux Convertible Notes (a “Conversion”);

- in this respect, a report of the Board (the “Board’s Report”) had been prepared and provided to the Shareholders

for inspection, with it detailing the T&amp;Cs of the Lux Convertible Notes - including the issuance price of the Lux Convertible
Notes as well as the terms and conditions in the event of a Conversion.

It was unanimously resolved to:
(i) acknowledge having received the Board’s Report, and further thereto, having reviewed carefully the provisions of

the Board’s Report in connection with the above;

(ii) declare that the information provided for in the Board’s Report in connection with the above is sufficient, clear

and unequivocal so that all Shareholders may approve the Lux Convertible Note Issuances with full knowledge thereof;

(iii) approve the content of the Board’s Report in connection with the above;
(iv) ratify, and to the extent necessary, approve the Lux Convertible Note Issuances;
(v) approve the T&amp;Cs of the Lux Convertible Notes; and
(vi) waive any preferential subscription right under Article 32-3 (5) of the Law in connection with the Lux Convertible

Note Issuances and in the event of a Conversion.

<i>Third resolution

It was unanimously resolved to temporarily remove the reference to the nominal value of the 31,843 (thirty-one

thousand eight hundred and forty-three) shares that represented the share capital of the Company, then set at EUR
31,843 (thirty-one thousand eight hundred and forty-three euros).

<i>Fourth resolution

It was unanimously resolved to issue to the Shareholders an aggregate amount of 3,152,457 (three million one hundred

and fifty-two thousand four hundred and fifty-seven) new shares in the Company without increasing the share capital of
the Company (the “New Shares”), so as to raise the number of shares representing the share capital of the Company
from its current amount of 31,843 (thirty-one thousand eight hundred and forty-three) shares without nominal value, to
an amount of 3,184,300 (three million one hundred and eight-four thousand and three hundred) shares without nominal
value (the “Aggregate Shares”), with the New Shares being issued individually as follows:

31906

L

U X E M B O U R G

- an amount of 2,842,488 (two million eight hundred and forty-two thousand four hundred and eighty-eight) to Mr. A

Neal (resulting in Mr. A Neal holding a total amount of 2,871,200 (two million eight hundred and seventy-one thousand
and two hundred) of the Aggregate Shares);

- an amount of 92,961 (ninety-two thousand nine hundred and sixty-one) to Treveri Market S.A. (resulting in Treveri

Market S.A. holding a total amount of 93,900 (ninety-three thousand nine hundred) of the Aggregate Shares);

- an amount of 30,987 (thirty thousand nine hundred and eighty-seven) to AMMC Law S.A. (resulting in AMMC Law

S.A. holding a total amount of 31,300 (thirty-one thousand three hundred) of the Aggregate Shares);

- an amount of 18,513 (eighteen thousand five hundred and thirteen) to Mr. M Frisch (resulting in Mr. M Frisch holding

a total amount of 18,700 (eighteen thousand seven hundred) of the Aggregate Shares);

- an amount of 18,513 (eighteen thousand five hundred and thirteen) to Mr. P Keller (resulting in Mr. P Keller holding

a total amount of 18,700 (eighteen thousand seven hundred) of the Aggregate Shares);

- an amount of 15,444 (fifteen thousand four hundred and forty-four) to Mr. H Ochsner (resulting in Mr. H Ochsner

holding a total amount of 15,600 (fifteen thousand six hundred) of the Aggregate Shares);

- an amount of 102,564 (one hundred and two thousand five hundred and sixty-four) to Mr. A Kouwenhoven (resulting

in Mr. A Kouwenhoven holding a total amount of 103,600 (one hundred and three thousand and six hundred) of the
Aggregate Shares);

- an amount of 30,987 (thirty thousand nine hundred and eighty-seven) to Mr. A Fourie (resulting in Mr. A Fourie

holding a total amount of 31,300 (thirty-one thousand three hundred) of the Aggregate Shares);

<i>Fifth resolution

It was unanimously resolved to reintroduce the reference to a nominal value of the Aggregate Shares which was set

at EUR 0.01 (one cent) per share, without any amendment to the share capital of the Company.

<i>Sixth resolution

It was proposed to approve the insertion of an authorized capital clause pursuant to which the Board shall be autho-

rized, for a period of 5 (five) years from the publication of this notarial deed introducing the said authorized share capital
in the Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations C, to increase the share capital of the Company by a maximum
amount of EUR 1,000,000 (one million Euros) represented by 100,000,000 (one hundred million) shares with a nominal
value of EUR 0.01 (one cent) each (the “Authorized Capital”) in the articles of association of the Company.

It was noted that pursuant to the provisions of article 32-3 and 32-4 of the Law:
- the Board, when convening this extraordinary general meeting, proposed that, in the framework of the Authorized

Capital, the Board be further authorized to limit or to withdraw any of the legal preferential subscription rights of the
Shareholders in connection therewith (the “Authorization”); and

- the reasons and justifications to limit or to withdraw the preferential subscription rights of the Shareholders (the

“Justification”) have been provided for in the Board Report, with it detailing the corresponding proposed amendments
to article 5 of the articles of association of the Company.

It was unanimously resolved to:
(i) declare having reviewed carefully the provisions of the Board’s Report in connection with the above;
(ii) declare that the information and the Justification provided for in the Board’s Report are sufficient, clear and une-

quivocal so that all Shareholders may approve the Authorized Capital and the Authorization with full knowledge thereof;

(iii) approve the content of the Board’s Report in connection with the Justification, the Authorized Capital and the

Authorization; and

(iv) approve the Authorized Capital and the Authorization.

<i>Seventh resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it was unanimously resolved to amend article 5 of the articles of

association of the Company to read as follows:

“ Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 31,843 (thirty-one thousand eight hundred and forty-three euros) re-

presented by 3,184,300 (three million one hundred eighty-four thousand three hundred) shares with a nominal value of
EUR 0.01 (one cent) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company may issue redeemable shares and may redeem those shares whenever the Board of Directors considers

this to be in the best interest of the Company, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with
article 49-8 of the law of August 10, 1915, as amended, on commercial companies. The Board of Directors may create
such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law)
and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue premiums on the issue and sale of its

31907

L

U X E M B O U R G

shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Directors to provide for the payment of any shares
which the Company redeem in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the Company shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to parti-

cipate in any dividends declared by the Company or in any distribution paid upon the liquidation or winding up of the
Company.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in aforementioned article

49-8 of the law of August 10, 1915, as amended, on commercial companies.

The Company may furthermore issue, by way of private placement only, notes, bonds, debenture and any kind of debt

and/or equity securities.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law
The authorized share capital is set at EUR 1,000,000 (one million Euros) represented by 100,000,000 (one hundred

million) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one cent) each (the “Authorized Capital”).

The Board of Directors is authorized, for a period of five (5) years from the publication of the notarial deed introducing

the authorized share capital here above in the Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations C (the “Authorization
Period”), to increase the share capital of the Company in one or more instalments, by a maximum amount equivalent to
the Authorized Capital. For the avoidance of doubt, in the context of the Authorized Capital, the Board of Directors is
authorized to issue a maximum of 100,000,000 (one hundred million) new shares of the Company with a nominal value
of EUR 0.01 (one cent) each.

In the framework and the limit of the Authorized Capital, the Board of Directors may decide the issuance of debt

instruments (of any form whatsoever) convertible into shares of the Company (the “Convertible Instruments”). The
Board will determine the nature, the price, the interest rate as well as any other conditions, including the conditions of
issuance and conversion, of the Convertible Instruments.

The issuance of the Convertible Instruments shall be made within the Authorized Period. The issuance of the Con-

vertible Instruments can be made by a decision of the Board of Directors without any preferential right of subscription
to the Convertible Instruments or shares resulting from the conversion of such Convertible Instruments being reserved
to the shareholders of the Company or to the holders of Convertible Instruments, with the limitation or the withdrawal
of any such preferential right of subscription being at the discretion of the Board of Directors.

Any amendments to the present articles of association as a result of the implementation of the Authorized Capital

shall be enacted in a notarial deed by the Board of Directors, or any other person duly authorized for that purpose. After
each increase of the subscribed share capital according to the above, these articles of association shall be amended to
reflect such an increase.

In case the Company has bonds or other similar debt instruments in issue, the provisions of the Law regarding general

meetings of bondholders shall apply, unless otherwise provided for in the present articles of association or in the terms
and conditions governing the said bonds.”

There being no further business before the meeting, the meeting was thereupon declared closed.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the change of currency, have been estimated at about EUR 1,400.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated herewith that on request of the above appearing

person, the present deed was worded in English and followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed, together with the notary, the original notarial

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le seizième jour de janvier,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réuni

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Oxford BioChronometrics S.A., une société anonyme de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 58, Boulevard de la Pétrusse, L-2230 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.812
(la «Société»).

La séance de l’assemblée est ouverte par Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster,

3, route de Luxembourg, en qualité de président, et qui désigne en qualité de secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ,
employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, L’assemblée choisit en qualité de scru-
tateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg,

31908

L

U X E M B O U R G

Il a été demandé au notaire instrumentant d’acter que:
I. les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de

présence; la liste de présence ainsi que les procurations, signées par les parties comparantes ainsi que le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement;

II. il ressort de la liste de présence que les 31.843 actions émises de la Société représentant l’intégralité du capital social

de la Société, étaient représentées, de sorte que l’assemblée a pu décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés; et

III. l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dispense de l’exigence relative aux délais légaux en matière d’avis de convocation;
2. Ratification, et pour autant que nécessaire, approbation de l’émission d’obligations convertibles par la Société et

renonciation aux droits préférentiels de souscription y relatifs;

3. Suppression de la mention de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
4. Emission de nouvelles actions de la Société sans augmentation du capital social de la Société;
5. Réintroduction d’une mention de la valeur nominale des actions de la Société;
6. Insertion d’une clause de capital autorisé dans les statuts de la Société autorisant le conseil d’administration de la

Société, pendant une période de cinq ans, à augmenter le capital social de la Société ainsi qu'à limiter ou supprimer tous
droits préférentiels de souscription des actionnaires de la Société y relatifs,

7. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société en vue de refléter ces opérations; et
8. Divers.
Après que l’agenda ait été approuvé par les actionnaires de la Société (les «Actionnaires»), représentés par les parties

comparantes, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Tel que noté ci-dessus, la totalité des Actionnaires étaient représentés lors de l’assemblée et ont déclaré, par l’inter-

médiaire de leur mandataire, avoir dûment été informés de tous les points portés à l’ordre du jour et ainsi il a été décidé
de renoncer aux délais légaux en matière d’avis de convocation tels que prévus par l’article 70 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et/ou par les statuts de la Société et ainsi de permettre
la tenue de cette assemblée et de décider valablement sur tous les points de l’ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

Il a été rappelé que:
- le 1 

er

 octobre 2014, le conseil d’administration de la Société (le «Conseil d’Administration») a ratifié, et pour autant

que nécessaire, approuvé:

* l’émission d’obligations convertibles en actions (chacune une «Première Obligation Convertible Lux» et ensemble

les «Premières Obligations Convertibles Lux») par la Société pour un montant global en principal de 500.000 EUR (cinq
cent mille Euros) (la «Première Emission d’Obligations Convertibles Lux»), le caractère convertible étant soumis (a) à
l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des Actionnaires et (b) à la renonciation par tous les Actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription dans le cadre de la Première Emission d’Obligations Convertibles Lux; et

* les conditions générales des Premières Obligations Convertibles Lux (les «T&amp;Cs des Premières Obligations Con-

vertibles Lux»);

- au cours des mois de novembre et décembre 2014, la Société a émis des obligations convertibles en actions supplé-

mentaires (ensemble les «Secondes Obligations Convertibles Lux» et avec les Premières Obligations Convertibles Lux,
les  «Obligations  Convertibles  Lux»)  par  la  Société  pour  un  montant  global  en  principal  de  350.000  EUR  (trois  cent
cinquante mille Euros) (la «Seconde Emission d’Obligations Convertibles Lux et avec la Première Emission d’Obligations
Convertibles Lux, les «Emissions d’Obligations Convertibles»), le caractère convertible ainsi que les conditions générales
desdites Secondes Obligations Convertibles Lux étant identiques à celles des Premières Obligations Convertibles Lux,
tels que mentionnés ci-dessus (les «T&amp;Cs des Secondes Obligations Convertibles Lux, et avec les T&amp;Cs des Premières
Obligations Convertibles Lux, les «T&amp;Cs des Obligations Convertibles Lux»).

Il a été noté que:
- conformément aux dispositions de l’article 32-3 (5) de la Loi, le Conseil d’Administration, dans le cadre de la con-

vocation  de  cette  assemblée  générale  extraordinaire,  a  proposé  aux  Actionnaires  de  renoncer  à  tous  leurs  droits
préférentiels de souscription (i) relatifs aux Emissions d’Obligations Convertibles et (ii) en cas de conversion des Obli-
gations Convertibles Lux (une «Conversion»);

- à cet égard, un rapport du Conseil d’Administration détaillant les T&amp;Cs des Obligations Convertibles Lux - incluant

le prix d’émission des Obligations Convertibles Lux ainsi que les conditions générales en cas de Conversion (le «Rapport
du Conseil d’Administration») a été préparé et fourni aux Actionnaires en vue d’être revu.

31909

L

U X E M B O U R G

Il a été unanimement décidé:
(i) de reconnaître avoir reçu le Rapport du Conseil d’Administration ainsi que d’avoir revu avec attention les dispo-

sitions du Rapport du Conseil d’Administration;

(ii) de déclarer que les informations contenues dans le Rapport du Conseil d’Administration sont suffisantes, claires

et non équivoques de sorte que chaque Actionnaire puisse approuver les Emissions d’Obligations Convertibles en toute
connaissance de cause;

(iii) d’approuver le contenu du Rapport du Conseil d’Administration;
(iv) de ratifier, et pour autant que nécessaire, approuver les Emissions d’Obligations Convertibles Lux;
(v) d’approuver les T&amp;Cs des Obligations Convertibles Lux; et
(vi) de renoncer à tout droit préférentiel de souscription prévu à l’article 32-3 (5) de la Loi concernant les Emissions

d’Obligations Convertibles Lux ainsi qu'en cas de Conversion.

<i>Troisième résolution

Il a été unanimement décidé de supprimer temporairement la mention de la valeur nominale des 31.843 (trente-et-un

mille huit cent quarante-trois) actions qui représentaient le capital social de la Société alors établi à 31.843 EUR (trente-
et-un mille huit cent quarante-trois Euros).

<i>Quatrième résolution

Il a été unanimement décidé d’émettre un nombre total de 3.152.457 (trois millions cent cinquante-deux mille quatre

cent cinquante-sept) nouvelles actions de la Société aux Actionnaires sans augmentation du capital social de la Société
(les «Nouvelles Actions») afin de porter le nombre d’actions de 31.843 (trente-et-un mille huit cent quarante-trois) actions
sans mention de la valeur nominale, à 3.184.300 (trois millions cent quatre-vingt-quatre mille trois cents) actions sans
mention de valeur nominale (les «Actions Globales») par l’émission des Nouvelles Actions telle que prévu ci-après:

- 2.842.488 (deux millions huit cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-huit) Nouvelles Actions à M. A. Neal

(M. A. Neal détenant ainsi un total de 2.871.200 (deux millions huit cent soixante-et-onze mille deux cents) Actions
Globales);

- 92.961 (quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-et-une) Nouvelles Actions à Treveri (Treveri détenant ainsi un

total de 93.900 (quatre-vingt-treize mille neuf cents) Actions Globales);

- 30.987 (trente mille neuf cent quatre-vingt-sept) Nouvelles Actions à AMMC (AMMC détenant ainsi un total de

31.300 (trente-et-un mille trois cents) Actions Globales);

- 18.513 (dix-huit mille cinq cent treize) Nouvelles Actions à M. M. Frisch (M. M. Frisch détenant ainsi un total de

18.700 (dix-huit mille sept cents) Actions Globales);

- 18.513 (dix-huit mille cinq cent treize) Nouvelles Actions à M. P. Keller (M. P. Keller détenant ainsi un total de 18.700

(dix-huit mille sept cents) Actions Globales);

- 15.444 (quinze mille quatre cent quarante-quatre) Nouvelles Actions à M. H. Ochsner (M. H. Ochsner détenant ainsi

un total de 15.600 (quinze mille six cents) Actions Globales);

- 102.564 (cent-deux mille cinq cent soixante-quatre) Nouvelles Actions à M. A. Kouwenhoven (M. A. Kouwenhoven

détenant ainsi un total de 103.600 (cent-trois mille six cents) Actions Globales); et

- 30.987 (trente mille neuf cent quatre-vingt-sept) Nouvelles Actions à M. A. Fourie (M. A. Fourie détenant ainsi un

total de 31.300 (trente-et-un mille trois cents) Actions Globales).

<i>Cinquième résolution

Il a été unanimement décidé de réintroduire la mention de la valeur nominale des Actions Globales qui a été fixée à

0,01 EUR (un centime d’Euro) par action, sans qu'aucune modification ne soit apportée au capital social de la Société.

<i>Sixième résolution

Il a été proposé d’approuver l’insertion dans les statuts de la Société d’une clause de capital autorisé en vertu de laquelle

le Conseil d’Administration sera autorisé, pendant une période de 5 (cinq) années suivant la publication de cet acte notarié
introduisant le capital autorisé susmentionné au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, à augmenter le capital
social de la Société d'un montant maximum de 1.000.000 EUR (un million d’Euros) représenté par 100.000.000 (cent
millions) d’actions ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d’Euro) chacune (le «Capital Autorisé»).

Il a été noté que conformément aux dispositions des articles 32-3 et 32-4 de la Loi:
- le Conseil d’Administration, en convoquant cette assemblée générale extraordinaire, a proposé que, dans le cadre

du Capital Autorisé, le Conseil d’Administration soit autorisé à limiter ou supprimer tout droit préférentiel de souscription
des Actionnaires y relatif (l’«Autorisation»); et

- les raisons et justifications pour limiter ou supprimer les droits préférentiels de souscription des Actionnaires (la

«Justification») sont incluses dans le Rapport du Conseil d’Administration, celui-ci détaillant également les changements
correspondant proposés à l’article 5 des statuts de la Société.

Il a été unanimement décidé:

31910

L

U X E M B O U R G

(i) de déclarer avoir revu avec attention les dispositions du Rapport du Conseil d’Administration;
(ii) de déclarer que les informations et la Justification incluses dans le Rapport du Conseil d’Administration sont suffi-

santes,  claires  et  non  équivoques  de  sorte  que  tous  les  Actionnaires  puissent  approuver  le  Capital  Autorisé  et
l’Autorisation en toute connaissance de cause;

(iii) d’approuver le contenu du Rapport du Conseil d’Administration concernant la Justification, le Capital Autorisé et

l’Autorisation; et

(iv) d’approuver le Capital Autorisé et l’Autorisation.

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, il a été décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin que

celui-ci soit lu comme suit:

« Art. 5. Le capital social est fixé à 31.843 EUR (trente-et-un mille huit cent quarante-trois Euros), représenté par

3.184.300 (trois millions cent quatre-vingt-quatre mille trois cents) actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime
d’Euro) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, par décision des actionnaires statuant comme en matière

de modification de ces statuts.

La Société peut émettre des actions rachetables et peut racheter ces actions à tout moment si le Conseil d’Adminis-

tration  considère  que  cela  est  dans  le  meilleur  intérêt  de  la  Société,  conformément  aux  termes  et  conditions  qu'il
déterminera conformément à l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée. Le Conseil d’Administration peut créer de temps à autre toute réserve de capital qu'il déterminera appropriée
(en plus de celles qui sont requises par la loi) et pourra créer des primes à partir des fonds reçus par la Société telles que
des primes d’émission sur les émissions et vente de ses actions, ces réserves ou primes peuvent être utilisée par le Conseil
d’Administration pour permettre le paiement de toutes actions que la Société rachètera en conformité avec ses statuts.

Les actions rachetées par la Société resteront existantes mais n’auront pas de droit de vote ou de droit à participer

aux dividendes déclarés par la Société ou dans toute distribution payée lors de la dissolution ou liquidation de la Société.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux limites prévues par l’article 49-8

susmentionnés de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

La Société pourra par ailleurs émettre, dans le seul but de placement privé, des notes, des obligations et toute sorte

de dette et/ou titres de participation.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Le capital social autorisé de la Société est fixé à 1.000.000 EUR (un million d’Euros) représenté par 100.000.000 (cent

millions) d’actions d’une valeur nominale de 0.01 EUR (un centime d’Euro) chacune (le «Capital Autorisé»).

Le Conseil d’Administration est autorisé pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l’acte

notarié introduisant le Capital Autorisé au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (la «Période d’Autorisation»),
à  augmenter,  en  une  ou  plusieurs  tranches  successives,  le  capital  social  d’un  montant  maximal  équivalent  au  Capital
Autorisé. Afin d’écarter tout doute, dans le cadre du Capital Autorisé, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre
au maximum 100.000.000 (cent millions) de nouvelles actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d’Euro)
chacune.

Dans le cadre et dans la limite du Capital Autorisé, le Conseil d’Administration peut décider de l’émission d’instruments

de dettes (de quelque forme que ce soit) convertibles en actions de la Société (les «Instruments Convertibles»). Le Conseil
d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt ainsi que toutes autres conditions, incluant les conditions
d’émission et de conversion des Instruments Convertibles.

L’émission des Instruments Convertibles devra être effectuée durant la Période d’Autorisation. L’émission des Ins-

truments Convertibles peut être décidée par le Conseil d’Administration sans qu'aucun droit préférentiel de souscription
attaché aux Instruments Convertibles ou aux actions résultant de la conversion desdits Instruments Convertibles ne soit
réservé aux actionnaires de la Société ou aux porteurs d’Instruments Convertibles; le droit de limiter ou retirer tels
droits préférentiels de souscription demeurant à la discrétion du Conseil d’Administration.

Toutes modifications aux présents statuts résultant de la mise en place du Capital Autorisé devront être actés par

acte notarié par le Conseil d’Administration, ou toute autre personne dûment autorisée à ces fins. Après chaque aug-
mentation du capital social souscrit conformément aux dispositions précédentes, les présents statuts seront modifiés afin
refléter ladite augmentation.

Dans le cas où la Société a émis des obligations ou autres instruments de dette, les dispositions de la Loi concernant

les assemblées générales des obligataires s’appliqueront, sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts ou
dans les conditions générales gouvernant lesdites obligations.»

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui doivent être mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève à environ 1.400,- EUR.

31911

L

U X E M B O U R G

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes repré-

sentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Bob PLEIN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 janvier 2015. Relation GAC/2015/742. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015019112/381.
(150022838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Lusinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 194.182.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

«FASCOLUX S.A.», a public limited liability company (“société anonyme”), incorporated and existing under Luxem-

bourg law, having its registered office at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies  Register  under  number  B  168.121,  duly  represented  by  the  sole  signature  of  Mrs  Johanna  SCHADECK,
chartered accountant, professionally residing at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

Such appearing party has required the undersigned notary to establish as follows the articles of association of a public

company limited by shares “société anonyme”.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby established a company (hereafter the “Company”) in the form of a public company limited by

shares (“société anonyme”) under the name of “LUSINVEST S.A.”.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other address within the municipality of the registered office by a

decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-

lution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to
the articles of association.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional

transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

Branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg

or abroad by resolutions of the board of directors.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may also hold interests in partnerships.
The Company may also acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg and abroad and

may lease or dispose of movable property.

The Company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and

debentures.

The Company may in general grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

31912

L

U X E M B O U R G

The Company may further carry out any other financial, industrial or commercial operations as well as any transactions

on real estate or on movable property.

Art. 5. The share capital of the Company is set at THIRTY-ONE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (31,500.- EUR)

represented by thirty-one thousand five hundred (31,500) ordinary shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each,
fully paid up.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the shareholders.
The bearer shares shall be deposited with a depositary appointed by the Board of Directors or the Management Board

and according to the requirements of Article 42, (2) of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
The depositary shall hold a bearer shares register in Luxembourg in which the bearer shares are registered in the name
of the shareholder as being the owner of such shares.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders or

in the bearer shares register as the full owner of such shares.

Upon request of the shareholders, certificates stating inscription of the registered shares shall be delivered to the

shareholders by the Company or by the depositary in case of bearer shares.

Transfer of registered or bearer shares shall be inscribed in the register of shareholders or in the bearer shares register.
The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.
The share capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three (3) members who need not be

shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is ack-
nowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the
board of directors may be limited to one (1) single member only until the next ordinary general meeting acknowledging
that there is more than one shareholder in the Company.

The directors are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholders which

may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision shall be ratified by the next general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will choose among its members a chairman.
The chairman shall preside at all meetings of the board of directors but, in his absence, the board of directors may

appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors at the place indicated in the convening

notice. No convening notice is needed when all the directors are present and/or represented at a meeting of the board
of directors.

The board of directors can deliberate or act validly if at least the majority of its members is present or represented

at the meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or telex

any other director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the
directors using this technology shall be deemed present and shall be authorized to vote by video or by phone. After
deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event
such vote is confirmed in writing.

Resolutions in writing, approved and signed by all directors, shall have the same effect as resolutions taken during a

board of directors’ meeting.

In the event that any director of the Company has an adverse personal interest in any transaction of the Company,

such director shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on such
transaction and such director’s interest therein shall be reported by the board of directors to the next succeeding meeting
of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object of the Company. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs to one or more directors, officers, managers or any
other agents who may but are not required to be shareholders. Their nomination, revocation and powers shall be settled
by a resolution of the board of directors.

The director(s) to whom such a delegation has been given shall be called managing director(s).

31913

L

U X E M B O U R G

The delegation in favour of a member of the board of directors shall entail the obligation for the board to report each

year to the general meeting of shareholders on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

Art. 9. The Company will be bound in any circumstances by the joint signature of two (2) directors, or by the sole

signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or sole signature of any person
to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. In case the board of directors is
composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 10. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, appointed by the general

meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration as well as the term of their office, which
must not exceed six (6) years.

If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of

auditors.

General meetings of shareholders

Art. 11. The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the

Company. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of
directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

When the Company has a sole shareholder, the latter will exert the powers reserved for the general meeting of

shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another

person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 12. The annual general meeting of shareholders will be held within the municipality of the Company’s registered

office or at the place specified in the convening notice on the second Monday of May of each year at 11.00 a.m..

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day.

Art. 13. The board of directors or the statutory auditor(s) may convene other general meetings of shareholders. Such

meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company’s share capital so require.

One or more shareholders who together hold at least 10% of the Company’s share capital may require that one or

more additional items be put on the agenda of any general meeting of shareholders.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the

board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Accounting year - Distribution of profits

Art. 14. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year.

Art. 15. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Com-

pany.

The board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
The general meeting of shareholders can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the

capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

31914

L

U X E M B O U R G

Reference to the law

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10 

th

 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitional provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and will end on 31 December

2015.

The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.

<i>Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the party appearing, in its capacity as sole shareholder, declares

to subscribe all the shares.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND FIVE HUNDRED

EURO (31,500.- EUR) is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The notary, drawing up the present deed, declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the

Law of August 10, 1915 on Commercial Companies as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately one thousand five hundred euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above-named person, representing the entire subscribed capital has immediately taken, in such capacity as sole

shareholder, the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at THREE (3)
The following have been appointed Directors:
1. Mrs Johanna SCHADECK, chartered accountant, born on 22 February 1979 in Messancy (Belgium), professionally

residing at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

2. Mrs Annabelle GIOVANARDI, employee, born on 28 April 1969 in Briey (France), professionally residing at 15, rue

Astrid, L-1143 Luxembourg.

3. FFA REAL ESTATE LIMITED, a company registered in the Cayman Islands under number CT282606, with registered

office at Criquet Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Ky1-1111, Cayman Islands, whose permanent representative
is Mr. Georges ROMANOS BOU JAOUDE, Director, born on March 18, 1970 in Ibadan (Lebanon), with address at One
FFA Gate, Maarfa 128 Building, Foch Street, Beirut Central District, Beirut (Lebanon).

FFA REAL ESTATE LIMITED is also appointed Chairman of the Board of Directors for the whole duration of its

mandate as Director.

Their term of office will expire after the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at ONE (1).
The following has been appointed Statutory Auditor:
FASCONTROL S.à r.l., having its registered office at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg and registered with the

Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180.135.

Its term of office will expire after the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.

<i>Third resolution

The registered office of the Company is established at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation; in case of discrepancies between the English and
the French text, only the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us the notary the

present original deed.

31915

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deux janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

«FASCOLUX S.A.», une société anonyme, établie et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant

son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxem-
bourg sous le numéro B 168.121, dûment représentée par la signature individuelle de Madame Johanna SCHADECK,
expert-comptable, résidant professionnellement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’elle

déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme (ci-après la «Société») sous la dénomination de «LUSINVEST S.A.».

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
L’adresse du siège social peut être transférée dans la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de

l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité

normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiraient ou seraient
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

De telles mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert pro-

visoire du siège, restera luxembourgeoise.

Des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger par décision du conseil d’administration.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placements, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute
autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes,
notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de
son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut également acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxembourg

ou à l’étranger et elle peut louer ou disposer de bien meuble.

La Société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d'obligations

et de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à
l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération financière, industrielle ou commerciale ainsi que toute transaction

sur des biens immobiliers ou mobiliers.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31.500,- EUR) divisé en trente et un

mille cinq cents (31.500) actions ordinaires d‘une valeur nominale d’UN EURO (1,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré des actionnaires.
Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire,

selon le cas, et répondant aux conditions du paragraphe (2) de l’Article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions
au porteur sont inscrites au nom de l’actionnaire qui en est le propriétaire.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

ou dans le registre des actions au porteur comme les pleins propriétaires de ces actions.

Sur demande des actionnaires, des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société

ou par le dépositaire en cas d’actions au porteur.

La cession d’actions nominatives ou au porteur devra être formalisée par une inscription au registre des actionnaires

ou au registre des actions au porteur.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires, sous les conditions prévues par

la loi.

31916

L

U X E M B O U R G

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme ne pouvant dépasser six

(6) années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs rémunérations sont fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant, les administrateurs restants peuvent y pourvoir temporairement,

une telle décision devant être ratifiée à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d'administration devra choisir un président parmi ses membres. Le président préside toutes les

réunions du conseil d’administration, mais en son absence, le conseil d’administration pourra nommer un autre président
pro tempore par vote à la majorité des présents à ces réunions du conseil d’administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la

convocation. Aucune convocation ne sera nécessaire si tous les administrateurs sont présents ou représentés à une
réunion du conseil d’administration.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est

présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions seront prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à ces réunions.

Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administrateur, par

écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipements pour conférence vidéo
et conférence téléphonique est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être présents
et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibérations, les votes pourront ainsi être exprimés par
écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas, le vote doit être confirmé par écrit.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises lors

d’une réunion du conseil d’administration.

Dans le cas où un administrateur de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé dans une transaction de la

Société, cet administrateur devra faire connaître au conseil d’administration son intérêt personnel et ne pourra délibérer
ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra rendre compte de l’intérêt de cet administrateur à la
prochaine assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité du conseil d’administration.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration

ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les
présents Statuts à l’assemblée générale tombent sous la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société

ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d’administration.

L’administrateur à qui pareille délégation a été donnée sera appelé administrateur-délégué.
La délégation à un membre du conseil d’administration impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte

à l’assemblée générale des actionnaires des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Lorsque la Société compte un administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.

Art. 9. La Société est engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, par la

signature unique de l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou par la signature conjointe ou
unique de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration. Lorsque
le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Art. 10. La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder
six (6) années.

S’il y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commis-

saires aux comptes.

Assemblées des actionnaires

Art. 11.  L'assemblée  générale  des  actionnaires  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  faire  ou  ratifier  les  actes  qui

intéressent la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans

31917

L

U X E M B O U R G

lesquels le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale
des actionnaires.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnaires

de la Société, sauf autrement prévu par les présents Statuts.

Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment convoquée

seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra déterminer toute les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires

pour pouvoir participer aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue dans la commune du siège social de la Société ou

au lieu indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant.

Art. 13. Le conseil d’administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées

générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un
dixième du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital social peuvent demander l’in-

scription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Exercice social - Distribution des profits

Art. 14. L’exercice social de la Société commence le premier du mois de janvier et se termine le trente et un du mois

de décembre de chaque année.

Art. 15. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux actionnaires en proportion de leur participation dans le capital de

la Société.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués sur décision du conseil d’administration, sous réserve des con-

ditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires pourra décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à

l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. La Société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. La liqui-

dation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et rémunérations.

Référence à la loi

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.
La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2016.

<i>Souscription et paiement

Les Statuts ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, en sa susdite capacité d’actionnaire unique, déclare souscrire

à toutes les actions.

Les actions ont été intégralement libérées par paiement en numéraire de sorte que la somme de TRENTE ET UN

MILLE CINQ CENTS EUROS (31.500,- EUR) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

31918

L

U X E M B O U R G

<i>Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

La partie comparante, pré-qualifié, représentant la totalité du capital social souscrit, agissant ainsi en sa qualité d’ac-

tionnaire unique, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à TROIS (3)
Sont nommés Administrateurs:
1. Madame Johanna SCHADECK, expert-comptable, née le 22 février 1979 à Messancy (Belgique), résidant profes-

sionnellement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

2. Madame Annabelle GIOVANARDI, employée privée, née le 28 avril 1969 à Briey (France), résidant professionnel-

lement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

3. FFA REAL ESTATE LIMITED., une société enregistrée aux Iles Caïmans sous le numéro CT282606, avec siège social

à Criquet Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, KY1-1111, Iles Caïmans, ayant comme représentant permanent Mon-
sieur Georges ROMANOS BOU JAOUDE, Administrateur, né le 18 mars 1970 à Ibadan (Liban), avec adresse à One FFA
Gate, Maarfa 128 Building, Foch Street, Beyrouth Central District, Beyrouth (Liban).

FFA REAL ESTATE LIMITED est également nommé Président du Conseil d’Administration pendant toute la durée de

son mandat d’Administrateur dans la Société.

Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2020.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à UN (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FASCONTROL S. à r.l., ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, enregistrée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.135.

Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2020.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis de rédiger le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une traduction française et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte.

Signé: J. SCHADECK, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1980. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015019005/408.
(150022589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

VIPdent GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6484 Echternach, 36, rue de la Sûre.

R.C.S. Luxembourg B 96.339.

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.
Den sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

31919

L

U X E M B O U R G

Frau Ulrike SPARTZ, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-54668 Schankweiler, An der Brücke, 12.
Welche Komparentin hier vertreten ist durch Herrn Michael KESSLER, Bilanzbuchhalter, beruflich ansässig in L-6484

Echternach, 36, rue de la Sûre, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 19. Januar 2015,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, dem unterzeichneten Notar erklärte, dass sie die alleinige Anteil-

haberin  der  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  VIPdent  GmbH  ist,  mit  Sitz  in  L-7240  Bereldange,  87,  route  de
Luxembourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 96.339 (NIN 2003
2416 838).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem

Amtssitze in Niederanven, am 19. September 2003, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 1182 vom 11. November 2003 und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitze in Junglinster, am 26. Oktober 2004,

veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 61 vom 21. Januar 2005;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Jean SECKLER, am 27. April 2009, veröffentlicht im Memorial

C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1048 vom 20. Mai 2009;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Jean SECKLER, am 20. Juli 2010, veröffentlicht im Memorial

C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2051 vom 1. Oktober 2010;

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in fünfzig (50)

Anteile von je zwei hundert fünfzig Euro (€ 250.-), alle zugeteilt Frau Ulrike SPARTZ, vorgenannt.

Alsdann ersuchte die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden

wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Bereldange nach Echternach zu verlegen, und

demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:

„ Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.“.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6484 Echternach, 36, rue de

la Sûre.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.

Signé: M. KESSLER, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 janvier 2015. Relation: GAC/2015/836. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): C. PIERRET.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  auf  Begehr  erteilt,  zwecks  Hinterlegung  beim  Handels-  und  Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 4. Februar 2015.

Référence de publication: 2015020075/51.
(150023413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Silver Sea Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.153.

Les comptes annuels au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2015.

Référence de publication: 2015019968/10.
(150023888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

31920


Document Outline

19 B S.A.

19 B S.A.

Aedes SCI

Air Valanga S.A.

Auto Klass Concept

Car Doc S.à r.l.

Deka Rue Cambon S.à r.l.

Ermital Invest S.à r.l.

Fortune Finance Participations (Luxembourg) S.A.

Futuradent G.m.b.H.

Interfinancial S.A.

Limalux S.A.

Lusinvest S.A.

Medima S.A.

Oriel S.A.

Oriel S.A.-SPF

Orion IV European 16 S.à r.l.

Orion IV European 2 S.à r.l.

Oxford BioChronometrics S.A.

Samena (Lux) Global Funds

Silver Sea Holdings S.A.

Société Anonyme Immobilière A.G.

Sofis Baraka S.A.

Solaria S.A.

Startone S.A.

Steinweber Aktiengesellschaft A.G.

Terabyte Holding S.à r.l.

Timentaves S.A.

Times Realisations S.A.

Toiture C.F.C. S.àr.l.

Toolcarrier

Tosal S.à r.l.

Toys Investment S.A.

Tricol S.A.

Trivium S.A.

Tudor Immo S.A.

Twinerg

Twins Development S.A.

Urban Capital Lender 2 S.à r.l.

Usantar Two S.A.

Vallis Sustainable Investments I, G.P., S.à r.l.

Vallis Sustainable Investments I, S.C.A., SICAR

VALORITECH International S.à r.l.

Vauban Strategies S.A.

Vaulux International SPF S.A.

VIPdent GmbH

Vistra Holdings S.àr.l.