This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 269
3 février 2015
SOMMAIRE
3C Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12890
Amorim Alternative Investments S.A. . . .
12874
Avolon Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
12874
Berkeley 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12873
Borden Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
12872
Chesapeake Investments Company S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12872
Dekan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12868
Elbblick (Mike) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12872
Elbblick (Oscar) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12871
Elbblick (Papa) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12872
Exelon Nuclear Partners International S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12867
FoamCo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12873
FoamCo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12873
FoamCo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12868
German Multi Industrial I S. à r. l. . . . . . . .
12890
JFT.Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12870
JJL Gardenservice S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
12870
JMDN Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12870
Kallima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
Kaola S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12870
Kolfi Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
12868
Kunst & Dekoration S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
La Bulle de Vin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12905
Loyalty Partner Holdings S.A. . . . . . . . . . . .
12869
Lucida S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
Luxidea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12867
Machold S.A., société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12871
Madi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12870
Madulo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12871
Markanne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12903
Marketing Control Holding S.A. . . . . . . . . .
12904
Matrix Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
12902
Mbandako S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
Meridiam Infrastructure Europe II (SCA)
SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12875
Modasia Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12866
Multitube Technical Services S.à r.l. . . . . .
12900
My Home Mag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12871
PetroSantander Luxembourg Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12867
Pfizer International Luxembourg Sàrl . . . .
12908
Powerwave Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
12896
Powerwave Technologies S.à r.l. . . . . . . . . .
12894
Prêt-à-porter Catalogue . . . . . . . . . . . . . . . .
12898
ProLogis European Holdings XXIII S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12907
ProLogis UK IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12905
Skipper Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12866
Source de Beauté S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
12866
V11 Studiogame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12866
Vafage S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12912
Vafage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12912
Val de Morgon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12911
12865
L
U X E M B O U R G
V11 Studiogame, Société Anonyme.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 56, rue Jaen Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 189.808.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MISE EN LIQUIDATION
qui se tiendra le <i>11 février 2015i> à 15 heures à l'étude du notaire Jean SECKLER à L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. - Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. - Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 23 janvier 2015.
<i>Pour la société.i>
Référence de publication: 2015012478/15.
Modasia Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 59.351.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>12 février 2015i> à 10.00 heures, pour
délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Report de la date de l'Assemblée au 12 février 2015,
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos
au 31 octobre 2013,
3. Approbation des comptes annuels au 31 octobre 2013 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Nominations statutaires,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2015004996/19.
Skipper Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 335.152,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 151.279.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2014.
Référence de publication: 2014208528/10.
(140231962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.
Source de Beauté S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 291, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 134.459.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014208596/10.
(140233363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.
12866
L
U X E M B O U R G
Luxidea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 83.325.
Les actionnaires ainsi que les obligataires sont priés d'assister à
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>11 février 2015i> à 10h00 au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Décharge au conseil d'administration pour la convocation de l'assemblée générale annuelle à une autre date que la
date statutaire et au délai de mise à disposition des documents ;
2. rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, affectation des
résultats;
4. délibération quant aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
6. ratification de la démission de Monsieur Guy BAUMANN de ses fonctions d'administrateur et de la cooptation de
Monsieur Eric BREUILLE au conseil d'administration ;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015012481/1017/21.
Exelon Nuclear Partners International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 161.386.
<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 23 décembre 2014.i>
1. La révocation de M. Amir Shahkarami, en tant que gérant de la société, a été acceptée avec effet au 23 décembre
2014.
2. M. Corey Nels Hessen, né le 4 mai 1969 en Illinois, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement à 10
South Dearborn Street, 52 Floor, Nw, Chicago, IL 60603, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé en tant que gérant avec
effet au 23 décembre 2014 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Exelon Nuclear Partners International S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014206870/16.
(140231633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 37.136.000,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 150.668.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 19 décembre 2014i>
L'associé unique a décidé de nommer, pour une période indéterminée, en qualité de gérants A de la Société Monsieur
Bertrand de FAYS, employé privé, né le 12 juillet 1980 à Woluwé-St-Lambert, Belgique et Monsieur Attila SENIG, employé
privé, né le 23 août 1980 à Székesfehérvar, Hongrie, les deux demeurant professionnellement 8-10, avenue de la Gare,
1610 Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la société en date du 23 décembre 2014i>
Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 16, avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg avec effet au 23 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208392/17.
(140232173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.
12867
L
U X E M B O U R G
Dekan, Société Européenne.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.200.
Les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 février 2015i> à 11.00 heures à Luxembourg au 5, boulevard Royal, au premier étage, aux fins de
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan arrêté au 30 septembre 2013 et du compte de profits et pertes y relatif.
2. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration ainsi que du rapport de contrôle
du commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 30 septembre 2013.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 30
septembre 2013.
5. Ratification du transfert du siège social au 5 boulevard Royal à Luxembourg (L-2449).
6. Approbation du bilan arrêté au 30 septembre 2014 et du compte de profits et pertes y relatif.
7. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration ainsi que du rapport de contrôle
du commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 30 septembre 2014.
8. Affectation du résultat.
9. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 30
septembre 2014.
10. Questions diverses.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015004995/26.
FoamCo 4, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.425,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 121.172.
<i>Extrait des résolutions de l'associée unique prises en date du 9 décembre 2014i>
1. L'associée unique prend acte de et accepte la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat de gérant de
catégorie B
2. L'associée unique décide de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences
économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme nouveau
gérant de catégorie B.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 23 décembre 2014.
Référence de publication: 2014206914/16.
(140231227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
Kolfi Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 192.527.
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein une présidente en la personne de Madame Anne-Marie GREGIS. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2020.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2014.
Référence de publication: 2014208156/12.
(140232871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.
12868
L
U X E M B O U R G
Lucida S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.869.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 136.454.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014208174/10.
(140233087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.
Loyalty Partner Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 110.640.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2014.
Référence de publication: 2014208173/10.
(140232929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.
Kunst & Dekoration S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 61.411.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208158/9.
(140233000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.
Mbandako S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1540 Luxembourg, 27A, rue Benjamin Franklin.
R.C.S. Luxembourg B 84.395.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014208290/10.
(140232276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.
Kallima S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 154.810.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 décembre 2014i>
<i>Première résolutioni>
Afin de se conformer aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au
porteur, le Conseil d'Administration décide de nommer HRT Fidalux S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, sous le numéro B 41178 en qualité de dépositaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KALLIMA S.A.i>
Référence de publication: 2014209314/15.
(140234831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
12869
L
U X E M B O U R G
Kaola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 113.814.
Par la présente, je vous informe de ma démission en tant que gérant de la société Kaola S.à r.l. avec effet au 14 décembre
2014.
Je vous demande par conséquent de bien vouloir procéder à toutes les formalités nécessaires en vue de l'enregistre-
ment de ma démission.
A Luxembourg, le 3 décembre 2014.
Martijn Sinninghe Damsté.
Référence de publication: 2014209315/12.
(140234754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
JMDN Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Thilges.
R.C.S. Luxembourg B 150.653.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 30 décembre 2014.
SAIL S.a.
Kaiser Alain
<i>Adm. dél.i>
Référence de publication: 2014209308/13.
(140234456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
JJL Gardenservice S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5681 Dalheim, 39, Waasserklapp.
R.C.S. Luxembourg B 167.297.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 29 décembre 2014.
Référence de publication: 2014209307/10.
(140233683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
JFT.Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.
R.C.S. Luxembourg B 172.420.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2014209306/10.
(140233726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
Madi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 5, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R.C.S. Luxembourg B 175.290.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014209419/9.
(140234308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
12870
L
U X E M B O U R G
Madulo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 192.387.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2014i>
Monsieur Etienne GILLET est désigné en tant que Président du Conseil d'Administration.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014209421/12.
(140233410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
Machold S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 89.419.
Suite à la démission de la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl de son poste de Commissaire aux Comptes en date
du 18/12/2014, avec effet au 01/01/2014, il y a lieu de rayer son inscription auprès du RCS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
MACHOLD S.A. S.P.F.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014209418/16.
(140233671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
My Home Mag, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 144.382.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014209417/10.
(140233691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
Elbblick (Oscar) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 127.074.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 19 décembre 2014 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister à dater du 19 décembre
2014;
- Décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir
du 19 décembre 2014 au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2014.
Référence de publication: 2014206863/16.
(140231641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
12871
L
U X E M B O U R G
Elbblick (Mike) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 127.076.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 19 décembre 2014 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister à dater du 19 décembre
2014;
- Décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir
du 19 décembre 2014 au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2014.
Référence de publication: 2014206862/16.
(140231592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
Elbblick (Papa) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 127.079.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 19 décembre 2014 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister à dater du 19 décembre
2014;
- Décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir
du 19 décembre 2014 au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2014.
Référence de publication: 2014206864/16.
(140231657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
Borden Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 105.411.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2014.
Gérald Stevens
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2014206715/12.
(140231445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
Chesapeake Investments Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 79.734.
Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014206767/10.
(140230382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
12872
L
U X E M B O U R G
FoamCo 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 101.600,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 121.178.
<i>Extrait des résolutions de l'associée unique prises en date du 9 décembre 2014i>
1. L'associée unique prend acte de et accepte la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat de gérant de
catégorie B
2. L'associée unique décide de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences
économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme nouveau
gérant de catégorie B.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 23 décembre 2014.
Référence de publication: 2014206912/16.
(140231188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
FoamCo 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 336.925,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 121.175.
<i>Extrait des résolutions de l'associée unique prises en date du 9 décembre 2014i>
1. L'associée unique prend acte de et accepte la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat de gérant de
catégorie B.
2. L'associée unique décide de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences
économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme nouveau
gérant de catégorie B.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 23 décembre 2014.
Référence de publication: 2014206911/16.
(140230797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
Berkeley 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 144.379.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2014i>
L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport du commissaire à la liquidation de la Société;
- approuve le rapport du liquidateur de la Société;
- donne décharge au gérant unique, au commissaire à la liquidation et au liquidateur de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 16 décembre
2014;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse
suivante: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2014.
Berkeley 2 S.à r.l., en liquidation volontaire
Signature
Référence de publication: 2014206713/22.
(140231114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
12873
L
U X E M B O U R G
Avolon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 120.965,73.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 153.147.
EXTRAIT
En date du 11 décembre 2014 l'associé unique de la Société a transféré l'intégralité des parts sociales de la Société
qu'il détenait à Avolon Holdings Limited, une exempted company constituée sous les lois des Iles Caïmanes ayant son
siège sociale à South Church Street PO Box 309, Ugland House, KY1 1104 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
et immatriculée auprès du General Registry des Iles Caïmanes sous le numéro 288612.
Suite à ce transfert Avolon Holdings Limited détient toutes les parts sociales de la Société telles que listées ci-dessous:
- 134.707 parts sociales de classe A1;
- 134.706 parts sociales de classe A2;
- 134.706 parts sociales de classe A3;
- 134.706 parts sociales de classe A4;
- 134.706 parts sociales de classe A5;
- 2.280.046 parts sociales de classe B1;
- 2.280.047 parts sociales de classe B2;
- 2.280.047 parts sociales de classe B3;
- 2.280.047 parts sociales de classe B4;
- 2.280.047 parts sociales de classe B5;
- 4.563 parts sociales de classe C1;
- 4.562 parts sociales de classe C2;
- 4.561 parts sociales de classe C3;
- 4.561 parts sociales de classe C4; et
- 4.561 parts sociales de classe C5.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2014206651/33.
(140230704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
Amorim Alternative Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.064.
<i>Extrait du procès-verbal des décisions prises en la forme circulaire des administrateurs restants et de la décision du conseil d'ad-i>
<i>ministration en date du 12 décembre 2014i>
1. M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant profession-
nellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été coopté comme administrateur B de la société en
remplacement de Mme Katia CAMBON, administrateur B et présidente du conseil d'administration démissionnaire, dont
il achèvera le mandat d'administrateur de catégorie B qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de
2017.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
2. M. Sébastien ANDRE, précité, a été élu comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2017.
Luxembourg, le 24 décembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AMORIM ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014206676/21.
(140231750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
12874
L
U X E M B O U R G
Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 149.213.
In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
I. Mrs Laure MERSCH, avocat, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
acting as chairperson in the extraordinary general meeting of July 21
st
, 2014 of the company referred to as Meridiam
Infrastructure Europe II (SCA) SICAR, with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, entered in the
Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 149.213,
in her capacity as authorised representative of the nineteen (19) shareholders having participated in the said extraor-
dinary general meeting mentioned above, these shareholders being mentioned in detail on the presence sheet appended
to the said deed of July 21
st
, 2014.
II. Mrs Marie BERNOT, employee, residing professionally at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, acting as secretary
in the extraordinary general meeting mentioned above.
III. Mrs Christelle VAUDÉMONT, employee, residing professionally at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, acting as
scrutineer in the extraordinary general meeting mentioned above.
In the extraordinary general meeting of the Luxembourg investment company in risk capital formed as a corporate
partnership limited by shares (société d’investissement en capital à risque ayant la forme d’une société en commandite
par actions) named Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR, with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, entered in the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 149.213, drafted on July 21
st
, 2014 by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, number 1796 of her Répertoire and registered
with the Administration de l’Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, on July 30
th
, 2014 with the
relation LAC/2014/35956, deposited at the Luxembourg Register of Trade and Companies on August 6
th
, 2014
(L140141895), published in the official gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2779 of October
7
th
, 2014,
the said appearing parties, acting as mentioned above, requested the officiating notary to record that in the extraor-
dinary general meeting of July 21
st
, 2014, whose purpose was, among others, the complete restatement of the articles
of association of the Company (the Articles),
a material error occurred when restating the Articles, namely when reference was made to the governance body of
the Company,
so that the Articles should have read as follows:
“ Art. 1. Form. There is hereby formed, among the General Partner as subscriber of the GP Share, the Founding
Shareholders and all those who may become holders of Shares, a company in the form of a société en commandite par
actions organised as a société d'investissement en capital a risque (the Partnership), governed by the present Articles of
Association and by current Luxembourg laws, and notably by the 1915 Law and the SICAR Law.
Art. 2. Name. The Partnership's name is “Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR”.
Art. 3. Purpose. The Partnership's purpose is to invest its assets in securities and other assets representing risk capital
within the widest possible meaning as permitted under Article 1 of the SICAR Law in order to provide its Shareholders
with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk they incur in this respect.
The investment objectives and strategy of the Partnership are more fully described in the Prospectus.
The Partnership may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in
particular, without limitation, grant to any Portfolio Company, or any other company associated in any way with the
Partnership, or with any of the said Portfolio Companies, in which the Partnership has a direct or indirect financial interest,
any assistance, loans, advances or guarantees; borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any
money borrowed; in particular, the Partnership may borrow money from third parties or from its Shareholders, for itself
or its Portfolio Companies for the funding, completion, refinancing of an Investment or Add-on Investment, or to cover
any of its expenses.
In addition, the Partnership can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or
indirectly to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent
permitted by the SICAR Law.
Art. 4. Registered Office. The Partnership has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
12875
L
U X E M B O U R G
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the General
Partner.
The registered office of the Partnership may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by
means of a resolution of an extraordinary general meeting of Shareholders deliberating in the manner required for
amendment of these Articles of Association, but cannot be transferred abroad, except as otherwise provided hereunder.
The Partnership may have offices, branches (whether or not a permanent establishment) and subsidiaries either in
Luxembourg or abroad.
Art. 5. Duration. The Partnership is constituted for limited duration to terminate twenty-five (25) years from the Initial
Closing Date as set forth in the Prospectus.
However, If the IRR on the Class A Shareholders' Aggregate Capital Contributions is below seven percent (7%) based
inter alia on the Net Asset Value of the Class A Shares derived from audited consolidated accounts of the Partnership
for the year ended on 31 December prior to the twelfth (12
th
) anniversary of the Initial Closing Date, the Partnership
will terminate automatically, unless the continuation of the Partnership is decided on or prior to such anniversary by a
Shareholders’ Supermajority Approval (which vote, for the avoidance of doubt, shall not require the approval of the
Manager or of the General Partner). If the IRR on the Class A Shareholders’ Aggregate Capital Contributions is above
seven percent (7%) based on the audited consolidated accounts of the Partnership for the year ended on 31 December
prior to the twelfth (12
th
) anniversary of the Initial Closing Date, the Partnership shall continue in existence, unless the
termination of the Partnership is decided by a Shareholders’ Supermajority Approval (which vote, for the avoidance of
doubt, shall not require the approval of the Manager or of the General Partner).
Except in the cases referred to under the foregoing paragraphs, the Partnership may be terminated at any other time
before its term by a decision of the general meeting of Shareholders in the manner required for the amendment of these
Articles of Association, subject to the consent of the Manager and the General Partner.
The life of the Partnership does not come to an end upon the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any of its Shareholders.
Art. 6. Liability. The General Partner is liable for all liabilities which cannot be satisfied out of the assets of the Part-
nership. The limited Shareholders shall be liable only to the extent of their Commitment to the Partnership.
Art. 7. Share Capital. At the date of incorporation, the Partnership's share capital is set at four hundred fifty thousand
and twenty-five Euro (EUR 450,025), represented by one (1) GP Share with no par value, and eighteen thousand (EUR
18,000) Class A Shares with no par value, all fully paid-up registered Shares.
The Partnership's share capital shall at any time be equal to its Net Asset Value, as determined in accordance with
Article 14 hereafter.
The minimum subscribed share capital including share premium, if any, of the Partnership, which must be achieved
within twelve (12) months as from the date on which the Partnership has been authorised as a SICAR by the Luxembourg
Supervisory Authority, shall be one million Euro (EUR 1,000,000) as required by the SICAR Law.
Art. 8. Issuance of Shares. Further Class A and Class B Shares may be issued by the General Partner acting on behalf
of the Partnership during the Investment Period, each time at the Issue Price, subsequently and proportionally to Addi-
tional Capital Contributions made in accordance with Article 9. No further GP Share shall be issued.
Unless otherwise provided for herein or in the Prospectus, no preferential subscription rights shall apply.
The Initial Capital Contribution of each Class A will represent zero point five percent (0.5%) of the amount of its
Aggregate Commitment.
Fractions of Shares may be issued up to three (3) decimal places. Fractional Shares shall confer to its holder the rights
in proportion to the fraction of the Share represented. However a fractional Share shall not confer a voting right in itself,
unless together with other fractional Share(s) that the respective Shareholder holds, their number is such that they
represent one (1) or more whole Shares.
A Class A Shareholder acceding to the Partnership after the Initial Closing Date shall be required to contribute to the
Partnership at the latest on its Admission Date, an aggregate amount equivalent to its Initial Capital Contribution, plus a
late entry subscription premium equal to the sum of (i) the amount of any Additional Drawdown(s), required from existing
Class A Shareholders prior to its Admission Date and commensurate to its share holding in the Partnership (the Initial
Additional Drawdown Proportion); and (ii) an amount in respect of interest at a rate per annum of EURIBOR three (3)
months plus two percent (2%) calculated on the sum of its Initial Capital Contribution and its Initial Additional Drawdown
Proportion (together the Total Initial Contribution), such payment to be made in cash or in kind, in accordance with the
procedure set out in the Prospectus and the Subscription Agreement. The costs incurred in respect of any such contri-
bution, including the cost of any Auditor's special report, shall be borne by the Shareholder.
A Class A Shareholder acceding to the Partnership shall pay its Total Initial Contribution in whole to the benefit of
the Partnership (i) in case of contributions made in cash, into a bank account of the Partnership (with the Depositary)
designated by the General Partner for that purpose, and (ii) in case of contribution in kind, in conformity with the
12876
L
U X E M B O U R G
investment policy of the Partnership, by the transfer of the assets contributed to the Partnership, and together with a
valuation of the contribution by an Auditor's special report in compliance with the 1915 Law.
Class A Shares shall be issued only upon the completion of all the conditions precedent referred to in the Subscription
Agreement and the Prospectus and notably after (i) the execution of the Subscription Agreement, (ii) the acceptance of
the subscription by the General Partner, and (iii) the payment of the Total Initial Contribution.
Class B Shares may further be converted into Class C Shares after the Investment Period under the conditions des-
cribed in the Prospectus.
The conversion shall be effected by way of a redemption and cancellation of Class B Shares and the payment of the
redemption proceeds by means of new Class C Shares as set forth in the Prospectus. The General Partner shall be
authorised to issue such additional Class C Shares, subject to the production of an audit report. No preferential sub-
scription rights shall apply in respect of the issue of such Shares.
Art. 9. Further Commitments of Shareholders. In addition to their respective Initial Capital Contribution or Total
Initial Contribution, Class A and Class B Shareholders have irrevocably committed themselves in their respective Sub-
scription Agreements, to provide the Partnership with additional funding (the Further Commitments) as further described
in the Subscription Agreement and in the Prospectus.
The Further Commitments of each Class A and Class B Shareholder will represent ninety-nine point five percent
(99.5%) of its Aggregate Commitment.
The General Partner may, at its sole discretion, from time to time request payment, on a pro rata basis from each
Class A and Class B Shareholder of a portion or the whole of such Further Commitments in the form of Additional
Capital Contributions (an Additional Drawdown) as required, in the opinion of the Manager, in order for the Partnership
to (i) finance its Investments, or (ii) meet other commitments or obligations of the Partnership, including, without limi-
tation, management fees or other Partnership expenses, at any time during the Investment Period. The procedure relating
to these Additional Drawdowns is further detailed in the Prospectus.
For the avoidance of doubt, under no circumstances shall a Class A or Class B Shareholder be required to contribute
an aggregate amount of Additional Capital Contributions, which exceed their Aggregate Commitments.
At the end of the Investment Period, Shareholders shall have no further obligation to make Additional Capital Con-
tributions, other than to fund (a) any Additional Drawdown or Redrawn Commitment called on or before the end of the
Investment Period, and (b) any Additional Drawdown payable to the Partnership in relation to (i) the funding obligation
in respect of any Investments to which the Partnership has committed prior to the end of the Investment Period, or (ii)
the ongoing obligations and operating expenses of the Partnership including any borrowings made, guarantees, and un-
dertakings given directly or indirectly by the Partnership for the duration of the Partnership.
If any Class A Shareholder fails to pay (a Defaulting Shareholder) to the Partnership any amount required to be paid
under an Additional Drawdown Notice on or before the date of expiry of such notice, the General Partner shall issue a
Default Notice and may proceed in the following manner:
1) Subject to the provisions of paragraph 3 below, the Defaulting Shareholder (i) will receive no Distribution of any
kind until the date on which the Partnership has realised or distributed all its assets and may make a final Distribution of
all remaining assets to the Shareholders and (ii) will not be authorised to participate in any Shareholder vote. If the
Defaulting Shareholder is a member of the Investor Committee, it will automatically be suspended from its duties in this
respect.
2) In addition, any delay in payment of the Additional Drawdown amount will entail the payment of Interest Com-
pensation in favour of the Partnership, automatically and without it being necessary to proceed with any formality, without
prejudice to any action which the Partnership may bring against the Defaulting Shareholder, and the option for the
Partnership to exercise the rights described in paragraph 4 below.
3) In the event that its situation is remedied within thirty (30) Business Days of the date on which the Default Notice
was sent, and therefore of payment of the Additional Drawdown and the Interest Compensation, the Defaulting Share-
holder will recover its right (i) to receive the Distributions made, including the Distributions which took place between
the date of expiry of the Additional Drawdown Notice and the date on which the situation was remedied and (ii) to
participate in Shareholder votes. If it was suspended from the Investor Committee, it may be invited to retake its seat.
4) Failing remedy within thirty (30) Business Days from the date on which the Default Notice was sent, the General
Partner may, at its sole discretion, exercise one or more of the following options:
(a) the Class A Shares held by the Defaulting Shareholder (the Defaulting Shareholder's Shares) may be transferred in
full or in part to one or more other Shareholders and/or to one or more third party(ies). The transferee(s) may be
designated by the Defaulting Shareholder within thirty (30) Business Days from the date of expiry of the Additional
Drawdown Notice, it being specified that this period may be extended by the General Partner. Any planned transfer must
comply with the provisions of Article 13 in particular as concerns the Right of First Refusal and the prior consent of the
General Partner. If the Defaulting Shareholder and the designated transferee(s) agree a transfer price, the Defaulting
Shareholder's Shares will be sold at the agreed price. If (I) the Defaulting Shareholder and the designated transferee(s)
do not agree on a transfer price, or (II) the Defaulting Shareholder did not designate (a) transferee(s) within the required
period, or (b) pursuant to Article 13, the General Partner did not approve the transfer to the designated transferee(s),
12877
L
U X E M B O U R G
or (III) all or part of the Defaulting Shareholder's Shares are not transferred for any other reason the General Partner
may proceed at its discretion as is provided in sub-paragraph (b) below.
From the net proceeds of the transfer of the Defaulting Shareholder's Shares, the General Partner shall be entitled to
deduct, claim or request the amounts which are owed to the Partnership under Additional Drawdown(s) and Interest
Compensation up to the date of such transfer. The General Partner will then deduct, claim or request an amount equal
to all the expenses incurred or damages suffered by any agent or Shareholder of the Partnership following non-payment
of the called funds by the Defaulting Shareholder. The Defaulting Shareholder will receive the balance, if any.
In the event of sale, the Defaulting Shareholder will automatically be struck off the register of Shares. The designated
transferee(s) will only become owner(s) of the Shares after having met the conditions referred to in Article 13.
(b) If the General Partner decides not to proceed pursuant to subparagraph (a) above or if all or part of the Defaulting
Shareholder's Shares are not sold under the conditions described in sub-paragraph (a) above, the General Partner may,
at its sole discretion, decide that the Partnership will redeem all or part of the Defaulting Shareholder's Shares.
The Class A Shares may be redeemed by the Partnership at a price equal to fifty percent (50%) of the lesser of the
two following amounts: (i) the amounts paid up by the Defaulting Shareholder under the Class A Shares, or (ii) the Net
Asset Value of the Class A Shares so redeemed determined in accordance with the provisions of Article 14 (the Default
Redemption Price).
The General Partner may deduct from the Default Redemption Price, the Interest Compensation up to the redemption
date, as well as an amount equal to all the expenses incurred or damages suffered by any agents of the Partnership or
Shareholders as a result of the default. The Defaulting Shareholder will receive the balance if any.
Any Class A Shares so redeemed shall be automatically cancelled.
If the Defaulting Shareholder is a Feeder Fund, and the defaulting Shareholder's default is caused by the default of one
or several of its own investors, the General Partner may decide to apply the provisions of this Article nine only to the
portion of the Defaulting Shareholder's Commitment corresponding to the proportion that, at the Feeder Fund level,
the defaulting investor's commitment represents compared to the Feeder Fund's Aggregate Commitment.
Art. 10. Shareholders. The holding of Shares is exclusively restricted to “Well-Informed Investors” as defined under
article 2 of the SICAR Law.
The General Partner shall have the power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose notably
of ensuring that (i) no Shares in the Partnership are acquired or held by (a) any person in breach of these Articles of
Association, the Prospectus, the law or requirement of any country or governmental authority, or (b) any person in
circumstances which in the opinion of the General Partner might result in the Partnership incurring any liability to taxation
or suffering any other pecuniary disadvantage which the Partnership might not otherwise have incurred or suffered.
For such purposes the General Partner may:
a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of a Share where it appears to it that such registration
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Share being held by a person who is precluded
from holding Shares of the Partnership;
b) at any time require any person whose name is entered in the register of Shareholders to furnish it with any infor-
mation, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not legal or
beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests or will rest in a person who is precluded from holding Shares of
the Partnership; and
c) where it appears to the Partnership that any person, who is precluded from holding Shares of the Partnership is a
legal or beneficial owner of Shares or holds Shares, cause the Partnership compulsorily to repurchase from any such
Shareholder all Shares held by such Shareholder in the manner specified in Article 16 hereof.
Art. 11. Form of Shares/Register of Shareholders. Shares will only be issued in registered form.
All issued Shares of the Partnership shall be registered in the register of Shareholders, which shall be kept by the
person in charge of the maintenance of the register and designated as the Registrar and Transfer Agent. Such register
shall contain the name and address of each Shareholder, the number of Shares held by it and, if applicable, their date of
transfer. Any transfer of Shares shall be notified to the the General Partner. Transfer of ownership will become effective
only after its entry in the register of Shareholders of the Partnership.
The registration of the Shareholder's name in the register of Shares evidences its right of ownership over such regis-
tered Shares. The Shareholder shall receive a written confirmation of its share holding. Certificates representing the
Shares will be issued only upon written request made to the Registrar and Transfer Agent by the relevant Shareholder.
The Shareholder may, at any time, change its address as entered in the register of Shareholders by means of a written
notification to the Partnership at its registered office, or at such other address as may be set by the Partnership from
time to time.
The Shares are indivisible with regard to the Partnership, which admits only one owner per Share.
Art. 12. Voting Right. Each whole Share entitles its holder to one vote. Unless otherwise provided in these Articles
of Association, the consent of the General Partner is required in order for a Shareholder's resolution to be validly adopted.
12878
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Transfer of Shares.
a) GP Share
The GP Share held by the General Partner is not transferable except in the case of change of the General Partner as
contemplated in the Articles of Association and/or in the Prospectus.
b) Other Transfers
Until the 7
th
anniversary of the Initial Closing Date, Class A Shareholders may neither transfer, assign, sell or pledge
their Class A Shares, without the prior written consent of the General Partner, which may be granted or withheld in the
sole discretion of the General Partner. Except for transfers to Affiliates, other Class A Shareholders will have a Right of
First Refusal to acquire the transferred Class A Shares in accordance with provisions set forth in the Articles of Association
of Association.
During that period, as regards transfers to Affiliates, and thereafter, the General Partner shall accept all transfers of
Class A Shares, unless
(i) the new holder of Class A Shares does not comply with all requirements relating to the fight against money laundering
and financing of terrorism or (ii) the new holder of Class A Shares is not a Well Informed Investor or (iii) the approval
of such new shareholder would have an adverse effect to the Partnership and / or the other Shareholders. Furthermore,
the other Class A Shareholders will not have any Right of First Refusal to acquire the transferred Class A Shares.
c) Right of First Refusal
A Class A Shareholder who wishes to transfer its Shares (the Transferor) to a proposed transferee which is not its
Affiliate (the Transferee), shall give notice of such intention to the General Partner, by registered letter, such notice shall
specify the number of Shares it wishes to transfer, the person(s) to whom it wishes to transfer the Shares, the intended
price and a written undertaking of the Transferee of its firm intention to acquire the Shares concerned, to be bound by
the Articles of Association and the Prospectus and the obligation to pay the remainder of any Commitments which are
payable pursuant to an Additional Drawdown Notice issued on or prior to the date of the transfer (the Initial Notice).
Within five (5) Business Days of receipt of the Initial Notice by the General Partner, the General Partner shall give
notice of the intended transfer by registered letter or against a receipt (the Second Notice) to the other Shareholders
who are eligible to acquire the Shares under this Article (the Eligible Shareholders), specifying the (i) number of Shares
to be transferred, and (ii) the price, in order for the respective Eligible Shareholders to be able to exercise partly or
entirely their Right of First Refusal.
The Right of First Refusal of each Eligible Shareholder shall be calculated pro rata to the number of Shares of the
relevant Class for the time being held by it in relation to the total number of Shares in such Class.
The Second Notice shall be accompanied by a copy of the Initial Notice and shall require each Shareholder to state
by registered letter, within fifteen (15) Business Days of the receipt of the Second Notice (i) whether or not it wishes to
exercise its Right of First Refusal and (ii) the number of Shares subject to the exercise of its Right of First Refusal in
respect of which it intends to exercise such right. A Shareholder shall be deemed not to have exercised its Right of First
Refusal in respect of the Shares if the General Partner does not receive a response from such Shareholder within the
aforementioned period.
Within the following fifteen (15) Business Days, the General Partner shall determine the number of Shares which have
not been taken up by the Eligible Shareholders pursuant to exercise of their respective Right of First Refusal (the Remaining
Shares) and offer to each Eligible Shareholder which have expressed its intention to exercise totally its Right of First
Refusal, the opportunity to purchase the Remaining Shares pro rata to the number of Shares that it holds in the relevant
Class of Shares. This mechanism shall be applicable in the same manner until the earliest of the following occurs: (i) all
the Remaining Shares have been taken up by Eligible Shareholders, (ii) no Shareholder is interested in acquiring the
Remaining Shares or (iii) two (2) months have elapsed as from the reception of the Initial Notice by the General Partner.
Thereafter, within fifteen (15) Business Days, the Partnership shall be entitled (but not obliged), at the discretion of
the General Partner, to redeem the Remaining Shares in accordance with the provisions of Article 16 at the price offered
by the Transferee.
Art. 14. Net Asset Value. The Net Asset Value (NAV) of the Partnership shall be calculated by the Administration
Agent and supervised by the Manager, based on the fair value and in accordance with the Articles of Association.
The NAV of the Partnership shall be determined as often as the Manager may think useful, but in no event less than
four times a year as at 31 March, 30 June, 30 September and 31 December (each a Valuation Day).
The Net Asset Value will be expressed in Euro and shall be determined by the Administration Agent on the basis of
the valuation of the underlying assets of the Partnership as provided by (i) the Manager on each Valuation Day by aggre-
gating the value of all assets of the Partnership and deducting all liabilities of the Partnership or (ii) the Independent Valuer
on (x) the seventh anniversary of the Initial Closing Date, (y) the Calculation Date, and (z) two (2) other dates before
the Calculation Date at the request of the Investor Committee. The fees and expenses of the Independent Valuer in
connection with the valuations referred under (z) will be borne by the Partnership.
The Net Asset Value attributable to a particular Class of Shares shall be the value of the total assets and Distributions
entitlements adjusted with the liabilities relating to that Class on that Valuation Day.
12879
L
U X E M B O U R G
The Net Asset Value per Share of one Class on a Valuation Day equals the Net Asset Value of that Class divided by
the total number of Shares of that Class in issue on that day.
The assets of the Partnership shall be deemed to include:
(a) all cash in hand or on deposit, which may be held on an accessory and temporary basis, including any interest
accrued thereon;
(b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered), which
may be held on an accessory and temporary basis;
(c) all bonds, time notes, shares, stocks, debenture stocks, subscription rights, warrants, and other investments and
securities owned or contracted for by the Partnership;
(d) all stocks, stock dividends, cash dividends, cash Distributions receivable by the Partnership to the extent information
thereon is reasonably available to the Partnership;
(e) all interest accrued on any interest bearing securities owned by the Partnership, except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
(f) the primary expenses of the Partnership insofar as the same have not been fully amortized; and
(g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The valuation of such assets shall be calculated in the following manner:
1. The value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, dividends
and interest matured but not yet received shall be represented by the par value of these assets except however if it
appears that such value is unlikely to be received. In the latter case, the value shall be determined by deducting a certain
amount to reflect the true value of these assets;
2. The value of transferable securities listed or dealt in on a regulated market which operates regularly and is recognised
and open to the public is based on the latest available price and if such transferable security is dealt in on several markets,
on the basis of the latest available price on the main market for such security. If the latest available price is not repre-
sentative, the value will be assessed on the basis of the fair value which shall be estimated prudently and in good faith by
the Manager;
3. The securities not quoted or dealt in on a stock exchange or a regulated market operating regularly shall be assessed
on a fair value basis by reference to discounted long term cash flows subject to the discretion of the Manager to make
adjustments in good faith to take into account material special factors relevant to the circumstances of the particular
securities and their issuer; and
4. All other assets shall be assessed on the basis of the fair value which shall be estimated prudently and in good faith
by the Manager in accordance with generally accepted valuation principles and procedures;
in each case based on generally accepted practices for valuing PPP assets (where applicable).
The liabilities of the Partnership shall be deemed to include:
(a) all loans, shareholder loans, bills and accounts payable;
(b) all accrued or payable administrative expenses, including but not limited to management, advisory and depositary
fees;
(c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property;
(d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Partnership, and other reserves, if any, authorised and approved by the Manager;
(e) the Establishment Costs, which shall be amortised over a five (5) year period; and
(f) all other liabilities of the Partnership of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the
Partnership.
In determining the amount of such liabilities the Partnership shall take into account all expenses payable by the Part-
nership which shall comprise formation expenses, fees payable to management, its accountants, administration, domici-
liary, registrar and transfer agents and any other agent employed by the Partnership, fees for legal and auditing services,
promotion, printing reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of this
Prospectus, explanatory memoranda or registration statements, annual reports, taxes or governmental charges, and all
other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage,
telephone and telex. The Partnership may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature
on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any
such period.
For the purpose of the Net Asset Value calculation:
(a) shares in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed
to be existing;
(b) shares of the Partnership to be redeemed under Article 16 of the Articles of Association shall be treated as existing
and until paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Partnership;
12880
L
U X E M B O U R G
(c) further Commitments shall not be taken into consideration;
(d) all Investments, cash balances and other assets of the Partnership not expressed in Euro, shall be valued after taking
into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value;
and
(e) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Partnership
on such Valuation Day, to the extent practicable.
Art. 15. Suspension. The Manager may temporarily suspend the calculation of the Net Asset Value during:
a) any period when, in the reasonable opinion of the Manager, a fair valuation of the assets of the Partnership is not
practicable for reasons beyond the control of the Partnership; or
b) any period when any of the principal stock exchanges on which a substantial proportion of the Investments of the
Partnership are quoted are closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted
or suspended; or
c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned
by the Partnership would be impractical; or
d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the
price or value of any of the Investments or the currency price or values on any such stock exchange.
Art. 16. Redemption of Shares.
a) Redemption of Shares at the sole discretion of the General Partner.
Unless otherwise provided for in these Articles of Association, Shares may be redeemed upon determination of the
General Partner only. No redemption may be requested by the holders of Shares.
The payment of the redemption price shall be made for cash or consideration in kind at the discretion of the General
Partner. The allotment of Partnership's assets in respect of a redemption for consideration in kind shall be fair and not
detrimental to the interests of the other Shareholders of the Partnership. Any redemption for consideration in kind shall
be subject to the (i) approval of the Shareholder(s) whose Shares are to be redeemed and (ii) confirmation by an Auditor's
special report of the valuation of the Partnership and of the Partnership's assets to be allocated, the costs of which shall
be borne by the Partnership.
Redemption of Shares shall be made at a price, which is determined by the General Partner to be the fair market value
for the Shares to be redeemed. In determining the fair market value, the General Partner shall apply the principles
described in Article 14. The rules relating to Distributions as set forth in the Prospectus are furthermore applicable.
b) Other cases of redemption of Shares by the Partnership
Without prejudice to (i) the above, and (ii) the right of the Partnership to redeem Shares under Article 13, and provided
the Partnership has sufficient available funds, the Partnership shall redeem the Shares held by a Shareholder in the following
circumstances:
1) such Shareholder ceases to be a “Well-Informed Investor” as defined under Article 2 of the SICAR Law;
2) such Shareholder (other than AECOM Global Inc or an Affiliate of the same) becomes a U.S. person as referred to
in the Prospectus; or
3) in the event that a Shareholder is declared bankrupt, enters into an arrangement for the benefit of its creditors or
goes into liquidation.
Under assumptions 1) and 2), the redemption price shall be equal to (i) the Issue Price, if the redemption occurs prior
to the end of the Investment Period, or (ii) the applicable Net Asset Value per Share as determined in accordance with
Article 14, if the redemption occurs after the end of the Investment Period. Under assumption 3), the redemption price
per Share shall be equal to the Net Asset Value per Share as determined by the Manager in accordance with this Article.
Payment of the redemption price will be made within a period not to exceed ten (10) Business Days from the date of
redemption, as determined by the General Partner.
All redeemed Shares shall be automatically cancelled.
Art. 17. Manager of the Partnership. The Partnership may be managed by the Manager pursuant to the terms set out
in the Prospectus and the Articles of Association. The Manager will be appointed with the prior approval of the CSSF.
The other Shareholders of the Partnership may not participate or interfere in the management of the Partnership.
The General Partner as general partner (associé gérant commandité) will have the powers as provided in Article
eighteen (18). In the absence of a Manager, the General Partner will have the powers of the Manager.
The remuneration of the General Partner is described in the Prospectus and can be modified by a Shareholders' Super
majority Approval.
Art. 18. Power. In its capacity as unlimited general partner (associé gérant commandité) of the Partnership, the General
Partner shall be responsible for carrying out its duties and obligations as required under the 1915 Law, the SICAR Law,
these Articles of Association and as more fully set out in the Prospectus.
12881
L
U X E M B O U R G
The General Partner’s powers shall be limited to the following decisions: (i) to administrate the Partnership and carry
out secretarial work (ii) to represent the Partnership in its relation with the Manager, including with respect to the
conclusion of the Management Agreement (iii) to provide technical assistance to portfolio companies, (iv) to supervise
accounting matters and ensure the bookkeeping; and (v) more generally to implement all decisions made by the Manager
as instructed by the Manager. In addition, the General Partner shall have the power (without prejudice to the powers of
the Manager) to (i) convene and organise general meetings of Shareholders, (ii) admit new Shareholders to the Partnership,
(iii) enter into contract for services with services providers designated by the Manager, (iv) carry out drawdowns and
distributions and (v) consent to transfers of interests in the Partnership in each case) pursuant to the terms set out in
the Prospectus and these Articles of Association.
In its capacity as manager (gérant) of the Partnership, the Manager shall be responsible for carrying out its duties and
obligations as required under the 1915 Law, any applicable French regulations, the Prospectus and the Articles of Asso-
ciation. The Manager will have complete discretion and full power, authority and right to represent the Partnership and
to exercise the functions, duties, powers and discretion exercisable by it as manager (gérant) under the terms of the 1915
Law, the SICAR Law, any applicable French regulation, the Prospectus and the Articles of Association, either by itself or
through its authorised agents or delegates, to manage the Investment for the account of the Partnership with a view to
achieving the Investment Strategy.
All powers not expressly reserved by the 1915 Law or these Articles of Association to the general meeting of Share-
holders shall be exercised by the General Partner or the Manager, as applicable in accordance with these Articles.
In particular, subject to the restrictions contained in the Prospectus and the 1915 Law, the Manager shall have the
broadest powers to implement the Investment Strategy and borrowing restrictions, as well as the course of conduct of
the management and business affairs of the Partnership and to manage the Investments for the account of the Partnership
with a view to achieving the Investment Strategy. The Manager shall have complete discretion and full power, authority
and right to represent and bind the Partnership.
Investments of the Partnership may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the Manager may
from time to time decide. Reference in these Articles of Association to “Investments” and “assets” shall mean, either,
investments made and assets held directly, or investments made and assets held indirectly by the aforementioned subsi-
diaries, as appropriate.
The Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Partnership in any manner or capacity other than by
exercising their rights as Shareholder in general meetings.
Art. 19. Delegation of Power. The Manager or the General Partner may from time to time and under its responsibility
subdelegate their respective powers to perform specific tasks to one or more ad hoc agent(s) In particular, the Manager
or the General Partner may, from time to time, appoint one or more committees and delegate certain of its functions to
such committees.
The Manager or the General Partner, as applicable, will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its
agent(s) and/or committees, the duration of their appointment and any other relevant conditions to his/her/its/their
appointment.
Art. 20. Removal of the General Partner and the Manager.
1. Removal of the General Partner and the Manager without fault
a. Removal of the General Partner
Shareholders whose Aggregate Commitments represent at least 60% of the share capital of the Partnership may request
the General Partner, at any time as from the third (3 rd) anniversary of the Final Closing Date, by registered letter with
return receipt requested, to submit to a vote of a general meeting of the Shareholders and within a maximum period of
two (2) months as from the receipt date of the aforementioned registered letter, the transfer of the management of the
Partnership to a new general partner (the New General Partner), without giving the reasons for such request.
The aforementioned registered letter shall indicate the name of the New General Partner and certify that (i) the New
General Partner is a general partner approved by the Luxembourg Supervisory Authority, (ii) none of the Shareholders
controls or holds, directly or indirectly through one or more holding companies, shares or any other similar interest in
the New General Partner, and (iii) the Shareholders do not represent more than 50% of the Aggregate Commitments
of the most recent fund managed or advised by such New General Partner.
The appointment of the New General Partner may only be executed with a Shareholders’ Supermajority Approval
(which vote, for the avoidance of doubt, shall not require the approval of the General Partner).
In the event that the general meeting of the Shareholders decide to transfer the management of the Partnership to a
New General Partner in accordance with the above provisions:
(a) the Depositary, following the vote of the Shareholders, shall approve the transfer of the management of the Part-
nership to the New General Partner, which approval shall not be unreasonably withheld;
(b) the New General Partner shall agree to (u) purchase the GP Share, (v) adhere to the Prospectus, (w) adhere to
any agreements with the Shareholders relating to their investment in the Partnership, which have been accepted by the
General Partner, (x) purchase 100% of the shares held by the Manager or by the General Partner and/or its Affiliates in
12882
L
U X E M B O U R G
the general partner of any Feeder Funds (y) change the names of the Partnership and the Feeder Funds for a name that
does not contain the word “Meridiam” or any reference to this name, and (z) relinquish the use of the name “Meridiam”
in connection with the management of the Partnership and each Feeder Fund, if any;
(c) the Partnership shall pay in cash to the General Partner, no later than fifteen (15) days prior to the effective transfer
of the management of the Partnership to the New General Partner, an amount (excluding tax) equal to once the amount
of the annual Management Fee as calculated as set forth in the Prospectus for the preceding year.
If the date of the effective transfer of the management of the Partnership to the New General Partner occurs before
the Calculation Date (the Period 1), the management carry vehicle shall retain the number of Class B Shares equal to the
greater of the following ratios (i) 50% or (ii) the ratio of the Invested Commitments over the Aggregate Commitment.
The remaining Class B Shares will be transferred to the New General Partner for a consideration equal to the NAV with
respect to the said transferred Class B Shares.
If the date of the effective transfer of the management of the Partnership to the New General Partner occurs after
the Calculation Date (the Period 2), the management carry vehicle will retain 100% of the Class A Shares, Class B Shares
and Class C Shares that it holds.
b. Removal of the Manager
Removal of the General Partner pursuant to this paragraph “Removal of the General Partner and the Manager without
fault” shall give rise to the immediate termination of the Management Agreement. Either the New General Partner or an
alternative investment fund manager (gestionnaire) appointed by the New General Partner will replace the Manager as
manager of the Partnership.
2. Removal of the General Partner and the Manager for fault
a. Removal of the General Partner
In the event of gross negligence of the General Partner or the Manager, as determined by a Luxembourg court decision,
which causes substantial harm to the economic interests of the Partnership (without prejudice to the possibility for the
General Partner or the Manager subsequently recovering its rights by way of appeal proceedings), Shareholders whose
aggregate Commitments represent at least 50% of the share capital of the Partnership (the Claiming Shareholders) may
request the General Partner, by registered letter with return receipt requested (setting out the above mentioned gross
negligence) (the Request Letter), to remedy or propose a solution to remedy the adverse effect of such gross negligence
to the interests of the Partnership.
The General Partner shall have a period of twenty (20) Business Days as from the receipt of the Request Letter to
notify the Claiming Shareholders (the Response Letter) (i) of the measures taken to remedy to the aforementioned
adverse effect or (ii) of the solution proposed in order to so remedy.
The Claiming Shareholders shall notify the General Partner within a fifteen (15) Business Day period as from the receipt
of the Response Letter either (i) their agreement to the measures taken or the proposed solution, or (ii) their disagree-
ment with the measures taken or the proposed solution (the Notification).
In the event of an act of gross negligence by the General Partner, which is a reoccurrence of a previous act of gross
negligence by the General Partner and which has been the subject of a Response Letter and the agreement of the Claiming
Shareholders to the measures taken or the proposed solution therein, the General Partner shall not have the right to
remedy or propose a solution to remedy the adverse effect of such gross negligence to the interests of the Partnership
and the Claiming Shareholders may request the General Partner, by a registered letter with return receipt requested, to
propose to the general meeting of the Shareholders and within a maximum period of two (2) months as from the receipt
date of such letter, the options set out in the paragraph below.
In the event of a disagreement by Shareholders whose aggregate Commitment represent at least 50% of the share
capital of the Partnership on the measures taken or the proposed solution, the Claiming Shareholders may request the
General Partner, in the Notification, to propose to the general meeting of the Shareholders and within a maximum period
of two (2) months as from the receipt date of the Notification, the following option:
(a) terminate the Investment Period, subject to the Shareholders’ Ordinary Approval (which vote, for the avoidance
of doubt, shall not require the approval of the General Partner), it being specified that the date of the Shareholders’
Ordinary Approval shall constitute the date on which the Investment Period ends; or
(b) transfer the management of the Partnership to a New General Partner, subject to the Shareholders’ Ordinary
Approval (which vote, for the avoidance of doubt, shall not require the approval of the General Partner).
The Notification shall indicate the name of the New General Partner and certify that (i) the New General Partner is
a general partner approved by the Luxembourg Supervisory Authority, (ii) none of the Shareholders controls, holds,
directly or indirectly through one or more holding companies, shares or any other similar interest in the New General
Partner, and (iii) the Shareholders do not represent more than 50% of the aggregate commitments of the most recent
fund managed by such New General Partner.
In the event that the general meeting of the Shareholders decides to transfer the management of the Partnership to a
New General Partner in accordance with the above provisions:
12883
L
U X E M B O U R G
(a) the Depositary, following the vote of the general meeting of the Shareholders, shall acknowledge the transfer of
the management of the Partnership to the New General Partner, which acknowledgment shall not be unreasonably
withheld;
(b) the New General Partner shall agree to (u) purchase the GP Share, (v) adhere to the Prospectus, (w) adhere to
any agreements with the Shareholders relating to their investment in the Partnership which have been accepted by the
General Partner, (x) purchase 100% of the shares held by the General Partner and/or its Affiliates in the general partner
of any Feeder Fund, (y) change the names of the Partnership and any Feeder Fund for a name that does not contain the
word “Meridiam” or any reference to this name, and (z) relinquish the use of the name “Meridiam” in connection with
the management of the Partnership and any Feeder Fund.
If the date of the effective transfer of the management of the Partnership to the New General Partner occurs during
the Period 1, the management carry vehicle will transfer to the New General Partner (i) 50% of its Class B Shares for a
consideration equal to the NAV with respect to such Class B Shares and (ii) 50% of its Class B Shares for a consideration
equal to the paid-up amount of such Class B Shares.
If the date of the effective transfer of the management of the Partnership to the New General Partner occurs during
the Period 2, the management carry vehicle will transfer to the New General Partner (i) 50% of its Class C Shares for a
consideration equal to the NAV with respect to such Class C Shares and (ii) 50% of its Class C Shares for a consideration
equal to the paid-up amount of such Class C Shares.
At any time, in case of effective transfer of the management of the Partnership to a New General Partner following a
removal of the General Partner for fault as described in this paragraph “Removal of the General Partner and the Manager
for fault”, the management carry vehicle shall commit to transfer any Class A Share subscribed on the Final Closing Date
and use its commercially reasonable efforts to sell those shares on the secondary market within six (6) months after the
effective transfer.
b. Removal of the Manager
Removal of the General Partner pursuant to this paragraph “Removal of the General Partner and the Manager for
fault” shall give rise to the immediate termination of the Management Agreement. Either the New General Partner or an
alternative investment fund manager (gestionnaire) appointed by the New General Partner will replace the Manager as
manager of the Partnership.
Art. 21. Conflicts of Interest. No contract or other transaction between the Partnership and any other company, firm
or entity shall be affected or invalidated by the fact that the Manager, the General Partner or one or more of the officers
of the Partnership is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company, firm or entity.
The Manager, the General Partner or any officer of the Partnership who serves as a director, officer or employee of any
company, firm or entity with which the Partnership shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of
such affiliation with such other company, firm or entity be prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.
Complementary conflict of interest rules and guidance are further described in the Prospectus.
Art. 22. Signature. The Partnership shall be bound by the sole signature of the Manager or the General Partner acting
through (i) one or more of its duly authorized signatories, or (ii) such person(s) to which such power has been delegated.
Art. 23. Indemnification. The Partnership agrees to indemnify and hold harmless out of the assets of the Partnership
the Indemnified Persons against any and all liabilities, actions, proceedings, claims, reasonable costs, demands, damages
and reasonable expenses (including reasonable legal fees) incurred or threatened arising out of or in connection with or
relating to or resulting from the Indemnified Person being or having acted as a manager, general partner or investment
advisor in respect of the Partnership or arising in respect of or in connection with any matter or other circumstance
relating to or resulting from the exercise of its powers as a manager, general partner or investment advisors or from the
provision of services to or in respect of the Partnership or under or pursuant to any agreement relating to the Partnership
or in respect of services as a Nominated Director or which otherwise arise in relation to the operation, business or
activities of the Partnership provided however that any Indemnified Person shall not be so indemnified with respect to
any matter resulting (i) from their gross negligence, fraud or wilful misconduct or their material breach of the provisions
of these Articles of Association or the Prospectus or the law or (ii) in connection with any dispute that is solely between
or among the General Partner and the Manager.
To the extent applicable, permitted and practicable under the circumstances, prior to seeking indemnification pursuant
to this Article twenty-three, an Indemnified Person shall use commercially reasonable efforts to first seek indemnification
from (i) a Portfolio Company or SPV that is related to the Investment that is the subject of the claim giving rise to
indemnification and (ii) any other indemnity or insurance policies by which such Indemnified Person is indemnified or
covered, as the case may be.
To the extent the Indemnified Person would be entitled to an advance or payment from a Portfolio Company or SPV
or other third party source, (x) the Manager or the General Partner will use its commercially reasonable efforts to ensure
that such Indemnified Person will assign to the Partnership all of the Indemnified Person’s right to indemnification and
advancement of expenses from such Portfolio Company or SPV; and (z) the Manager or the General Partner will use its
12884
L
U X E M B O U R G
commercially reasonable efforts to ensure that such Indemnified Person will execute all documents and take all other
actions appropriate to effectuate the foregoing clause (x).
This indemnity shall continue in effect notwithstanding the fact that the Indemnified Person shall have ceased to act as
general partner, manager or otherwise to provide services to or in respect of the Partnership or to act in any of the
capacities listed in this Article twenty-three, provided, that such Indemnified Person would be entitled to such indemni-
fication, i.e. has not acted with gross negligence, fraud, etc. as set forth above.
For the avoidance of doubt, the satisfaction of the Partnership’s obligations to indemnify the Indemnified Persons as
provided above shall be solely from and be limited to the assets of the Partnership and no Shareholder shall have any
personal liability on account thereof.
Art. 24. General Meetings of Shareholders. The decisions of the Shareholders are taken by resolutions passed at
meetings of the Shareholders held at a time and place specified in the notice of the meeting.
The general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Partnership. Its resolutions
shall be binding upon all the Shareholders of the Partnership.
General meetings of Shareholders are convened by the General Partner.
If all Shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Each Shareholder may participate in any general meeting by telephone or video conference or by any other similar
means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by the Shareholders for them to take
part in any meeting of Shareholders. Any Shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax,
cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means another person who needs not
be Shareholder.
Each Shareholder may participate in general meetings of Shareholders.
All general meetings of Shareholders shall be chaired by the General Partner or by any person designated by the
General Partner.
One general meeting shall be held annually at the registered office of the Partnership or elsewhere as may be specified
in the notice of meeting at 11.00 am on the second Tuesday of May and for the first time in 2010. If this day is not a
Business Day, the general meeting shall be held on the first following Business Day.
Unless otherwise provided for in these Articles of Association, Shareholders' resolutions are validly passed by Share-
holders' representing a majority of the voting rights at Shareholders' meetings validly convened and quorate in accordance
with the 1915 Law. In any case, unless otherwise provided, the consent of the Manager or the General Partner is required
for any Shareholders' resolution to be validly adopted.
Any amendment to these Articles of Association may be adopted according to the rules prescribed in the 1915 Law.
The SICAR status may only be abandoned by the Partnership with the prior approval of the CSSF and the unanimous
consent of the Shareholders.
No amendment to these Articles of Association which may increase any Shareholder's liability or reduce any Share-
holder's rights can be made without the unanimous consent of the Shareholders.
Art. 25. Financial Year. The Partnership's financial year begins on 1 January and closes on 31 December of the same
year.
Art. 26. Accounts. Each year, the General Partner will draw up the annual accounts of the Partnership.
The annual accounts shall be approved by the annual general meeting of Shareholders upon proposal of the General
Partner.
The accounts shall be expressed in Euro.
Art. 27. Supervision. The operations of the Partnership and its financial situation shall be supervised by one independent
Auditor qualifying as a “réviseur d'entreprises agréé” who shall be appointed by the General Partner for a renewable
term of one (1) year. The Auditor shall be remunerated by the Partnership and shall remain in office until its successor
is appointed. The Auditor shall fulfil all duties prescribed by the SICAR Law. The independent Auditor may only be
removed by the General Partner on serious grounds.
Art. 28. Distribution. Subject to permitted reinvestments, and the requirements of Luxembourg law. Distributions
shall be payable by the Partnership on its Shares on an interim basis when declared by the General Partner in accordance
with these Articles of Association and the Prospectus. Annual distributions will be made by the general meeting of
Shareholders upon a proposal of the General Partner.
No Distribution may be made if after the declaration of such Distribution the Net Asset Value of the Partnership
would fall below one million Euro (EUR 1,000,000).
12885
L
U X E M B O U R G
The Partnership can make distributions in kind as further described in the Prospectus. Such Distributions in kind shall
each time be subject to a special report of the Auditor, the costs of which shall be borne by the Partnership.
Art. 29. Depositary. The Partnership shall enter into a Depositary Agreement with a financial institution, which shall
satisfy the requirements of the SICAR Law. The Depositary shall assume towards the Partnership and the Shareholders
the responsibilities set out in the SICAR Law (notably in article 8 and 9 of the SICAR Law), the Depositary Agreement
and any other law applicable. Notably, the Depositary shall hold the Partnership's assets in the name and on behalf of the
Partnership.
The Depositary shall assume the liability, and be responsible in accordance with Luxembourg regulations and with the
Depositary Agreement, for the safekeeping of all the assets of the Partnership.
The Depositary shall verify the compliance by the Manager and the General Partner with the Articles of Association
with respect to the assets of the Partnership and shall verify the receipt under custody for the Partnership of counterparts
of all documentation for all transactions made on behalf of the Partnership.
The Depositary Agreement may be terminated on ninety (90) Business Days' notice.
The Depositary will receive an annual fee out of the net assets of the Partnership, payable quarterly in arrears, which
fee shall be determined from time to time by agreement between the Partnership and the Depositary and calculated in
accordance with usual banking practice in Luxembourg for the provision of similar services.
In the event of termination of the Depositary Agreement or the resignation of the Depositary, the Manager or the
General Partner shall use its best endeavours to find within two months a financial institution to act as Depositary and
upon doing so the Manager or the General Partner shall appoint such financial institution to be Depositary in place of the
former Depositary.
After dismissal, the Depositary must continue to carry out its function as long as is necessary to enable the entire
assets of the Partnership to be transferred to the new Depositary.
Art. 30. Winding-up. The Partnership may (i) be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Sha-
reholders deliberating as prescribed for amendment of these Articles of Association, with the consent of the General
Partner or (ii) dissolve as set out in Article 5.
Art. 31. Liquidation. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed
at a general meeting of Shareholders deliberating as prescribed for amendment of these Articles of Association and which
will specify their powers and fix their remuneration.
Such liquidator(s) appointed must be approved by the Luxembourg Supervisory Authority and must provide all requisite
guarantees of honorability and professional skills.
Once the Partnership is placed in liquidation, the assets of the Partnership will be distributed to the Shareholders in
accordance with the principles described in Article 28 and the Prospectus.
Art. 32. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the 1915 Law and the SICAR Law for which no specific
provision is made in these Articles of Association.
Art. 33. Definitions and Interpretation. In these Articles of Association, unless inconsistent with the context or other-
wise defined, the following expressions shall have the following meaning:
- “Add-on Investment”: any supplementary Investments in existing Portfolio Companies;
- “Acquisition Cost”: the total amount paid by the Partnership with respect to an Investment, including all the expenses
borne, if any, by the Partnership (in particular due diligence expenses, registration duty or any other similar taxes and
duties) in connection with such Investment;
- “Additional Capital Contribution(s)”: any capital contribution made by a Shareholder in excess of its Initial Capital
Contribution;
- “Additional Drawdown”: at any particular point in time, such portion of its Commitment as may be requested by the
General Partner to be contributed to the Partnership by way of an Additional Capital Contribution pursuant to an
Additional Drawdown Notice;
- “Additional Drawdown Notice”: a notice from the General Partner to each Shareholder by facsimile, e-mail or post,
in such form as may be approved by the General Partner from time to time, stating that an Additional Drawdown is to
be paid and the purpose for which the Additional Drawdown is to be used;
- “Administration Agent”: the administration and paying agent of the Partnership, or any successor administration and
paying agent thereto;
- “Admission Date”: in relation to a Shareholder, the date, comprised within the Offer Period, as determined by the
General Partner in its absolute discretion and notified to such Shareholder by the General Partner prior thereto, on
which such Shareholder is admitted to the Partnership and entered as a Shareholder in the Register;
- “Affiliate”: in relation to any person, (i) any other person which directly or indirectly Controls, is Controlled by, or
is under common Control with such person; or (ii) any officer, director, partner or employee of such person or such
other person; or (iii) if such person is a public pension fund, its successor trustee; or (iv) if such person is a public body,
any other body which is established by the same public authority and is a successor body of such person;
12886
L
U X E M B O U R G
- “Aggregate Capital Contributions” the aggregate of the Initial Capital Contribution and each Additional Capital Con-
tribution;
- “Aggregate Commitment(s)”: the aggregate commitment of all Shareholders;
- “Articles of Association”: regulating the Partnership as amended, supplemented or otherwise modified from time to
time, including any subsequent articles of association regulating the Partnership;
- “Auditor”: the auditor to the Partnership appointed in accordance with article 27 of the SICAR Law or any other or
successor auditor to it appointed by the General Partner;
- “Business Day”: a day on which banks and other financial institutions are open for business (other than Saturdays,
Sundays and public holidays) in Luxembourg;
- “Calculation Date”: in respect of payments or other Distributions on the Class B Shares, the 12
th
anniversary of the
Initial Closing Date;
- “Class” or “Classes”: includes the GP Share, each of the Class A Shares, Class B Shares and, upon issuance, the Class
C Shares and any further Class of Shares issued by the Partnership;
- “Class A Shareholder”: a holder of Class A Shares being a limited partner (actionnaire commanditaire) within the
meaning of the 1915 Law;
- “Class A Shares”: the class A shares of the Partnership issued pursuant to these Articles of Association;
- “Class B Shareholder”: a holder of Class B Shares being a limited partner (actionnaire commanditaire) within the
meaning of the 1915 Law;
- “Class B Shares”: the class B shares of the Partnership issued pursuant to these Articles of Association;
- “Class C Shares”: the class C shares of the Partnership to be issued upon the conversion of certain Class B Shares
as set forth in the Prospectus;
- “Closing” and “Closing Date(s)”: the date (or dates) determined by the Manager on or prior to which Subscription
Agreements for Class A Shares must be received and accepted by the General Partner, being for the first time the Initial
Closing Date. The Partnership may accept further subscriptions for Class A Shares during the Offer Period which ends
on the Final Closing Date;
- “Commitment”: the commitment of each Investor made pursuant to a Subscription Agreement to be entered into
between such Investor and the Partnership, pursuant to which the Investor will commit to pay the Initial Capital Con-
tribution and make a Further Commitment to provide Additional Capital Contributions up to the maximum aggregate
amount specified therein as its Commitment to the Partnership;
- “Control”: the power to direct the management or policies of a person or an entity (whether incorporated or
unincorporated), directly or indirectly, whether through the ownership of shares, possession of voting power in respect
of shares or other securities, by contract or otherwise, and “Controlled” and “Controlling” have corresponding meanings;
- “Depositary”: shall mean the depositary bank appointed in accordance with article 8 of the SICAR Law or any
successor depositary thereto;
- “Depositary Agreement”: the agreement between the Partnership and the Depositary as amended, supplemented
or otherwise modified from time to time;
- “Default Notice”: a notice given to any Class A Shareholder who fails to pay to the Partnership the amount, which
is the subject of an Additional Drawdown Notice on or before the date of expiry of such notice, demanding payment of
such Additional Drawdown amount plus Interest Compensation for each day of default. Such Default Notice shall also
set out the consequences (as specified in these Articles of Association) of a failure to pay the amount of the Additional
Drawdown and any applicable Interest Compensation within thirty (30) days of the date of such notice;
- “Defaulting Shareholder”: as defined in Article 9;
- “Distribution”: any distribution of dividends, proceeds of redemption of Shares, any allocation of liquidation proceeds,
or other distribution by the Partnership in respect of Shares;
- “Euro or EUR”: the currency of the member states of the EU that have adopted the single currency in accordance
with the Treaty establishing the European Community (signed in Rome 1957) as amended by the Treaty on European
Union (signed in Maastricht on 7 February 1992);
- “EURIBOR”: the percentage rate per annum equal to the offered quotation which appears on the page of the Telerate
Screen which displays an average rate of the Banking Federation of the European Union for three month EURO (being
currently page 248) at or about 11.00 am (Brussels time) on the Specified Date or, if such page or such service shall cease
to be available, such other page or such other service for the purpose of displaying an average rate of the Banking
Federation of the European Union as the Manager or the General Partner shall reasonably select;
- “Feeder Fund”: means a limited partnership or other entity setup for the purpose of facilitating an investment into
the Partnership by certain types of investors due to tax, regulatory or other reasons;
- “Final Closing Date”: 15 March 2012;
- “Founding Shareholders”: the shareholders appearing as founding shareholders in the incorporation deed of the
Partnership;
12887
L
U X E M B O U R G
- “Further Commitment(s)”: as defined in Article 9;
- “General Partner”: MERIDIAM Infrastructure Managers S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, is the
unlimited general partner of the Partnership and acts as its manager (associé gérant commandité);
- “GP Share”: the GP share in the Partnership held by the General Partner;
- “Income Receipts”: all sums received by way of dividends or payments of interest received by the Partnership from
any Portfolio Companies, but excluding all amounts received by the Partnership from any Portfolio Company upon or in
relation to the disposal of any Investment;
- “Indemnified Individual”: means any officer, director, shareholder, agent, member, adviser, consultant, partner or
employee of the Manager, the General Partner or any of their Affiliates or a Nominated Director;
- “Indemnified Person”: means any of the Manager, the General Partner or their Affiliates and any Indemnified Individual;
- “Independent Valuer”: an independent valuer appointed by the Manager to value the assets of the Partnership and
having relevant expertise and experience in the valuation of infrastructure assets;
- “Initial Additional Drawdown Proportion”: as defined in Article 8;
- “Initial Capital Contribution”: the initial capital contribution made by each Shareholder at its Admission Date in
respect of the Shares acquired by it, being an amount equal to the Issue Price multiplied by the number of Shares acquired
by it at its Admission Date;
- “Initial Closing Date”: the first Closing Date for the Class A Shares as determined in the Prospectus;
- “Interest Compensation”: the interest due from a Class A Shareholder to the Partnership accrued between the date
payment in respect of any of its Commitment was due until the date such amount was paid, calculated based on an interest
rate equal to three (3) months EURIBOR plus two percent (2%) per annum, calculated from the date payment of such
amount falls due until the date payment is received by the Partnership;
- “Investment”: any investment made by the Partnership in a Portfolio Company or SPV or any other type of equity
capital, debt securities, loans and/or other financing facilities and/or arrangements, as granted by the Partnership to any
Portfolio Company including without limitation (i) any Add-on Investment, (ii) the refinancing of any one or more of such
investments, and (iii) and any such investment made through a joint venture with a third party;
- “Investment Period”: the period commencing on the Initial Closing Date and ending on the 5 th anniversary of the
Final Closing Date, subject to an extension by the Manager for one additional period of one year, such extension to be
subject to the approval of the Investor Committee;
- “Investment Strategy”: the investment strategy of the Partnership as described in the Prospectus, as such investment
strategy may be amended from time to time by the Manager, with the approval of the Investor Committee and a
Shareholder’s Special Majority Approval;
- “Investor Committee”: the investor committee of the Partnership if any, which may be set-up by the Manager as
more fully described in the Prospectus;
- “IRR”: the annualised internal rate of return (compounded on an annual basis) on the cash flows of the Partnership
taking into account (i) the Initial Capital Contribution paid by the Class A Shareholders, (ii) all amounts drawn down from
Class A Shareholders in the form of Additional Capital Contributions, and (iii) all Income Receipts and the residual value
of the assets of the Partnership estimated at the date of the calculation as calculated by the Administration Agent at each
record date for the payment of dividends (as determined by the Manager) and according to normal statistical techniques
using annual rests so that, in the absence of manifest error, such calculation by the Administration Agent shall be binding
on all Shareholders and the Partnership. For the purpose of such calculation, the Administration Agent shall assume in
respect of any drawdown that the cost to the Partnership thereof was incurred (i) on the Initial Closing Date, in respect
of the Issue Price of the Class A Shares, and (ii) in the case of further contributions in respect of Commitment as Additional
Capital Contributions on the date on which such amounts were required to be paid to the Partnership as specified in the
relevant Additional Drawdown Notice;
- “Issue Price”: the initial issue price of the Class A and the Class B Shares, being twenty-five Euro (EUR 25) per Class
A Share and per Class B Share, respectively;
- “Management Agreement”: means the agreement between the Partnership, the General Partner and the Manager in
relation to the management and operation of the Partnership;
- “Management Fee”: means the annual management fee paid to the General Partner as detailed in the Prospectus;
- “Manager”: the entity appointed by, and dismissed at the discretion of, the General Partner, as the case may be, in
accordance with the directive 2011/61/EU on alternative investment fund managers;
- “Net Asset Value”: the net asset value of the Partnership as determined by the Administration Agent on the basis of
the valuation of the assets of the Partnership, as provided by the Manager, and calculated in accordance with the provisions
of Article 14;
- “New General Partner”: means a new general partner appointed upon removal of the General Partner;
- “Nominated Director”: means any person nominated by the Partnership or the Manager (or any Affiliate) to be a
director (or equivalent) of any company in which the Partnership holds an Investment or to be a member (or equivalent)
of any relevant committee of a Portfolio Company;
12888
L
U X E M B O U R G
- “Notification”: as defined in Article 20;
- “OECD”: Organisation for Economic Cooperation and Development;
- “Offer Period”: the period starting on the Initial Closing Date and ending on the Final Closing Date, during which
further investors may be admitted as Class A Shareholders;
- “Portfolio Company” or “SPV”: any corporation or other entity investing (directly or indirectly) in PPP infrastructure
projects in the transportation, facilities and accommodation, and environment sectors or providing related services in
any OECD country, which requires development, project construction or operations related finance, in which the Part-
nership has made or intends to make an Investment;
- “PPP”: public private partnership;
- “Prospectus”: the prospectus relating to the Partnership, including any supplement thereto, as amended or restated
from time to time;
- “Redrawn Commitment”: funds representing the proceeds from the disposal of an Investment or part thereof that
have been distributed to the Shareholders, and drawn down again by the General Partner, provided that, in the case of
funds returned on disposal of an Investment or part thereof (i) the Partnership has acquired such Investment and sub-
sequently disposed of it within eighteen (18) calendar months of its acquisition; (ii) such draw down takes place within
twelve (12) months of the Distribution of such funds to the Shareholders (and, in any event, within the Investment Period);
and (iii) the aggregate amount of Commitments redrawn by the General Partner shall not exceed twenty percent (20%)
of the Aggregate Commitments;
- “Registrar and Transfer Agent”: the registrar and transfer agent appointed as the registrar and transfer agent of the
Partnership, or any successor registrar and transfer agent thereto;
- “Right of First Refusal”: the right of first refusal as defined in Article 13;
- “Share”: a share in the capital of the Partnership which may be issued in different Classes by the Partnership pursuant
to these Articles of Association, including, but not limited to, the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares
and the GP Share that will have to be fully paid up at the date of subscription;
- “Shareholder”: a holder of a Share;
- “Shareholders’ Special Majority Approval”: the approval of Shareholders representing ninety six percent (96%) of the
share capital of the Partnership;
- “SICAR”: société d'investissement en capital à risque (investment company in risk capital);
- “SICAR Law”: the Luxembourg law of 15 June 2004, on the investment company in risk capital, as amended from
time to time;
- “Subscription Agreement”: an agreement entered into between each potential investor and the Partnership pursuant
to which potential investors subscribe Shares in the Partnership;
- “Total Initial Contribution”: as defined in Article 8; and
- “1915 Law”: the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.”
The appearing parties require the notary to mention the rectification wherever necessary.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person(s), the present deed is worded in English.
Whereof the present rectification deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are know to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Signé: L. Mersch, M. Bernot, C. Vaudémont et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63584. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003233/848.
(150002528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
12889
L
U X E M B O U R G
German Multi Industrial I S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 120.205.
<i>Extrait des résolutions des associés prises en date du 2 décembre 2014i>
Est nommé, pour une durée indéterminée, gérant de la Société en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, gérant
démissionnaire:
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 02.12.2014.
Référence de publication: 2014206958/16.
(140230739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.
3C Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 193.344.
STATUTS
L'an deux mille quatorze.
Le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU
La société Luxglobal Services S.à r.l., ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 160.089,
ici représentée par Monsieur Rob SONNENSCHEIN, directeur, demeurant professionnellement à L-2134 Luxem-
bourg, 50, rue Charles Martel, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 29 décembre 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte con-
stitutif d'une société anonyme qu’elle déclare vouloir constituer et dont elle a arrêté‚ les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de 3C Lux S.A..
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d’une
résolution de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires, au moyen d’une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires.
Le siège de la société pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'ad-
ministration ou de l’administrateur unique.
Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique aura le droit d’instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, dans
d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en
particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à
l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter
12890
L
U X E M B O U R G
des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales,
sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobilières ou immobilières, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par cent (100) actions d'une
valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310.-) par action.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sous respect des dispositions légales.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés
jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Administration - Surveillance
Art. 8. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un membre, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-
présidents du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale.
En cas d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent
désigné à cet effet.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqué dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, courriel ou fax.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation
du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
12891
L
U X E M B O U R G
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 10. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signés par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs ou l’administrateur unique.
Art. 11. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-
complir tous les actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration ou de l’administrateur
unique.
Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d’admi-
nistration ou l’administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d’administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d’administrateur-délégué.
Art. 13. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- en cas d’administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle
du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore
- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pou-
voirs, ou
- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'admi-
nistration.
Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale ou l’actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 16. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le premier lundi du mois de juin à 10.30 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l’administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
12892
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation
des règles y relatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale ou de l’associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale ou par l’associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Disposition générale
Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) actions ont été souscrites par la société Luxglobal Services S.à r.l., préqualifiée.
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents Euros
(€ 1.300.-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui du commissaire à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à
L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
- Monsieur Hendrik H.J. (Rob) KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-2134 Luxembourg, 50,
rue Charles Martel.
- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, directeur, demeurant professionnellement à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles
Martel.
- La société Luxglobal Management S.à r.l., ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 159.893,
représentée par son représentant permanent Monsieur Rob SONNENSCHEIN, prénommé.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.
4.- Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2020.
5.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-
délégué.
6.- Le siège social est fixé à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
12893
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. SONNENSCHEIN, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2015. Relation: GAC/2015/54. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003520/205.
(150003017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Powerwave Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 67.960,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 181.099.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of December,
Before the undersigned, Maître Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Powervave Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and organized
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 296-298, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 50,000.-and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 180683 (the Sole Shareholder),
here represented by Peggy Simon, notary's clerk, whose professional address is in Echternach, by virtue of a power
of attorney given on under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested that the undersigned notary record that:
- the Sole Shareholder holds all of the shares in Powervave Technologies S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital
of EUR 67,960.- and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 181099
(the Company);
- the Company was incorporated on 4 October 2013 pursuant to a deed drawn up by Maître Jean Seckler, notary
resident in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the Memorial) number 2979 of 26 November 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have been
amended once since the incorporation on 17 January 2014 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, pre-named, published
in the Memorial number 756 of 24 March 2014;
- the Company's share capital is set at sixty-seven thousand nine hundred sixty United States dollars (USD 67,960),
represented by sixty-seven thousand nine hundred sixty (67,960) shares in registered form, having a nominal value of one
United States dollar (USD 1) each, all entirely subscribed and fully paid up;
- the Sole Shareholder has full and complete knowledge of the Articles and of the Company's financial situation;
- the Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to dissolve the Company with
immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire);
- the Sole Shareholder resolves to act as liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the activity of the Company has ceased;
(ii) the liquidation accounts have been prepared and show that most of the known liabilities of the Company have been
settled or fully provided for;
(iii) it will receive all the outstanding assets of the Company; and
(iv) it will assume all remaining liabilities of the Company (including but not limited to hidden or unknown liabilities, if
any).
- the Sole Shareholder approves the liquidation accounts of the Company dated 29 December 2014;
- the Sole Shareholder waives the appointment of a liquidation auditor;
12894
L
U X E M B O U R G
- the Sole Shareholder resolves to grant the managers of the Company full discharge for the performance of their
respective mandates up to the date of the present meeting;
- the Sole Shareholder resolves to confirm that the Company is hereby liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder resolves to keep the books, documents and records of the Company at IF Experts-Comptables,
296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, for a period of five years after the publi-
cation of this deed in the Memorial and to pay any and all costs associated with the liquidation;
- the Sole Shareholder resolves to grant power to any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., any
employee of IF Experts-Comptables and any employee of the notary enacting this deed, each of them acting individually,
to carry-out and perform any formalities necessary to complete and file any outstanding tax returns of the Company and
to undertake any formalities necessary in connection with filing the accounts and closing the Company's liquidation and
these powers expiring one year after the closing of the Company's liquidation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this
deed is drawn up in English followed by a French version, and that in case of discrepancies, the English version prevails.
WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Echternach, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le trentième jour de décembre,
Par-devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Powerwave Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, dont le siège social est établi au 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
disposant d'un capital social de EUR 50,000 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 180683 (l'Associé Unique),
représentée par Peggy Simon, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Echternach en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, la procuration
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales de Powerwave Technologies S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 296-298, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de EUR 67.960 et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181099 (la Société);
- la Société a été constituée le 4 octobre 2013 suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Memorial) numéro 2979
du 26 novembre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés une fois depuis sa constitution le 17 janvier
2014 suivant un acte de Maître Jean Seckler, précité, publié au Memorial numéro 756 le 24 mars 2014;
- le capital social de la Société est fixé à soixante-sept mille six-cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 67.690),
représenté par soixante-sept mille six-cent quatre-vingt-dix (67.690) parts sociales sous forme nominative, ayant une
valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées;
- l'Associé Unique a une connaissance pleine et entière des Statuts et de la situation financière de la Société;
- l'Associé Unique décide, en sa qualité d'associé unique de la Société, de dissoudre la Société avec effet immédiat et
de la mettre en liquidation (liquidation volontaire);
- l'Associé Unique décide d'agir en tant que liquidateur de la Société;
- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) l'activité de la Société a cessé;
(ii) les comptes de liquidation ont été préparés et montrent que la plupart du passif connu de la Société a été payé ou
provisionné;
(iii) qu'il recevra tous les actifs restants de la Société; et
(iv) qu'il prendra à sa charge tout le passif restant de la Société (incluant notamment tout le passif caché ou inconnu
à ce jour, le cas échéant).
- l'Associé Unique approuve les comptes de liquidation de la Société datés du 29 décembre 2014;
- l'Associé Unique renonce à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
- l'Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs
mandats respectifs jusqu'à la date de la présente assemblée;
12895
L
U X E M B O U R G
- l'Associé Unique décide de confirmer que la Société est par conséquent liquidée et sa liquidation clôturée;
- l'Associé Unique décide de conserver les livres, documents et registres de la Société à IF Experts-Comptables,
296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg pour une durée de cinq (5) ans à compter
de la publication du présent acte au Memorial et de payer tous les frais en rapport avec la liquidation;
- l'Associé Unique décide de donner pouvoir à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., à tout
employé de IF Experts-Comptables, et à tout employé du notaire passant le présent acte, chacun d'eux agissant indivi-
duellement, de faire et d'effectuer toutes les formalités nécessaires afin de compléter et d'enregistrer les déclarations
fiscales manquantes de la Société et de faire tout le nécessaire pour déposer les comptes et tout ce qui est requis en
relation avec la clôture de la liquidation de la Société, les présents pouvoirs expirant un an après la clôture de la liquidation
de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de l'Associé Unique, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2015. Relation: GAC/2015/38. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003322/123.
(150002804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Powerwave Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 180.683.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of December,
Before the undersigned, Maître Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
PW Technologies (Cayman), L.P., an exempted limited partnership organized under the laws of Cayman Islands and
having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309,
Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1104 (the Sole Shareholder),
here represented by Peggy Simon, notary's clerk, whose professional address is in Echternach, by virtue of a power
of attorney given on under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested that the undersigned notary record that:
- the Sole Shareholder holds all of the shares in Powerwave Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR
50,000 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 180683 (the Com-
pany);
- the Company was incorporated on 18 September 2013 pursuant to a deed drawn up by Maître Jean Seckler, notary
resident in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the Mémorial) number 2922 of 20 November 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have been
amended once since the incorporation on 17 January 2014 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, pre-named, published
in the Mémorial number 766 of 25 March 2014;
- the Company's share capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000), represented by fifty thousand (50,000) shares
in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, all entirely subscribed and fully paid up;
- the Sole Shareholder has full and complete knowledge of the Articles and of the Company's financial situation;
12896
L
U X E M B O U R G
- the Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to dissolve the Company with
immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire);
- the Sole Shareholder resolves to act as liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the activity of the Company has ceased;
(ii) the liquidation accounts have been prepared and show that most of the known liabilities of the Company have been
settled or fully provided for;
(iii) it will receive all the outstanding assets of the Company; and
(iv) it will assume all remaining liabilities of the Company (including but not limited to hidden or unknown liabilities, if
any).
- the Sole Shareholder approves the liquidation accounts of the Company dated 15 December 2014;
- the Sole Shareholder waives the appointment of a liquidation auditor;
- the Sole Shareholder resolves to grant the managers of the Company full discharge for the performance of their
respective mandates up to the date of the present meeting;
- the Sole Shareholder resolves to confirm that the Company is hereby liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder resolves to keep the books, documents and records of the Company at IF Experts-Comptables,
296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, for a period of five years after the publi-
cation of this deed in the Mémorial and to pay any and all costs associated with the liquidation;
- the Sole Shareholder resolves to grant power to any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., any
employee of IF Experts-Comptables and any employee of the notary enacting this deed, each of them acting individually,
to carry-out and perform any formalities necessary to complete and file any outstanding tax returns of the Company and
to undertake any formalities necessary in connection with filing the accounts and closing the Company's liquidation and
these powers expiring one year after the closing of the Company's liquidation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this
deed is drawn up in English followed by a French version, and that in case of discrepancies, the English version prevails.
WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Echternach, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le trentième jour de décembre,
Par-devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
PW Technologies (Cayman), L.P., une société en commandite (exempted limited partnership) régie par les lois des
Îles Cayman et dont le siège social est établi à c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church
Street, PO Box 309, Grand Cayman, Îles Cayman, KY1-1104 (l'Associé Unique),
représentée par Peggy Simon, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Echternach en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, la procuration
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales de Powerwave Holdings S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 296-298, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de EUR 50,000 et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180683 (la Société);
- la Société a été constituée le 18 septembre 2013 suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 2922
du 20 novembre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés une fois depuis sa constitution le 17 janvier
2014 suivant un acte de Maître Jean Seckler, précité, publié au Mémorial numéro 766 le 25 mars 2014;
- le capital social de la Société est fixé à cinquante mille euro (EUR 50.000), représenté par cinquante mille (50.000)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes entièrement sou-
scrites et libérées;
- l'Associé Unique a une connaissance pleine et entière des Statuts et de la situation financière de la Société;
- l'Associé Unique décide, en sa qualité d'associé unique de la Société, de dissoudre la Société avec effet immédiat et
de la mettre en liquidation (liquidation volontaire);
- l'Associé Unique décide d'agir en tant que liquidateur de la Société;
12897
L
U X E M B O U R G
- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) l'activité de la Société a cessé;
(ii) les comptes de liquidation ont été préparés et montrent que la plupart du passif connu de la Société a été payé ou
provisionné;
(iii) qu'il recevra tous les actifs restants de la Société; et
(iv) qu'il prendra à sa charge tout le passif restant de la Société (incluant notamment tout le passif caché ou inconnu
à ce jour, le cas échéant).
- l'Associé Unique approuve les comptes de liquidation de la Société datés du 15 décembre 2014;
- l'Associé Unique renonce à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
- l'Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs
mandats respectifs jusqu'à la date de la présente assemblée;
- l'Associé Unique décide de confirmer que la Société est par conséquent liquidée et sa liquidation clôturée;
- l'Associé Unique décide de conserver les livres, documents et registres de la Société à IF Experts-Comptables,
296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg pour une durée de cinq (5) ans à compter
de la publication du présent acte au Mémorial et de payer tous les frais en rapport avec la liquidation;
- l'Associé Unique décide de donner pouvoir à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., à tout
employé de IF Experts-Comptables, et à tout employé du notaire passant le présent acte, chacun d'eux agissant indivi-
duellement, de faire et d'effectuer toutes les formalités nécessaires afin de compléter et d'enregistrer les déclarations
fiscales manquantes de la Société et de faire tout le nécessaire pour déposer les comptes et tout ce qui est requis en
relation avec la clôture de la liquidation de la Société, les présents pouvoirs expirant un an après la clôture de la liquidation
de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de l'Associé Unique, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2015. Relation: GAC/2015/39. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003321/120.
(150002803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Prêt-à-porter Catalogue, Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 176.385.
DISSOLUTION
the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of the month of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
“Gold Flamingo Inc.”, a company governed by the laws of Bahamas, having its registered office in Nassau, West Bay
Street, PO Box SP-63131, Bayside Executive Park, Building No. 1 (Bahamas), registered with the Trade Registry of Nassau
(Bahamas) under number 167010B,
here represented by Mrs. Deborah BUFFONE, employee, residing professionally in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue
Edward Steichen, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed
“ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be
recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:
1) That the public limited company (“société anonyme”) “Prêt-à-porter Catalogue”, established and having its regis-
tered office in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, registered with the Trade and Companies Register of
Luxembourg, section B, under the number 176385, (the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me
12898
L
U X E M B O U R G
Cosita DELVAUX, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), on March 29, 2013, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 879 of April 2013,
and that the articles of associations (the “Articles”) have not been amended since;
2) That the corporate capital is set at one hundred thousand Euros (100,000.-EUR), divided into one thousand (1,000)
shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, fully paid up;
3) That the appearing party, represented as said before, is the sole owner of all the shares of the Company (the “Sole
Shareholder”);
4) That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the Articles and the financial standing of the Company;
5) That the Sole Shareholder of the Company declares explicitly, the winding-up of the Company and the start of the
liquidation process, with effect on today's date;
6) That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, it has full powers
to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful
so to bring into effect the purposes of this deed;
7) That the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authentify its decla-
ration that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation of the
close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual
liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such eventual
liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;
8) That the Sole Shareholder declares that it takes over all the assets of the Company, and that it will assume any
existing debts of the Company pursuant to point 7);
9) That the Sole Shareholder declares formally withdraw the appointment of an auditor to the liquidation;
10) That the Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the
Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;
11) That full and entire discharge is granted to the board of directors and statutory auditor for the performance of
their assignment.
12) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the former
registered office of the Company in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder, acting as said before, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
“Gold Flamingo Inc.”, une société régie par les lois des Bahamas, ayant son siège social à Nassau West Bay Street, PO
Box SP-63131, Bayside Executive Park, Building No. 1 (Bahamas), enregistrée au Registre de Commerce de Nassau
(Bahamas) sous le numéro 167010B,
ici représentée par Madame Deborah BUFFONE, employée, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg,
26-28, rue Edward Steichen, (la “Mandataire”), en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle pro-
curation, après avoir été signée “ne varietur” par la Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme “Prêt-à-porter Catalogue”, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28,
rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
176385, (la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-
sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 879 du 13 avril 2013, et que les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors;
12899
L
U X E M B O U R G
2) Que le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions avec une valeur
nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées;
3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule détentrice de toutes les actions de la Société
(l'“Actionnaire Unique”);
4) Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l'Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet
en date de ce jour;
6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins
pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout
ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
7) Que l'Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif
de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en
outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume
l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société
est réglé;
8) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de
la Société indiqué au point 7);
9) Que l'Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
10) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;
11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur
mandat;
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien
siège social de la Société à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la Mandataire, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état
civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. BUFFONE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2014. LAC/2014/63247. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 07 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003323/116.
(150002851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Multitube Technical Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4804 Rodange, 3, rue du Maribor.
R.C.S. Luxembourg B 160.780.
DISSOLUTION
L'an deux mil quatorze, le dix-huit décembre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange,
A comparu
Monsieur Anthony VIGERSTAFF, ingénieur mécanique, né le 14 mai 1964, à Stockport (Royaume Uni), demeurant à
L-4804 Rodange, 3 rue Maribor,
Lequel comparant agissant en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
MULTITUBE TECHNICAL SERVICES S.à.r.l.
12900
L
U X E M B O U R G
établie et ayant son siège social à L-4804 Rodange, 3, rue du Maribor,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 160.780,
constituée suivant acte reçu par Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 avril 2011,
publié au Mémorial C n° 1546, page 74176 du 12 juillet 2011,
dont le capital social s’élève à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00,-) représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,00 €) chacune.
La partie comparante représentant l’intégralité du capital social de ladite société se constitue en assemblée générale
et renonçant à tout délai et toute formalité de convocation, déclare constater que ladite assemblée générale est valable-
ment constituée.
Par la suite, la partie comparante a prié le notaire d'acter ce qui suit:
I. L’associé unique constate que Monsieur Josephus Jacobus Henri Marie VERBEECK, directeur, né le 8 juillet 1954, à
Eidhoven (Pays-Bas), demeurant à L-4735 Pétange, 28 rue J.B. Gillardin et Monsieur Leonardus COOLEN, directeur, né
le 5 octobre 1984, à Weert (Pays-Bas), demeurant à NL-6001BA Weert (Pays-Bas), Emmasingel 7 ont cédé chacun 33
parts sociales à Monsieur Anthony VIGERSTAFF, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 4 décembre 2014, ci-
annexé.
II. Les parties comparantes, représentant l’intégralité du capital social, déclarent et décident expressément de dissoudre
et liquider la société avec effet à ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité.
III. Les parties soussignées connaissent parfaitement la situation financière et les statuts de la société.
IV. Les parties soussignées, associées de la prédite société, se considérant comme liquidateur de ladite société, décla-
rent avoir réglé ou provisionné tout le passif de la société et déclarent répondre personnellement et solidairement de
tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à ce jour.
V. Les parties soussignées donnent décharge expresse aux gérant technique unique, Monsieur Anthony VIGERSTAFF,
et au gérant administratif, Monsieur Leonardus COOLEN, pour l’exécution de leur mandat jusqu'à la date de l’acte notarié.
VI. Les parties soussignées approuvent encore par les présentes les comptes de ladite société.
VII. La liquidation de la société est par conséquent achevée.
VIII. Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l’adresse de L-4804
Rodange, 3 rue Maribor.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à
sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de mille trois cents euros (1.300,-€). A l’égard du notaire
instrumentant, toutes les parties comparantes et / ou signataires des présentes reconnaissent être solidairement tenues
du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
<i>Déclarations généralesi>
La partie comparante déclare que le notaire instrumentant lui a expliqué tous les effets et toutes les conséquences du
présent acte. Elle a persisté à procéder par le présent acte et a déclaré décharger le notaire instrumentant de toute
conséquence et responsabilité éventuelle pouvant découler du présent acte.
DONT ACTE, fait est passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signés: A. VIGERSTAFF, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2014. Relation: EAC/2014/18117. Reçu soixante-quinze euros
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Pour expédition conforme.
Pétange, le 7 janvier 2014.
Référence de publication: 2015003270/67.
(150002448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
12901
L
U X E M B O U R G
Matrix Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 86.665.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille quatorze,
le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MATRIX INVESTMENTS S.A., avec siège
social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 86.665 (NIN 2002 2207 394),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 mars 2002, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations numéro 971 du 26 juin 2002,
au capital social de trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur
nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune, entièrement libérées.
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 19 décembre 2014, en voie de
publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée est présidée par Monsieur Rob SONNENSCHEIN, directeur, demeurant professionnellement à L-2134
Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Djilali KEHAL, employé, demeurant professionnellement
à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Valérie ALBANTI, employée, demeurant professionnellement à
L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- L'assemblée générale extraordinaire tenue le 23 décembre 2014, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a
nommé en qualité de commissaire-vérificateur, la société ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxem-
bourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507,
et a fixé à ce jour la présente assemblée ayant pour ordre du jour:
1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4.- Clôture de la liquidation.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III.- Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV.- L'assemblée aborde l'ordre du jour.
<i>1. - Rapport du commissaire-vérificateuri>
L'assemblée approuve le rapport sur la liquidation établi par le commissaire-vérificateur, à savoir la société ZIMMER
& PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.
Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.
<i>2. - Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptesi>
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l'exécution de leur mandat.
<i>3. - Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateuri>
Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction à la société à responsabilité limitée Luxglobal Services S.à r.l., avec siège social à
L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 160.089, de sa gestion de la liquidation et au commissaire-vérificateur ZIMMER & PARTNERS S.A.
12902
L
U X E M B O U R G
<i>4. - Clôture de la liquidationi>
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société MATRIX INVESTMENTS S.A. a cessé
définitivement d'exister.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période
de cinq ans à l'ancien siège social.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: R. SONNENSCHEIN, D. KEHAL, V. ALBANTI, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2015. Relation: GAC/2015/55. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003248/71.
(150003262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Markanne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 114.882.
DISSOLUTION
L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Thierry FROELIGER, administrateur de société, né à Strasbourg (France), le 22 octobre 1963 demeurant à
F-67300 Schiltigheim, 28, rue de Lattre de Tassigny.
Lequel comparant déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme “MARKANNE S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue
Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114882,
(la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 20 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1105 du 7 juin 2006,
et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Paul DECKER, alors de résidence
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 6 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 643 du 25 mars 2009;
2) Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;
3) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de
la Société (l'“Actionnaire Unique”);
4) Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l'Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet
en date de ce jour;
6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins
pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout
ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
7) Que l'Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif
de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en
outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume
l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société
est réglé;
8) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de
la Société indiqué au point 7);
12903
L
U X E M B O U R G
9) Que l'Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
10) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;
11) Que décharge pleine et entière est donnée à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes pour l'exé-
cution de leur mandat;
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à
L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant
a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. FROELIGER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2014. LAC/2014/62326. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 6 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003246/58.
(150002673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Marketing Control Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, op der Ahlkerrech.
R.C.S. Luxembourg B 42.234.
Im Jahre zweitausendvierzehn, den achtzehnten Tag im Monat Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,
der Aktiengesellschaft MARKETING CONTROL HOLDING S.A., deren Gesellschaftssitz gekündigt wurde, eingetragen
im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 42234, gegründet durch Urkunde des Notars Edmond Schroeder,
mit damaligem Amtssitzes in Mersch vom 10. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 95 vom 1. März
1993, letztmalig abgeändert unter Privatschrift (von LUF nach EURO), am 3. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 629 vom 23. April 2002.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Richard Kohl, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-6776 Grevenmacher,
6-8, op der Ahlkerrech;
Zum Schriftführer wird bestimmt Herrn Jean-Pierre Dias, Angestellter, beruflich wohnhaft in Senningerberg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Richard Kohl, vorbenannt.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf
einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.
Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem ins-
trumentierenden Notar “ne varietur“unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.
3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-6776 Grevenmacher, 6-8, op der Ahlkerrech.
2.- In Folge dessen, Abänderung von Artikel 1 der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschluss:i>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz der Gesellschaft nach L-6776 Grevenmacher, 6-8, op der
Ahlkerrech zu verlegen.
12904
L
U X E M B O U R G
<i>Zweiter Beschlussi>
In Folge dessen beschliesst die Generalversammlung Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern wie folgt:
Art. 1. „Zwischen den Vertragsparteien und solchen, die es noch werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der
Bezeichnung „MARKETING CONTROL HOLDING S.A.“gegründet. Sie unterliegt den Gesetzen vom zehnten August
eintausendneunhundertfünfzehn einschließlich der Änderungsgesetze, sowie den gegenwärtigen Satzungen. Der Sitz der
Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.“
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf EINTAUSENDEIN-
HUNDERT EURO (EUR 1.100,-) abgeschätzt.
<i>Bevollmächtigungi>
Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten
Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Richard Kohl, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 décembre 2014. LAC / 2014 / 61181. Reçu 75.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 6. Januar 2015.
Référence de publication: 2015003247/56.
(150002734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
La Bulle de Vin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 24, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 179.133.
Les comptes annuels en date du 26 juillet 2013 au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014209356/10.
(140234398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.
ProLogis UK IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 69.901.
In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of December.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis Holding XI (A) B.V., a company organized under the laws of the Netherlands, having its registered office at
17, Gustav Mahlerplein, NL-1082 MS Amsterdam, registered at the Chamber of Commerce of Amsterdam under the
number 34188102,
duly represented by its managing director, Prologis Directorship II B.V., itself represented by its managing director,
Mr Gerrit Jan Merkeerk, residing professionally in Luxembourg,
Such appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of "ProLogis UK IV S.à r.l.", a limited liability company,
having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 69.901 (the "Com-
pany"), incorporated under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed on the 10
th
day of
May, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 577 of the 27
th
day of July, 1999, and
whose articles of incorporation have been amended pursuant to a notarial deed of the on the 19
th
day of December,
12905
L
U X E M B O U R G
2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 636 of the 14
th
day of August, 2001, has
required the undersigned notary to state its unique resolution as follows:
<i>Resolution:i>
The sole shareholder decides to amend article 21 of the articles of incorporation who will henceforth read as follows:
“ Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers.
4. The payment is based on the understanding that the rights of the creditors of the Company are not threatened.”
<i>Estimate of costsi>
The person appearing estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which
shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this deed at ONE THOUSAND EUROS
(1.000.-EUR).
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation
L'an deux mille quatorze, le quatre décembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
ProLogis Holding XI (A) B.V., une société existant sous la loi des Pays-Bas, ayant son siège social au 17, Gustav Mah-
lerplein, NL-1082 MS Amsterdam, immatriculée à la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34188102,
Ici représentée par son directeur, la société Prologis Directorship II B.V., ellemême représentée par son directeur,
Monsieur Gerrit Jan Merkeerk, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Laquelle société comparante, agissant en sa qualité d'associée unique de "ProLogis UK IV S.à r.l.", une société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social à 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
(69.901) (la "Société"), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte notarié en date du 10 mai
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 577 du 27 juillet 1999, et dont les statuts ont été
modifiés par acte notarié en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
577 du 27 juillet 1999, a requis le notaire soussigné de constater la résolution unique suivante:
<i>Résolution Unique:i>
L'associée unique décide de modifier l'article 21 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. La décision de la distribution d'acomptes sur dividendes est prise par le gérant ou le conseil de gérance.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.»
<i>Fraisi>
Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette opération à MILLE EUROS (1.000.-EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
12906
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. J. Merkeerk, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60168. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75.-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003330/83.
(150002862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
ProLogis European Holdings XXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 151.746.
In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of December.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis European Holdings VI S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 85.899),
duly represented by its manager PROLOGIS DIRECTORSHIP Sàrl, itself represented by its manager Gerrit Jan Mer-
keerk, residing professionally in Luxembourg,
Such appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of "ProLogis European Holdings XXIII S.à r.l.", a limited
liability company, having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
151.746 (the "Company"), incorporated under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the
undersigned notary on the 2
nd
day of March 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number
777 of the 14
th
day of April, 2010, and whose articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the
undersigned notary on the 27
th
day of May, 2013, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number
1842 of the 31
st
day of July, 2013, has required the undersigned notary to state its unique resolution as follows:
<i>Resolution:i>
The sole shareholder decides to amend article 21 of the articles of incorporation who will henceforth read as follows:
“ Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers.
4. The payment is based on the understanding that the rights of the creditors of the Company are not threatened.”
<i>Estimate of costsi>
The person appearing estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which
shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this deed at ONE THOUSAND EUROS
(1.000.-EUR).
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence the person appearing signed together with the notary the present deed.
12907
L
U X E M B O U R G
Follows the French translation
L'an deux mille quatorze, le neuf décembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
ProLogis European Holdings VI S.à r.l., une société existant sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 85.899)
Ici représentée par son gérant la société PROLOGIS DIRECTORSHIP Sàrl, elle-même représentée par son gérant
Monsieur Gerrit Jan Merkeerk, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Laquelle société comparante, agissant en sa qualité d'associée unique de "ProLogis European Holdings XXIII S.à r.l.",
une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg B (151.746) (la "Société"), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire
instrumentant en date du 2 mars 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 777 du 14 avril
2010, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant en date du 27 mai 2013, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1842 du 31 juillet 2013, a requis le notaire soussigné de constater la
résolution unique suivante:
<i>Résolution Unique:i>
L'associée unique décide de modifier l'article 21 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. La décision de la distribution d'acomptes sur dividendes est prise par le gérant ou le conseil de gérance.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.»
<i>Fraisi>
Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette opération à MILLE EUROS (1.000.-EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. J. Merkeerk, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60164. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75.-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003329/83.
(150002864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Pfizer International Luxembourg Sàrl, Société Anonyme.
Siège social: L-1652 Luxembourg, 12, rue Hugo Gernsback.
R.C.S. Luxembourg B 79.433.
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of December,
Before us Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
12908
L
U X E M B O U R G
PFIZER SHAREHOLDINGS LUXEMBOURG SARL, organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
with registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade Register under number B 165.903,
here represented by Me Sonia BELLAMINE, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg
on December 17, 2014.
Which proxy shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named person and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed entity, PFIZER SHAREHOLDINGS LUXEMBOURG SARL, is the sole partner of PFIZER INTERNA-
TIONAL LUXEMBOURG SARL, organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at
12, rue Hugo Gernsback, L-1652 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
Register under number B 79.433 (the "Company"), incorporated a deed of the undersigned notary on the 22
nd
December
2000, published in the Mémorial C, number 515 dated July 9, 2001 and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under section B number 79 433.
The Company's by-laws have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on 1 December 2014
not yet published in the Memorial C.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole part holder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EIGHT HUNDRED EURO
(EUR 800.-) to bring it from its present amount of TWO HUNDRED EIGHTY TWO MILLION ONE HUNDRED THIRTY
FIVE THOUSAND AND TWO HUNDRED EUROS (EUR 282,135,200.-) to the amount of TWO HUNDRED EIGHTY
TWO MILLION ONE HUNDRED THIRTY SIX THOUSAND EUROS (EUR 282,136,000.-) by the issuance of EIGHT
(8) new shares having a par value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each (the “New Shares”), having the same
rights and obligations as the existing shares, together with total issue premium of EIGHTY TWO MILLION NINE HUN-
DRED NINETY NINE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 82,999,200.).
The aggregate contribution of EIGHTY THREE MILLION EURO (EUR 83,000,000.-) in relation to the New Shares is
allocated as follows: (i) EIGHT HUNDRED EURO (EUR 800.-) to the share capital of the Company and (ii) EIGHTY
TWO MILLION NINE HUNDRED NINETY NINE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 82,999,200.-) to the
share premium account of the Company.
<i>Subscriptioni>
PFIZER SHAREHOLDINGS LUXEMBOURG SARL, prenamed, represented as stated hereabove has declared to sub-
scribe for the EIGHT HUNDRED (800.-) New Shares, and to pay them a total price of EIGHT HUNDRED EUROS (EUR
800.-) together with total issue premium of EIGHTY TWO MILLION NINE HUNDRED NINETY NINE THOUSAND
TWO HUNDRED EURO (EUR 82,999,200.-) by a contribution in kind consisting in the contribution of a claim against
the Company.
The above contribution in kind has been dealt with in a statement issued by the management of the Company, based
on accounts of the Company as at December 17, 2014 which certifies the existence and the total value of the claim
contributed.
<i>Second resolutioni>
The sole partner resolves to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the Company in order to reflect
such increase of capital, which now reads as follows:
Art. 7. First paragraph. “The corporate capital of the company is set at TWO HUNDRED EIGHTY TWO MILLION
ONE HUNDRED THIRTY SIX THOUSAND EUROS (EUR 282,136,000.-) divided into TWO MILLION EIGHT HUN-
DRED TWENTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY (2,821,360) shares having a par value of one hundred
EURO (EUR 100.-) each all of which have been fully paid up. (...)”
<i>Valuation - Costsi>
The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged
to it by reason of the present deed are estimated at EUR 6,800.
Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby
grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign
any deed rectifying the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
12909
L
U X E M B O U R G
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN notaire de résidence à Luxembourg soussigné;
A COMPARU
PFIZER SHAREHOLDINGS LUXEMBOURG SARL, ayant son siège au 51 Avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
165.903,
représentée par Me Sonia BELLAMINE, avocate, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée en Luxembourg le 17 décembre 2014.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la personne représentant la partie comparante susnom-
mée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
La société prénommée, PFIZER SHAREHOLDINGS LUXEMBOURG SARL, est l'associé unique de PFIZER INTER-
NATIONAL LUXEMBOURG SARL, ayant son siège social 12, rue Hugo Gernsback, L-1652 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée par un acte du notaire instrumentaire du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro
515 du 9 juillet 2001, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79433 (la
«Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en date de 1
décembre 2014, non encore publié dans le Mémorial C.
Laquelle personne comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société par un montant de HUIT CENTS EUROS (EUR
800,-) pour le porter de son montant actuel de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLIONS CENT TRENTE-CINQ
MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 282.135.200,-) à un montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLIONS
CENT TRENTE-SIX MILLE EUROS (EUR 282.136.000,-) par l'émission de HUIT (8) de nouvelles parts sociales ayant une
valeur CENT EUROS (EUR 100) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et obligations que les
parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission de QUATRE-VINGT-DEUX MILLIONS NEUF CENT
QUATRE-VINGT-DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 82.999.200,-).
L'apport total de QUATRE-VINGT-TROIS MILLIONS d'EUROS (EUR 83.000.000,-) relativement aux Nouvelles Parts
Sociales est alloué comme suit: (i) HUIT CENTS (EUR 800,-) au capital social de la Société et (ii) QUATRE-VINGT-DEUX
MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 82.999.200,-) au compte de
prime d'émission de la Société.
<i>Souscriptioni>
PFIZER SHAREHOLDINGS LUXEMBOURG SARL, a déclaré souscrire toutes les HUIT (8) nouvelles parts sociales
et les libérer pour un prix total de HUIT CENTS EUROS (EUR 800,-) ensemble avec une prime d'émission de QUATRE-
VINGT-DEUX MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 82.999.200,-),
par l'apport en nature d'une créance contre la Société.
L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'une confirmation de l'existence et de la valeur émise par les gérants de la
Société, sur base d'un bilan de la Société daté du 17 décembre 2014, qui certifient la valeur totale de l'apport en nature.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide alors de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter
l'augmentation de capital, lequel article sera comme suit:
Art. 7. Premier paragraphe. «Le capital social de la société est fixé à DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLIONS
CENT TRENTE-SIX MILLE EUROS (EUR 282.136.000,-) divisé en DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT ET UN MILLE
TROIS CENT SOIXANTE (2.821.360) parts sociales ayant une valeur nominale de CENT EURO (EUR 100,-) chacune»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont évalués à EUR 6.800.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à
tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.
12910
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête e la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état
et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Sonia Bellamine, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 décembre 2014. LAC / 2014 / 62087. Reçu 75.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003340/129.
(150002686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Val de Morgon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 143.854.
L'an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de la société anonyme «VAL DE MORGON S.A.»
ayant son siège social au 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Jean-Joseph
WAGNER, prénommé, le 17 décembre 2008, publié au Mémorial C n° 156 le 23 janvier 2009, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n°143.854 (la «Société»).
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant profes-
sionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling (le «Président»).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Monique GOERES, clerc de notaire, demeurant professionnellement
à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling (le «Secrétaire»).
L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Virginie PIERRU, demeurant professionnellement à L-1466 Luxem-
bourg, 12, rue Jean Engling (le «Scrutateur» ensemble avec le «Président» et le «Secrétaire» le «Bureau»).
Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I.- Que l’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de la réalisation de la fusion avec la société anonyme «MALCOLM & PETER INTERNATIONAL
HOLDING S.A.» ayant son siège social au 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 108.563.
2. Cessation de la Société.
3. Décharge à accorder aux organes de la Société.
4. Désignation du lieu où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal.
5. Divers.
B) Que l’actionnaire unique (l’“Actionnaire Unique”), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu’il possède,
sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l’actionnaire unique présent ou le mandataire
qui le représente, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que la procuration de l’Actionnaire Unique représenté, signée “ne varietur” par les membres du bureau de l’As-
semblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que l’Actionnaire Unique, dûment
représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée
et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
12911
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée constate qu'en application des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle qu'amendée, (la “Loi”), la société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg «MAL-
COLM & PETER INTERNATIONAL HOLDING S.A.» ayant son siège social au 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Me Jean-Joseph WAGNER, alors notaire de résidence à Sanem, en date du 3 juin 2005,
publié au Mémorial C n° 1069 le 20 octobre 2005, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
section B numéro 108.563,, a fusionné avec la Société par absorption de cette dernière conformément au projet de fusion
passé par acte du notaire instrumentant, en date du 24 octobre 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 3416 du 17 novembre 2014.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée constate en outre que cette fusion a été faite suivant les prescriptions de l’article 279 de la Loi et que
par conséquent, la fusion se trouve réalisée, entraînant de plein droit et simultanément les effets visés à l’article 274,
notamment la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l’égard des tiers, de
l’ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante.
La fusion est effective à partir de la date du présent acte notarié comme indiquée en haut.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée constate que suite à cette fusion la Société a cessé d'exister.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée accorde décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société sans préjudice des
dispositions de l’article 272 de la Loi.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide que les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège
social de la Société Absorbante.
<i>Attestationi>
Conformément aux dispositions de l’article 271 de la Loi, le notaire soussigné, après vérification, atteste l’existence
et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes ainsi qu’au projet commun de fusion.
Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a
ensuite clôturé l’Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros (1.000,- EUR).
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, V. PIERRU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. LAC/2014/63101. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 07 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003483/81.
(150002623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Vafage S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Vafage S.A.).
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 59.318.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Référence de publication: 2015003482/10.
(150002520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
12912
3C Lux S.A.
Amorim Alternative Investments S.A.
Avolon Investments S.à r.l.
Berkeley 2 S.à r.l.
Borden Luxembourg S.à r.l.
Chesapeake Investments Company S.à.r.l.
Dekan
Elbblick (Mike) S.à r.l.
Elbblick (Oscar) S.à r.l.
Elbblick (Papa) S.à r.l.
Exelon Nuclear Partners International S.à r.l.
FoamCo 1
FoamCo 2
FoamCo 4
German Multi Industrial I S. à r. l.
JFT.Lux S.A.
JJL Gardenservice S.à.r.l.
JMDN Sàrl
Kallima S.A.
Kaola S.à r.l.
Kolfi Investissements S.A.
Kunst & Dekoration S.A.
La Bulle de Vin S.à r.l.
Loyalty Partner Holdings S.A.
Lucida S.à r.l.
Luxidea S.A.
Machold S.A., société de gestion de patrimoine familial
Madi S.A.
Madulo S.A.
Markanne S.A.
Marketing Control Holding S.A.
Matrix Investments S.A.
Mbandako S.A.
Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR
Modasia Holding S.A.
Multitube Technical Services S.à r.l.
My Home Mag
PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l.
Pfizer International Luxembourg Sàrl
Powerwave Holdings S.à r.l.
Powerwave Technologies S.à r.l.
Prêt-à-porter Catalogue
ProLogis European Holdings XXIII S.à r.l.
ProLogis UK IV S.à r.l.
Skipper Topco S.à r.l.
Source de Beauté S.à r.l.
V11 Studiogame
Vafage S.A.
Vafage S.à r.l.
Val de Morgon S.A.